This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 563
7 avril 2007
SOMMAIRE
Albanel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27020
Alluxbau s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26997
Alpha Factoring S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27000
Avantgarde Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
26978
Avery Dennison Finance Luxembourg
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27017
Batichimie et Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27022
Benimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27022
BF Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27019
Brambachlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27018
Brookbylux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27018
Clarisse LB Lotion G.m.b.H. . . . . . . . . . . . .
27024
Cresos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26979
Desch-Tennis Bouneweg a. s. b. l. . . . . . . . .
26997
Desch-Tennis Union Lëtzebuerg a. s. b. l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26997
DIAC Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26980
Ets. MARCO FELTEN, orthopédie techni-
que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26998
Frank Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27016
Fuentesanco SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26979
Gaston Administration S.A. . . . . . . . . . . . . .
27020
General CGF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27023
Gero Investments Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
27015
HCEPP Luxembourg Czech Republic III
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27000
Immo Avenir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26978
Immobilière Rivoli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27017
IonBond S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27017
KD DeLux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27015
KH Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27000
Luxtrid S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27021
Memory Corp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26979
Memory Corp. Services S.à.r.l. . . . . . . . . . .
26979
Métal Lux Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
27019
M.G. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27021
Naia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26980
Outlet Mall Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
27015
Outlet Mall Sub Group Holding No. 1 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27000
Panalpina Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
26999
Property Development Corporation . . . . .
26997
SKMCom One S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27023
SKMCom Two S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27022
Venere S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27016
Virgilate Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27024
Vrway Marketing & Service S.A. . . . . . . . . .
26998
Werasp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27018
Wycombe Investment Holdings S.A. . . . . .
26997
26977
Immo Avenir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 63, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 55.972.
EXTRAIT
Sur demande du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la
prédite Société le 20 décembre 2006, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
- 1.- le siège de la Société est transféré de L-1225 Luxembourg, 2, rue Beatrix de Bourbon, à L-2561 Luxembourg, 63,
rue de Strasbourg;
- 2.- révocation de leur poste d'Administrateurs de
- DUSTIN INVEST INC avec siège social au 2, Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue
- PARSIVAL INC avec siège social au 2, Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue
- DURBAN INC avec siège social au 2, Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue
- 3.- nominations y consécutives de
- Madame Karine Ferrara, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, née le 1
er
janvier 1974 à F-Thionville (57)
- Mademoiselle Katia Roti, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, née le 3
juin 1978 à F-Thionville (57)
- Madame Nora Brahimi, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, née le 20
mai 1973 à F-Amnéville (57)
- 4.- Révocation de la prédite société PARSIVAL INC de son poste d'administrateur-délégué. (Pas de remplacement,
pour l'instant)
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Un Administrateuri> / <i>Un Administrateuri>
Référence de publication: 2007025548/1038/30.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00173. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070016469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Avantgarde Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 36.020.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 octobre 2006i>
1. L'Assemblée décide d'accepter la démission de deux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Marco Fritsch, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Patrick Marchal, demeurant à Longwy-Haut.
L'Assemblée décide de nommer en remplacement:
- Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix
- Madame Caria Barbosa, comptable, demeurant à L-8077 Bertrange, 95, rte de Luxembourg
L'Assemblée décide de nommer comme administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature
conformément à l'article six des statuts, Monsieur Robert Elvinger prénommé.
Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra
en l'an 2009.
2. l'Assemblée décide de nommer comme nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Robert
Elvinger, Monsieur Roberto Vasta, conseiller fiscal, L-1521 Luxembourg, 106, rue Adolphe Fischer.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2009.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007026557/1595/25.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05346. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
26978
Cresos S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 97.950.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier recommandé adressé aux actionnaires de la société en date du 11 janvier 2007 que :
- le contrat de domiciliation conclu entre la société et le L-1840 Luxembourg, 39, bd. Joseph II, a été dénoncé avec
effet au 31 décembre 2006;
- Victor Elvinger a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007025558/304/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06321. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070016531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Fuentesanco SA, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 88.372.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier recommandé adressé aux actionnaires de la société en date du 11 janvier 2007 que:
- le contrat de domiciliation conclu entre la société et le L-1840 Luxembourg, 39, bd Joseph II, a été dénoncé avec
effet au 31 décembre 2006;
- Victor Elvinger a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007025559/304/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06322. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070016534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Memory Corp. Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 100.962.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier recommandé adressé aux actionnaires de la société en date du 11 janvier 2007 que:
- le contrat de domiciliation conclu entre la société et le 39, bd Joseph II, L-1840 Luxembourg, a été dénoncé avec
effet au 31 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007025560/304/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06324. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070016538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Memory Corp S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 97.951.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier recommandé adressé aux actionnaires de la société en date du 11 janvier 2007 que:
- le contrat de domiciliation conclu entre la société et le L-1840 Luxembourg, 39, bd. Joseph II, a été dénoncé avec
effet au 31 décembre 2006;
26979
- Victor Elvinger et Catherine Dessoy ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs avec effet au 31 décembre
2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007025561/304/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06323. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070016540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Naia, Société Anonyme Holding.
R.C.S. Luxembourg B 93.126.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier recommandé adressé aux actionnaires de la société en date du 11 janvier 2007 que:
- le contrat de domiciliation conclu entre la société et le L-1840 Luxembourg, 39, bd Joseph II, a été dénoncé avec
effet au 31 décembre 2006;
- Victor Elvinger a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007025562/304/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06325. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070016543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
DIAC Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.050,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 120.911.
In the year two thousand and six, on the nineteenth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Civil Law Notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg);
There appeared:
(1) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 87453 acting as general partner for and on behalf of CVC CAPITAL PARTNERS
ASIA PACIFIC II LP, a limited partnership formed and organised under the laws of the Cayman Islands and having its
registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK15195,
(2) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 87453 acting as general partner for and on behalf of CVC CAPITAL PARTNERS
ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, LP, a limited partnership formed and organised under the laws of the Cayman
Islands and having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK15194,
(3) CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 89461 acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY
PARTNERS IV (A) LP, a limited partnership formed and organised under the laws of the Cayman Islands and having its
registered office at Walker House, Mary Street., George Town, Grand Cayman, Cayman Island, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-15604,
(4) CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 89461 acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY
26980
PARTNERS IV (B) LP, a limited partnership formed and organised under the laws of the Cayman Islands and having its
registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-15898,
(5) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 90393 acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY
PARTNERS IV (C) LP, a limited partnership formed and organised under the laws of the Cayman Islands and having its
registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-15931,
(6) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 90393 acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY
PARTNERS IV (D) LP, a limited partnership formed and organised under the laws of the Cayman Islands and having its
registered office at Walker House, Mary Street, George Town,, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-15934, and
(7) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 90393 acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY
PARTNERS IV (E) LP, a limited partnership formed and organised under the laws of the Cayman Islands and having its
registered office at, Walker House, Mary Street, Goerge Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK-15933
being all the shareholders (the «Shareholders») of DIAC HOLDINGS S.à r.l, a société à responsabilité limitée, with
registered office at L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, registered with the trade and companies' register of Lux-
embourg Section B 120.911 (the «Company»),
all duly represented by Ms. Emanuela Brero, Director of Corporate Administration, 5, place du Theatre, L-2613
Luxembourg,
by virtue of seven (7) proxies, given in Jersey, on December 19, 2006,
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed in order to be registered therewith.
The appearing parties representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital from its present amount of twenty-five thousand and fifty euros (EUR 25,050.-) rep-
resented by one thousand and two (1,002) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, up to two million
seven hundred and sixty seven thousand and seven hundred euros (EUR 2,767,700.-) represented by one hundred and
ten thousand seven hundred and eight (110,708) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, by the issue of one hundred
and nine thousand seven hundred and six (109,706) new shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
2. Restatement of the articles of association of the Company.
After having reviewed the item of the agenda, the appearing parties, representing the whole corporate capital require
the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to increase the share capital from its present amount of twenty-five thousand and fifty euros
(EUR 25,050.-) represented by one thousand and two (1,002) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-)
each, up to the total amount of two million seven hundred and sixty seven thousand and seven hundred euros (EUR
2,767,700.-) represented by one hundred and ten thousand seven hundred and eight (110,708) shares of twenty-five euros
(EUR 25.-) each, by the issue of one hundred and nine thousand seven hundred and six (109,706) new shares of twenty-
five euros (EUR 25.-) each, to be fully paid up by the contribution in kind of part of a loan granted by the Shareholders
to CAID PTY LIMITED on December 8, 2006 together with a total issue premium of Eight Euros (EUR 8.-);.
All new issued shares have been entirely subscribed as follow:
1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC CAPITAL PART-
NERS ASIA PACIFIC II LP 37,840 shares
here represented by Ms Emanuela Brero, Director of Corporate Administration, 5, place du Theatre, L-2613 Luxem-
bourg,
by virtue of a proxy given in Jersey on December 19, 2006
2. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC CAPITAL PART-
NERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, LP 7,307 shares
here represented by Ms Emanuela Brero, prenamed,
by virtue of a proxy given in Jersey on December 19, 2006
26981
3. CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (A) LP 13,075 shares
here represented by Ms. Emanuela Brero, prenamed,
by virtue of a proxy given in Jersey on December 19, 2006
4. CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (B) LP 12,411 shares
here represented by Ms Emanuela Brero, prenamed,
by virtue of a proxy given in Jersey on December 19, 2006
5. CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (C) LP 20,034 shares
here represented by Ms Emanuela Brero, prenamed,
by virtue of a proxy given in Jersey on December 19, 2006
6. CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (D) LP 16,918 shares
here represented by Ms Emanuela Brero, prenamed,
by virtue of a proxy given in Jersey on December 19, 2006
7. CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (E) LP 2,121 shares
here represented by Ms Emanuela Brero, prenamed,
by virtue of a proxy given in Jersey on December 19, 2006
Said proxies after signature ne varietur, by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed, to be filed at the same time.
The subscribed shares have been fully paid up, together with a total issue premium of Eight Euros (EUR 8.-), through
a contribution in kind consisting of part of a loan granted by the Shareholders to CAID PTY LIMITED on December 8,
2006 up to the counter value of a total amount of two million seven hundred and forty two thousand six hundred and
fifty eight euros (EUR 2,742,658.-).
The proof of the existence and of the value of the Interim Loan has been produced according to the undersigned
notary through a management report, which report, after signature ne varietur by all the parties and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.
<i>Second resolutioni>
The appearing parties, after deliberation, unanimously approve the new articles of association of the Company, which
shall read as follows:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which
will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association
(hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one
member company.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company
law of 31st July 1929.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination DIAC HOLDINGS S.à r.l.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
26982
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or
in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1- Subscribed and authorised share capital
The Company's corporate capital is fixed at two million seven hundred and sixty seven thousand and seven hundred
euros (EUR 2,767,700.-), represented by one hundred and ten thousand seven hundred and eight (110,708) shares of
twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
At the moment and as long as al the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2- Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general
shareholders' meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of
the Law.
6.3- Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in
existence.
6.4- Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5- Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may not be transferred without the prior
approval of the shareholders representing at least sixty five percent of the share capital («Special Majority Consent») and
in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters
of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.
6.6- Preemptive rights
The provisions of this article shall not apply to any offer to purchase under article 6.8. If a shareholder proposes to
sell or transfer all or any portion of its shares in the Company (and other debt securities to be sold or transferred with
them) («Offer Shares»), such person («Offerer») shall first offer all such offer shares («Offer Shares») by written notice
to the other shareholders («Offerers») in accordance with the following procedures:
The Offerer shall give written notice («Offer Notice») to the Company and each of the Offerers of its offer to sell
the Offer Shares, specifying the number of Offer Shares offered to each Offerer (being their proportionate share of the
Offer Shares) («entitlement»), the price and other terms and conditions of sale.
Every such offer shall:
- be accompanied by a form of acceptance for use by the Offerers in applying for their entitlement;
- be open for acceptance in whole or in part of their entitlement for a period of 30 days from the date of dispatch of
the offer («Acceptance Period»); and
- invite the Offerers to state whether they would wish to accept the offer in respect of Offer Shares not accepted by
any other Offerer («Untaken Shares»).
During the Acceptance Period, each Offerer shall indicate in writing to the Company whether it chooses to accept or
reject the offer in respect of its entitlement. If an Offerer fails to indicate its decision before the end of the Acceptance
Period, such Offerer shall be deemed to have rejected the offer. Subject to paragraph (d) below, any Offerer accepting
the offer shall submit to the Company a completed form of acceptance, executed by a duly authorised signatory, specifying
its acceptance as well as the number, if any, of Untaken Shares that it will agree to accept. The Company shall promptly
inform the Offerer and other Offerers of each Offerer's decision. The Offerer may nominate another member of its CVC
Investor Group to take up its entitlement.
There shall be allocated to each accepting Offerer the number of Offer Shares that such Offerer has agreed to accept
as its entitlement and, subject to the following, as Untaken Shares. Any Untaken Shares shall be allocated to the Offerers
who have indicated that they would accept Untaken Shares, in the first instance pro rata to their Interests (as between
the Offerers who have indicated they would accept Untaken Shares). For the avoidance of doubt, no Offerer shall be
26983
obliged to accept any Untaken Shares in excess of the number of Untaken Shares that such Offerer indicated in its form
of acceptance that it would accept.
Based on the allocation of Offer Shares pursuant to paragraph d above, so long as all, and not less than all, of the Offer
Shares are taken up by the Offerers (whether by acceptance of all offers in respect of entitlement's or by acceptance of
such offers in part and agreement to accept all Untaken Shares), the Offerer and each of the Offerers that has taken up
Offer Shares must complete the sale and purchase of the Offer Shares within 30 days after the end of the Acceptance
Period.
In the event that not all of the Offer Shares are agreed to be taken up by the Offerers (whether by acceptance of offers
in respect of entitlement's or by acceptance of such offers and agreement to accept Untaken Shares) within the Acceptance
Period, the Offerer may, by written notice to Top Company within 5 days after the end of the Acceptance Period, elect
at its sole option:
- not to dispose of any of the Offer Shares;
to dispose of Offer Shares taken up by Offerers in accordance with the allocation in accordance with paragraph d
above; or
to dispose of the Offer Shares taken up by Offerers to the Offerers and to dispose of the Offer Shares not agreed to
be taken up by the Offerers to any third party in accordance with paragraph 0 below.
Any Offer Shares sold by the Offerer to a purchasing Offerer under this article shall be sold and transferred with all
rights and benefits attaching thereto and free from any mortgage, charge, option, pledge, lien or encumbrance or third
party rights whatsoever.
Pursuant to paragraph 6.6 above and subject to article 6.8, the Offerer shall, provided that any such sale is approved
by Special Majority Consent, be free to dispose of Offer Shares not taken up by Offerers to any person (including a CVC
Investor) within a period of 90 days after the expiration of the Acceptance Period («Free Sale Period»), provided that
the Offerer shall not so sell the Offer Shares not agreed to be taken up by the Offerers:
- at a lower price than the price at which such Offer Shares were offered to the Offerers (after deducting, where
appropriate, any net dividend or other distribution to be retained by the Offerer); or
- on other terms or conditions more favourable than those offered to the Offerers.
For the avoidance of doubt, any Offer Shares which are not disposed of in accordance with this paragraph 0 within
the Free Sale Period shall become subject anew to the terms of this article as if they had never before been offered for
sale.
6.8- Tag-Along Rights
Subject to the prior satisfaction of the requirements under articles 6.7 and 6.9, if one or more shareholders (for the
purposes of this article the «Seller» or «Sellers») has received a bona fide offer from any person («Potential Purchaser»,
which may be a shareholder) to purchase any Top Company Shares (with the proportion of the Sellers' Top Company
Shares proposed to be sold to the Potential Purchaser being referred to in this article as the «Relevant Proportion») each
other shareholder («Tag-Along parties») shall have a right («Tag-Along Right») to sell the number of shares which rep-
resents the Relevant Proportion of its shares («Tag Proportion») (together with any other debt securities to be sold with
them), on the same terms and conditions offered by the Potential Purchaser. The Tag-Along Right shall be exercised as
follows:
The Seller or Sellers shall require the Potential Purchaser to extend its purchase offer to include the relevant shares
of the Company (and any other debt securities to be sold with them) held by the Tag-Along parties in order to give effect
to the sale of the Tag Proportion by each Tag-Along party. Such purchase offer shall be made to all of the Tag-Along
parties as far as possible on the same terms and conditions and in any event terms and conditions such that each Seller
and Tag-Along party receives the same pro rata value for their shares and any other debt securities to be sold with them
(if they were to accept the offers made by the Potential Purchaser), specifying the identity of the Potential Purchaser,
number of relevant shares of the Company and any other debt securities to be sold with them to be purchased, the price
per share and other terms and conditions of sale («Tag-Along Offer»).
Within 15 days after receiving a Tag-Along Offer, each Tag-Along party shall by notice in writing to the Seller(s) and
other Top Company Shareholders elect:
to sell all or only part of its Tag Proportion to the Potential Purchaser pursuant to the terms and conditions of the
Tag-Along Offer, whereupon it shall be bound to transfer such shares (and any other debt securities to be sold with
them) to the Potential Purchaser; or
not to sell any of its Tag Proportion to the Potential Purchaser.
If any Tag-Along party does not serve notice within the above 15 day period, it shall be deemed to have elected not
to sell any shares of the Company to the Potential Purchaser.
If the number of the shares to be sold after the exercise of the Tag-Along Right exceeds the number of the shares
that the Potential Purchaser wishes to purchase as set out in the Tag-Along Offer then all sales of shares to the Potential
Purchaser pursuant to the Tag-Along Offer shall be conducted on a pro rata basis among the selling Tag-Along parties
such that:
they each dispose of the same proportion of their Interests; and
26984
they each receive the same pro rata value for the proportion of their shares (and any other debt securities to be sold
with them) disposed of.
If the total number of the relevant shares to be sold by the shareholders to the Potential Purchaser after the exercise
of the Tag-Along Rights («Voluntary Shares») is less than the number of the shares that the Potential Purchaser wishes
to purchase as set out in the Tag-Along Offer («Target Shares») and the conditions set out in this article have been
satisfied then the Seller or Sellers may sell such further number of the shares, in the same proportions as those Sellers
have taken up in the Tag Along Offer, equal to the difference between the number of Target Shares and the number of
Voluntary Shares.
6.8- Drag-Along Rights
If a Potential Purchaser (as defined in article 6.7) offers to purchase debt securities held by CVC Investors representing
25% or more of the CVC Investors' shares of the Company («Dragging Shareholders»), the Dragging Shareholders shall
have the right («Drag-Along Right») to require the other shareholders to sell the same proportion of their respective
holdings of the shares of the Company (and any debt securities required to be disposed of with them) on the same terms
and conditions offered by the Potential Purchaser and in any event on terms and conditions such that each shareholder
receives the same pro rata value for its respective shares (and any debt securities required to be disposed of with them).
6.9- Exit Events
Each shareholder may participate in any listing, disposal, directly or indirectly, of in excess of fifty percent (50%) of
either the shares in the Company or any of its subsidiary or the sale of any shares, business or other assets, having a value
in excess of fifty percent (50%) of the aggregate value of the business conducted by the Company from time to time or
a sale, buy back or cancellation of, or distribution or return of capital on any share or a winding up of the Company (the
«Exit Event») pro rata to their current Interests. The aggregate price received by each shareholder in an Exit Event for
disposal of all or part of their interest in the Company is the same aggregate price as received by each other shareholder
for disposal of a pro rata share of their interests in the Exit Event.
6.10- Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in
accordance with Article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1- Appointment and removal
7.1.1. The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, they will constitute
a board of directors. The director(s) need not to be shareholder(s).
7.1.2. The director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3. A director may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by
the shareholders.
7.1.4. In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of
any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders' meeting.
7.1.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as directors, unless otherwise
resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings
on the board.
7.2- Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.
7.3- Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the sole
signature of any member of the board of directors.
The director, or in case of plurality of directors, the board of directors, may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
7.4- Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary,
who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors
and of the shareholders.
26985
The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the
secretary and recorded in the corporate book. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial
proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any director.
The board of directors can discuss or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at the meeting of the board of directors and at least one CVC APAC Nominated Director and one CVC EUROPE
Nominated Director is present.
If a quorum is not present within 30 minutes after the time appointed for the meeting, the meeting shall stand adjourned
and be reconvened on the fifth business day following the date of the adjourned meeting (provided that notice of the
time, date and place of the reconvened meeting must be given to each director not less than 48 hours before the meeting).
If a quorum is not present within 30 minutes after the time appointed for an adjourned meeting of the Company,
provided there are two directors present, those present shall be deemed to constitute a quorum for the purposes of
that meeting only.
In case of plurality of directors, resolutions shall be taken when approved by i) a majority of the votes of the directors
present or represented at such meeting, ii) at least one CVC APac Nominated Director (means any director appointed
by CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II LP, CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A
LP or any investment fund which (i) holds Top Company Shares; and (ii) is advised by CVC ASIA PACIFIC SERVICE
COMPANY LIMITED) and iii) at least one CVC Europe Nominated Director (means any director appointed by CVC
EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) LP, CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B) LP, CVC EUROPEAN EQUI-
TY PARTNERS IV (C) LP, CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) LP, CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV
(E) LP or any investment fund which (i) holds Top Company Shares; (ii) is advised, either directly or through a chain of
advisory agreements, by CVC CAPITAL PARTNERS ADVISORY COMPANY LIMITED; and (iii) is not a member of the
CVC APAC GROUP).
The consent of 75% of the votes of the directors present or represented at the meeting of the board of directors is
required to adopt the following resolutions:
a. Amendments to any agreement signed during the course of the year 2006;
b. Lending monies except to any of its subsidiary and except extensions of credit to customers in the ordinary course
of business;
c. Material changes in the nature of the Company's business, and the commencement of new material business activities;
d. Acquiring or disposing of material companies, businesses or assets;
e. Any matter not in the ordinary course of business of the Company;
f. Filing for bankruptcy, reorganisation, composition or similar proceeding based on actual or impending insolvency;
g. Creating a mortgage, pledge or other encumbrance over any assets and giving any guarantee, other than in the
ordinary course of trading;
h. Appointing or removing any directors to or from the board of any subsidiary of the Company other than the CVC
APac Nominated Directors and the CVC Europe Nominated Directors;
i. Appoint or remove any employee of any subsidiary of the Company as a director;
j. Appointing or dismissing auditors, which shall in any case only be selected from among firms of international repute;
k. An agreement for the sale of any shares, business, or other assets of the Company or any of its subsidiary, having
a value in excess of $500,000.-;
l. Adoption of the annual budget and/or business plan of the Company or any of its subsidiary;
m. Approving of the unconsolidated and/or consolidated annual accounts for the Company or any of its subsidiary;
n. Recommendation of a dividend with respect to any class of share in the Australian holding subsidiary, the Company
or the Belgian subsidiary or payment of Loan Note interest;
o. Any investment or other expenditure of the Company or any of its subsidiary not provided for in the annual budget
and in excess of $ 500,000.-;
p. Changes in accounting policies and principles of the Company or any of its subsidiary;
q. Entering into any agreement or arrangement with a shareholder of the Company, Director, or any member of the
board of directors or the Belgian subsidiary Board, or any person related to a Shareholder, Director, or any member of
the board of directors or the Belgian subsidiary board, other than:
- employment agreements approved by the board of directors of the Company; and
- agreements for the supply of goods and or services entered into at arm's length and in the ordinary course of business.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
The board of directors must take place in Luxembourg.
Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone, or by one or more of the
directors participating by telephone, provided that each of the directors participating can both hear and be heard by each
of the others simultaneously throughout the meeting. Participation by telephone shall constitute presence at a meeting.
26986
The meeting takes place where the greatest number of directors is located or, if there is no single location where thera
are more directors present that anywhere else, then the meeting takes place wherever the person chairing the meeting
is located.
Each such meeting shall be convened by a notice sent to all directors (or their alternates) entitled to receive notice
of such meetings within a reasonable period of time prior to the meeting and every such notice shall be accompanied by
a written agenda specifying the matters to be raised at the meeting. Copies of all papers to be laid before the meeting
must be delivered to the relevant board four business days before the meeting.
The CVC Apac Nominated Directors on one hand and the CVC Europe Nominated Directors on the other may
require one observer chosen by them respectively to attend at any meeting of the board of directors of the Company.
Each party will use its best endeavours to procure that observers have the same access to the papers of the relevant
board of directors or managers as the directors/managers. For the avoidance of doubt, observers will not have the right
to vote or participate at board meetings.
7.5- Liability of directors
The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders' meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general share-
holders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
The majority of 65% of the share capital is required to adopt the following resolutions:
1. Any listing;
2. The disposal, directly or indirectly, of in excess of fifty percent (50%) of either the shares in the Company or any
of its subsidiary or the sale of any shares, business or other assets, having a value in excess of fifty percent (50%) of the
aggregate value of the business conducted by the Company from time to time;
3. A sale of the Belgian direct subsidiary Shares or any issue, cancellation or redemption of debt or equity capital (of
whatever form) by the said subsidiary;
4. The redemption of any security if any;
5. The issuance by the Company or any of its subsidiary of new shares, debt securities or other instruments convertible
into shares, options, warrants or other securities;
6. Appointing or removing any directors to or from the board of the Company other than the CVC APac Nominated
Directors and the CVC Europe Nominated Directors;
7. Appoint or remove any employee of the Company as a director; and
8. Liquidation, dissolution or winding-up.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,
may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual
general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 16th day of May at
2.00 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the
board of directors, exceptional circumstances so require.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be
supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1- Fiscal year
The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
11.2- Annual accounts
Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.
26987
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office,
the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor
(s) set-up in accordance with Article 200.
Art. 12. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortization and expenses represent the net profit.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until
and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
Art. 15. Modification of articles. These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of share-
holders, by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of
Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with
Us the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the proxy holder of
the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
This deed having been read and translated to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder appearing
signed together with Us the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre,
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
Ont comparu:
(1) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, a limited company soumise au droit de Jersey et ayant son siège social
à 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, enregistré auprès de Jersey Financial Services Commission
sous le numéro 87453 agissant en tant que general partner de et pour le compte de CVC CAPITAL PARTNERS ASIA
PACIFIC II LP, a limited partnership organisée et constituée aux iles Cayman et ayant son siège social à Walker House,
Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistré auprès du registre de Exempted Limited Partnerships,
Iles Cayman, sous le numéro WK15195,
(2) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, a limited company soumise au droit de Jersey et ayant son siège social
à 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, enregistré auprès de Jersey Financial Services Commission
sous le numéro 87453 agissant en tant que general partner de et pour le compte de CVC CAPITAL PARTNERS ASIA
PACIFIC II PARALLEL FUND - A, LP, a limited partnership organisée et constituée aux iles Cayman et ayant son siège
social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistré auprès du registre de
Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK15194,
(3) CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a limited company soumise au droit de Jersey et ayant son siège
social à 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, enregistré auprès de Jersey Financial Services
Commission sous le numéro 89461 agissant en tant que general partner de et pour le compte de CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (A) LP, a limited partnership organisée et constituée aux iles Cayman et ayant son siège social à
Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistré auprès du registre de Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK-15604,
(4) CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a limited company soumise au droit de Jersey et ayant son siège
social à 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, enregistré auprès de Jersey Financial Services
Commission sous le numéro 89461 agissant en tant que general partner de et pour le compte de CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (B) LP, a limited partnership organisée et constituée aux iles Cayman et ayant son siège social à
26988
Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistré auprès du registre de Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK-15898,
(5) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a limited company soumise au droit de Jersey et ayant son siège
social à 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, enregistré auprès de Jersey Financial Services
Commission sous le numéro 90393 agissant en tant que general partner de et pour le compte de CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (C) LP, a limited partnership organisée et constituée aux iles Cayman et ayant son siège social à
Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistré auprès du registre de Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK-15931,
(6) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a limited company soumise au droit de Jersey et ayant son siège
social à 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, enregistré auprès de Jersey Financial Services
Commission sous le numéro 90393 agissant en tant que general partner de et pour le compte de CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (D) LP, a limited partnership organisée et constituée aux iles Cayman et ayant son siège social à
Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistré auprès du registre de Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK-15934, and
(7) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a limited company soumise au droit de Jersey et ayant son siège
social à 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, enregistré auprès de Jersey Financial Services
Commission sous le numéro 90393 agissant en tant que general partner de et pour le compte de CVC EUROPEAN
EQUITY PARTNERS IV (E) LP, a limited partnership organisée et constituée aux iles Cayman et ayant son siège social à
Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistré auprès du registre de Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK-15933
étant les seules associées (les «Associées») de DIAC HOLDINGS S.à r.l. une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg Section B. 120.911 (la «Société»),
toutes dûment ici représentées par Madame Emanuela Brero, employé privé, demeurant à 5, place du Théâtre, L-2613
Luxembourg,
en vertu de sept (7) procurations données à Jersey, le 19 décembre 2006.
Lesdites procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont délibéré sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille cinquante euros (EUR
25.050,-) représenté par mille et deux (1.002) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune
à un montant de deux millions sept cent soixante-sept mille sept cents euros (EUR 2.767.700,-) représenté par cent dix
mille sept cent huit (110.708) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par
l'émission de cent neuf mille sept cent six (109.706) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-).
2. Refonte des statuts de la Société.
Après avoir analysé les points à l'ordre du jour, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont requis
le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associées décident d'augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille cinquante
euros (EUR 25.050,-) représenté par mille et deux (1.002) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, à un montant total de deux millions sept cent soixante-sept mille sept cents euros (EUR 2.767.700,-),
représenté par cent dix mille sept cent et huit (110.708) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, par l'émission de cent neuf mille sept cent six (109.706) nouvelles parts sociales, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libéré par apport en nature d'une partie d'un prêt accordé
par les Associés à CAID PTY LIMITED, le 8 décembre 2006 ensemble avec une prime d'émission de huit euros (EUR 8,-);
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED agissant en sa qualité d'associé commandité au nom et pour compte
de CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II LP: 37.840 parts sociales
ici représentée par Madame Emanuela Brero, employé privé, demeurant à 5, place du théâtre, L-2613 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 19 décembre 2006,
2. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED agissant en sa qualité d'associé commandité de au nom et pour compte
de CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, LP: 7.307 parts sociales
ici représentée par Madame Emanuela Brero, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 19 décembre 2006,
26989
3. CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED agissant en sa qualité d'associé commandité de au nom et pour compte
de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) LP: 13.075 parts sociales
ici représentée par Madame Emanuela Brero, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 19 décembre 2006,
4. CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED agissant en sa qualité d'associé commandité de au nom et pour compte
de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B) LP: 12.411 parts sociales
ici représentée par Madame Emanuela Brero, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 19 décembre 2006,
5. CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED agissant en sa qualité d'associé commandité de au nom et pour
compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) LP: 20.034 parts sociales
ici représentée par Madame Emanuela Brero, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 19 décembre 2006,
6. CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED agissant en sa qualité d'associé commandité de au nom et pour
compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) LP: 16.918 parts sociales
ici représentée par Madame Emanuela Brero, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 19 décembre 2006,
7. CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED agissant en sa qualité d'associé commandité de au nom et pour
compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (E) LP: 2.121 parts sociales
ici représentée par Madame Emanuela Brero, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 19 décembre 2006,
Lesdites procurations resteront, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, annexées
au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Toutes les parts sociales émises ont été entièrement libérées ensemble avec une prime d'émission de huit euros (EUR
8,-) par un apport en nature consistant en une partie d'un prêt accordé par les Associés à CAID PTY LIMITED en date
du 8 décembre 2006 correspondant à la contre valeur d'un montant total de deux millions sept cent quarante-deux mille
six cent cinquante-huit euros (EUR 2.742.658,-).
La preuve de l'existence et de la valeur du Prêt Temporaire a été rapportée au notaire instrumentant par la production
d'un «management report», lequel, après signature ne varietur par toutes les parties et par le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées, après avoir délibéré, décident à l'unanimité des voix d'adopter les nouveaux statuts de la Société, qui
auront la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après
«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et
11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le
transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de
quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société
peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles
(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.
D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et
de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-
action sur des biens mobiliers ou immobiliers.
La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: DIAC HOLDINGS S.à r.l.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des Associées délibérant comme en matière de modification des Statuts.
26990
L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1- Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à deux millions sept cent soixante-sept mille sept cents euros (EUR 2.767.700,-) représenté
par cent dix mille sept cent huit (110.708) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
toutes entièrement souscrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2- Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.
6.3- Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.4- Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5- Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve de l'approbation
préalable des actionnaires représentant au moins soixante-cinq pour cent du capital social («Assentiment spécial de la
majorité») et du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en
assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être
opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
6.6- Droits de préemption
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un achat effectué au titre de l'article 6.8. Si un actionnaire
propose de vendre ou de céder tout ou partie de ses parts sociales (et tout autre titre de créance y étant rattaché)
(«Parts sociales offertes»), cette personne («Initiateur») devra tout d'abord offrir la totalité des ses parts sociales offertes
(«Parts sociales offertes») par le biais d'une notification écrite à l'attention des autres associés («Destinataires») en accord
avec les modalités suivantes:
L'initiateur sera tenu de signifier par écrit («Avis d'offre») à la Société et à chacun des Destinataires son désir de vendre
les Parts sociales offertes, en en indiquant le nombre offert à chaque Destinataire (à savoir le prorata des Parts sociales
offertes) («droit»), le prix et les autres conditions de la vente.
Chacune de ces offres:
- sera accompagnée d'un formulaire d'acceptation que les Destinataires utiliseront dans la présentation de leur droit;
- devra prévoir l'acceptation totale ou partielle de leur doit dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission
de l'offre («Délai d'acceptation»); et
- invitera les Destinataires à préciser s'ils acceptent que l'offre contienne des Parts sociales offertes acceptées par
aucun autre Destinataire («Part sociale non prise»).
Durant le Délai d'acceptation, chaque Destinataire sera tenu de déclarer par écrit à la Société s'il accepte ou rejette
l'offre par rapport à son droit. Si un Destinataire omet de faire connaître sa décision avant la fin du Délai d'acceptation,
l'offre sera considérée comme rejetée. Sous réserve du paragraphe (d) ci-dessous, tout Destinataire qui accepte l'offre
sera tenu de remettre à la Société un formulaire d'acceptation rempli, signé par une personne dûment habilitée, précisant
tant son acceptation que le nombre, le cas échéant, de Parts non prises qu'il acceptera de prendre. La Société informera
immédiatement l'Initiateur et les autres Destinataires de la décision de chaque Destinataire. Le Destinataire peut désigner
un autre membre de son CVC INVESTOR GROUP pour faire valoir son droit.
Chaque Destinataire ayant accepté l'Offre se verra attribuer le nombre de Parts sociales offertes qu'il a convenu
d'accepter suivant son droit et, sous réserve de ce qui suit, au titre de Parts sociales non prises. Toute Part sociale non
prises sera attribuée aux Destinataires qui ont précisé qu'ils accepteraient des Parts sociales non prises, en premier lieu
26991
au prorata de leur participation (entre les Destinataires qui ont déclaré accepter des Parts sociales non prises). Pour
éviter toute confusion, aucun Destinataire ne sera tenu d'accepter un nombre de Parts sociales non prises qui dépasserait
le nombre de Parts sociales non prises que ce Destinataire a précisé dans le formulaire d'acceptation.
Sur la base de la répartition des Parts sociales offertes suivant le paragraphe d ci-dessus, tant que la totalité, et jamais
moins de la totalité, des Parts sociales offertes est prise par les Destinataires (soit par l'acceptation de toutes les offres
par rapport aux droits, soit par l'acceptation d'une partie de ces offres et sur accord d'acceptation de toutes les Parts
sociales non prises), l'Offrant et chacun des Destinataires ayant pris des Parts sociales offertes doit conclure la vente et
l'achat des Parts sociales offertes dans le délai de 30 jours à compter du terme du Délai d'acceptation.
Dans le cas où la totalité des Parts sociales offertes n'a pas été acceptée par les Destinataires (soit par l'acceptation
de toutes les offres aux titres des droits, soit par l'acceptation d'une partie de ces offres et sur accord d'acceptation de
toutes les Parts sociales non prises) durant le Délai d'acceptation, l'Initiateur peut, sur préavis écrit adressé à Top Company
dans un délai de 5 jours à compter de la fin du Délai d'acceptation, choisir à sa seule discrétion:
de n'aliéner aucune des Parts sociales offertes;
d'aliéner les Parts sociales offertes prises par des Destinataires conformément à l'attribution visée au paragraphe d ci-
dessus; ou
de céder les Parts sociales offertes prises par des Destinataires aux Destinataires et de céder les Parts sociales offerte
rejetées par les Destinataires à tous tiers conformément au paragraphe h0 ci-dessous.
Toute Part sociale offerte vendue par l'Initiateur à un Destinataire acquéreur en vertu du présent article seront vendues
et cédées accompagnées de tous les droits et les bénéfices y afférents et exempts de toute hypothèque, de tout nantis-
sement, de toute option, de tout privilège ou de toute servitude ou de droits de tiers, quels qu'ils soient.
Conformément au paragraphe f ci-dessus et sous réserve de l'article 6.8, l'Initiateur sera libre, à condition que cette
vente ait reçu l'Assentiment spécial de la majorité, de céder les Parts sociales offertes non prises par des Destinataires à
toute personne (y compris un Investisseur CVC) dans un délai de 90 jours à compter de la fin du Délai d'acceptation
(«Délai de vente libre») à condition que l'Initiateur ne soit pas tenu de vendre les Parts sociales offertes que les Desti-
nataires n'ont pas accepté d'acquérir:
- à un prix inférieur à celui auquel ces Parts sociales offertes ont été offertes aux Destinataires (après déduction, le
cas échéant, de tout dividende net ou de toute autre distribution devant être retenue par l'Initiateur); ou
- sous d'autres conditions plus favorables que celles offertes aux Destinataires.
Pour éviter toute confusion, toute Part sociale offerte non aliénée conformément au présent paragraphe h dans le
Délai de vente libre seront à nouveau sujettes aux dispositions du présent article comme si elles n'avaient jamais été mises
en vente.
6.7- Droit à l'égalité de traitement (ou droit de cession conjointe)
Sous réserve du respect des dispositions visées aux articles 6.7 et 6.9, si un ou plusieurs actionnaire(s) (pour les besoins
du présent article, le «Vendeur» ou les «Vendeurs») a (ont) reçu une offre faite de bonne foi par toute personne («Ache-
teur potentiel», qui peut être un actionnaire) désireuse d'acheter des actions Top Company (la proportion des actions
Top Company des Vendeurs mises en vente étant désignée dans le présent article comme «Proportion pertinente»),
chacun des autres actionnaires («Parties de la cession conjointe») aura le droit («Droit à l'égalité de traitement») de
vendre le nombre de parts sociales représentant la Proportion pertinente de ses (leurs) parts sociales («Proportion de
la cession conjointe») (plus tout autre titre de créance devant être vendu ensemble), selon le mêmes modalités offertes
par l'Acheteur potentiel. L'exercice du Droit à l'égalité de traitement sera comme suit:
Le ou les Vendeurs demandera (ont) à l'Acheteur potentiel d'étendre son offre d'achat pour y inclure les parts sociales
pertinentes de la Société (et tout autre titre de créance devant être vendu ensemble) détenues par les parties de la cession
conjointe, de façon à donner effet à la vente de la Proportion de la cession conjointe par chaque parties de la cession
conjointe. Cette offre d'achat sera présentée à la totalité des parties de la cession conjointe dans la mesure du possible
dans les mêmes conditions et, en tout état de cause, dans tous les cas, dans des conditions telles que chaque Vendeur et
chaque partie de la cession conjointe recevront la même valeur au pro rata pour leurs parts sociales et pour tout titre
de créance vendu ensemble (s'ils devaient accepter les offres présentées par l'Acheteur potentiel), en précisant l'identité
de l'Acheteur potentiel, le nombre de parts sociales pertinentes de la Société et de tout autre titre de créance devant
être vendu ensemble qui sera acquis, le prix par part sociale et toute autre modalité de vente («Offre de cession con-
jointe»).
Dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une offre de cession conjointe, chaque partie de la cession
conjointe choisira, sur préavis écrit adressé au(x) vendeur(s) et à d'autres actionnaires de Top Company:
de vendre tout ou partie de sa Proportion de la cession conjointe à l'Acheteur potentiel suivant les conditions de
l'Offre de cession conjointe, après quoi il sera obligé de céder ses parts sociales (et tous autres titres de créance devant
être vendus ensemble) à l'Acheteur potentiel ou
de ne rien vendre de sa Proportion de la cession conjointe à l'Acheteur potentiel.
Si une des Parties de la cession conjointe ne signifie aucun avis au cours du susdit délai de 15 jours, elle sera réputée
avoir choisi de ne vendre aucune part sociale de la Société à l'Acheteur potentiel.
26992
si le nombre de parts sociales à vendre après l'exercice du droit à l'égalité de traitement dépasse celui des parts sociales
que l'Acheteur potentiel désire acheter tel que visé à l'Offre de cession conjointe, toutes les ventes de parts sociales au
profit de l'Acheteur potentiel, conformément à l'Offre de cession conjointe, se concrétiseront au pro rata entre les parties
de la cession conjointe, de sorte telle que:
chacune d'entre elles détiendra une participation dans une même proportion; et
chacune recevra la même valeur au pro rata pour la proportion de leurs parts sociales (et de tout autre titre de créance
devant être vendu ensemble) cédée.
Si le nombre total des parts sociales pertinentes devant être vendues à l'Acheteur potentiel après l'exercice du droit
à l'égalité de traitement («Parts sociales volontaires») est inférieur à celui des parts que cet Acheteur potentiel désire
acheter comme stipulé dans l'Offre de cession conjointe («Parts sociales cible») et que les conditions visées au présent
article ont été remplies, le ou les Vendeurs peut (peuvent) alors vendre un nombre supplémentaire de parts sociales dans
des proportions correspondant à sa (leur) participation prise dans l'Offre de cession conjointe, égale à la différence entre
le nombre de Parts sociales cibles et le nombre de Parts sociales volontaires.
6.8- Droits de forcer la vente
Si un Acheteur potentiel (tel que défini à l'article 6.7) offre d'acheter des titres de créance détenus par des Investisseurs
CVC représentant 25 % ou plus des parts sociales de la Société des Investisseurs CVC («les Associées entraînant»), ces
derniers auront le droit («droit de forcer la vente» ou «droit d'entraînement») de demander aux autres associés de
vendre la même proportion de leurs portefeuilles respectifs des parts sociales de la Société (et de tout titre de créance
devant être cédé ensemble) dans les mêmes conditions que celles offertes par l'Acheteur potentiel et, en tout état de
cause, dans des conditions telles que chaque associé recevra la même valeur au pro rata pour ses parts sociales (et tout
titre de créance dont la cession a été demandée).
6.9- Cas de sortie
Chaque actionnaire peut participer à toute admission à la cote, à toute aliénation, directe ou indirecte, de plus de
cinquante pour cent (50 %) des parts sociales de la Société ou de l'une de ses filiales ou de la vente de toute part sociale,
de toute activité ou de tout autre actif, dont la valeur dépasse cinquante pour cent (50 %) de la valeur totale de l'activité
exécutée de temps à autre par la Société ou une vente, un rachat ou une annulation, ou encore une distribution ou un
retour de capital sur toute part sociale ou une dissolution de la Société (le «Cas de sortie») au pro rata de leur participation
actuelle. Le prix total encaissé par chaque associé dans un Cas de sortie pour l'aliénation de tout ou partie de leur
participation dans la Société est le même prix total encaissé par chacun des autres actionnaires pour l'aliénation d'une
partie proportionnelle de leur participation dans le Cas de sortie.
6.10- Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des
Associées conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Management.
7.1- Nomination et révocation
7.1.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).
7.1.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3. Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les
associés.
7.1.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d'un
gérant, l'assemblée générale des associés, pourvoiront à son remplacement.
7.1.5. Les gérants ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérants, sauf s'il en est décidé autrement
par l'assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser aux gérants les dépenses raisonnables survenues
lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la
participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.
7.2- Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.3- Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes
du présent article 7.3.
En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants
par la seule signature d'un des gérants.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
26993
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
7.4- Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un
secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et le
secrétaire et seront déposées dans les livres de la Société.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, le secrétaire ou par un gérant.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration et au moins un administrateur nommé par CVC Apac
et un administrateur nommé par CVC Europe sont présents.
En l'absence d'un quorum dans un délai de 30 minutes à compter de l'heure fixée pour la réunion, celle-ci sera ajournée
et reconvoquée le cinquième jour ouvré à compter de la date de la réunion ajournée (à condition que chaque adminis-
trateur reçoive l'avis de convocation de la réunion ajournée précisant le lieu, la date et l'heure au plus tard 48 heures
avant l'assemblée).
En l'absence d'un quorum dans un délai de 30 minutes à compter de l'heure fixée pour une réunion ajournée de la
Société et à condition que deux administrateurs soient présents, les personnes présentes seront réputées constituer le
quorum pour les besoins de cette seule réunion.
En cas de pluralité d'administrateurs, les résolutions seront approuvées 1) par la majorité des votes des administrateurs
présents ou représentés lors de ladite réunion, ii) par au moins un administrateur nommé par CVC APac (c'est-à-dire
tout administrateur désigné par CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II LP, CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PA-
CIFIC II PARALLEL FUND - A LP ou tout fond d'investissement qui (i) détient des Actions Top Company; et (ii) est
conseillé par CVC ASIA PACIFIC SERVICE COMPANY LIMITED et iii) par au moins un gérant nommé par CVC EUROPE
(c'est-à-dire tout administrateur désigné par CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) LP, CVC EUROPEAN EQUI-
TY PARTNERS IV (B) LP, CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) LP, CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV
(D) LP, CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (E) LP ou tout fond d'investissement qui (i) détient des Actions Top
Company; (ii) est conseillé, soit directement ou soit au travers d'une chaîne contractuelle, par CVC CAPITAL PARTNERS
ADVISORY COMPANY LIMITED; et (iii) n'est pas membre de CVC APAC GROUP).
Les résolutions qui suivent ne seront adoptées que si elles sont approuvées par 75% des votes des administrateurs
présents ou représentés dans la réunion du Conseil d'administration:
a. avenants à tout accord signé au cours de l'année 2006;
b. prêter de l'argent, sauf à l'une de ses filiales et en dehors des prêts accordés à des clients dans le cours normal des
affaires;
c. changements substantiels dans la nature de l'activité de la Société, et la mise en œuvre de nouvelles activités sub-
stantielles;
d. acquisition ou aliénation de sociétés, d'activités ou d'actifs substantiels;
e. toute question ne relevant pas du cours normal des affaires de la Société;
f. dépôt d'une demande de faillite, de restructuration, d'un accord amiable ou une procédure similaire sur la base d'une
cessation de paiement effective ou imminente;
g. institution d'une hypothèque, d'un nantissement ou d'une autre servitude sur tout actif et octroi de toute garantie,
autrement que dans le cours normal des affaires;
h. nomination ou révocation de tout administrateur au sein des conseils d'administration de toute filiale de la Société
autre que les administrateurs nommés par CVC APAC et CVC EUROPE;
i. désigner ou révoquer tout salarié de toute filiale de la Société en qualité d'administrateur;
j. désignation ou renvoi de commissaires aux comptes, lesquels ne devront être choisis, en tout état de cause, que
parmi des sociétés de renom international;
k. un accord pour la vente de toute part sociale, de toute activité ou de tout autre actif de la société ou de l'une de
ses filiales, d'une valeur dépassant $ 500.000,-;
l. adoption du budget annuel et/ou plan d'affaires de la Société ou de l'une de ses filiales;
m. approbation des comptes annuels non consolidés et/ou consolidés de la Société ou de l'une de ses filiales;
n. recommandation de déclaration d'un dividende par rapport à toute catégorie de part sociale dans la filial holding
australienne, dans la Société ou dans la filiale belge ou versement d'intérêts sur des obligations à court terme;
o. tout investissement ou toute autre dépense de la société ou de l'une de ses filiales non inscrite au budget annuel et
dépassant $500.000,-;
p. changements dans les politique et les principes comptables de la Société ou de l'une de ses filiales;
26994
q. conclusion de tout accord ou arrangement avec un actionnaire de la Société, un administrateur ou tout membre du
conseil d'administration ou du conseil de la filiale belge, ou toute personne liée à un Associé, à un Gérant ou à tout
membre du conseil d'administration ou du conseil de la filiale belge, autre que:
- contrats de travail approuvés par le conseil d'administration de la Société; et
- accords pour la fourniture de biens et/ou de services conclus sans lien de dépendance et dans le cours normal des
affaires.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut se faire sur un seul et unique document ou sur plusieurs
documents distincts.
Le conseil d'administration doit avoir lieu à Luxembourg
Un administrateur, ou la totalité d'entre eux, peut participer à toute réunion du conseil d'administration par téléphone,
ou par ou plusieurs administrateur participant par téléphone, à condition que chacun des gérants y participant puisse à
la fois entendre et être entendu simultanément par chacun des autres durant toute la réunion. Une participation par voie
téléphonique constituera une présence physique à la réunion. La réunion est tenue là où se trouve le plus grand nombre
d'administrateurs ou, à défaut, là où le nombre d' administrateurs présents dépasse celui des autres endroits, auquel cas
la réunion est tenue là ou se trouve la personne qui préside la réunion.
Chacune de ces réunions sera convoquée par un avis envoyé à tous les administrateurs (ou à leurs suppléants) habilités
à recevoir de tels avis dans des délais raisonnables avant la réunion et chacun de ces avis sera accompagné d'un ordre du
jour écrit précisant les questions qui seront abordées dans la réunion. Des exemplaires de tous les documents soumis
lors de la réunion doivent être remis au Conseil approprié quatre jours ouvrés avant le jour de la réunion.
Les administrateurs nommés par CVC APAC, d'une part, et les administrateurs nommés par CVC EUROPE, de l'autre,
peuvent demander à ce qu'un observateur de leur choix assiste à toute réunion du conseil d'administration de la Société.
Chaque partie fera tout son possible pour faire en sorte que les observateurs jouissent du même accès que les adminis-
trateurs/gérants aux documents du conseil d'administration ou de gérance correspondants. Pour éviter toute confusion,
les observateurs ne pourront ni voter ni participer aux réunions du conseil.
7.5- Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Les résolutions qui suivent ne peuvent être approuvées qu'à une majorité de 65 % des parts sociales:
1. Toute admission à la cote:
2. Aliénation, directe ou indirecte, de plus de cinquante pour cent (50) des parts sociales de la Société ou de l'une de
ses filiales, ou vente de toute part sociale, de toute activité ou de tout actift d'une valeur dépassant cinquante pour cent
(50%) de la somme totale de l'activité exécutée de temps en temps par la Société;
3. Vente de parts sociales de la filiale belge directe ou toute émission, annulation ou tout rachat de dette ou de capitaux
propres (sous quelque forme que ce soit) par la dite filiale;
4. Le rachat de toute valeur mobilière s'il y a lieu;
5. Émission par la Société ou par l'une des filiales de nouvelles parts sociales, de titres de créance ou d'autres instru-
ments convertibles en parts sociales, en options, en bons ou autres valeurs mobilières;
6. Nomination ou révocation de tous gérants par rapport au conseil de toute filiale de la Société autres que les gérants
nommés par CVC APAC et ceux nommés par CVC EUROPE;
7. Désigner ou révoquer tout salarié de toute filiale de la Société en qualité d' administrateur;
8. Liquidation ou dissolution.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée
générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 16 du mois de mai, à 14h00. Si ce jour devait
26995
être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée
générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le
requièrent
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société
sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1- L'exercice social
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
11.2- Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes
les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)
s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.
Art. 15. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l'assemblée des associés selon le
quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le mandataire des comparantes ont requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête du dit mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
Nous notaire.
Signé: E. Brero, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 157S, fol. 7, case 6. — Reçu 27.426,58 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007028488/230/926.
(070022946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
26996
Property Development Corporation, Société Anonyme Holding.
R.C.S. Luxembourg B 90.573.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier recommandé adressé aux actionnaires de la société en date du 11 janvier 2007 que:
- le contrat de domiciliation conclu entre la société et le L-1840 Luxembourg, 39, bd Joseph II, a été dénoncé avec
effet au 31 décembre 2006;
- Victor Elvinger a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007025563/304/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06327. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070016544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Wycombe Investment Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 90.011.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007025564/1321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07407. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070016230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Alluxbau s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 34A, rue des Muguets.
R.C.S. Luxembourg B 10.789.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2007.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
Signature
Référence de publication: 2007025565/2266/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA06280. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070016677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Desch-Tennis Union Lëtzebuerg a. s. b. l., Association sans but lucratif,
(anc. Desch-Tennis Bouneweg a. s. b. l.).
Siège social: L-1613 Luxembourg, 42, rue Jean-François Gangler.
R.C.S. Luxembourg F 2.030.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2006, a été décidé à l'unanimité une modification statutaire
consistant en un changement de la dénomination de l'a. s. b. l. DESCH-TENNIS BOUNEWEG.
L' a. s. b. l. aura désormais comme nom
DESCH-TENNIS UNION LËTZEBUERG a. s. b. l.
Les autres articles des statuts tels que déposés ont été maintenus en leur entièreté.
26997
Il est expressément retenu que l'association ainsi dénommée a été constituée exclusivement de membres du DESCH-
TENNIS BOUNEWEG et du DESCH-TENNIS HOLLERICH.
Signé: G. Pierret, M. Muller, G. Thill, G. Pierson, E. Kohner, B. Walte, F. Medernach, G. Beissel, N. Lamesch, C. Turmes,
P. Mertz, G. Faber, J. Krier
Luxembourg, le 9 novembre 2006.
Pour copie conforme
M
e
G. Pierret
Référence de publication: 2007025624/2435/22.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2007, réf. LSO-CB00384. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070017733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Ets. MARCO FELTEN, orthopédie technique, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 11, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 86.379.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 6 octobre 2006i>
En date du 6 octobre 2006,
- Monsieur Marco Felten, maître orthopédiste-technique, demeurant à L-8151 Bridel, 41B, rue de Schoenfels, et
- Monsieur Patrick Kugener, administrateur commercial, demeurant à L-4491 Belvaux, 10, rue Wenschel, se sont réunis
en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Monsieur Walter Roemer, maître cordonnier-orthopédiste, né le 15 juillet 1939 à Herxheim (D) et demeurant à
D-76863 Herxheim, Käsgasse 7, est nommé gérant technique du département «cordonnerie-orthopédie» pour une durée
indéterminée.
La société se trouve valablement engagée pour toute opération relative à ce département par la co-signature obligatoire
d'un autre gérant.
Luxembourg, le 6 octobre 2006.
M. Felten / P. Kugener.
Référence de publication: 2007026330/820/21.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06463. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Vrway Marketing & Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 79.916.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., société de droit panaméen, avec siège social à Panama (République
de Panama), East 53
rd
Street, Swiss Bank Building, Second Floor, inscrite sous le numéro 42169 auprès du registre publique
de Panama,
ici représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt,
en vertu d'une procuration générale déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Differ-
dange, en date du 3 mai 2000, enregistrée à Esch/Alzette A.C., le 5 mai 2000, volume 849, folio 66, case 9,
agissant au nom et pour compte de:
La société FARDAFID S.A., avec siège social à CH-6901 Lugano, Via G.B. Piodda 9, inscrite au «Registro di Commercio
del Cantone Ticino numéro CH-514.3001.418-3,»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Lugano, le 22 décembre 2006, laquelle restera annexée au
présent acte,
ci-après «la Soussignée».
26998
Lequel comparant a requis le notaire d'acter:
1.- Qu'il existe une société anonyme holding sous la dénomination de VRWAY MARKETING & SERVICE S.A., avec
siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
ci-après «la Société»,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 79.916, constituée suivant acte du
notaire soussigné, en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 611 du 8 août 2001.
2.- Que le capital social est fixé à cent mille francs suisses (100.000,- CHF), divisé en cent (100) actions de mille francs
suisses (1.000,- CHF) chacune.
3.- Que la Soussignée est devenue successivement propriétaire de toutes les actions, ce dont la preuve a été rapportée
au notaire soussigné.
4.- Qu'en tant que seule actionnaire, la Soussignée déclare expressément vouloir dissoudre et liquider la Société, celle-
ci ayant cessé toute activité.
5.- Que la Soussignée connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la Société.
6.- Que la Soussignée, actionnaire unique, se considérant comme liquidateur, déclare avoir réglé ou provisionné tout
le passif de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même
inconnus à ce jour.
7.- Que la Soussignée donne décharge expresse aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution
de leur mandat jusqu'à la date de l'acte notarié, ainsi qu'au notaire soussigné du chef de la documentation de cet acte.
8.- Que partant, la liquidation de la Société est achevée.
9.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l'ancien siège
de la Société à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
10.- Ensuite la Soussignée a remis au notaire toutes les actions de la Société en sa possession pour destruction.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête,
Et lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Piek, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 51, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
J.-P. Hencks.
Référence de publication: 2007025696/216/53.
(070017314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Panalpina Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1360 Senningerberg, Luxair Cargo Center.
R.C.S. Luxembourg B 62.052.
Il résulte de la décision du conseil d'Administration du 6 décembre 2006, que Monsieur Charles Van der Steene,
résidant à 4-II korte Meerhuizenstraat à NL-1078 TL Amsterdam, est nommé administrateur de la société en remplace-
ment de Monsieur John Klompers, résidant à 4/a Mauritsgaarde à NL-5671 XM Nuenen.
Cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale pour ratification.
En outre, le conseil lui délègue tous les pouvoirs du conseil d'administration pour gérer et administrer, tant activement
que passivement, les affaires de la société et lui permet de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
L'administrateur-directeur, agissant seul pourra, au nom de la société, signer tous actes de gestion journalière, no-
tamment tous contrats de transport, connaissement et autres documents relatifs à l'achat et la vente, à l'expédition,
l'agence en douane, l'affrètement et l'entreposage de toutes marchandises.
Il représentera la société vis-à-vis de toutes administrations publiques ou privées, douanes, accises, armements, chemins
de fer, compagnies de transport, postes, télégraphes, téléphones, etc.
Il pourra créer, endosser, escompter et réescompter, accepter et avaliser tous effets de commerce et documents
négociables, signer tous chèques, toutes lettres de garantie, faire et recevoir tous paiements et en donner décharge,
donner toutes signatures pour le fonctionnement des comptes en banque et office des chèques postaux.
Il pourra exercer contre qui de droit toutes poursuites nécessaires, plaider devant les tribunaux, transiger, compro-
mettre, constituer tous avoués et avocats, obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter.
Il pourra nommer et révoquer tous directeurs, sous-directeurs, fondés de pouvoir, secrétaires, agents et employés.
Il réglera les attributions, pouvoirs et émoluments, fixes et/ou proportionnels, de chacun d'eux.
Il pourra leur consentir toutes délégations pour la gestion d'une ou de plusieurs branches de l'activité sociale.
26999
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 12 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007025633/1026/30.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00779. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070017393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Outlet Mall Sub Group Holding No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.317.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 114.754.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société adoptées le 30 octobre 2006i>
L'associé unique a décidé d'accpter la démission de Monsieur Rodney Bysh de son poste d'administrateur de la Société
et de le remplacer, pour une durée indéterminée, par Monsieur John Sutherland, résidant au 9, rue Principale, L-6990
Hostert (Grand-Duché de Luxembourg), à compter du 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2007026350/267/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03654. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Alpha Factoring S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 225.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 114.697.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 5 janvier 2007i>
L'associé unique de ALPHA FACTORING S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Michel van Krimpen, en tant que Gérant B, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Jean Baptiste Brekelmans, avec adresse professionnel au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
gérant B de la société avec effet immédiat;
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
J. B. Brekelmans.
Référence de publication: 2007026529/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11235. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
KH Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HCEPP Luxembourg Czech Republic III S.àr.l.).
Capital social: EUR 47.500,00.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 76.006.
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of the month of December,
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
(1) HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under B-108.984, having its registered office at
2/8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, hereby represented by M
e
Laurent Schummer, lawyer, residing in
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 14 December 2006; and
27000
(2) KIZ, GmbH SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN BAUTRÄGER, a limited liability company governed by the laws of
Germany, registered in the Commercial Register of Hanau under HRB 90145 and having its registered office at Hegelstraße
8, D-63628 Bad Soden-Salmünster, hereby represented by M
e
Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue
of a power of attorney given on 15 December 2006;
(hereafter jointly the «Shareholders»)
Said proxies, signed ne varietur by the representative of the appearing parties and by the undersigned notary will remain
attached to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders are all the shareholders of HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III S.à r.l., a Société à re-
sponsabilité limitée, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, with a share capital of forty-seven thousand five hundred euro (EUR 47,500.-) divided into one thousand
nine hundred (1,900) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, incorporated on 22 May 2000
pursuant to a deed of M
e
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 693 of 26 September 2006 and registered with the Register
of Commerce and Companies of Luxembourg, Section B, under number 76.006 (the «Company»). The articles of incor-
poration of the Company have been last amended pursuant to a deed of M
e
Henri Hellinckx, notaire de residence à
Mersch on 7 December 2006, which has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1 To create two classes of shares, the Class A Shares and the class B shares, to convert the one thousand seven
hundred ten (1,710) shares having a value of twenty-five euro (EUR 25.-) each held by HEPP III LUXEMBOURG MASTER
S.à r.l. into one thousand seven hundred ten (1,710) Class A Shares having a value of twenty-five euro (EUR 25.-), and to
convert the one hundred ninety (190) shares having a value of twenty-five euro (EUR 25.-) each held by KIZ, GmbH
SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN BAUTRÄGER, into one hundred ninety (190) Class B Shares having a value of twenty-
five euro (EUR 25.-).
2 To fully restate the articles of incorporation of the Company, which restatement, next to reflecting the above changes
to the issued capital, shall consist inter alia in adopting the corporate name KH INVESTMENTS S.à r.l. and in adopting
the following corporate object:
« Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings, mainly in Bulgaria, Hungary and Rumania, as well as the administration, development and management of
such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of which the Company
is a member such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or
form.
The Company may also use its funds to directly or indirectly invest in real estate, in intellectual property rights or any
other movable or immovable assets in any kind or form. The Company may directly or indirectly acquire, develop, operate,
refurbish, let, market and sell portfolios of pre-leased consumer markets and/or do-it-yourself markets, as well as ware-
house and/or logistics assets, mainly across Bulgaria, Hungary and Romania (individually «Property» and collectively
«Properties»).
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.»
3 To acknowledge the resignation of Mr. Gordon Black as manager of the Company, to grant full discharge to Mr.
Gordon Black for the fulfillment of his duties as manager, to set at four (4) the number of the new managers of the
Company, to appoint Mr. Sansal Ozdemir and Mrs. Renata Miazga as Class A Managers as well as Mr. Norbert Kittler
and Mr. André Muth as new Class B Managers of the Company, and to determine the duration of their mandate.
have requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to create two classes of shares, the Class A Shares and the Class B Shares, to convert the
one thousand seven hundred ten (1,710) shares having a value of twenty-five euro (EUR 25.-) each held by HEPP III
LUXEMBOURG MASTER S.à r.l. into one thousand seven hundred ten (1,710) Class A Shares having a value of twenty-
five euro (EUR 25.-), and to convert the one hundred ninety (190) shares having a value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each held by KIZ GmbH Schlüsselfertiges Bauen Bauträger into one hundred ninety (190) Class B Shares having a value
of twenty-five euro (EUR 25.-).
27001
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved that the articles of association of the Company shall be entirely restated so as to read from
now on as follows:
«Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established by the current shareholders a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the
«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on
commercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company is composed of two shareholders, owners of all the shares. The Company may however at any time be
composed of one single shareholder or more than two shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders or such
lower number of shareholders as specified in Article 6 of these Articles of Incorporation, notably as a result of the transfer
of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of KH INVESTMENTS S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a
resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s) or of the Board of Managers.
In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social
developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily
transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings, mainly in Bulgaria, Hungary and Rumania, as well as the administration, development and management of
such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of which the Company
is a member such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or
form.
The Company may also use its funds to directly or indirectly invest in real estate, in intellectual property rights or any
other movable or immovable assets in any kind or form. The Company may directly or indirectly acquire, develop, operate,
refurbish, let, market and sell portfolios of pre-leased consumer markets and/or do-it-yourself markets, as well as ware-
house and/or logistics assets, mainly across Hungary, Romania and Bulgaria (individually a «Property» and collectively the
«Properties»).
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders
adopted with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at forty-seven thousand five hundred euro (EUR
47,500.-) divided into one thousand seven hundred ten (1,710) class A shares (the «Class A Shares»), with a par value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each, and one hundred ninety (190) class B shares (the «Class B Shares»), with a par value
of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in the Articles of Incorporation,
shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by applicable laws. The
shareholders and the Company may in addition enter into any shareholders' agreement.
27002
Each share entitles its owner to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit
acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general
meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its Class A Shares or its Class B Shares when the Company is composed
of a single shareholder. Without prejudice to any more stringent provisions in these Articles of Incorporation or any
shareholders' agreement as may from time to time be entered into between the Company and the shareholders, the
Class A Shares and the Class B Shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed
of several shareholders. Notwithstanding any more stringent provisions in these Articles of Incorporation or any share-
holders' agreement as may from time to time be entered into between the Company and the shareholders, the Class A
Shares and the Class B Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting
of shareholders representing at least three quarters of the capital.
Additional terms and conditions may be agreed in writing by the shareholders in relation to the transfer of shares.
Transfers shall be made in compliance with any such additional terms and conditions and with these Articles of Incorpo-
ration. The Company is entitled to refuse to register any transfer of shares unless transferred in accordance with these
Articles of Incorporation or in accordance with any agreement relating to the transfer of shares to which the Company
is a party.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private agreement. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
If at any one time, the Company holds directly or indirectly more than three (3) real estate properties, the Company's
shares shall not be held by more than thirty (30) shareholders. In such case, the shares issued by the Company shall not
be held by any individuals, nor by any entity which is not a non-transparent corporation (Körperschaft) pursuant to
German tax law and which has one or more individuals as its members or owners.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the single shareholder or by unanimous vote of the shareholders.
Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Manager(s), Board of managers, Statutory auditors
Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers which,
if their number is three and more, shall form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and who
need not be shareholders themselves (the «Manager(s)»).
The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting by unanimous vote, which
will determine their number, for a limited or unlimited period, and they will hold office until their successors are elected.
They are re-eligible, but they may be removed at any time, with cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders' meeting by unanimous vote.
The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Manager(s) and one or
several Class B Manager(s).
Art. 10. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members, and, in the case
several Class A and Class B Managers have been appointed, from a list of Managers proposed by the holder(s) of Class
A Shares, a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager him/herself and who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in his
absence the Board of Managers may appoint another Manager from the list referred to under paragraph one above (if
several Class A and Class B Managers have been appointed) and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Each Manager may call a meeting of the Board of Managers by written notice delivered to the other Managers at the
latest eleven (11) days before the date of the meeting if the meeting takes place in person or seven (7) days before the
date of the meeting if the meeting takes place using any means of telecommunication, or as otherwise agreed. If at the
time appointed for the meeting there is not a quorum, there will be another meeting of the Board of Managers in seven
(7) days, in the same venue (or by the same means of telecommunication) at the same time and with the same agenda
and that meeting will be considered valid if at least one Manager is present. Any written convening notice shall specify
the time and place of the meeting or the means of telecommunication to be used as well as the agenda and the nature of
the business to be transacted. The written notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each
27003
Manager. No separate written notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Managers.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
As stated above, one or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar
means of telecommunication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
Every meeting of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers
may from time to time determine. In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence
or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A Manager and one Class
B Manager. Decisions will be taken by a simple majority of the votes of the Managers present or represented at such
meeting, unless otherwise provided in these Articles of Incorporation.
In case of a tie, the Chairman of the Board of Managers has a casting vote.
The following major business related decisions require the unanimous consent of the Board of Managers:
(i) any material deviation from a strategic business plan or an annual business plan;
(ii) any investment proposal;
(iii) the selection of any service provider by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries for the exercise
of due diligence work or any other business or company related work (e.g. legal or tax advice);
(iv) the purchase by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries of any real estate assets or any real estate
owning legal entity;
(v) the annual business plan, being understood that, as long as the annual business plan has not been approved by the
Board of Managers, the annual business plan of the preceding financial year remains in place with its budget adjusted by
the then current inflation rate;
(vi) any change to the corporate structure of any of the Company's direct or indirect subsidiaries including changes in
the respective share capital;
(vii) any creation of, sale, pledge or other disposal of shares in the Company's direct or indirect subsidiaries, or
liquidation of the Company's direct or indirect subsidiaries; and
(viii) the adoption of or changes to the articles of association of any of the Company's direct or indirect subsidiaries.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of each meeting shall be prepared by a Manager
nominated by the Chairman of the Board of Mangers and distributed to the other Manager(s) participating in the meeting
for approval and signature. Each Manager may apply for amendments to be made to the text of minutes if the minutes in
his/her opinion do not reflect the content of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in case there
is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful
for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation
to the single shareholder or the general meeting of shareholders or to the Board Committee are in the competence of
the Manager(s) or of the Board of Managers.
Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies, or
entrust determined permanent or temporary functions to committees, persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
27004
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature of any
single Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been
delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.
However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one or
several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A
Manager and one Class B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.
Art. 16. Board Committee. The Manager(s) or the Board of Managers shall create a board committee (the «Board
Committee») composed of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
The Board Committee appoints among its members the Class A Manager as chairman (the «Committee Chairman»).
It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board Committee him/herself and who will be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board Committee.
The Board Committee shall be responsible for approving (i) any material deviation from standard lease terms, (ii) the
entering into, amending, prepaying or terminating any third party finance or shareholder loan, (iii) any payment of dividends
or any other distribution of profits or cash flow by the Company's direct or indirect subsidiaries, (iv) any change to the
number of board members or the appointment of new board members of any of the direct or indirect subsidiaries of the
Company, (v) any sale or disposal of any real estate asset or portfolio of real estate - either by asset or share deal type
of transaction - or any other material fixed asset by the Company or any of its direct or indirect subsidiaries, (vi) the
entering into major contracts not falling into the competence of the Board of Managers by the Company or any of its
direct or indirect subsidiaries, (vii) a lawsuit by the Company, as the case may be, or the filing of any petition for the
commencement of an insolvency proceeding for the Company, as the case may be, and/or (viii) such other matters as
determined by any shareholders' agreement as may from time to time be entered into between the Company and the
shareholders and, on the basis thereof, delegated to the Board Committee by the Board of Managers.
The Board Committee shall decide by way of unanimous approval on the measures outlined in sections (i) and (ii) and
(iv) above. In case of a tie in relation to the vote on other matters than those referred to under (i) and (ii) and (iv) above,
the Committee Chairman has a casting vote.
Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders themselves.
The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may
be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as
the case may be, by a resolution of the shareholders' meeting.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 18. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the
powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th,
1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be
taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by the
Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation
to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and
mail it to the Company.
Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in
compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more
subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a shareholder.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manager
(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company
represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Manager(s), to the Board of Managers or to the Board Committee by
law or the Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of
the Company.
27005
Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25
shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice
convening the meeting on 31 March at 2:00 p.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 21. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose
adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority
rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a unanimous decision of the shareholders.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation and/or any shareholders' agreement
as may from time to time be entered into between the Company and the shareholders, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
The following decisions to be taken by the general meeting of shareholders require unanimous decision:
(i) any change to the number of Managers of the Company or their scope of representation;
(ii) any creation of or pledge of shares in, or liquidation of the Company;
(iii) any business decisions to be taken at the level of the subsidiaries of the Company which are not covered by their
respective business purpose and which are not to be taken by the Board of Managers or the Board Committee; and
(iv) other than any increase or reduction of capital pursuant to Article 7, any change to the corporate structure of the
Company.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the by the Chairman or by any Manager.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January in every year and ends on the
last day of December.
Art. 23. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s)
or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account,
in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 24. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to
the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits as well as any carried forward profits, free reserves or share premium will be disposed of. It may decide to allocate
the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following
financial year or to distribute it to the shareholders as dividend, pari passu and pro rata to the shareholders' participation
in the Company's share capital.
Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on
dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fix the amount (in line with the provisions of this clause 24) and the
date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision
of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation,
unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.»
27006
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved:
(i) to acknowledge the resignation of Mr. Gordon Black from his mandate as manager of the Company with effect as
of the date of the present deed and to grant full discharge to the resigning manager for the performance of his duties as
far as legally possible and to decide again on the said discharge at the time the general meeting of the Company's share-
holders will approve the annual accounts as at 31 December 2007;
(ii) to set at four (4) the number of the new managers of the Company;
(iii) to appoint the following two (2) persons as new Class A Managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Sansal Ozdemir, Finance Director, born in Cankaya, Turkey, on 31 March 1973, with professional address at 180,
rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg; and
- Mrs Renata Miazga, Finance Manager, born in Zagan, Poland on 9 July 1973, with professional address at 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg;
(iv) to appoint the following two (2) persons as new Class B Managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Norbert Kittler, Engineer, born in Mainaschaff, Germany on 18 November 1950, residing at Burgstraße 13, Bad
Soden-Salmünster, D-63628 Germany; and
- Mr André Muth, Marketing Director, born in Bad Soden on 11 February 1963, with professional address at Kantstraße
13, Bad Soden-Salmünster, D-63628 Germany.
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at two thousand two hundred euro.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
Sind erschienen:
(3) HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit
Sitz in 2/8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B-108.984, vertreten durch M
e
Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund
einer Vollmacht, gegeben am 14. Dezember 2006; und
(4) KIZ, GmbH SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN BAUTRÄGER, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen
Rechts, mit Sitz in Hegelstraße 8, D-63628 Bad Soden-Salmünster, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts
Hanau unter HRB 90145, vertreten durch M
e
Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer
Vollmacht, gegeben am 15. Dezember 2006,
(hiernach gemeinschaftlich die «Gesellschafter»)
Die obengenannten Vollmachten, ne varietur unterzeichnet von den erschienenen Personen und dem amtierenden
Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Gesellschafter sind die alleinigen Gesellschafter der HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III S.à r.l., einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Sitz in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, und einem Stammkapital in Höhe von siebenundvierzigtausendfünfhundert Euro (EUR
47.500,-), eingeteilt in eintausendneunhundert (1.900) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig
Euro (EUR 25,-), gegründet am 22. Mai 2000 gemäß einer Urkunde des Notars Joseph Elvinger, Notar, wohnhaft in
Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
693 vom 26. September 2006, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B-76.006 (die «Gesellschaft»). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde des Notars Henri
Hellinckx, wohnhaft in Mersch, vom 7. Dezember 2006, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
veröffentlicht worden ist.
Die erschienenen Parteien, die bestätigen, vollständig über die Beschlüsse informiert zu sein, die aufgrund folgender
Tagesordnung zu treffen sind:
<i>Tagesordnungi>
1 Schaffung zweier Kategorien von Geschäftsanteilen, der Geschäftsanteile der Kategorie A und der Geschäftsanteile
der Kategorie B, Umwandlung der eintausendsiebenhundertzehn (1.710) Geschäftsanteile in einem Nennwert von jeweils
27007
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), die von der HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l. gehalten werden, in eintausend-
siebenhundertzehn (1.710) Geschäftsanteile der Kategorie A in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-), und Umwandlung der einhundertneunzig (190) Geschäftsanteile in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig
Euro (EUR 25,-), die von der KIZ GmbH Schlüsselfertiges Bauen Bauträger gehalten werden, in einhundertneunzig (190)
Geschäftsanteile der Kategorie B in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
2 Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, die neben den oben erwähnten Änderungen bezüglich des
Stammkapitals der Gesellschaft unter anderem in der Annahme der Firma KH INVESTMENTS S.à r.l. und in der Annahme
des folgenden Gesellschaftszwecks besteht:
« Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in
luxemburgischen und / oder ausländischen Unternehmen, bevorzugt in Bulgarien, Ungarn und Rumänien, sowie die Ver-
waltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung
gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.
Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere
bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren. Die Gesellschaft kann unmittelbar oder
mittelbar Portfolios vorvermieteter Verbraucher- und/oder Baumärkte sowie Lager- und/oder Logistikanlagen, vorzugs-
weise in Bulgarien, Ungarn und Rumänien, erwerben, Instand setzen, verwalten, modernisieren, vermieten, vermarkten
und verkaufen (einzeln eine «Immobilie» und gemeinsam «Immobilien»).
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-
scheine ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-
führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.»
3 Annahme des Rücktritts von Herrn Gordon Black als Geschäftsführer der Gesellschaft, Gewährung der Entlastung
an Herrn Gordon Black für seine Amtsausübung als Geschäftsführer, Festlegung der Anzahl der neuen Geschäftsführer
auf vier (4), Ernennung von Herrn Sansal Ozdemir und Frau Renata Miazga zu Geschäftsführern der Kategorie A, Ernen-
nung von Herrn Norbert Kittler und Herrn André Muth zu Geschäftsführern der Kategorie B, sowie Bestimmung der
Dauer ihres Mandats.
Haben den unterzeichneten Notar dazu aufgefordert folgende Beschlüsse aufzunehmen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschlossen die Schaffung zweier Kategorien von Geschäftsanteilen, der Geschäftsanteile der Ka-
tegorie A und der Geschäftsanteile der Kategorie B, sowie die Umwandlung der eintausendsiebenhundertzehn (1.710)
Geschäftsanteile in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), die von der HEPP III LUXEMBOURG
MASTER S.à r.l. gehalten werden, in eintausendsiebenhundertzehn (1.710) Geschäftsanteile der Kategorie A in einem
Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), und die Umwandlung der einhundertneunzig (190) Geschäftsan-
teile in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), die von der KIZ GmbH Schlüsselfertiges Bauen
Bauträger gehalten werden, in einhundertneunzig (190) Geschäftsanteile der Kategorie B in einem Nennwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Zweiter Beschluss
Die Gesellschafter beschlossen die vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, die nunmehr folgenden
Wortlaut annimmt:
«Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit durch die jetzigen Gesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschaftsver-
trag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).
Die Gesellschaft zählt ursprünglich zwei Gesellschafter, Eigentümer aller Geschäftsanteile. Die Gesellschaft kann jedoch
jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Geschäftsanteilen oder der Ausgabe neuer Geschäftsanteile, aus
einen Alleingesellschafter beziehungsweise mehr als zwei Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter
vorbehaltlich restriktiverer Bestimmungen in Artikel 6 des vorliegenden Gesellschaftsvertrags nicht überschreiten darf.
Der Name der Gesellschaft ist KH INVESTMENTS S.à r.l.
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Ge-
schäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.
Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in
anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.
Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-
scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
27008
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vo-
rübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.
Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in
luxemburgischen und / oder ausländischen Unternehmen, bevorzugt in Bulgarien, Ungarn und Rumänien, sowie die Ver-
waltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung
gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.
Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere
bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren. Die Gesellschaft kann unmittelbar oder
mittelbar Portfolios vorvermieteter Verbraucher- und/oder Baumärkte sowie Lager- und/oder Logistikanlagen, vorzugs-
weise in Bulgarien, Ungarn und Rumänien, erwerben, Instand setzen, verwalten, modernisieren, vermieten, vermarkten
und verkaufen (einzeln eine «Immobilie» und gemeinsam «Immobilien»).
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-
scheine ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-
führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafter-versammlung, die gemäß den
Bestimmungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrags hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst
werden.
Kapitel II. Kapital, Geschäftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf siebenundvierzigtausendfünfhundert Euro (EUR 47.500,-)
festgesetzt, eingeteilt in eintausendsiebenhundertzehn (1.710) Geschäftsanteile der Kategorie A (die «A-Geschäftsantei-
le») mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und einhundertneunzig (190) Geschäftsanteile der
Kategorie B (die «B-Geschäftsanteile») mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll einge-
zahlt.
Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelder,
die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Aufgeld-
kontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von
realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die gesetzliche
Rücklage verwendet werden.
Art. 6. Geschäftsanteile. Mit jedem Geschäftsanteil jeder in vorliegendem Gesellschaftsvertrag definierten Kategorie
sind, vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags oder anwendbarer Gesetze, die gleichen
Rechte und Pflichten verbunden. Die Gesellschafter und die Gesellschaft können ebenfalls Konsortialverträge abschließen.
Jeder Gesellschaftsanteil verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum
eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.
Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen
gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die A-Geschäftsanteile und die B-Geschäftsanteile frei übertrag-
bar. Unbeschadet restriktiverer Bestimmungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder eines von Zeit zu Zeit
zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft abgeschlossenen Konsortialvertrages sind die A-Geschäftsanteile und
die B-Geschäftsanteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar, wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter zählt. In
diesem Fall dürfen die die A-Geschäftsanteile und die B-Geschäftsanteile unbeschadet restriktiverer Bestimmungen des
vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder eines von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft abge-
schlossenen Konsortialvertrages lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterver-
sammlung, bei der drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.
Den Gesellschaftern steht es frei, bezüglich der Übertragung der Geschäftsanteile, zusätzliche Bedingungen und Mo-
dalitäten zu vereinbaren. Übertragungen erfolgen in Übereinstimmung mit solchen zusätzlichen Bedingungen und Moda-
litäten sowie mit dem Gesellschaftsvertrag. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Registrierung der Übertragung von
Gesellschaftsanteilen zu verweigern, solange eine solche Übertragung nicht in Übereinstimmung mit vorliegender Satzung
oder Vereinbarungen erfolgt, zu denen die Gesellschaft eine Vertragspartei ist.
27009
Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen
Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.
Hält die Gesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt mehr als drei (3) Immobilien, so darf die Gesellschaft nicht mehr als
dreißig (30) Gesellschafter zählen. In diesem Fall dürfen die von der Gesellschaft ausgegebenen Geschäftsanteile weder
von natürlichen Personen gehalten werden noch von juristischen Personen, bei denen es sich gemäß deutschem Steuer-
recht um nicht-transparente Körperschaften handelt und deren Gesellschafter oder Eigentümer eine natürliche Person
ist oder mehrere natürlichen Personen sind.
Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrmals
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung er-
höht oder herabgesetzt werden.
Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird weder durch die
Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das den Alleingesell-
schafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.
Kapitel III. Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare
Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern, die,
falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden werden (der «Geschäftsführungsrat»)
und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).
Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafter-versammlung, die deren
Anzahl festlegt, für eine begrenzte oder unbegrenzte Dauer einstimmig gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/
ihrer Nachfolger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesell-
schafters oder der Gesellschafterversammlung einstimmig mit oder ohne Grund abberufen werden.
Der Alleingesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung können beschließen, einen oder mehrere
Geschäftsführer der Kategorie A sowie einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.
Art. 10. Geschäftsführungsrat. Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte, (und, falls
mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und mehrere Geschäftsführer der Kategorie B bestellt worden sind, unter den
von den A-Gesellschaftern in Form einer Liste vorgeschlagenen Geschäftsführern), einen Vorsitzenden (der «Vorsitzen-
de»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht, und
welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der Gesellschafterversammlungen ver-
antwortlich ist.
Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen
den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt
sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer (der von der in Absatz eins weiter oben
erwähnten Liste auszuwählen ist, falls Geschäftsführer der Kategorien A und B bestellt worden sind) beziehungsweise
während einer Gesellschafterversammlung eine andere Person zum zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.
Jeder Geschäftsführer kann eine Geschäftsführungsratssitzung durch schriftlichen Einberufungsbescheid anberaumen,
der allen Geschäftsführern mindestens elf (11) Tage bei Abhaltung in persönlicher Anwesenheit und bei Abhaltung unter
Hinzuziehung von Telekommunikationsmitteln spätestens sieben (7) Tage vor dem Sitzungstag zugestellt wird, sofern
nichts anderes vereinbart wurde. Ist die Sitzung zum Zeitpunkt ihrer Anberaumung nicht beschlussfähig, findet sieben (7)
Tage später eine weitere Sitzung am selben Sitzungsort (beziehungsweise unter Verwendung derselben Telekommuni-
kationsmittel) zur selben Zeit und mit derselben Tagesordnung statt; diese Sitzung gilt als wirksam abgehalten, wenn
mindestens ein Geschäftsführer anwesend ist (beziehungsweise an ihr teilnimmt). Diese schriftlichen Einberufungsbe-
scheide enthalten Angaben über Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden
Geschäfte. Liegt die schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schrift-
liche Einberufung verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem
früheren Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen
Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.
Wie bereits erwähnt können ein Mitglied oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrats per Telefonkonferenz
oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnlichen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren
teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer per-
sönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichwertig.
Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungsrat
von Zeit zu Zeit festlegen kann. In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter
Beschluss gültig und rechtsverbindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsrats-
27010
sitzung gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem
Inhalt festgehalten werden, wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben
wird.
Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer
anwesend oder vertreten sind. Sind Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B bestellt worden, so ist der
Geschäftsführungsrat nur dann beschlussfähig, wenn gleichzeitig mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer
sowie mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten
sind. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen vorliegenden Gesellschaftsvertrags werden die Beschlüsse des Ge-
schäftsführungsrats mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Die nachfolgend genannten wesentlichen Geschäftsaktivitäten bedürfen zu ihrer Vornahme der einstimmigen Be-
schlussfassung des Geschäftsführungsrats;
(i) wesentliche Abweichungen von einem strategischen Geschäftsplan oder einem Jahresgeschäftsplan;
(ii) jegliche Anlagevorschläge;
(iii) die Auswahl und Beauftragung der Dienstleister durch die Gesellschaft oder durch eines ihrer unmittelbaren oder
mittelbaren Beteiligungsunternehmen für durchzuführende Due-Diligence-Aufgaben, sonstige Geschäftsaktivitäten oder
die Gesellschaft betreffende Aufgaben (beispielsweise Rechts- und Steuerberatung);
(iv) der Erwerb von Grundstücken oder Grundbesitz haltenden Unternehmen durch die Gesellschaft oder eines ihrer
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsunternehmen;
(v) der Jahresgeschäftsplan; solange der Jahresgeschäftsplan nicht beschlossen wurde bleibt der Jahresgeschäftsplan des
vorangehenden Geschäftsjahres in Kraft, und zwar mit einer Anpassung von dessen Budget um die jeweils aktuelle Infla-
tionsrate;
(vi) jegliche Änderung der gesellschaftsrechtlichen Struktur der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsunterneh-
men der Gesellschaft einschließlich der Änderungen des jeweiligen Stammkapitals;
(vii) jede Ausgabe, Veräußerung oder Verpfändung von Anteilen an unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsun-
ternehmen der Gesellschaft sowie die Abwicklung eines der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsunternehmen
der Gesellschaft; sowie
(viii) der Abschluss oder die Abänderung von Gesellschaftsverträgen eines unmittelbaren oder mittelbaren Beteili-
gungsunternehmens der Gesellschaft.
Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vorbereitet durch einen vom Vor-
sitzenden des Geschäftsführungsrats bestimmten Geschäftsführer und dem/den übrigen an der Sitzung teilnehmenden
Geschäftsführer(n) zwecks Annahme und Unterzeichnung unterbreitet. Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann
Änderungen am Text des Protokolls verlangen, wenn es der Meinung ist, dass dieses nicht den Inhalt der Sitzung wider-
spiegelt. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorgelegt
werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitgliedern
unterzeichnet.
Art. 12. Befugnisse des/der Geschäftsführer(s) oder des Geschäftsführungsrates. Jeder Geschäftsführer einzeln oder
der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, um jedwede
Handlung vorzunehmen, welche für die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche
Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesell-
schafter, der Gesellschafterversammlung oder dem Geschäftsführungsausschuss vorbehalten sind, liegen in der Zustän-
digkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats.
Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne Be-
fugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an Ausschüsse oder andere von ihnen
auserwählte Personen oder Vertreter übertragen.
Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner
anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Ge-
schäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/sind
oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma ist/
sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Ge-
sellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma, mit
der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder in anderer Weise Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Ver-
bindung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.
Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft
der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsführungsrat
zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber abstimmen,
27011
und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleingesellschafter
oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.
Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift jedes Ge-
schäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die
Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Geschäfts-
führungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen
Befugnisse gilt.
Sind jedoch ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie
B durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt worden, so wird die Gesellschaft gegenüber
Dritten durch die gemeinschaftlichen Unterschriften eines Geschäftsführers der Kategorie A sowie eines Geschäftsführers
der Kategorie B oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche
Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies je-
doch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.
Art. 16. Geschäftsführungsausschuss. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat werden einen Ausschuss
(der «Geschäftsführungsausschuss») bestehend aus einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäfts-
führer der Kategorie B bilden.
Der Geschäftsführungsausschuss bestellt aus der Mitte seiner Mitglieder den Geschäftsführer der Kategorie A zum
Vorsitzenden (der «Geschäftsführungsausschussvorsitzende»). Der Geschäftsführungsausschuss kann ebenfalls einen Sek-
retär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des
Geschäftsführungsausschusses verantwortlich ist.
Dem Geschäftsführungsausschuss obliegen folgende Verantwortungsbereiche: (i) jede wesentliche Abweichung von
standardisierten Vermietungsbedingungen, (ii) Abschluss, Änderung, vorfällige Rückführung oder Beendigung jeglicher
Drittfinanzierung oder jeglichen Gesellschafterdarlehens, (iii) sämtliche Ausschüttungen von Dividenden oder sonstige
Auszahlung von Gewinnen oder Cash-flow durch ein unmittelbares oder mittelbares Beteiligungsunternehmen der Ge-
sellschaft, (iv) jegliche Änderung in der Anzahl der Geschäftsführer oder die Bestellung neuer Geschäftsführer eines
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsunternehmens der Gesellschaft, (v) jegliche Veräußerung oder Verfügung über
ein Grundstück, ein Grundstücksportfolio - sei dies im Wege des Grundstücks- oder Anteilsgeschäftes - oder einen
sonstigen wesentlichen unbeweglichen Vermögensgegenstand durch ein unmittelbares oder mittelbares Beteiligungsun-
ternehmen der Gesellschaft, (vi) der Abschluss eines jeglichen wesentlichen Vertrags durch die Gesellschaft oder eines
ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsunternehmen, der nicht in den Kompetenzbereich des Geschäftsfüh-
rungsrates fällt, (vii) gegebenenfalls, jegliche Einleitung eines Rechtsstreits durch die Gesellschaft, oder gegebenenfalls,
jegliche Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft, und/oder (viii)
jeder andere in einem von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern zusammen mit der Gesellschaft abgeschlossenen
Konsortialvertrag bestimmte Gegenstand, mit dem der Geschäftsführungsausschuss aufgrund eines solchen Konsortial-
vertrags durch den Geschäftsführungsrat beauftragt worden ist.
Der Geschäftsführungsausschuss beschließt einstimmig über die unter den weiter oben aufgelisteten Ziffern (i), (ii) und
(iv) vorgesehenen Maßnahmen. Bei Stimmengleichheit während der Abstimmung über Gegenstände, die nicht unter den
obigen Ziffern (i), (ii) und (iv) vorgesehen sind, besitzt der Geschäftsführungsausschussvorsitzende eine ausschlaggebende
Stimme.
Art. 17. Kommissare. Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,
muss einem oder mehreren Kommissaren anvertraut werden, welche keine Gesellschafter sein müssen.
Die Kommissare werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, von der Gesellschafterver-
sammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben
im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können jedoch
jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesellschafter-
versammlung abberufen werden.
Kapitel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 18. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die Befug-
nisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes vom 10.
August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.
Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die
Geschäftsführer oder den Geschäftsführungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden.
Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zugang
des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.
Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberufung
gemäß luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführungsrat, oder subsidiär,
durch den Kommissar, oder subsidiär dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesellschaftskapitals
27012
darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäß Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, beinhaltet Zeitpunkt
und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte.
Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,
dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.
Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Tele-
gramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.
Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,
wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats liegen, dies erforderlich machen.
Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversamm-
lung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.
Mit Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den Ge-
schäftsführern, dem Geschäftsführungsrat beziehungsweise dem Geschäftsführungsausschuss vorbehalten sind, ist sie mit
den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, um jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung
durchzuführen oder zu genehmigen.
Art. 20. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten ist, wenn
die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am 31. März um 14 Uhr am Gesellschaftssitz oder an
jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag
abgehalten.
Art. 21. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages und
jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Gesetzes, der
mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit unterliegt, muss
durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter getroffen werden.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes, des vorliegenden Gesellschaftsvertrages oder von Zeit zu
Zeit zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern abgeschlossenen Konsortialverträgen werden alle übrigen Be-
schlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Folgende von der Gesellschafterversammlung zu treffenden Beschlüsse erfordern Einstimmigkeit:
(i) die Abänderung der Anzahl der Geschäftsführer der Gesellschaft oder deren Vertretungsbefugnisse;
(ii) jede Ausgabe oder Verpfändung von Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft oder deren Abwicklung;
(iii) Maßnahmen auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft, die über deren jeweiligen Unterneh-
mensgegenstand hinausgehen und die nicht in den Kompetenzbereich des Geschäftsführungsrates oder des Geschäfts-
führungsausschusses fallen; und
(iv) jegliche Veränderung der Gesellschaftsstruktur (zusätzlich zu Kapitalerhöhungen beziehungsweise -herabsetzungen
gemäß Artikel 7).
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht werden
können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschäftsführer unterzeichnet.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und verteilung von gewinnen
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am
einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.
Art. 23. Bilanz. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder der
Geschäftsführungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesell-
schafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.
Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz
einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen vor
dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.
Art. 24. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn abgezogen
und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr,
wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.
Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jähr-
lichen Reingewinns, der auf neue Rechnung übertragenen Gewinne, der ausschüttfähigen Reserven oder Emissionsauf-
gelder. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen, ihn auf neue
27013
Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter gleichrangig und im Verhältnis zu deren
Beteiligung am Gesellschaftskapital auszuschütten.
Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen
eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen (in Übereinstim-
mung mit vorliegendem Artikel 24) den Betrag und das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 25. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft durch
einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der gemäß denselben
Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschafts-
vertrags vorgesehen sind.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder
juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegen.
Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird
das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet, und zwar im Verhältnis
zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile.
Kapitel VII. Anwendbares recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ge-
regelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschlossen:
(i) den Rücktritt von Herrn Gordon Black als Geschäftsführer der Gesellschaft Mit Wirkung zum Datum der vorlie-
genden Urkunde anzunehmen und dem ausscheidenden Geschäftsführer, insoweit gesetzlich möglich, vollständige
Entlastung für dessen Amtsausübung zu erteilen und abermals über diese Entlastung zu dem Zeitpunkt zu entscheiden,
an dem die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 annimmt,
(ii) die Anzahl der neuen Geschäftsführer auf vier (4) festzulegen,
(iii) folgende zwei (2) Personen für einen unbestimmten Zeitraum zu Geschäftsführern der Kategorie A zu bestellen:
- Herrn Sansal Ozdemir, Finanzdirektor, geboren in Cankaya, Turkei, am 31. März 1973, geschäftsansässig in 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxemburg; und
- Frau Renata Miazga, Finanzmanager, geboren in Zagan, Polen, am 9. Juli 1973, geschäftsansässig in 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxemburg;
(iv) folgende zwei (2) Personen für einen unbestimmten Zeitraum zu Geschäftsführern der Kategorie B zu bestellen:
- Herrn Norbert Kittler, Diplom-Ingenieur, geboren in Mainaschaff am 18. November 1950, wohnhaft in Burgstraße
13, Bad Soden-Salmünster, D-63628, Deutschland; und
- Herrn André Muth, Marketingdirektor, geboren in Bad Soden am 11. Februar 1963, wohnhaft in Burgstraße 13, Bad
Soden-Salmünster, D-63628, Deutschland.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf zweitausendzweihundert Euro geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der
eingangs genannten erschienenen Personen, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung,
gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen
Textes, wird der englische Text vorwiegen.
Und nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit uns, dem Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: L. Schummer, M. Müller, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 20. Dezember 2006, Band 909, Blatt 49, Feld 10. — Erhalten 12 euros.
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beles, den 23. Januar 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007026029/239/802.
(070020526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
27014
Outlet Mall Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 706.600,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 95.977.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société adoptées le 30 octobre 2006i>
L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Rodney Bysh de son poste d'administrateur de la Société
et de le remplacer, pour une durée indéterminée, par Monsieur John Sutherland, résidant au 9, rue Principale, L-6990
Hostert (Grand-Duché de Luxembourg), à compter du 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2007026352/267/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03625. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070020630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
KD DeLux, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 105.156.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 19 janvier 2007i>
Sont nommés administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale ordinaire des
actionnaires en 2008
M. Matjaž Gantar avec adresse professionnelle à Celovška 206, SI 1000 Ljubljana, Slovenia
M. Gregor Sluga avec adresse professionnelle à Celovška 206, SI 1000 Ljubljana, Slovenia
M. Hugues Chambon avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale
M. Rudolf Kömen avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale
M. Johan Lindberg avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale.
Est nommé réviseur indépendant pour la même période:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400 route d'Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007026405/6275/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00868. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070020092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Gero Investments Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 901.950,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.006.
II résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre ELQ INVESTORS LTD., une société de
droit anglais, avec siège social à Peterborough Court, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, UK, MATLINPATTERSON
GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II L.P., un limited partnership de droit des Iles Cayman, avec siège
social Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
et MATLINPATTERSON GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS II L.P., un limited partnership du Delaware, avec siège
social à 520 Madison Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, USA, prenant effet le 7 septembre 2006, que onze mille
neuf cent cinquante-six (11.956) parts sociales de la société à responsabilité limitée GERO INVESTMENTS LUX S.à r.l.,
avec siège social à Luxembourg, sont détenues depuis le 7 septembre 2006 par ELQ INVESTORS LTD., huit mille huit
cent quatre (8.804) parts sociales de la société à responsabilité limitée GERO INVESTMENTS LUX S.à r.l., avec siège
social à Luxembourg, sont détenues depuis le 7 septembre 2006 par MATLINPATTERSON GLOBAL OPPORTUNITIES
PARTNERS II L.P., préqualifïée et que trois mille cent cinquante-deux (3.152) parts sociales de la société à responsabilité
27015
limitée GERO INVESTMENTS LUX S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, sont détenues depuis le 7 septembre 2006
par MATLINPATTERSON GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II L.P. préqualifiée.
Il en résulte que ELQ INVESTORS LTD détient 11.956 parts sociales dans GERO INVESTMENTS LUX S.àr.l., MP
MATLINPATTERSON GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS II L.P. détient à présent 8.804 parts sociales dans GERO
INVESTMENTS LUX S.à r.l. et MP MATLINPATTERSON GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II L.P.
détient à présent 3.152 parts sociales dans GERO INVESTMENTS LUX S.àr.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2007.
HALSEY Sàrl
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007026418/6762/32.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11227. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070020007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Frank Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4845 Rodange, 90, rue Joseph Philippart.
R.C.S. Luxembourg B 99.740.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FRANK LUX S.àr.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007026431/1113/13.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03698. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060139631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Venere S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 60.187.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 septembre 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'Assemblée décide d'élire pour
la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2006/2007 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
M.
Maurizio Mantero, employé, demeurant à via A. Volta 74, 1-22100 Como (Italie), président;
Mme
Carine Agostini, employée privée, demeurant à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, admi-
nistrateur;
M.
Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, admi-
nistrateur.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri L -1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007026524/24/28.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00555. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070020299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
27016
Avery Dennison Finance Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4801 Pétange, Zone Industrielle PED.
R.C.S. Luxembourg B 85.017.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 32683 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007026427/211/11.
(060135099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.
IonBond S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 7.165.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 101.100.
Par résolution signée en date du 18 décembre 2006, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Marco Marchetti, avec adresse au 16, Baarerstrasse, CH-6300 Zug, Suisse,
de son mandat de gérant avec effet immédiat.
- Nomination de la nomination de Madame Cornelia Gehrig, avec adresse professionnelle au 211, Industriestrasse,
CH-4603 Olten, Suisse, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- Nomination de la nomination de Monsieur Jakob Förschner, demeurant au 59, Cadogan Square, SW1X 0HZ Londres,
Royaume-Uni, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007026525/581/19.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00639. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070020228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Immobilière Rivoli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 59.473.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 septembre 2005,
que:
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Olivier Henz, Administrateur et décide de nommer pour une période
de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement au 25, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007026526/802/19.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00590. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070020242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
27017
Werasp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 59.779.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraodinaire du 12 janvier 2007, que l'Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Onelio
Piccinelli en qualité d'Administrateur et décide de nommer, pour un terme de -1 - (un) an, les Administrateurs suivants:
Davide Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil
d'Administration;
Jean-Philippe Fiorucci, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
Mirko La Rocca, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat ainsi conféré aux Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.
Le mandat du Commissaire expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un)
an, FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg en tant que Commissaire.
Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice
clôturé au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2007.
Le conseil d'administration
J.-P. Fiorucci / M. La Rocca
Référence de publication: 2007026550/43/28.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08188. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Brambachlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 499.300,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 111.270.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 5 janvier 2007i>
L'associé unique de BRAMBACHLUX S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Michel van Krimpen, en tant que Gérant B, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Hille-Paul Schut, avec adresse professionnel au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, gérant B de
la société avec effet immédiat;
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
H.-P. Schut.
Référence de publication: 2007026530/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11267. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Brookbylux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 9.075.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 109.757.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 5 janvier 2007i>
L'associé unique de BROOKBYLUX S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Michel van Krimpen, en tant que Gérant B, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Hille-Paul Schut, avec adresse professionnel au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, gérant B de
la société avec effet immédiat;
27018
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
H.-P. Schut.
Référence de publication: 2007026531/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11209. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Métal Lux Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 102.151.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 16 janvier 2007, que l'Assemblée a pris, entre autres,
la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Onelio
Piccinelli en qualité d'Administrateur et décide de nommer, pour un terme de -1 - (un) an, les Administrateurs suivants:
Davide Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil
d'Administration;
Jean-Philippe Fiorucci, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
Mirko La Rocca, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat ainsi conféré aux Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l'exercice clôturé au 30 juin 2007.
Le mandat du Commissaire expirant à la date de ce jour, TAssemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un)
an, FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg en tant que Commissaire.
Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice
clôturé au 30 juin 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2007.
Le Conseil d'Administration
J.-P. Fiorucci / M. La Rocca
Référence de publication: 2007026551/43/28.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08177. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
BF Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 89.458.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 4 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 4 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté à compter du 21
décembre 2006 Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant profes-
sionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Jean Lambert, administrateur, demeurant
professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant
à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire qui se tiendra en l'année 2010.
Pour extrait sincère et conforme
BF GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007026532/1022/20.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08609. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
27019
Gaston Administration S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 61.371.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GASTON
ADMINISTRATION S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en date du 4 dé-
cembre 2006 que:
- M. Peter Milne et Mlle Dawn Shand, demeurant professionnellement tous deux 15-17, avenue Gaston Diderich à
L-1420 Luxembourg, ont été nommés administrateurs de la société, à compter du 1
er
décembre 2006 et jusqu'à l'As-
semblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2008, en remplacement de M. Karl Horsburgh et M. Frederick Thomas,
démissionnaires.
-La société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, 9, Pelican Drive, Road
Town (Tortola), a été nommée Commissaire aux comptes de la société, à compter du 1
er
décembre 2006 et jusqu'à
l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2008, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT S.C., démission-
naire.
<i>Administrateurs:i>
Simon Baker
Peter Milne
Dawn Shand
<i>Commissaire aux comptes:i>
CARDINAL TRUSTEES LIMITED, 9, Pelican Drive, Road Town (Tortola), Iles Vierges Britanniques
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007028951/4642/30.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00937. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Albanel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 20.230.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 4 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 4 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté à compter du 21
décembre 2006 Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant profes-
sionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Jean Lambert, administrateur, demeurant
professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant
à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire qui se tiendra en l'année 2010.
Pour extrait sincère et conforme
ALBANEL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007026548/1022/20.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08655. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
27020
M.G. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 116.065.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 janvier 2007, que l'Assemblée a pris, entre autres,
la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1 -
(un) an, les Administrateurs suivants:
Davide Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil
d'Administration;
Jean-Philippe Fiorucci, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
Stefano De Meo, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat ainsi conféré aux Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l'exercice clôturé au 30 juin 2007.
Le mandat du Commissaire expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer, pour un terme d'1(un) an,
FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg en tant que Commissaire.
Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice
clôturé au 30 juin 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2007.
Le Conseil d'Administration
J.-P. Fiorucci / S. De Meo
Référence de publication: 2007026553/43/28.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08153. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Luxtrid S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 105.705.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 27 novembre 2006i>
1. Elections statutaires:
- L'Assemblée accepte la démission de Madame Marie-Claude Dumez de son mandat de Commissaire aux Comptes
et décide de nommer en remplacement Madame Letizia Licata demeurant 35, rue de Lattre de Tassigny à F-57280 Mai-
zieres-Les-Metz pour une période qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l'exercice se clôturant le 30 juin 2007.
- L'Assemblée décide du renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Gérard Lusatti, Monsieur Rudy
Paridaens et de Monsieur Nicolas Leonard pour une période qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Or-
dinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 30 juin 2007.
N. Leonard
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007026554/1707/20.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01220. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070020302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
27021
Batichimie et Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 37.813.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 15 janvier 2007i>
Les associés prennent les décisions suivantes:
Décident de révoquer M. Meis Johny de sa fonction de gérant ne faisant plus partie de la société depuis plusieurs années
et ayant démissionné de son poste de gérant.
Décident de révoquer M. Mike Waldbillig de sa fonction de gérant ne faisant plus partie de la société depuis plusieurs
années et ayant démissionné de son poste de gérant.
Décident de révoquer M. André Jentgen de sa fonction de gérant ne faisant plus partie de la société depuis plusieurs
années et ayant démissionné de son poste de gérant.
Décident de confirmer le pouvoir de signature seul pour/ M. Claude Wagner gérant unique de la société.
<i>Pour compte BATICHIMIE ET CIE SECS
i>C. Wagner
Référence de publication: 2007026555/3290/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB01024. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070020295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Benimo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 123.990.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte d'Assemblée Générale Extraordinaire, reçu par Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettel-
bruck, en date du 23 janvier 2007, enregistré à Diekirch le 24 janvier 2007, vol. 620, fol. 40, case 4,
de la société anonyme BENIMO S.A., avec siège social à L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville,
constituée suivant acte reçu par Maître Pierre Probst, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 28 novembre
2006,
que la gérance est modifiée comme suit:
1. Démission de l'administrateur-délégué Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, né à Bastogne (Belgique) le
26 juin 1951, demeurant à B-6800 Libramont, 11, rue de l'Ancienne Gare.
2. Est nommée en son remplacement la société à responsabilité limitée SOFIROM Sàrl, ayant son siège social à L-8832
Rombach, 18, route de Bigonville, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 104.680.
Ettelbruck, le 2 février 2007.
Pour copie conforme
P. Probst
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007028988/4917/22.
(070020303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
SKMCom Two S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 105.599.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 25 février 2005i>
Il résulte de la résolution prise par l'associé unique de la Société le 25 février 2005 que Monsieur Christopher K. Reilly,
homme d'affaires, né au Connecticut, le 13 mai 1962, et ayant son adresse professionnelle au 262 Harbor Drive, Stamford,
CT 06902, U.S.A., est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée et ce à partir du 25 février 2005.
27022
J. Dercksen
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007026558/7178/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA10032. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
SKMCom One S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 105.598.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 25 février 2005i>
Il résulte de la résolution prise par l'associé unique de la Société le 25 février 2005 que Monsieur Christopher K. Reilly,
homme d'affaires, né au Connecticut, le 13 mai 1962, et ayant son adresse professionnelle au 262 Harbor Drive, Stamford,
CT 06902, U.S.A., est nommé gérant de la Société pour une durée indeterminée et ce à partir du 25 février 2005.
J. Dercksen
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007026559/7178/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA10030. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
General CGF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 86.933.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 13 septembre
2006, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 5
avril 2006 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1-
(un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Gianfranco Natali, demeurant à Via Castelletto, 8, CH-6924 Sorengo, Administrateur et Président du
Conseil d'Administration;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12,
avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12,
avenue de la Liberté, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
L'Assemblée décide de ne pas renommer la société FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxem-
bourg, en qualité de Commissaire et décide de nommer pour un terme de -1- (un) la société ALTER AUDIT Sàrl, 10,
avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2007.
27023
GENERAL CGF S.A.
D. Murari / M. La Rocca
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2007026560/43/34.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08163. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Virgilate Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 35.402.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 27 décembre
2006 que:
- l'Assemblée a accepté les démissions de leur poste d'administrateurs de F.VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A,
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. and HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.
- l'Assemblée a accepté la démission de son poste de commissaire aux comptes de F. VAN LANSCHOT TRUST
COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
- l'Assemblée nomme aux postes d'administrateurs:
* Mr. Serge Cammaert, avec adresse professionnelle au 287, route d'Arlon L-1150 Luxembourg
* FIDELIN S.A., dont le siège social est situé au 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
* Mr Dominique Ransquin, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
- l'Assemblée nomme au poste de commissaire aux comptes:
* BANQUE DELEN LUXEMBOURG, dont le siège social est situé au 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de la prochaine Assemblée Gé-
nérale.
Pour extrait certifié conforme
Signature
Référence de publication: 2007026564/660/26.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10444. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070020692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.
Clarisse LB Lotion G.m.b.H., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-5692 Elvange, 13, Cité Ovenacker.
R.C.S. Luxembourg B 61.750.
CLOTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 7 décembre 2006, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Jean-Paul Meyers en son rapport
oral, le liquidateur, Maître Patrice Hoffman, avocat à la Cour et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close
pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée CLARISSE LB LOTION, GmbH.,
et a mis les frais à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 8 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007030277/1035/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02995. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
27024
Albanel S.A.
Alluxbau s.à r.l.
Alpha Factoring S.à r.l.
Avantgarde Holding S.A.
Avery Dennison Finance Luxembourg S.à.r.l.
Batichimie et Cie
Benimo S.A.
BF Group S.A.
Brambachlux S.à r.l.
Brookbylux S.à r.l.
Clarisse LB Lotion G.m.b.H.
Cresos S.A.
Desch-Tennis Bouneweg a. s. b. l.
Desch-Tennis Union Lëtzebuerg a. s. b. l.
DIAC Holdings Sàrl
Ets. MARCO FELTEN, orthopédie technique
Frank Lux S.àr.l.
Fuentesanco SA
Gaston Administration S.A.
General CGF S.A.
Gero Investments Lux S.àr.l.
HCEPP Luxembourg Czech Republic III S.àr.l.
Immo Avenir S.A.
Immobilière Rivoli S.A.
IonBond S. à r.l.
KD DeLux
KH Investments S.à r.l.
Luxtrid S.A.
Memory Corp S.A.
Memory Corp. Services S.à.r.l.
Métal Lux Financière S.A.
M.G. Holding S.A.
Naia
Outlet Mall Holding Sàrl
Outlet Mall Sub Group Holding No. 1 S.à r.l.
Panalpina Luxembourg S.A.
Property Development Corporation
SKMCom One S.àr.l.
SKMCom Two S.àr.l.
Venere S.A.
Virgilate Holding S.A.
Vrway Marketing & Service S.A.
Werasp S.A.
Wycombe Investment Holdings S.A.