logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 153

9 février 2007

SOMMAIRE

A Alpha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7303

Alex-Turi-Bar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7318

Alliance Santé Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . .

7313

Alliance Santé S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7313

Anciens Etablissements Holcher et Con-

zemius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7313

Anglo American Exploration Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7319

Anglo American Investments 1 S.A.  . . . . .

7319

Bader 6 Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

7313

Bara S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7309

Barwa 1 Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

7313

Batavia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7298

BGZ International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

7308

BGZ Zerlegeservice S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

7308

Blizzard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7298

Blue Sky Software S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

7308

Cad Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7298

Café Caramba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7337

Café Chez Negrita S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

7319

C.L.T.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7312

C.M.P. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7302

Cofra Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

7313

Customer View S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7300

De Gourmang S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7299

De Pefferkär S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7299

Editions Culturelles et Professionnelles

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7308

Elly's Jeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7300

Espace Ariane Immobilière S.A.  . . . . . . . .

7309

Eurowatt S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7330

Field Point I-A RE 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

7337

Field Point I-A RE 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

7331

Finanzgesellschaft A.G. "1ster Januar

1988"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7300

Gestiolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7318

Green World S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7318

GT-Sat International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

7299

Henneaux Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

7310

Hines Holdings Luxembourg 2 S.à r.l.  . . .

7330

HRD Luxembourg I A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7312

HRD Luxembourg II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7312

HRD Luxembourg II A  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7311

H & S Promotions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7300

Ikourde Financial Services S.A. . . . . . . . . . .

7311

Immo Garant S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7302

Insight S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7313

I.P.F.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7312

Isles S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7311

I.T.I. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7319

J.P. Morgan Capital Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7309

JP Morgan Partners Latin America Lu-

xembourg II, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7310

J.P. Morgan Partners (PTC) Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7310

Karvina Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

7301

Karvina Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

7301

Le Clos des Grands Crus S.à r.l.  . . . . . . . . .

7344

Maran International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

7302

Medipub S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7298

Merith International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

7299

Mini-Market S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7330

Mode Paris London  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7317

Mode Paris London  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7318

Montecaro Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

7301

Montecaro Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

7301

Napoli Calcio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7318

Pan Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7317

Seraya S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7310

Space S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7302

Sumba Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7343

Vimo & Partner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7343

Wintergames Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

7314

Z-Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7311

7297

Batavia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8147 Bridel, 23, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 55.218.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

M. Kaskas
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007005175/666/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04876. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Medipub S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 94.203.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005181/7075/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00715. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Cad Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 92.788.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005185/7075/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00724. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Blizzard S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 39.243.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007005653/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01679. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

7298

GT-Sat International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1518 Luxembourg, 2, rue Comte Joseph de Ferraris.

R.C.S. Luxembourg B 104.210.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

<i>GT-SAT INTERNATIONAL S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007005191/5470/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05248. - Reçu 95 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

De Gourmang S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4062 Esch-sur-Alzette, 69, rue Clair-Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 93.898.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19

décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2006.

FISOGEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2007005195/1218/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02861. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

De Pefferkär S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3340 Huncherange, 49, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 77.277.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19

décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2006.

FISOGEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2007005197/1218/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02855. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Merith International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.044.

Le bilan au 31 mai 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007005659/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01690. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

7299

Finanzgesellschaft A.G. "1ster Januar 1988", Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 27.242.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Signatures.

Référence de publication: 2007005269/763/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04130. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

H &amp; S Promotions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 3, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 75.291.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 15 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005270/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03933. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060137726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Elly's Jeans, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6477 Echternach, 61, rue des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 96.084.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 15 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005271/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03915. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060137731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Customer View S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 82.239.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007005655/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01681. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

7300

Karvina Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 90.096.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007005657/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01686. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Montecaro Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 44.266.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007005660/1023/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01692. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Montecaro Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 44.266.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007005661/1023/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01694. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Karvina Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 90.096.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007005656/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01683. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

7301

Immo Garant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4840 Rodange, 249, rue du Clopp.

R.C.S. Luxembourg B 83.285.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005665/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04143. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

C.M.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 32, rue du Fort Dumoulin.

R.C.S. Luxembourg B 83.814.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005667/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04154. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Space S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 62.986.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007005669/762/11.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04169. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Maran International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 65.557.

Le bilan au 31 mars 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2006.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d'entreprise
Signatures

Référence de publication: 2007005542/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04385. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

7302

A Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.593.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, a limited liability company organised under the laws of England, having its registered

office at 45, Pall Mall, London, SW1Y 5JG, United Kingdom, registered at the Companies House under the number 3047123,

represented by Mr. Patrick Santer, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 4th December,

2006 (such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of

association of a limited liability company A ALPHA, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is hereby established as
follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name A ALPHA, S.à r.l. (the «Company») is

hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be
governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and
carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, preferred equity certifi-

cates, debentures or other instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies

or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the
Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indi-

rectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its re-
gistered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into

five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law (in particular in the case

of pledges), a transfer of shares to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy
five percent of the Company's capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-

7303

termined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any

meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by
conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by
another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form
the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions,
shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive powers

to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the managers.

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he

owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference call,
video conference or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to hear one another
and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the
case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their

address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting.
If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the resolutions.
The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or
subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolutions may
be passed at any time without prior notice.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However,

decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the shareholders (ii) repre-
senting at least three quarters of the issued share capital.

Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year. The first

accounting year starts on the date of incorporation of the Company and ends on 31st December 2007.

Art. 12. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may

be, the board of managers.

The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 shareholders be subject to the supervision of

a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders. Such statutory
auditor in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without cause.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

7304

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but

do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers
and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1
and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party and the notary, the appearing

party have subscribed and entirely paid-up in cash the five hundred (500) shares against a contribution in cash of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) has been given to

the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of

its formation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
2. The following persons are named managers (each with sole signature power) of the Company for an undetermined

period of time subject to the articles of association of the Company:

Name, Title, address, Date of birth, Place of birth
Gérard Becquer, Chartered accountant, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Briey, France
Graeme Stening, General Counsel, 135, MacDonald Road, The Gables, Lightwater,United Kingdom, 10 May 1964, Chert-

sey, England

Cedric B. Stebel, Company administrator, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 5 May 1977, Virton, Belgium

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2007.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le quatre décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG,

Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 3047123,

représenté par Monsieur Patrick Santer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du

4 décembre 2006 (cette procuration sera enregistrée avec le présent acte).

La partie comparante agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

à responsabilité limitée A ALPHA, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à respon-

sabilité limitée sous la dénomination de A ALPHA, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les
dispositions légales afférentes.

Art. 2. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen,
de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et

7305

autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de
succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de cer-

tificats préférentiels d'actions, de certificats de créance ou d'autres instruments.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à toute société

ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société,
prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement
et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou

indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des Statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de

gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou les cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de
ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoi-
rement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun
effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise.
Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de
gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou
réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi (notamment en

case de gages), les cessions de parts sociales entre vifs à des non associés sont soumises à l'agrément d'au moins soixante-
quinze pour cent du capital social de la Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à
toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les uns avec les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une
réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion
tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant
au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions
des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis sous
la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d'un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations
relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par la signature
individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gérants.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme mandataires,

ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales

qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les

sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées y compris des assemblées

7306

tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication permettant à tous
les associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble. La participation à une
assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de la
Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c'est permis par la loi le cas échéant) représente l'entièreté des
associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d'une telle
assemblée. Si l'entièreté du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans

le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent
effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la
satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans con-
vocation préalable.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant

plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être
prises (i) qu'à la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 11. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année. La

première année sociale commence à la date de constitution et se termine au 31 décembre 2007.

Art. 12. Chaque année, à la fin de l'exercice social, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes

annuels.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 membres, les opérations de la Société feront l'objet d'une surveillance

par un commissaire aux comptes. Dans un tel cas le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale des membres.
Un commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale des membres avec ou
sans motifs.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant

ou le cas échéant le conseil de gérance , duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 paragraphe (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante et le notaire, celle-ci a souscrit et intégralement

libéré les cinq cents (500) parts sociales contre un apport en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été donnée au notaire

instrumentant.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa constitution

sont évaluées à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et aussitôt, l'associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

7307

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (chacun avec pouvoir de signature individuel) de la Société pour une

durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

Nom, Titre, Adresse, Date de naissance, Lieu de naissance
Gérard Becquer, Comptable, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 29 avril 1956, Briey, France
Graeme Stening, Conseiller, 135, MacDonald Road, The Gables, Lightwater, Royaume Uni 10 mai 1964, Chertsey, An-

gleterre

Cedric B. Stebel, Administrateur de sociétér, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 5 mai 1977, Virton, Belgique

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure,

la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Santer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 décembre 2006, vol. 440, fol. 12, case 3. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 8 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007007182/242/189.
(060140054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

BGZ International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BGZ Zerlegeservice S.à r.l.).

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 77.798.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 décembre 2006.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007007290/202/11.
(060140361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

ECP, Editions Culturelles et Professionnelles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 92.081.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2007005276/1427/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04526. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Blue Sky Software S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 83.755.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

7308

BLUE SKY SOFTWARE S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007005285/6264/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05302. - Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Bara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 48.149.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005329/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02734. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060137990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Espace Ariane Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 64.053.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 novembre 2005

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Jacques Lanoix demeurant au 19, rue du Vieux Lavoir, F-91190 Saint Aubin,

France, de Monsieur Eric Pouillevet, demeurant au 10, rue Walter, 76000 Rouen, France, et de Monsieur Philippe Renaud,
demeurant au 147ter, boulevard de la Reine, 78000 Versailles, France, sont reconduits pour une nouvelle période de six ans
jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social au 26,

rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2011.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>ESPACE ARIANE IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007005465/795/23.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06426. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060137984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

J.P. Morgan Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 78.868.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005330/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00731. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060137992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

7309

J.P. Morgan Partners (PTC) Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 92.478.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005331/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00740. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060137995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Seraya S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 56.549.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>SERAYA S.A.
MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

Référence de publication: 2007005809/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04658. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Henneaux Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 50.446.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005334/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04577. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

JP Morgan Partners Latin America Luxembourg II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 94.191.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005335/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00746. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060137999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

7310

Z-Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 80.856.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005341/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03861. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Ikourde Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 94.728.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005737/1369/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04382. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Isles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 76.351.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005361/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03879. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

HRD Luxembourg II A, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 91.730.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 16 novembre 2006

L'associé unique de HRD LUXEMBOURG II A, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Michel Van Krimpen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, avec adresse professionnelle au 20, rue de la poste,

L-2346 Luxembourg, gérant de la société avec effet immédiat;

M. Torbick
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007005365/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06585. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

7311

C.L.T.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4750 Pétange, 2, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 92.030.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

19 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007005405/1330/11.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04013. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

I.P.F.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 58.510.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

19 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007005406/1330/11.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04008. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

HRD Luxembourg I A, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 91.728.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 16 novembre 2006

L'associé unique de HRD LUXEMBOURG I A, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Michel Van Krimpen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, avec adresse professionnelle au 20, rue de la poste,

L-2346 Luxembourg, gérant de la société avec effet immédiat;

M. Torbick
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007005366/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06588. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

HRD Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 91.731.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 16 novembre 2006

L'associé unique de HRD LUXEMBOURG II, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Michel Van Krimpen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, avec adresse professionnelle au 20 rue de la poste,

L-2346 Luxembourg, gérant de la société avec effet immédiat.

M. Torbick
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007005367/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06586. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

7312

Cofra Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 98.221.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

Référence de publication: 2007005957/200/9.
(060138963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Alliance Santé Europe S.A., Société Anonyme,

(anc. Alliance Santé S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.279.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 45237 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 19 décembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007005949/211/9.
(060138838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Insight S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 41, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 98.673.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007005945/3642/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05550. - Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Anciens Etablissements Holcher et Conzemius, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4843 Rodange, 55, rue Fontaine d'Olière.

R.C.S. Luxembourg B 88.982.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ANCIENS ETABLISSEMENTS HOLCHER ET CONZEMIUS
Signature

Référence de publication: 2007005946/1113/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03701. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Barwa 1 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Bader 6 Luxembourg S.à r.l.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 119.010.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

7313

Senningerberg, le 15 décembre 2006.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007005952/202/11.
(060138921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Wintergames Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 120.197.

In the year two thousand and six, on the twenty fourth day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of WINTERGAMES HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»),

a société à responsabilité limitée having its registered office at 14a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, incorporated by deed
of the undersigned notary, on 16th October 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by M 

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary M 

e

 Miriam SchinnerRechtsanwältin, residing in Luxembourg and scrutineer M 

e

 Kathrin

Krämer, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to
these minutes to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all five hundred (500) shares in issue were represented at the general meeting of

the shareholders of the Company and declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly
constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

2. The agenda of the meeting was as follows:
1. Change the denomination of the issued share capital of the Company from euro to USD; convert the current issued

share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) into fifteen thousand seven hundred and fifty four point
thirty eight USD (USD 15,754.38) at the exchange rate of 1.26035, amendment of the nominal value from twenty five euro
(EUR 25.-) per share to fifty USD (USD 50.-), transfer of balance to the premium so that the issued share capital is set at
fifteen thousand seven hundred and fifty USD (15,750.-) represented by three hundred and fifteen (315) shares of a nominal
value of fifty USD (USD 50.-),

2. Immediate increase of the issued share capital of the Company from fifteen thousand seven hundred and fifty USD (USD

15,750.-) to two million five hundred five thousand five hundred USD (USD 2,505,500.-) by the issue of forty nine thousand
seven hundred and ninety five (49,795) shares with a nominal value and subscription price of USD 50.- each against the
contribution in kind of forty nine thousand seven hundred and ninety five (49,795) shares in WINTERGAMES, S.à r.l. with
a nominal value of USD 50.- each, subscription to the new shares by the subscribers set out hereafter, approval of the
valuation of the contribution in kind, consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.

Subscriber

Number of

subscribed

Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND A) L.P., CR16977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,420

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND B) L.P., CR16976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,208

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND C) L.P., CR16974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

829

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND D) L.P., CR16975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,721

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND E) L.P., CR16973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND F) L.P., MC17174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND G) L.P., MC17293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND A) L.P., CR17290 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,366

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND B) L.P., CR17255 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,450

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND C) L.P., CR17258 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND D) L.P., CR17256 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,352

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND F) L.P., MC17294 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND G) L.P., MC17295 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

398

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND A) L.P., MC17794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,068

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND B) L.P., MC17792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,071

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND C) L.P., MC17795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,644

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND D) L.P., MC17793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,217

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND G) L.P., MC17791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,902

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49,795

7314

After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital to two million five hundred five thousand five hundred USD

(USD 2,505,500.-) by the issue of forty nine thousand seven hundred and ninety five (49,795) shares with a nominal value of
USD 50.- each pursuant to the subscriptions and payments received by the Company as set out hereafter.

The newly issued shares are subscribed for as set out in the agenda to the meeting.
Each of the subscribers set out hereabove represented by M 

e

 Toinon Hoss, aforementioned, acting pursuant to proxies

dated 24th October 2006, subscribed and fully paid the number of shares subscribed set out against its name by the con-
tribution in kind as referred to herebelow.

The new shares subscribed for by the subscribers were fully paid for by way of contribution in kind of forty nine thousand

seven hundred and ninety five (49,795) shares of a nominal value of fifty USD (USD 50.-) each of WINTERGAMES, S.à r.l.,
a société à responsabilité limitée organised under Luxembourg law, having its registered office at 14a, rue des Bains, L-1212-
Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under the number B120095.

The above contribution in kind has been the subject of a report of the board of directors of the Company dated 24th

October 2006.

The report contains the following conclusion:
«In view of the above the Board of Managers believes that the value of the contribution in kind being 49,795 shares in

WINTERGAMES, S.à r.l., being all but 315 shares in issue in such company amounts to USD 2,489,750.-.»

Pursuant to the above the general meeting resolved to approve the evaluation of at least two million four hundred and

eighty nine thousand seven hundred and fifty USD (USD 2,489,750.-) of the contributions in kind. Proof of the transfer of
above contributions in kind to the Company was submitted to the undersigned notary.

Consequential to the preceding increase of the share capital of the Company and issue of Shares as aforementioned, the

meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company to be read as follows:

«The  issued  share  capital  of  the  Company  is  set  at  two  million  five  hundred  five  thousand  five  hundred  USD  (USD

2,505,500.-) divided into fifty thousand one hundred and ten (50,110) shares with a par value of fifty USD (USD 50.-) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of association. Any available share premium shall be distributable.»

There being no further item on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The contributions described above represent more than 65% of the issued share capital and shares in issue in WINTER-

GAMES, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, the parties therefore refer to the exemption of capital duty
provided by article 4-2 of the law of 29th December, 1971.

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which estimated at five thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the shareholders of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le vingt-quatrième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WINTERGAMES HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»),

une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 14a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, constituée le 16 octobre
2006 par acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été présidée par M 

e

 Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut nommé comme secrétaire M 

e

 Miriam Schinner, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur M

e

 Kathrin Krämer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont repris dans une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée au
présent acte pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.

Il appert de ladite liste de présence que toutes les cinq cent (500) parts sociales émises dans la Société étaient représentées

à la présente assemblée générale et les actionnaires ont déclaré avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de sorte
que l'assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. L'ordre du jour de l'assemblée était comme suit:
1. Changement de la devise d'expression du capital social émis de la Société de Euro en USD; conversion du capital social

émis actuel de douze mille cinq cent euro (EUR 12.500,-) en quinze mille sept cent cinquante quatre USD et trente huit

7315

cents (USD 15.754,38) au taux de change de 1,26035, modification de la valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) par
part sociale à cinquante USD (USD 50,-), transfert du solde à la prime pour que le capital social émis soit fixé à quinze mil
sept cent cinquante USD (EUR 15.750,-), représenté par trois cent quinze (315) parts sociales d'une valeur nominale de
cinquante USD (USD 50,-),

2. Augmentation immédiate du capital social émis de la Société de quinze mille sept cent cinquante USD (USD 15.750,-)

à deux millions cinq cent cinq mille cinq cent USD (USD 2.505.500,-) par l'émission de quarante neuf mille sept cent quatre-
vingts quinze (49.795) parts sociales d'une valeur nominale et d'un prix de souscription de cinquante USD (USD 50,-) chacune
contre apport en nature de quarante neuf mille sept cent quatre vingt quinze (49.795) parts sociales dans WINTERGAMES,
S.à r.l. avec une valeur nominale de cinquante USD (USD 50,-) chacune, souscription des nouvelles parts sociales par les
entités décrites ci-après, approbation de l'évaluation de l'apport en nature, modification subséquente de l'article 5 des statuts
de constitution.

Souscripteurs

Nombre de

parts sociales

souscrites

(1)

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND A) L.P., CR16977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.420

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND B) L.P., CR16976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.208

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND C) L.P., CR16974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

829

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND D) L.P., CR16975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.721

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND E) L.P., CR16973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND F) L.P., MC17174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327

(2)

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND G) L.P., MC17293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393

(3)

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND A) L.P., CR17290 . . . . . . . . . . . .

2.366

(4)

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND B) L.P., CR17255 . . . . . . . . . . . . .

1.450

(5)

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND C) L.P., CR17258 . . . . . . . . . . . .

289

(6)

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND D) L.P., CR17256 . . . . . . . . . . . .

1.352

(7)

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND F) L.P., MC17294 . . . . . . . . . . . .

120

(8)

FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND G) L.P., MC17295 . . . . . . . . . . . .

398

(9)

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND A) L.P., MC17794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.068

(10)

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND B) L.P., MC17792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.071

(11)

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND C) L.P., MC17795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.644

(12)

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND D) L.P., MC17793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.217

(13)

FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND G) L.P., MC17791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.902

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.795

Après délibération, l'assemblée a décidé à l'unanimité ce qui suit:

<i>Résolution unique

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à à deux millions cinq cent cinq mille cinq cent USD (USD 2.505.500,-)

par l'émission de quarante neuf mille sept cent soixante quinze (49.795) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante
USD (USD 50,-) chacune, conformément aux souscriptions et paiements reçu par la Société comme décrits ci-après.

Les nouvelles parts sociales sont souscrites tel que décrit dans l'ordre du jour de l'assemblée.
Chacun des souscripteurs représentés par M 

e

 Toinon Hoss, susmentionnée, qui agit conformément aux procurations

datées du 24 Octobre 2006, a souscrit et entièrement payé le nombre de parts sociales indiqué derrière son nom contre
un apport en nature décrit ci-dessous.

Les nouvelles parts sociales souscrites par les souscripteurs ont été entièrement payées par un apport en nature de

quarante neuf mille sept cent quatre-vingts quinze (49.795) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante USD (USD
50,-) chacune dans WINTERGAMES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 14a, rue des bains, L-1212 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B120095.

Les apports en nature ci-dessus ont fait l'objet d'un rapport du conseil de gérance de la Société daté du 24 Octobre 2006.
Le rapport contient la conclusion suivante:
«Au vu de ce qui précède, le Conseil de Gérance estime que la valeur de l'apport en nature de 49.795 parts sociales dans

WINTERGAMES, S.à r.l., représentant toutes les parts sociales, sauf 315 parts sociales en émission dans cette société s'élève
à USD 2.489.750,-.»

Sur base de ce qui précède, l'assemblée générale a décidé d'approuver l'évaluation des apports en nature à au moins deux

millions quatre cent quatre vingt neuf sept cent cinquante USD. Preuve du transfert des apports en nature à la Société a été
soumise au notaire instrument.

7316

Suite à l'augmentation du capital social de la Société et à l'émission des parts sociales comme susmentionné, l'assemblée

a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions cinq cent cinq mille cinq cent USD (USD 2.505.500,-) divisé

en cinquante mille cent dix (50.110) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de cinquante USD (USD 50,-). Le
capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée dans la manière requise
pour modifier les présents Statuts.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les apports décrits ci-dessus représentant plus de 65% du capital social et des parts sociales émises dans WINTERGAMES,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, les parties comparantes se réfèrent à l'exemption du droit
d'apport prévue à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971.

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son augmen-

tation du capital social et sont estimés à cinq mille Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes, ce

procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, la version anglaise faisant foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, M. Schinner, K. Kramer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, vol. 155S, fol. 86, case 8. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Poue expédition comforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007005971/211/301.
(060138541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Pan Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 70.872.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

<i>Pour PAN INVESTMENTS S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007005928/1021/13.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03322. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Mode Paris London, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9250 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.759.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005371/718/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04705. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

7317

Napoli Calcio S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 75.817.

Le soussigné Maître Pierre Thielen, agissant en sa qualité de liquidateur, nommé en date du 1 

er

 octobre 2004, démissionne

avec effet immédiat de ses fonctions de liquidateur.

Luxembourg, le 15 octobre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005372/278/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01256. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Mode Paris London, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9250 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.759.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005374/718/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04708. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Gestiolux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 31.032.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007005752/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03923. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Green World S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 80, route Principale.

R.C.S. Luxembourg B 42.348.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005384/718/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04710. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Alex-Turi-Bar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 20, rue Joseph Junck.

R.C.S. Luxembourg B 38.040.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

7318

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007005386/718/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04711. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Café Chez Negrita S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 24, route de Peppange.

R.C.S. Luxembourg B 101.118.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

LUXCOMPTA S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007005389/679/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03760. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

I.T.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 27.211.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007005760/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03919. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Anglo American Exploration Luxembourg, Société Anonyme,

(anc. Anglo American Investments 1 S.A.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 107.157.

In the year two thousand and six, on the fourth of December.
Before Us, M 

e

 Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the company established in the Grand Duchy of

Luxembourg under the denomination of ANGLO AMERICAN INVESTMENTS 1 S.A., having its registered office in Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 107,157, incorporated pursuant
to a deed of M 

e

 André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated March 31, 2005, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 793 of August 8, 2005.

The meeting begins at 9.30 a.m., Mrs. Jacqueline Anne McNally, Company Secretary, with professional address at 48, rue

de Bragance, L-1255 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Lynsey Blair, Assistant Company Secretary, with professional

address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Chantai Sales, Company Secretarial Assistant, with professional address at 48, rue

de Bragance, L-1255 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the one thousand (1,000)

shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each representing the total capital of fifty thousand United
States Dollars (USD 50,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced.

7319

The attendance list, signed by the proxy holder of the sole shareholder represented and the members of the bureau, shall

remain attached to the present deed, together with the proxy, to be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company from ANGLO AMERICAN INVESTMENTS 1 S.A. to ANGLO AMERICAN EX-

PLORATION LUXEMBOURG.

2. Cancellation of the authorised capital of the Company.
3. Change of the financial year end of the Company from March 14 to December 31.
4. Resignation of the present directors of the Company and discharge.
5. Resignation of the present statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company and discharge.
6. Transformation of the Company from a public limited company (Société anonyme) into a private limited liability company

(Société à responsabilité limitée) with immediate effect.

7. Total restating of the Company's Articles of Incorporation.
8. Appointment of four directors of the Company.
9. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes,

after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to change the name of the Company from ANGLO AMERICAN INVESTMENTS 1 S.A. to

ANGLO AMERICAN EXPLORATION LUXEMBOURG.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to cancel the authorised capital.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to change the financial year end of the Company from March 14 to December 31 so that

the current financial year which started on March 15, 2006 shall end on December 31, 2006 and that the following financial
year will start on January 1, 2007.

<i>Fourth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present directors Mrs. Gillian Fay Adams, Mr. Alexander Francis Pace-

Bonello, Mrs. Jacqueline Anne McNally and Mr. Arjan Kirthi Singha with immediate effect and, by special vote, gives them
discharge for the execution of their mandates until today.

<i>Fifth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present statutory auditor (commissaire aux comptes) Mrs. Francesca

Heffernan with immediate effect and, by special vote, gives her discharge for the execution of her mandate until today.

<i>Sixth resolution

The General Meeting resolves to transform the Company from a public limited company (Société anonyme) into a private

limited liability company (Société à responsabilité limitée) with immediate effect.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the preceding resolutions the Articles of Incorporation of the Company are totally restated and shall

henceforth have the following wording:

«Title I.- Form - Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. Form. There exists a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which is governed by the

laws pertaining to such an entity (the «Company»), and in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies,
as amended (the «Law»), as well as by the present Articles of Incorporation (the «Articles»).

Art. 2. Name. The Company exists under the name of ANGLO AMERICAN EXPLORATION LUXEMBOURG.

Art. 3. Object.
3.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies,

and  to  manage,  control  and  develop  such  interests.  The  Company  may  in  particular  borrow  funds  from  and  grant  any
assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any rights

7320

ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same by sale,
transfer exchange, license or otherwise.

(c) To borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures

or otherwise except by way of public offer.

(d) To undertake any and all activities in connection with the exploration, the exploitation and the mining of any and all

natural resources.

(e) To provide or procure services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects referred to above

or closely associated therewith.

3.2 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects and

it shall be considered as a fully taxable «Société de Participations Financières» according to applicable law.

3.3 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through

the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg City.
4.2 It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the directors of the Company and

to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of members.

4.3 If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may
be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Com-
pany which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

Art. 5. Duration.
5.1 The Company is established for an unlimited period.
5.2 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the members adopted in the manner required by law

for the amendment of these Articles.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. Capital.
6.1 The Company's issued capital is set at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) represented by one thousand

(1,000) shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.2 As far as permitted by Law, the members may amend these Articles so as to:
(a) Consolidate or subdivide all or any of the shares of the Company into shares of larger or smaller amount than its

existing shares;

(b) Convert any of the shares of the Company into shares of another class or classes and attach thereto any preferential,

qualified, special deferred rights, privileges or conditions; or

(c) Increase or reduce the subscribed capital of the Company.
6.3 As far as permitted by law, the Company may repurchase its shares on the following terms and conditions:
(a) The repurchase price per share shall be determined by the directors of the Company and shall be no less than the par

value of such share;

(b) Any repurchase by the Company of shares shall be done pro rata in respect of all members; and
(c) The repurchase of any shares may only be funded by the Company using reserves available for distributions, as provided

for by Law, or from the proceeds of a new issue made with a view to carry out such repurchase.

Art. 7. Shares.
7.1 Shares may be freely transferred by a sole member to any person.
7.2 If there is more than one member:
(a) The shares are freely transferable among members; and
(b) The shares are transferable to non-members only with the prior approval of the members in a members meeting

representing at least three- quarters of the capital.

7.3 Share certificates may be issued to members in such form and in such denominations as the directors shall determine.
7.4 The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be bound

to recognise any other claim or interest in any such share on the part of any other person.

Title III.- Management

Art. 8. Directors.
8.1 The Company shall be managed by at least two directors appointed by a resolution of the general meeting of members

that sets the term of their office. The directors need not be members.

8.2 The directors may be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest powers with regard to third

parties.

8.3 A director may be dismissed without notice and without reason.

Art. 9. Powers of Directors.
9.1 The directors shall have full power to perform such acts as may be necessary or useful to carrying out the objects of

the Company.

7321

9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members are within

the competence of the directors.

9.3 Subject to Article 9.4, the directors may delegate, for specific tasks, part of their powers to one or more directors or

other officers who need not be a member of the Company and may give authority to such directors or other officers to
sub-delegate.

9.4 The delegation to any director or other officer of powers to carry out the day-to-day management of the Company

is subject to a previous authorisation by unanimous vote at a general meeting of the members.

9.5 The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two directors of the Company

or by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signing power has been validly delegated.

Art. 10. Procedure.
10.1 The directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another director may preside over the meeting.
10.2 The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as they

think fit, provided at all times there is a quorum of at least two directors present in person or by proxy and that a majority
of the directors so present or represented is comprised of directors who are not present in the United Kingdom.

10.3 Resolutions shall require a majority vote. In the case of a tie, the Chairman has a casting vote.
10.4 Resolutions or other actions of the directors at a meeting shall be confirmed in the minutes of such meeting signed

by the Chairman and Secretary of the meeting.

10.5 Any director may participate in any meeting of the directors by telephone or video conference call or by any other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.6 Any action required or permitted to be taken at a meeting of the directors may be taken without a meeting if a

resolution setting forth such action is signed by all directors. Such signatures may appear on a single document or multiple
copies of an identical resolution in any form and shall be filed with the minutes of the proceedings of the directors.

Art. 11. Liability of the Directors.
11.1 Subject to Article 11.3, every director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified by the

Company against, and it shall be the duty of the directors to pay out of the funds of the Company, all damages, charges,
costs, losses and expenses which any such director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason of:

(a) any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such director, officer, servant or agent;
(b) any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 11.3) to which he

may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the
Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the director, officer, servant or agent
would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 11.3;

(c) his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other

company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise
fully indemnified, or

(d) his discharging his duties as such director, officer, servant or agent, including travelling expenses.
11.2 Subject to Article 11.3, no director or other officer, servant or agent of the Company shall be liable to the Company

for any loss or expense incurred by the Company arising from:

(a) the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer, servant or agent or for joining in on any such act,

receipt, neglect or other default; or

(b) the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of directors, or for the insufficiency or deficiency

of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested; or

(c) the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be deposited;

or

(d) any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall

happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

11.3 A director shall not be entitled to the benefits of the indemnity under Article 11.1 or the dispensation under Article

11.2:

(a) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or willful act

or default; or

(b) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these Articles

unless the director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the director and unless the director
notifies the breach to the next general meeting of members.

11.4 Should any part of this Article 11 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which such

Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not invalid or
modified.

Art. 12. Directors' Interests.
12.1 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
manager, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity.

7322

12.2 Any director or officer who is a director, officer or employee of any company, firm or other entity with which the

Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company,
firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.

12.3 Subject to the previous Article, any director who has an interest in a contract or an agreement submitted to the

directors for its approval, and which interest is contrary to the Company's interests, shall be obliged, upon such submission,
to inform the directors accordingly and such information shall be recorded in the minutes of the meeting. Such director may
not deliberate or vote in respect of such contract or agreement but may be counted for the purpose of constituting a quorum.

Art. 13. Disqualification of Directors. The office of director or commissaire shall, ipso facto, be vacated:
(a) if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being in force

for the relief of insolvent debtors; or

(b) if by notice in writing he resigns his office; or
(c) if he is prohibited by the Law from being a director; or
(d) if he ceases to be a director by virtue of the Law or is removed from office pursuant to these Articles.

Title IV.- Decisions of the members

Art. 14. Powers and Voting Rights
14.1 The members have full power to authorise or ratify all acts done by or on behalf of the Company.
14.2 Each member shall have voting rights commensurate to its shareholding.
14.3 Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, facsimile

or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

14.4 In the event that the Company has a single member, such single member shall assume all powers conferred by the

Law to the general meeting of members.

Art. 15. Form, Quorum and Majority.
15.1 Convening notices of all general meetings of members shall be made in compliance with the Law, each director being

entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the members must be called at the request of any member
(s) holding at least ten percent (10%) of the issued capital.

15.2 If all the members are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted

to their consideration, the general meeting of the members may take place without convening notices.

15.3 Every member has the right to vote in person or by proxy, who need not be a member.
15.4 Each share gives the right to one vote.
15.5 Subject to Article 15.6, decisions of members are only validly taken insofar as they are adopted by members owning

more than half of the share capital failing which a second meeting may be convened, by registered letter, at which the decision
may be taken by the majority of votes of the members present.

15.6 Any other action than those provided by Article 15.7 required or permitted to be taken by the members in a general

meeting may be taken without a meeting if a resolution setting forth such action is signed by all the members otherwise
entitled to vote at such meeting if held, save that, where the number of members does not exceed twenty-five and subject
to any other provision of these Articles, such resolution shall be duly adopted if approved by members representing more
than half of the corporate capital or, if that majority is not reached following the first submission of the resolution to the
members, and after a second submission to the members by registered letter, by a majority of the votes cast, regardless of
the portion of capital represented.

15.7 Any amendment to these Articles, or anything that is required by these Articles or the Law to be done in accordance

with the requirements that apply to an amendment of these Articles, shall be only effective if approved by the majority of
members representing three quarters of the issued and outstanding capital.

15.8 If there are two or more classes in issue and the question before the meeting is such as to modify the rights of one

or more of those classes, the quorum and majority requirements set out in these Articles must be satisfied in respect of
each class of share whose rights are being modified.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 16. Accounting Year and Financial Statements.
16.1 The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December

of the same year (the «Financial Year»).

16.2 In respect of each Financial Year, the directors shall prepare Financial Statements which shall include a balance sheet

and profit and loss account of the Company. The Financial Statements shall be drawn up in accordance with the provisions
of the Law. To the Financial Statements shall be annexed or attached reports and documents containing the details required
by the Law.

16.3 The financial statements will be at the disposal of the members at the registered offices of the Company.

Art. 17. Allocation of Profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law.

This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

7323

17.2 The allocation and distribution of the remaining net profits (including any balance brought forward) of the Company

and the balance to be carried forward shall be determined by the general meeting of members upon recommendation of the
directors. This allocation may include the distribution of dividends in any currency or in kind, the issue by the Company of
bonus shares or of subscription rights and the creation or maintenance of reserve funds and provisions.

17.3 Dividends and other distributions shall be paid to members in accordance with their rights and interests and in

proportion to the amount paid up on their shares during any portion or portions of the period in respect of which the
dividend is being paid.

17.4 As far as permitted by law the general meeting of members may decide to pay interim dividends on the basis of

statements of accounts prepared by the directors showing that sufficient funds are available for distribution, it being un-
derstood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by
profits carried forward and distributable reserves, including share premium but decreased by losses carried forward and
sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

Title VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the incapacity or the financial failure of a

member.

18.2 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members which will
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s) or by Law,
the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of
the Company.

18.3 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid

to the sole member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each member
in the Company.

Title VIII.- General provisions

Art. 19. General.
19.1 All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
19.2 These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two

versions, the English version will prevail.»

<i>Eighth resolution

The following are appointed as directors of the Company for an unlimited period of time with effect from today:
a) Mrs. Gillian Fay Adams, Group Human Resources Manager, born in Bexley Heath (UK), on August 2, 1958, with pro-

fessional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

b) Mr. Alexander Francis Pace-Bonello, General Manager, born at Mtarfa (Malta), on February 1, 1957, with professional

address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

c) Mrs. Jacqueline Anne McNally, Company Secretary, born in Ipswich (UK), on February 1, 1968, with professional address

at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

d) Mr. Arjan Kirthi Singha, Financial Controller, born in Singapore, on November 11, 1969, with professional address at

48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are

estimated at two thousand Euros.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 37,878.79 EUR.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 9.45 a.m.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names, civil

status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le quatre décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme établie au Grand-Duché

de Luxembourg sous la dénomination de ANGLO AMERICAN INVESTMENTS 1 S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.157, constituée suivant acte

7324

reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mars 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 793 du 8 août 2005.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Jacqueline Anne McNally, «Company Secretary», avec

adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Lynsey Blair, «Assistant Company Secretary», avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Chantai Sales, «Company Secretarial Assistant», avec adresse professionnelle

au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg. Madame la Présidente expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

d'une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de
cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit.

Ladite liste de présence, portant les signatures de la mandataire de l'actionnaire unique et des membres du bureau, restera

annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités de
l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement du nom de la Société de ANGLO AMERICAN INVESTMENTS 1 S.A. en ANGLO AMERICAN EXPLO-

RATION LUXEMBOURG.

2. Annulation du capital autorisé de la Société.
3. Changement de la fin de l'exercice social de la Société du 14 mars au 31 décembre.
4. Démission des administrateurs actuels de la Société et décharge.
5. Démission du commissaire aux comptes actuel de la Société et décharge.
6. Transformation de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée avec effet immédiat.
7. Refonte complète des statuts de la Société.
8. Nomination de quatre gérants de la Société.
9. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée,

aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer le nom de la Société de ANGLO AMERICAN INVESTMENTS 1 S.A. en ANGLO

AMERICAN EXPLORATION LUXEMBOURG.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'annuler le capital autorisé.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la fin de l'exercice social de la Société du 14 mars au 31 décembre, de sorte que

l'exercice social en cours qui a commencé le 15 mars 2006 finira le 31 décembre 2006 et que l'exercice social suivant
commencera le 1 

er

 janvier 2007.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat des administrateurs actuels Madame Gillian Fay Adams,

Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, Madame Jacqueline Anne McNally et Monsieur Arjan Kirthi Singha et, par vote
spécial, leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat du commissaire aux comptes actuel Madame Francesca

Heffernan et, par vote spécial, lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de transformer la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée avec effet

immédiat.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est procédé à une refonte compète des statuts de la Société lesquels

auront désormais la teneur suivante:

7325

«Titre I 

er

 .- Forme - Nom - Objet - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 . Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la

«Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par
les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Nom. La Société existe sous le nom ANGLO AMERICAN EXPLORATION LUXEMBOURG.

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet de conduire les activités suivantes:
(a) Détenir des participations dans toute entreprise ayant pour objet toute activité, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, et

de gérer, contrôler et développer ces participations. La Société pourra en particulier emprunter des fonds, et fournir assis-
tance, crédits, avances ou garanties aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt ou qui ont une participation dans la
Société.

(b) Acquérir des titres négociables ou non négociables de toute sorte (y compris ceux émis par un gouvernement ou une

autre autorité internationale, nationale ou municipale), brevets, droits d'auteur et toute autre forme de propriété intellec-
tuelle et tout droit qui y est rattaché, que ce soit par contribution, souscription, option, achat ou autre et de l'exploiter par
la vente, l'échange, la licence ou autrement.

(c) Emprunter ou de rassembler des fonds avec ou sans garantie dans toutes devises par l'émission de bons, d'obligations

ou autres, sauf par voie d'offre publique.

(d) Entreprendre toutes activités en relation avec l'exploration, l'exploitation et l'extraction de toutes ressources natu-

relles.

(e) Fournir des services de toute sorte nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet en référence ou d'un objet qui lui

est étroitement associé.

3.2 La Société aura tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet et sera considérée

selon les dispositions applicables «Société de Participations Financières» pleinement imposable.

3.3 Toute activité menée par la Société sera directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire

du siège principal ou de succursales à Luxembourg ou ailleurs, qui pourront être ouvertes au public.

Art. 4. Siège Social.
4.1 Le siège social est établi dans la municipalité de Luxembourg-Ville.
4.2 Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple résolution des gérants et dans une

autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés.

4.3 Lorsque des événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront, ou seront
imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l'étranger. Une telle mesure temporaire n'aura, cependant,
aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société luxembourgeoise.

Art. 5. Durée.
5.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
5.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision des associés prise dans la forme prescrite par la Loi

pour la modification des présents statuts.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital.
6.1 La Société a un capital émis de cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-) représenté par mille (1.000) parts

sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune, toutes entièrement souscrites et
intégralement libérées.

6.2 Pour autant que permis par la Loi, les associés peuvent modifier les statuts de manière à:
(a) Consolider ou subdiviser toutes les parts sociales de la Société en parts sociales d'un montant supérieur ou inférieur

que les parts sociales existantes;

(b) Convertir des parts sociales de la Société en parts sociales d'une autre classe ou d'autres classes et y attacher des

droits préférentiels, conditionnels ou différés, des privilèges ou des conditions; ou

(c) Augmenter ou réduire le capital souscrit de la Société.
6.3 Pour autant que permis par la Loi, la Société est autorisée à racheter ses parts sociales dans les termes et conditions

suivants:

(a) Le prix de rachat par part sociale sera déterminé par les gérants et ne sera pas inférieur à la valeur nominale de telle

part sociale;

(b) Tout rachat par la Société de parts sociales sera effectué au prorata par rapport à tous les associés; et
(c) Le rachat de parts sociales pourra uniquement être financé par la Société en utilisant des réserves disponibles pour

distribution, comme prévu par la Loi, ou par les produits d'une nouvelle émission effectuée en vue de réaliser ce rachat.

Art. 7. Parts sociales.
7.1 Les parts sociales sont librement transmissibles par l'associé unique à des tiers.
7.2 En cas de pluralité d'associés:
(a) Les parts sont librement transmissibles entre associés; et

7326

(b)  La  cession  à  des  non-associés  n'est  possible  qu'avec  le  consentement  préalable  des  associés  réunis  en  assemblée

générale représentant au moins les trois quarts du capital social.

7.3 Les certificats de parts sociales peuvent être émis aux associés dans la forme et les dénominations déterminées par

les gérants.

7.4 Le détenteur déclaré d'une part sociale nominative sera le propriétaire de cette part sociale et la Société ne sera

nullement tenue de reconnaître les revendications sur les intérêts dans cette part sociale qui émaneraient de qui que ce soit
d'autre.

Titre III.- Gestion

Art. 8. Gérants.
8.1 La Société est gérée par au moins deux gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés et laquelle

fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

8.2 Les gérants peuvent être nommés pour une période indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs

les plus étendus.

8.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 9. Pouvoirs des Gérants.
9.1 Les gérants ont tous pouvoirs pour effectuer les actes jugés nécessaires et utiles conformément à l'objet social de la

Société.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents statuts

seront de la compétence des gérants.

9.3 Sous réserve de l'Article 9.4, les gérants peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à

un ou plusieurs gérants ou autres représentants qui ne doivent pas nécessairement être associé et pourront donner autorité
à ces gérants ou autres représentants de sous-déléguer.

9.4 La délégation à un gérant ou une autre personne de la gestion quotidienne de la Société est soumise à l'autorisation

préalable par vote unanime lors de l'assemblée générale des associés.

9.5 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par la signature

conjointe ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été valablement délégué.

Art. 10. Procédure.
10.1 Les gérants peuvent élire un Président. En l'absence de ce dernier, un autre gérant présidera la réunion.
10.2 Les gérants pourront se réunir, ajourner et programmer leurs réunions comme ils le jugent utile, à condition qu'un

quorum d'au moins deux gérants présents en personne ou par procuration soit respecté et qu'une majorité des gérants ainsi
présents ou représentés soit composée de gérants qui ne sont pas présents au Royaume-Uni.

10.3 Les résolutions nécessitent la majorité des votes. Dans le cas d'une égalité des votes, le Président a une voix pré-

pondérante.

10.4 Toute décision ou autre action des gérants lors d'une réunion sera confirmé dans les procès-verbaux de la réunion

et signé par le Président et le Secrétaire de la réunion.

10.5 Tout gérant peut participer à la réunion des gérants par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de

communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler.
La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

10.6 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme

si la réunion des gérants dûment convoquée avait été tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un document unique
ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, sous toute forme et enregistré avec les délibérations des gérants.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1 Sous réserve des dispositions de l'Article 11.3, chaque gérant et autre représentant, employé ou agent de la Société

sera indemnisé par la Société et le devoir des gérants sera de payer des fonds de la Société tous les dommages, charges,
frais, pertes et dépenses qu'un gérant, représentant, employé ou agent pourra encourir ou dont il peut être passible en raison
de:

(a) tout contrat qu'il a conclu ou d'un acte fait ou omis par lui en tant que gérant, représentant, employé ou agent;
(b) toute action ou procès (y compris des procès en relation avec les matières énumérées à l'article 11.3) qui ne sont pas

couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans ce dernier cas, le conseiller juridique de la
Société soit d'avis que si le procès était allé à son terme, le gérant, l'agent, l'employé ou le représentant n'aurait pas été fautif
en relation avec cette matière selon l'article 11.3;

(c) du fait qu'il a agi en tant que ou du fait qu'il a été, à la requête de la Société, gérant ou représentant d'une autre société

dans laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n'est pas en droit d'être entièrement indemnisé;
ou

(d) de son accomplissement de ses devoirs, y compris les dépenses de voyage.
11.2 Sous réserve des dispositions de l'article 11.3 aucun gérant ou autre représentant, employé ou agent de la Société

ne sera responsable vis-à-vis de la Société pour une perte ou une dépense de la Société en relation avec:

(a) les actes, reçus, négligences ou fautes d'un autre gérant, représentant, employé ou le fait d'avoir participé à un tel acte,

reçu, négligence ou faute; ou

7327

(b) l'insuffisance ou le défaut de titre d'une propriété acquise sur l'ordre des gérants ou l'insuffisance ou le défaut d'une

valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis; ou

(c) la faillite, l'insolvabilité ou un acte fautif d'une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés; ou
(d) une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques

qui se produisent dans l'exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

11.3 Un gérant ne pourra pas profiter du bénéfice d'indemnisation de l'article 11.1 ou des dispenses de l'article 11.2:
(a) s'il est de façon définitive jugé dans un procès responsable de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou
(b) s'il est de façon définitive jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d'un manquement grave aux

dispositions de la loi ou des présents statuts, à moins que le gérant n'ait pas participé à ce manquement, qu'aucune faute ne
lui soit imputable et que le gérant communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

11.4 Si une partie de l'Article 11 n'était pas valable pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l'étendue d'application

de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite ou ils ne sont pas invalidés ou modifiés.

Art. 12. Intérêts des gérants.
12.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société, entreprise ou autre entité, ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou représentants de la Société ont un intérêt ou sont gérant, administrateur,
associé, employé ou agent de l'autre société, entreprise ou entité.

12.2 Tout gérant ou agent qui est gérant, administrateur, agent ou employé d'une société, entreprise ou autre entité avec

laquelle la Société aurait un contrat ou serait engagée en affaires ne sera pas, en raison de son lien avec l'autre société,
entreprise ou autre entité, empêché de voter et agir en rapport avec ledit contrat ou ladite affaire.

12.3 Sous réserve du paragraphe précédent, le gérant qui a un intérêt dans un contrat ou un accord soumis à l'agrément

des gérants, et dont l'intérêt est contraire aux intérêts de la Société, sera obligé, lors de cette soumission, d'en informer les
gérants et cette information sera reprise dans les procès-verbaux de la réunion. Ce gérant ne sera pas admis à délibérer et
à voter concernant ledit contrat ou accord, mais pourra être pris en compte pour la constitution d'un quorum.

Art. 13. Disqualification des gérants. Le poste de gérant ou de commissaire sera, ipso facto, rendu vacant:
(a) si celui-ci est déclaré en faillite ou en concordat avec ses créditeurs ou s'il bénéficie d'une mesure quelconque, applicable

le moment venu, en matière de redressement de débiteurs insolvables;

(b) s'il remet sa démission par écrit; ou
(c) si le poste de gérant lui est interdit par la Loi; ou
(d) s'il cesse d'être gérant en vertu de la Loi ou est déchu de son poste en vertu des présents statuts.

Titre IV.- Résolutions des associés

Art. 14. Pouvoirs et droits de vote.
14.1 Les associés ont les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou ratifier toutes actions effectués ou accomplies par

ou pour compte de la Société.

14.2 Chaque associé dispose d'un droit de vote proportionnel à sa participation.
14.3 Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, fax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

14.4 Si la Société n'a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale

des associés.

Art. 15. Forme, Quorum et Majorité.
15.1 Il sera donné à tous les associés un avis de toute assemblée générale des associés selon les prescriptions de la Loi,

chaque gérant ayant le droit de convoquer une assemblée. De plus une assemblée générale doit être convoquée à la demande
d'un associé détenant au moins dix pour cent (10%) du capital souscrit.

15.2 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les associés sont présents ou représentés

lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

15.3 Tout associé a le droit de voter en personne ou en se faisant représenter par un mandataire qui ne doit pas néces-

sairement être un associé.

15.4 Chaque part sociale donne droit à un vote.
15.5 Sous réserve de l'Article 15.6, les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu'elles soient

adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, à défaut de quoi une seconde assemblée sera convoquée,
par lettre recommandée, au cours de laquelle la décision sera prise à la majorité des votes des associés présents.

15.6 Toute décision autre que celles prévues à l'article 15.7 requise ou permise d'être prise par les associés réunis en

assemblée générale peut être prise en dehors d'une assemblée, si une résolution exposant une telle action est signée par
tous les associés, et elle sera considérée comme étant valablement adoptée comme si l'assemblée générale dûment convo-
quée avait été tenue, pourvu que le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq et sauf stipulation contraire des
statuts, si elle est approuvée par des associés représentant plus de la moitié du capital social ou, si ce chiffre n'est pas atteint
à la première consultation par écrit, après une seconde consultation par lettre recommandée, par une majorité des votes
émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

15.7 Toute modification des présents statuts, ou bien toute décision requise par les présents statuts ou par la Loi pour

une modification des présents statuts, ne sera effective que si elle est approuvée par la majorité des associés représentant
les trois quarts du capital social émis.

7328

15.8 Au cas où il y aurait deux ou plusieurs classes de parts sociales émises et que la question portée devant l'assemblée

générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, les quorum et majorités exigés par les présents Statuts devront
être atteints pour chacune de ces classes de parts sociales dont les droits seraient modifiés.

Titre V.- Comptes annuels - Bilan - Distributions

Art. 16. Exercice social et Comptes annuels.
16.1 L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et prendra fin le trente-et-un décembre

de la même année (l'«Exercice Social»).

16.2 Pour chaque Exercice Social, les gérants prépareront les comptes annuels qui comportent un bilan et un compte des

pertes et profits de la Société. Les comptes annuels seront établis selon les prescriptions de la Loi. A ces comptes annuels
seront annexés les rapports et documents reprenant les détails exigés par la Loi.

16.3 Les comptes annuels seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 17. Affectation des bénéfices.
17.1 Sur le bénéfice net annuel de la Société sera prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer la réserve exigée par la Loi.

Cette affectation cessera d'être nécessaire dés que et aussi longtemps que cette réserve s'élèvera à dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.

17.2 L'affectation et la distribution des bénéfices nets restants (y compris les résultats reportés) de la Société et le résultat

à reporter seront déterminés par l'assemblée générale des associés sur les recommandations des gérants. Cette affectation
pourra inclure la distribution de dividendes en toutes devises ou en nature, l'émission par la Société de parts sociales gratuites
ou de droits de souscription et la création ou le maintien de réserves et de provisions.

17.3 Les dividendes seront payés aux associés en conformité avec leurs droits et intérêts et et en proportion du montant

libéré sur leurs parts sociales durant la portion de période en rapport avec laquelle le dividende est payé.

17.4 Pour autant que permis par la Loi, l'assemblée générale peut décider de verser des acomptes sur dividendes sur base

des états comptables préparés par les gérants et montrant que des fonds suffisants sont disponibles à la distribution, étant
entendu les montants distribués ne pourront excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale augmentés
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, y compris des primes d'émission, mais diminués des pertes reportées
et des sommes devant être affectées à la réserve requise par la Loi et les présents statuts.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
18.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.3 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à

l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 19. Général.
19.1 Pour tout ce qui ne fait pas réglé par les présents statuts, il est fait référence à la Loi.
19.2 Les présents statuts existent en anglais et en français. En cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise

fera foi.»

<i>Huitième résolution

Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée avec effet à partir de ce jour:
a) Madame Gillian Fay Adams, «Group Human Resources Manager», née à Bexley Heath (UK), le 2 août 1958, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

b) Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, «General Manager», né à Mtarfa (Malte), le 1 

er

 février 1957, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

c) Madame Jacqueline Anne McNally, «Company Secretary», née à Ipswich (UK), le 1 

er

 février 1968, avec adresse pro-

fessionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

d) Monsieur Arjan Kirthi Singha, «Financial Controller», né à Singapour, le 7 novembre 1969, avec adresse professionnelle

au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à deux mille euros.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 37.878,79 EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 9.45 heures.

7329

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-A. McNally, L. Blair, C. Sales, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 décembre 2006, vol. 540, fol. 12, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 décembre 2006.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007006872/231/455.
(060139178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Mini-Market S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8220 Mamer, 46, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 63.878.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

LUXCOMPTA S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007005392/679/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03754. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060138434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Hines Holdings Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.282.700,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 79.935.

Il a été résolu par l'associé unique en date du 18 octobre 2006 d'accepter la démission de Mr. Godfrey Abel et Mr. Marek

Domagala avec effet au 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 2 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007006880/250/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04258. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Eurowatt S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R.C.S. Luxembourg B 48.020.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 juillet 2006 que:
- Monsieur Roberto Bianchi demeurant à Via Ansperto, 9, Milano, Italie, a été nommé membre du conseil de surveillance

en remplacement de Monsieur Guido Josef Banholzer à partir du 18 juillet 2006.

- Suite à cette nomination, le conseil de surveillance se compose des membres suivants:
- Madame Luisa De Vecchi, demeurant à Via Regina, 65, 22011 Griante, Italie
- Monsieur Alberto De Vecchi demeurant à Via Quarenghi 27, Milan, Italie
- Monsieur Roberto Bianchi, demeurant à Via Ansperto 9, Milano, Italie
Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

7330

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007006884/507/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04113. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060139104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Field Point I-A RE 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 122.587.

STATUTES

In the year two thousand six, on the sixth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

FIELD POINT I-A, S.à r.l, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with

registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 121088,

duly represented by Mr. Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on 6th December 2006.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to

this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a société

à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby established

by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,

warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment

of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of FIELD POINT I-A RE 7, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to

any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to

new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a

7331

majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. The board shall be composed of at least one manager A and at least one manager B.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one manager A and one manager B.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partici-
pation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can
deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of
managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire set of
such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at least

three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

7332

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts

to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT I-A, S.à r.l., prenamed, for a total price of twelve

thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) entirely

allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hudnred euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital

and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, the Grand Duchy

of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr. James L. Varley, Manager A, born on 29 July 1965 in Mineola, New York, USA residing at 183 Cedar Shore Drive,

Massapequa, New York 11758;

- Mr. Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing at 3, St. Michael's

Mews, London SW18JZ, United Kingdom;

- Mr. Thijs van Ingen, Manager B, born on 5 December 1974 in Tiel, the Netherlands, residing at 20, rue de la Poste L-2346

Luxembourg; and

- Mr. Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, residing at 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary, the

present original deed.

Es folgt die Deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

7333

FIELD POINT I-A, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 121088 (die «Gesellschaft»),

hier  vertreten  durch  Herrn  Jean-Baptiste  Beauvoir-Planson,  maître  en  droit,  wohnhaft  zu  Luxemburg,  aufgrund  einer

privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 6. Dezember 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesell-

schafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesellschaft»)
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland, sowie

die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen in luxem-
burgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die
Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldscheinen,

Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch Immo-
bilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung

ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FIELD POINT I-A RE 7, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen oder
andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) An-

teile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapital bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die min-

destens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen

eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile

zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an
den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder Do-

kumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die

Dauer ihres Mandates.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet, der aus mindestens

einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer besteht.

In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und einem

B Geschäftsführer verpflichtet.

7334

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund nota-

riell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht
Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verant-
wortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln

und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungss-

chreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat

mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungss-

chreiben.  Dies  gilt  nicht  für  den  Fall  einer  Dringlichkeit,  in  dem  die  Natur  und  die  Gründe  dieser  Dringlichkeit  im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch
ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Ein-
berufungsschreiben  verzichtet  werden.  Ein  spezielles  Einberufungsschreiben  ist  nicht  erforderlich  für  Sitzungen  des  Ge-
schäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des
Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten
lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis
der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom

stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle,
die  vor  Gericht oder anderweitig  vorgelegt werden sollen,  werden  vom  Vorsitzenden oder  von  zwei Geschäftsführern
unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer,

nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen

der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptver-

sammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

7335

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines von

den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung
stehen,  wobei  der  auszuschüttende  Betrag  selbstverständlich  nicht  die  seit  dem  Ende  des  letztes  Steuerjahres  erzielten
Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich der über-
tragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve zugewiesen
werden.

F. Gesellschaftsauflösung- Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung

ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und
Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Be-
gleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im

Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von FIELD POINT I-A, S.à r.l., vorgenannt, für einen Gesamtpreis von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die  der  Gesellschaft  aus  Anlass  ihrer  Gründung  entstehenden  Kosten,  Honorare  und  Auslagen  werden  auf  ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt,

folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr James Varley, Manager A, geboren am 29. Juli 1965 in Mineola, New York, USA, wohnhaft in 183 Cedar Shore

Drive, Massapequa, New York 11758;

- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft in 3, St.

Michael's Mews, London SW18JZ, Vereinigtes Königreich von England.

- Herr Thijs van Ingen, Manager B, geboren am 5. Dezember 1974 in Tiel, Niederlande, wohnhaft in 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Pierre Beissel, Manager B, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, wohnhaft in 14, rue Erasme, L-2010 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei diese

Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen
zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienene hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: J.-B. Beauvoir-Planson, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 2006, vol. 440, fol. 17, case 12. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

7336

Mersch, den 14. Dezember 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007007186/242/225.
(060139995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

Café Caramba, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 60, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 111.946.

<i>Ext

L'assemblée générale accepte la démission de:
Madame Rodrigues Fernandes Alexandra, Inès, demeurant à L-1713 Luxembourg, 160, rue de Hamm, de ses fonctions de

gérante technique,

et de
Madame Ferreira Bonfim Abilène, épouse Garcia Martinez, demeurant à L-1260 Luxembourg, 81, rue de Bonnevoie, de

ses fonctions de gérante administrative.

L'assemblée générale nomme Madame Ferreira Bonfim Abilène, épouse Garcia Martinez, préqualifiée, gérante technique.
La société est de ce fait à partir de cette date valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants dont l'une

obligatoire de la gérante technique.

Luxembourg, le 8 décembre 2006.

<i>Pour CAFE CARAMBA, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant administratif / <i>Gérante technique

Référence de publication: 2007007095/1286/25.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04043. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Field Point I-A RE 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 122.585.

STATUTES

In the year two thousand six, on the sixth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

FIELD POINT I-A, S.à r.l, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with

registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 121088 (the «Company»),

duly represented by Mr. Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on 6th December 2006.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to

this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a société

à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby established

by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,

warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

7337

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment

of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of FIELD POINT I-A RE 5, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to

any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to

new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. The board shall be composed of at least one manager A and at least one manager B.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one manager A and one manager B.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partici-
pation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can
deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of
managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire set of
such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

7338

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at least

three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts

to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT I-A, S.à r.l, prenamed, for a total price of twelve

thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) entirely

allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital

and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

7339

1. The registered office of the Company shall be at Carré Bonn, 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, the Grand Duchy

of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr. James L. Varley, Manager A, born on 29 July 1965 in Mineola, New York, USA residing at 183 Cedar Shore Drive,

Massapequa, New York 11758;

- Mr. Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing at 3, St. Michael's

Mews, London SW18JZ, United Kingdom;

- Mr. Thijs van Ingen, Manager B, born on 5 December 1974 in Tiel, the Netherlands, residing at 20, rue de la Poste L-2346

Luxembourg; and

- Mr. Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, residing at 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary, the

present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

FIELD POINT I-A, S.à r.l,, eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 121088 (die «Gesellschaft»),

hier  vertreten  durch  Herrn  Jean-Baptiste  Beauvoir-Planson,  maître  en  droit,  wohnhaft  zu  Luxemburg,  aufgrund  einer

privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 6. Dezember 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesell-

schafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesellschaft»)
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland, sowie

die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen in luxem-
burgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die
Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldscheinen,

Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch Immo-
bilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung

ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FIELD POINT I-A RE 5, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen oder
andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) An-

teile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

7340

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapital bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die min-

destens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen

eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile

zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an
den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder Do-

kumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die

Dauer ihres Mandates.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet, der aus mindestens

einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer besteht.

In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und einem

B Geschäftsführer verpflichtet.

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund nota-

riell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht
Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verant-
wortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln

und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungss-

chreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat

mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungss-

chreiben.  Dies  gilt  nicht  für  den  Fall  einer  Dringlichkeit,  in  dem  die  Natur  und  die  Gründe  dieser  Dringlichkeit  im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch
ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Ein-
berufungsschreiben  verzichtet  werden.  Ein  spezielles  Einberufungsschreiben  ist  nicht  erforderlich  für  Sitzungen  des  Ge-
schäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des
Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten
lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis
der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom

stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle,

7341

die  vor  Gericht  oder anderweitig  vorgelegt  werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei  Geschäftsführern
unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer,

nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen

der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptver-

sammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines von

den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung
stehen,  wobei  der  auszuschüttende  Betrag  selbstverständlich  nicht  die  seit  dem  Ende  des  letztes  Steuerjahres  erzielten
Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich der über-
tragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve zugewiesen
werden.

F. Gesellschaftsauflösung- Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung

ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und
Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Be-
gleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im

Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von FIELD POINT I-A, S.à r.l,, vorgenannt, für einen Gesamtpreis von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die  der  Gesellschaft  aus  Anlass  ihrer  Gründung  entstehenden  Kosten,  Honorare  und  Auslagen  werden  auf  ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt,

folgende Beschlüsse gefasst:

7342

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr James Varley, Manager A, geboren am 29. Juli 1965, in Mineola, New York, USA, wohnhaft in 183 Cedar Shore

Drive, Massapequa, New York 11758;

- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft in 3, St.

Michael's Mews, London SW18JZ, Vereinigtes Königreich von England.

- Herr Thijs van Ingen, Manager B, geboren am 5. Dezember 1974 in Tiel, Niederlande, wohnhaft in 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Pierre Beissel, Manager B, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, wohnhaft in 14, rue Erasme, L-2010 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei diese

Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen
zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienene hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: J.B. Beauvoir-Planson, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 2006, vol. 440, fol. 17, case 10. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Mersch, den 12. Dezember 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007007183/242/225.
(060139988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

Vimo &amp; Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8283 Kehlen, 9, rue Gaessel.

R.C.S. Luxembourg B 113.973.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2006 accepte la démission de Mme Dominique Zens comme membre

du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration décide de nommer un nouvel administrateur:
- la société VIMO S.A. avec siège social au 9, rue Gaessel L-8283 Kehlen, R.C. B 50.180

<i>Pour VIMO &amp; PARTNER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007007092/1113/13.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03690. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060139644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Sumba Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 98.283.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le trois novembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

SINFORD FINANCE LIMITED
Société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges

Britanniques,

Représentée par Stéphanie Stacchini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès-qualitées qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclara-

tions:

I.- Que la société anonyme SUMBA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, R.C.S.

Luxembourg section B 98283, a été constituée en date du 30 décembre 2003 par devant Maître Marc Lecuit, notaire de

7343

résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
acte publié au Mémorial C recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 174 du 11 février 2004. Les statuts n'ont
jamais été modifiés.

II.- Que le capital social de la société anonyme SUMBA HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente deux

mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

III.- Que le mandant est l'actionnaire unique de la prédite société SUMBA HOLDING S.A.
IV.- Que le mandant en sa qualité de liquidateur a décidé de dissoudre et de liquider la société SUMBA HOLDING S.A.,

qui a interrompu ses activités.

V.- Que le mandant déclare qu'il a réglé tous les engagements et dettes de la société SUMBA HOLDING S.A.
VI.- Qu'il est attesté que tout l'actif est dévolu à la mandante et qu'elle assure le payement de toutes les dettes de la société

dissoute, même inconnues à l'instant.

VII.- Que la liquidation de la société SUMBA HOLDING S.A. est à considérer comme définitivement close.
VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l'exécution de leur mandat.

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société

dissoute.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Stacchini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 155S, fol. 99, case 8. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 <i>ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007005954/211/52.
(060138841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Le Clos des Grands Crus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 10, rue Lankelz.

R.C.S. Luxembourg B 86.974.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2006.

LUXCOMPTA S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007005399/679/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03750. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

7344


Document Outline

A Alpha S.à r.l.

Alex-Turi-Bar S.à r.l.

Alliance Santé Europe S.A.

Alliance Santé S.A.

Anciens Etablissements Holcher et Conzemius

Anglo American Exploration Luxembourg

Anglo American Investments 1 S.A.

Bader 6 Luxembourg S.à r.l.

Bara S.A.

Barwa 1 Luxembourg S.à r.l.

Batavia S.A.

BGZ International S.à r.l.

BGZ Zerlegeservice S.à r.l.

Blizzard S.A.

Blue Sky Software S.à r.l.

Cad Group S.A.

Café Caramba

Café Chez Negrita S.à r.l.

C.L.T.S. S.A.

C.M.P. S.A.

Cofra Investments S.à r.l.

Customer View S.A.

De Gourmang S.à r.l.

De Pefferkär S.à r.l.

Editions Culturelles et Professionnelles S.A.

Elly's Jeans

Espace Ariane Immobilière S.A.

Eurowatt S.C.A.

Field Point I-A RE 5 S.à r.l.

Field Point I-A RE 7 S.à r.l.

Finanzgesellschaft A.G. "1ster Januar 1988"

Gestiolux S.A.

Green World S.à r.l.

GT-Sat International S.à r.l.

Henneaux Luxembourg S.A.

Hines Holdings Luxembourg 2 S.à r.l.

HRD Luxembourg I A

HRD Luxembourg II

HRD Luxembourg II A

H &amp; S Promotions

Ikourde Financial Services S.A.

Immo Garant S.A.

Insight S.A.

I.P.F.S. S.A.

Isles S.à r.l.

I.T.I. S.A.

J.P. Morgan Capital Luxembourg S.à r.l.

JP Morgan Partners Latin America Luxembourg II, S.à r.l.

J.P. Morgan Partners (PTC) Luxembourg S.à r.l.

Karvina Finance Holding S.A.

Karvina Finance Holding S.A.

Le Clos des Grands Crus S.à r.l.

Maran International S.A.

Medipub S.à r.l.

Merith International S.A.

Mini-Market S.A.

Mode Paris London

Mode Paris London

Montecaro Holding S.A.

Montecaro Holding S.A.

Napoli Calcio S.A.

Pan Investments S.A.

Seraya S.A.

Space S.A.

Sumba Holding S.A.

Vimo &amp; Partner S.A.

Wintergames Holdings S.à r.l.

Z-Ventures S.A.