logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

115969

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2417

28 décembre 2006

S O M M A I R E

Agefi Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116004

LYX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116015

Artemis Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

115987

Maripe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

115970

Bistro 88, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116009

Matrix German Portfolio One Kaiserslautern, S.à r.l.,

Borletti Group Management S.A., Luxembourg. . 

116015

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115977

Bressoles Décoration S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

116010

Matrix German Portfolio One Kaiserslautern, S.à r.l.,

Bressoles Décoration S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

116011

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115980

British Vita (Lux IV), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

116000

Media Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

116009

CCom  Holdings  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-

Media Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

116012

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116012

Mirror   International   Holding,   S.à r.l.,   Luxem-

Compagnie Holding Financière Hirsch SNCA, Lu-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115970

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116004

Nesey Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

115999

Corefi-Finance S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116000

New Terra-Nova, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

116003

DVL.TV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116005

NTEL S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116011

European  Middle  East  Investment  Corporation 

P-Build Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

116005

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116003

Pacolux S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116012

Eye.Mail, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . 

116014

Peguform Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

116002

Fürlehre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

116012

Prométhée S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

116001

Haag Frères, Menuiserie Moderne de Meubles et 

REDK 1, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

115980

de  Constructions,  Transports,  S.e.n.c.,  Luxem-

Redbox Wine and Food S.A., Luxembourg  . . . . . 

116004

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116007

Société   Immobilière   Bellevue,   S.à r.l.,   Luxem-

Hitchard, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

115974

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116015

Hitchard, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

115977

SPX Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

116007

Ibertrans   (Luxembourg)   S.à r.l.,   Luxembourg-

Taros Capital II SLP MLP, S.à r.l., Luxembourg. . 

115996

Bonnevoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116002

Time Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

116003

ICGRedStone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

115972

Trident LI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

115998

ICGRedStone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

115974

Unibanco-União  de  Bancos  Brasileiros  (Luxem-

Immo-Office S.A., Elvange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116014

bourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115970

Immobilière Buchholtz, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

116004

Unibanco-União  de  Bancos  Brasileiros  (Luxem-

ING REEIF Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

116012

bourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115977

Incomex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116002

Unibanco-União  de  Bancos  Brasileiros  (Luxem-

Iwa S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115996

bourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115985

itmedia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115994

Unibanco-União  de  Bancos  Brasileiros  (Luxem-

JRJ S.A., Tétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115999

bourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115987

Kaupthing Life & Pension, Luxembourg S.A., Lu-

WPP  Luxembourg  Gamma  Two,  S.à r.l.,  Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116009

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115994

Koch HC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

116013

WPP  Luxembourg  Gamma  Two,  S.à r.l.,  Luxem-

LCI Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115986

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115996

Lens S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116002

115970

MARIPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.077. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07780, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117795.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.703. 

EXTRAIT

Le conseil d’administration de la société anonyme UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEM-

BOURG) S.A., dans sa réunion du 31 mars 2006,

- nomme PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, aux fonctions de réviseur d’en-

treprise externe et fixe la fin de son mandat à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007;

- ratifie le transfert du siège social de la société du 11 novembre 2005 à l’adresse suivante: 8-10, avenue de la Gare,

L-1610 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118259.6//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

MIRROR INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 84.862. 

In the year two thousand six, on the twenty-sixth day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BANCA INTESA S.p.A., a company incorporated under the law of Italy, having its registered office at 10, Piazza

Paolo Ferrari, I-20121 Milan registered in the Commercial Register of Italy, under the number 00799960158;

2) MIRROR TRE, S.à r.l. (in liquidation), a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered

office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered in the Commercial Register of Luxembourg, under the number
B 101.700;

3) PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., a company incorporated under the law of Luxembourg, having its reg-

istered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered in the Commercial Register of Luxem-
bourg, under the number B 85.227;

4) TOP MIRROR, S.à r.l., a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 5, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg registered in the Commercial Register of Luxembourg, under the number B 107.148;

all here represented by SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. a company with registered office at 19-21, bd

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

by virtue of four proxies given on October 9 and 11, 2006,
itself represented by:
- Mr Laurent Forget, private employee, residing professionally in Luxembourg,
- Mr Seiji Amino, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting respectively with joint A signature.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated hereabove have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

1) That they are the sole actual shareholders of MIRROR INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., a limited liability

corporation incorporated by deed of the undersigned notary, residing then in Hesperange, on the 6th of December
2001, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 489 on March 28, 2002, the articles of
which have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on December 19, 2001, published in
the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 673 on May 2, 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature

115971

2) All this having been declared, the shareholders, represented as stated hereabove have immediately proceeded to

hold an extraordinary general meeting and have taken by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide the anticipated dissolution of the company and to put it into liquidation with effect as on

this day.

<i>Second resolution

The shareholders decide to appoint T.A.S.L., S.à r.l. with registered office located at n

o

28, rue Michel Rodange, L-

2430 Luxembourg as liquidator.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He

may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for

such period he may determine.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BANCA INTESA S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Milan (Italy) 10, Piazza Paolo Ferrari,

I-20121, inscrite au Registre de Commerce d’Italie, sous le numéro 00799960158;

2) MIRROR TRE, S.à r.l. (en liquidation), une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1450 Luxem-

bourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, sous le numéro B 101.700;

3) PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1724

Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, sous le
numéro B 85.227;

4) TOP MIRROR, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue

Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, sous le numéro B 107.148;

toutes ici représentées par SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. une société ayant son siège social au 19-21,

bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

en vertu de quatre procurations délivrées en date du 9 et du 11 octobre 2006,
elle-même représentée par:
- Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Seiji Amino, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant avec signatures conjointes A.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
1) qu’elles sont les seules et uniques associées actuelles de la société à responsabilité limitée MIRROR INTERNA-

TIONAL HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant alors de résidence à Hesperange, en date du 6 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 489 du 28 mars 2002, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du
notaire soussigné du 19 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 673 du 2 mai
2002.

2) Ceci ayant été déclaré, les associées se sont se réunies en assemblée générale extraordinaire de la société et ont

pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées décident la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation avec effet au jour des présentes.

<i>Deuxième résolution

Les associées décident de nommer T.A.S.L., S.à r.l. avec siège social au 28, rue Michel Rodange, L - 2430 Luxembourg,

en qualité de liquidateur de la société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

115972

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Forget, S. Amino, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, vol. 155S, fol. 84, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126191.3/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

ICGRedStone, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 118.244. 

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of October,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg, under-

signed.

ICGLUXHOLD, S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office at 28, rue Michel Rodange,

L-2430 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B.
118.065 (the «Sole Shareholder»),

in its capacity as Sole Shareholder of ICGRedStone, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée, having its registered office at 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under the number B. 118.244 and incorporated by a deed drawn up by the no-
tary Henri Hellinckx, residing at Mersch, Grand-Duchy Luxembourg, on 20 July 2006, and whose articles of incorpora-
tion have been published in the Mémorial C number 1781 dated 22 September 2006, page 85,462 (the «Company»);

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of

articles 200-2 of Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time
to time (the «Law»).

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of proxy given under private seal dated October 23rd 2006, which, initialled ne varietur by the appearing per-
son and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

<i>Resolutions

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company with an amount of twelve thousand and

five hundred Euro (EUR 12,500.-) in order to raise it from the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR
12,500.-) to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) by creating and issuing five hundred (500) new shares, having the
same rights and obligations as the existing ones, with nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (the «New
Shares»), subject to a global share premium of an amount of twelve millions two hundred thirty nine thousand seven
hundred and fifty eight Euro (EUR 12,239,758.-) to be attached to the New Shares (the «Share Premium»).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder records the subscription and the full payment in cash of the New Shares and the share premium

by the Sole Shareholder as follows:

- ICGLUXHOLD, S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office at 28, rue Michel Ro-

dange, L-2430 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the
number B. 118.065 duly represented by Hubert Janssen, prenamed, by virtue of a proxy, which shall remain attached to
the present minutes, who, after having stated that his principal has full knowledge of the Articles, declares to subscribe
to five hundred (500) New Shares, having the same rights and obligations as the existing one, with a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each, for the global amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) plus
a global share premium in the amount of twelve millions two hundred thirty nine thousand seven hundred and fifty eight
Euro (EUR 12,239,758.-), fully paid up by contribution in cash.

These New Shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve millions two hundred fifty two thou-

sand two hundred and fifty eight Euro (EUR 12,252,258.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has
been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the article 5.1 of the Articles regarding the corporate capital of the Company

so as to reflect the taken decisions, which shall read now as follows:

«5.1. The corporate capital is fixed at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) represented by thousand (1,000)

shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are to-
gether referred to as the «Shareholders».

Luxembourg, le 16 novembre 2006.

G. Lecuit.

115973

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately hundred thirty thousand Euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
son, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt-sept octobre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

ICGLUXHOLD, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430

Luxembourg et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 118.065,

en qualité d’Associé Unique de ICGRedStone, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au

28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B. 118.244 et constituée en vertu d’un acte du notaire Henri Hellinckx, demeurant à
Mersch, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 20 juillet 2006, et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C
numéro 1781 du 22 septembre 2006, page 85.462 (la «Société»);

adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l’article 13 des statuts de la Société et à l’ article 200-2 de

la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L’Associé Unique est représenté aux présentes par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu de la procuration sous seing privé du 23 octobre 2006, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) pour le porter de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR)
par la création et l’émission de cinq cent (500) nouvelles parts sociales, ayant les mêmes droit et obligations que celles
existantes, d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant une prime d’émis-
sion globale d’un montant de douze millions deux cent trente-neuf mille sept cent cinquante-huit euros (12.239.758,-
EUR) laquelle sera attachée aux Nouvelles Parts Sociales (la «Prime d’émission»).

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique constate la souscription et l’entière libération en espèces des nouvelles Parts Sociales et de la prime

d’émission par l’Associé Unique comme suit:

- ICGLUXHOLD, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, rue Michel Rodange, L-

2430 Luxembourg et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 118.065 dûment repré-
sentée par Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration, laquelle restera attachée aux présentes minutes, qui
après avoir fait constater que son mandant a pleine connaissance des Statuts, déclare souscrire à cinq cents (500) Nou-
velles Parts Sociales, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune, pour le montant global de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), moyen-
nant une prime d’émission d’un montant total douze millions deux cent trente-neuf mille sept cent cinquante-huit euros
(12.239.758,- EUR), entièrement libérées par apport en numéraire.

Ces Nouvelles Parts Sociales ont été intégralement libérées en numéraire de telle sorte que le montant de douze

millions deux cent cinquante-deux mille deux cent cinquante-huit euros (12.252.258,- EUR) est maintenant à la disposi-
tion de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire lequel le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts relatif au capital social souscrit de la Société afin de re-

fléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Le capital social souscrit est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales

(les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de mille euros (25,- EUR), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales
sont définis ci-après les «Associés».

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ cent trente mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

115974

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, vol. 155S, fol. 91, case 4. – Reçu 122.522,58 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126205.3/211/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

ICGRedStone, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 118.244. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44639 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 22 novembre 2006.

(126207.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

HITCHARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 119.836. 

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth day of October,
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

(1) Mr Daniel Francis O’Mahony, residing at 126 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 04, Ireland,
hereby represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 23 October 2006,
(2) FULCRUM LIMITED, as Trustee of the RM Settlement, a company having its registered office at P.O. Box 1, Port-

land House, Station Road, Ballasalla, Isle of Man, IM99 6AB registered with the Company Register of the Isle of Man
under number at 108914C, Ireland,

hereby represented by Mr Laurent Schummer, prenamed,
by virtue of a proxy given on 24 October 2006,
being hereafter collectively referred to as the «Shareholders»,
I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The Shareholders declare that they are the sole shareholders of HITCHARD, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which has been incorporated by the undersigned no-
tary, on September 8, 2006, not yet published in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, registrated with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 119.836, and having its registered office at 12,
rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not yet been
amended.

III. The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To change the object of the Company which shall read as follows:
«Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in

foreign undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes».

2. To acknowledge and accept the resignation of Mr Joost Tulkens and Mr Bart Zech as managers of the Company.
3. To grant discharge to the resigning managers.
4. To appoint Mr Daniel O’Mahony and ANCROFT LIMITED, as new managers of the Company in replacement of

the resigning managers for an undefined period.

5. Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following resolutions, each time unanimously adopted:

<i>First resolution

The sole shareholders resolved to change the object of the Company.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

115975

The sole shareholders consequently resolved to amend article 2 of the articles of association of the Company which

shall read as follows:

«Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in

foreign undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes».

<i>Second resolution

The sole shareholders resolved to acknowledge and accept the resignation with immediate effect of Mr Joost Tulkens

and Mr Bart Zech from their office of managers of the Company.

<i>Third resolution

The sole shareholders resolved to grant full discharge to the resigning managers for the proper performance of their

mandate and to vote again on their discharge at the approval of the annual accounts as at December 31, 2007.

<i>Fourth resolution

The sole shareholders resolved to appoint each of the following as new managers of the Company for an unlimited

duration:

1. Mr Daniel O’Mahony, company manager, residing at 126 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 04, Ireland, and
2. ANCROFT LIMITED, a company incorporated in the Isle of Man, having its registered office at P.O. Box 1, Portland

House, Station Road, Ballasalla, Isle of Man, IM99 6AB (ANCROFT).

The sole shareholders acknowledged that the Company’s board of managers is forthwith composed as follows:
1. Mr Daniel O’Mahony, prenamed, and
2. ANCROFT, prenamed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid deed are

estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).

No items remaining on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-six octobre,
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

(1) Monsieur Daniel Francis O’Mahony, avec adresse professionnelle à 126 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 04, Ir-

lande,

représenté par Monsieur Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration

donnée le 23 octobre 2006,

(2) FULCRUM LIMITED, as Trustee of the RM Settlement, une société ayant son siège social au P.O. Box 1, Portland

House, Station Road, Ballasalla, Isle of Man, IM99 6AB et enregistrée au Company Register of the Isle of Man sous le
numéro 108914C, Irlande,

représentée par Monsieur Laurent Schummer prénommé, agissant en vertu d’une procuration donnée le 24 octobre

2006,

étant ci-après collectivement dénommés les «Associés»,
I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
II. Les Associés déclarent qu’ils sont les seuls associés de HITCHARD, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné du 8 septembre 2006, non
encore publié au Journal Officiel de Luxembourg, Mémorial C, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.836, ayant son siège social au 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg
(la «Société»). Les Statuts de la Société n’ont pas encore été changés.

III. Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, reconnaissent être entièrement informés des résolu-

tions à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet de la Société qui aura la teneur suivante:
«Art. 2. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

115976

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.»

2. Reconnaissance et acceptation de la démission de M. Joost Tulkens et M. Bart Zech comme gérants de la Société.
3. Reconnaissance de la décharge des gérants démissionnaire.
4. Nomination de M. Daniel O’Mahony et ANCROFT LIMITED, comme nouveaux gérants de la Société en rempla-

cement des gérants démissionnaires pour une durée indéterminée.

5. Divers.
ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés uniques ont décidé de modifier l’objet de la Société.
Par conséquent, les associés uniques ont décidé de modifier l’article 2 des statuts de la Société qui aura la teneur

suivante:

«Art. 2. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.»

<i>Deuxième résolution

Les associés uniques ont décidé de reconnaître et d’accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Joost

Tulkens et Monsieur Bart Zech comme gérants de la Société.

<i>Troisième résolution

Les associés uniques ont décidé de donner décharge aux gérants de la société et de voter à nouveau sur la décharge

au moment de l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007.

<i>Quatrième résolution

Les associés uniques ont décidé de nommer les personnes suivantes comme nouveaux gérants de la Société pour une

durée indéterminée:

1. Monsieur Daniel O’Mahony, gérant de la Société, demeurant à 126 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 04, Irlande, et
2. ANCROFT LIMITED, une société ayant son siège social au P.O. Box 1, Portland House, Station Road, Ballasalla,

Isle of Man, IM99 6AB (ANCROFT).

Les associés uniques reconnaissent que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
1. Monsieur Daniel O’Mahony, prénommé, et
2. ANCROFT, prénommée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cet acte sont

estimés à mille euros (1.000,- EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, vol. 155S, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126193.3/220/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Luxembourg, le 16 novembre 2006.

G. Lecuit.

115977

HITCHARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 119.836. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126194.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.703. 

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASI-

LEIROS (LUXEMBOURG) S.A., dans sa réunion du 28 avril 2006,

reconduit dans leurs fonctions d’administrateurs de la société UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS

(LUXEMBOURG) S.A. et fixe la fin de leur mandat à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se
tiendra en 2007.

1. Monsieur Celso Scaramuzza, Director (Chairman), 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;
2. Monsieur Alfredo Althen Schiavo, Director, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;
3. Monsieur Daniel Luiz Gleizer, Director, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg; et
4. Madame Ana Ferreira Mendes, Director, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118259.7//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 112.078. 

In the year two thousand and six, on the seventeenth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MATRIX EPH, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) formed under the law of Luxem-

bourg, having its registered office in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

being the holder of 94 (ninety-four) shares of EUR 125 (one hundred and twenty-five Euro) in MATRIX GERMAN

PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with its registered office at boulevard Royal 25B, L-2449 Luxembourg («the Company») registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ register under number B 112.078,

and
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, a Guernsey company, having its registered

office in P.O. Box 290, Investec House, St Peter Port, Guernsey GY1 3RP,

being the holder of 6 (six) shares of EUR 125 (one hundred and twenty-five Euro) in MATRIX GERMAN PORTFOLIO

ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l.

Both here represented by Mr Jacques de Patoul, lawyer, with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Lux-

embourg, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Company MATRIX GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée», has been incorporated and organised under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary
on 9 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 445, dated 1 March
2006, page 21,345. The articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated
14 July 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Such appearing parties declare to deliberate on the following agenda:
- Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 125.- (one hundred and twenty-five Euro) increasing the

present subscribed capital from EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 12,625.- (twelve thousand
six hundred and twenty-five Euro), to be fully paid-up by contribution in cash, together with a total share premium
amounting to EUR 2,661,424.- (two million six hundred and sixty-one thousand four hundred and twenty-four Euro);

Luxembourg, le 16 novembre 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature

115978

- Issuance of 1 (one) additional share, having the same rights and obligations as the existing shares, increasing the

number of issued shares up to 101 (one hundred and one);

- Approval of the subscription in the name and for the account of MATRIX EPH, S.à r.l. to 1 (one) share, with a par

value of 125.- EUR (one hundred and twenty-five Euro) by contribution in cash of EUR 125.- (one hundred and twenty-
five Euro) and payment of a share premium amounting to EUR 2,661,424.- (two million six hundred and sixty-one thou-
sand four hundred and twenty-four Euro);

- Subsequent amendment of article 6, Paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company;
- Miscellaneous.
The appearers take the following resolutions:
The shareholders resolve to increase the subscribed capital by an amount of EUR 125.- (one hundred and twenty-

five Euro), so as to bring the Company’s share capital from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred Euro) to EUR 12,625.- (twelve thousand six hundred and twenty-five Euro) by the creation and issue of 1 (one)
additional share with a par value of 125.- EUR (one hundred and twenty-five Euro), having the same rights and obligations
as the existing shares, increasing the number of the issued shares up to 101 (one hundred and one), to be fully paid-up
by contribution in cash, together with a total share premium amounting to EUR 2,661,424.- (two million six hundred
and sixty-one thousand four hundred and twenty-four Euro).

<i>Subscription and payment

The shareholders approve the subscription of the new share, with a par value of EUR 125.- (one hundred and twenty-

five Euro) by MATRIX EPH, S.à r.l., represented as aforementioned, and declaring to subscribe the new share and to
fully pay it up together with a share premium amounting to EUR 2,661,424.- (two million six hundred and sixty-one
thousand four hundred and twenty-four Euro) by a contribution in cash:

The share has been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash and the issuance of the

share is subject to the payment of a share premium in cash of an aggregate amount of EUR 2,661,424.- (two million six
hundred and sixty-one thousand four hundred and twenty-four Euro), so that the amount of EUR 2,661,549.- (two mil-
lion six hundred and sixty-one thousand five hundred and forty-nine Euro) is now available to the Company, evidence
thereof having been given to the notary by a certificate.

The proof of the payment has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
As a consequence of the foregoing resolution Article 6, first paragraph, of the articles of incorporation of the Com-

pany is amended as follows:

Art. 6. (first paragraph). The Company’s corporate capital is set at twelve thousand six hundred and twenty-five

Euro (EUR 12,625.-) represented by one hundred and one (101) shares (parts sociales) of one hundred and twenty-five
Euro (EUR 125.-) each.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 30,000.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in
case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with us, the notary, the

present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendsechs, den siebzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

MATRIX EPH, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité

limitée), mit Sitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Eigentümerin von 94 (vierundneunzig) Anteilen von jeweils EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro) in MATRIX

GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l., eine Gesellschaft gegründet unter luxemburgischem Gesetz,
mit Sitz in Boulevard Royal 25B, L-2449 Luxemburg («die Gesellschaft»), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsre-
gister unter der Nummer B 112.078,

und
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, ein Guernsey Gesellschaft mit Sitz in P.O. Box

290, Investec House, St Peter Port, Guernsey GY1 3RP,

Eigentümerin von 6 (sechs) Anteilen von jeweils EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro) in MATRIX GERMAN

PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l.,

beide hier vertreten durch Herrn Jacques de Patoul, Jurist, beruflich domiziliert in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-

burg, auf Grund zwei Vollmächte unter Privatschrift.

Diese Vollmachten, nachdem sie durch den Erschienenen und den Notar ne varietur unterschrieben wurden, bleiben

gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit dieser einregistriert zu werden.

115979

Die Gesellschaft MATRIX GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung luxemburgischen Rechts, wurde gegründet gemäß Urkunde des obengenannten Notars am 9. November
2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 445 vom 1. März 2006, Seite 21,345.

Die Statuten wurden geändert gemäss einer Urkunde des obengenannten Notars vom 14. Juli 2006, noch nicht

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Erschienenen erklären über folgende Tagesordnung abzustimmen: 
- Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro)

um das gegenwärtige Gesellschaftskapital von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) auf EUR 12.625,- (zwölftau-
sendsechshundertfünfundzwanzig Euro) zu erhöhen, voll eingezahlt durch Bareinlage zusammen mit einem Emissions-
agio von EUR 2.661.424,- (zwei Millionen sechshunderteinundsechzigtausendvierhundertvierundzwanzig Euro);

- Ausgabe von 1 (einem) zusätzlichen Anteil, welche die gleichen Rechte und Pflichten wie die bestehenden Anteile

hat, um die Zahl der Anteile auf 101 (einhunderteins) zu erhöhen;

- Annerkennung der Zeichnung des Anteils, mit einem Nennwert von EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro),

im Namen von MATRIX EPH, S.à r.l. und vollständige Einzahlung zusammen mit einem Emissionsagio von EUR
2.661.424,- (zwei Millionen sechshunderteinsundsechzigtausendvierhundertvierundzwanzig Euro);

- Entsprechende Abänderung von Artikel 6, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft.
- Verschiedenes.
Und fassen folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, dass Gesellschaftskapital um EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro) zu erhöhen

um das gegenwärtige Gesellschaftskapital von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) auf EUR 12.625,- (zwölftau-
sendsechshundertfünfundzwanzig Euro) zu erhöhen durch die Ausgabe von 1 (einem) zusätzlichen Anteil mit einem
Nennwert von EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro), welcher die gleichen Rechte und Pflichten wie die beste-
henden Anteile hat. Die Zahl der ausgegebenen Anteile wird somit auf 101 (einhunderteins) erhöht. Der Anteil wird
voll eingezahlt durch Bareinlage zusammen mit einem Emissionsagio von EUR 2.661.424,- (zwei Millionen sechshundert-
einundsechzigtausendvierhundertvierundzwanzig Euro).

<i>Zeichung und Einzahlung

Die Gesellschafter beschliessen und stellen fest, dass der neue Anteil, mit einem Nennwert von EUR 125,- (einhun-

dertfünfundzwanzig Euro) vollständig durch MATRIX EPH, S.à r.l., vertreten wie vorstehend angegeben, gezeichnet und
vollständig in bar eingezahlt wird durch den Betrag von EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro) zusammen mit einer
Emissionsagio von EUR 2.661.424,- (zwei Millionen sechshunderteinundsechzigtausendvierhundertvierundzwanzig
Euro).

Der Anteil, hier gezeichnet durch MATRIX EPH, S.à r.l., ist voll eingezahlt durch Bareinlage zusammen mit einer Emis-

sionsagio von EUR 2.661.424,- (zwei Millionen sechshunderteinundsechzigtausendvierhundertvierundzwanzig Euro).
Der Nachweis über die Barzahlung von EUR 2.661.549,- (zwei Millionen sechshunderteinundsechzigtausendfünfhundert-
neunundvierzig Euro) wurde dem Notar erbracht und von diesem ausdrücklich festgestellt.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses, wird Artikel 6, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft wie folgt abgeändert:

«Art. 6. (Absatz 1). Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf EUR 12.625,- (zwölftausendsechshundertfünfund-

zwanzig Euro) festgesetzt, eingeteilt in 101 (einhunderteins) Anteile mit einem Nominalwert von je einhunderfünfund-
zwanzig Euro (EUR 125,-).»

<i>Kostenschätzung

Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesell-

schaft getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr
EUR 30.000,- geschätzt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde, auf

Ersuchen des Erschienenen, in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen des Erschie-
nenen ist im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung
maßgeblich. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: J. De Patoul, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 octobre 2006, vol. 438, fol. 59, case 11. – Reçu 26.615,49 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(127479.3/242/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

Mersch, den 6. November 2006.

H. Hellinckx.

115980

MATRIX GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 112.078. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127480.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

REDK 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 121.465. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-seventh day of October.
Before us M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), under Lux-

embourg Law, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register, at section B, under number 117.987

here represented by Mr Jos Junker, tax consultant, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire,

by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. - Purpose, Duration, Name, Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either

in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of REDK 1, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg. It may be transferred to any other place

in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. - Share capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Mersch, le 6 novembre 2006.

H. Hellinckx.

115981

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. - Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal

115982

year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. - Decisions of the sole partner, Collective decisions of the partners

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euros.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
2. - Mr Ely-Michel Ruimy, Managing Director, born in Casablanca on December 31, 1964, residing at 77ter, rue

Charles Laffitte, F-92200 Neuilly sur Seine,

- Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knighstbridge,

London, SW1X 7RZ, UK,.

are appointed managers of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

115983

A comparu:

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siè-

ge social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, section
B sous le numéro 117.987,

ici représentée par Monsieur Jos Junker, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. - Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l’accomplissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de REDK 1, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. - Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la seule signature d’un gérant.

115984

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. - Décisions de l’associé unique, Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. - Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

115985

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
2. - Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né à Casablanca le 31 décembre 1964, demeurant à

77ter, rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly sur Seine,

- Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25,

Knighstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK,

sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Junker, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, vol. 155S, fol. 91, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126481.3/211/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.703. 

EXTRAIT

Le conseil d’administration de la société anonyme UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEM-

BOURG) S.A., dans sa réunion du 20 février 2006,

reconduit aux fonctions de Délégué à la gestion journalière et fixe la fin de leur mandat au 31 décembre 2006, Ma-

dame Ana Ferreira Mendes, Director, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et Monsieur Keong Kong, 8-10,
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118259.8//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Luxembourg, le 10 novembre 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature

115986

LCI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LCI LUX LIMITED, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 120.201. 

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of October.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of LCI LUX LIMITED, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 12, rue Léon Thyes in L-2636 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120.201 (the Company). The Company has
been incorporated on September 29, 2006 pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, not
yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

There appeared:

LIG, LLC, a limited liability company organized under the laws of Missouri (United States) having its registered office

at BC AGENT SERVICES, INC, 1200 Main Street, Suite 3300 Kansas City, MO 64105, FEIN 20-5585509 (the Sole Share-
holder), hereby represented by Ms Habiba Boughaba, Attorner-At-Law, with professional address in Luxembourg, by
virtue of a proxy given on October 25th, 2006, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder
acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed
with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the Company’s name into LCI LUX, S.à r.l., and subsequent amendment of article 1 of the Articles; and
2. Miscellanous
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First and sole resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name into LCI LUX, S.à r.l., and resolves to amend and here-

by amends article 1 of the Articles, which will henceforth read as follows:

«Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

LCI LUX, S.à r.l., (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately seven hundred euro (700.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de LCI LUX LIMITED, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxem-
bourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 120.201 (la Société). La Société a été constituée le 29 septembre 2006 par acte de M

e

 Gérard Lecuit,

notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

A comparu:

LIG, LLC, une société à responsabilité constituée sous les lois du Missouri (Etats-Unis) ayant son siège social à BC

AGENT SERVICES, INC, 1200 Main Street, Suite 3300 Kansas City, MO 64105, numéro FEIN 20-5585509 (l’Associé
Unique), ici représentée par M

e

 Habiba Boughaba, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en ver-

tu d’une procuration donnée le 25 octobre 2006.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:

115987

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en LCI LUX, S.à r.l, et modification subséquente de l’article

1

er

 des Statuts;
2. Divers
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première et unique résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 1

er

 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

 Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination LCI LUX, S.à r.l. (la

Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui pourraient incomber à la Société à la suite du

présent acte sont estimés à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergen-
ces entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec Nous, le notaire.
Signé: H. Boughaba, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 31 octobre 2006, vol. 471, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126643.3/5770/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.703. 

EXTRAIT

Le conseil d’administration de la société anonyme UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEM-

BOURG) S.A., dans sa réunion du 18 mai 2006,

nomme Monsieur Roberto De Almeida Martinho, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, aux fonctions de

Délégué à la gestion journalière et fixe la fin de son mandat au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118259.9//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

ARTEMIS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 121.701. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-second day of November.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

BONOHURST GP LIMITED, an exempted company organized under the laws of the Cayman Islands, registered with

the Cayman Islands companies’ register under number 152253 and having its registered office at the offices of WALKERS
SPV LIMITED, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands, here repre-
sented by M

e

 Cécile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in the Cayman Islands, on

November 21, 2006,

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party has requested the notary to draw up the following articles of association of a société à respon-

sabilité limitée which it declared to form:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. Legal Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular

the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on limited liability companies, as

Remich, le 23 novembre 2006.

M. Schaeffer.

<i>Pour la société
Signature

115988

amended and the law of December 28th, 1992 on unipersonal limited liabilities companies, and the present articles of
association.

Art. 2. Denomination. The denomination of the company is ARTEMIS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. Registered office. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with t he normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. Object. The company shall have as its main business purpose the investment in financial asset investments.
The company shall have as its general business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, participations in Delaware partnerships and other
securities of any kind, whether domestic or foreign, the possession, the administration, the development and the man-
agement of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

The company may borrow in any form and grant security over its assets for its debts as well as for debts of its share-

holders.

The company may open and maintain branch offices or permanent establishments either in Luxembourg or abroad.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 5. Duration. The company is formed for an unlimited period.

Title II.- Capital - Parts

Art. 6. Capital. The capital is fixed at GBP 12,500.- (twelve thousand five hundred Pounds Sterling), represented

by 625 (six hundred and twenty five) shares having a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each, entirely
subscribed for.

In addition to the corporate capital, the shares may be issued with a share premium.

Art. 7. Shares. Every share entitles its owner to one vote.

Art. 8. Transfer of shares. The company keeps a register of the company’s shareholders. The register indicates

the name and residence of the shareholder, the number of shares he holds in the company, the date of acquisition of
such shares as well as any transfers made to existing or new shareholders. The register is updated by any manager of
the company upon any transfer of shares to existing or new shareholders, any share capital increase and any other
change affecting the ownership of the shares.

Shares are freely transferable among shareholders.
Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be made with the prior approval of shareholders repre-

senting three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10th, 1915 on commercial

companies as amended.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable.

Art. 9. Classes of shares. The share capital of the company may be represented by classes of shares.
The classes of shares may be issued with a share premium. The share premium paid by the shareholders of one class

shall be allocated to the share premium account of this class.

Unless the context indicates otherwise, the term «shares» as used in these articles of association shall refer to all

classes of shares.

Except where stated otherwise in these articles of association, the classes shall all have the same rights, privileges,

restrictions and obligations.

Art. 10. Dividend and liquidation dividend prerogatives for each class of shares. The shareholders shall be

entitled to receive a dividend payment (the «Dividend»), as well as liquidation proceeds at a pro-rata rate of their re-
spective investment, i.e. the capital in issue and the share premium account plus the amount allocated to the legal re-
serve.

The Dividend shall be equal to the available and distributable profits and shall be payable on a monthly basis and the

eleventh (11th) day of the subsequent month or at any other time at the sole discretion of the board of managers.

Art. 11. Termination. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy

or insolvency of any shareholder.

Art. 12. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder

cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

115989

Title III.- Management

Art. 13. Board of Managers. The company is managed by a board of managers composed of at least two members,

who need not be shareholders, and who are either «A Managers» or «B Managers». The board of managers shall always
be composed so that at least one (1) Manager is tax resident in Luxembourg and that no manager shall be UK tax res-
ident. If this tax residency requirement is at any time not met, the relevant manager shall automatically cease to be in
office and shall be replaced by vote of the shareholders meeting. Managers are appointed and removed from office by
vote of the general meeting of shareholders resolving at the majority of the capital and which determines their powers
and the term of their mandates. Managers may be reelected and revoked ad nutum and at any time.

The board of managers shall deliberate and act validly only if at least two of its members, including one A Manager

when one is appointed to the board, are physically present or represented in Luxembourg. In case of even number of
Managers voting, the A Manager shall have the casting vote

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications de-
vice) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting, pro-
vided such manager(s) is/are physically present in Luxembourg.

Subject to the foregoing, a meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these

means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Subject to the foregoing, any manager is entitled to appoint another manager of the company as his proxy to valid

participate and vote at the meeting of the board of managers.

Art. 14. Powers of the Board of Managers. Vis-à-vis third parties the board of managers has the most extensive

powers to act on behalf of the company in all circumstances and to do and authorize all acts and operations relative to
the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of managers.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Signature power. For any administrative activities (filings, correspondence, etc. but not dealing with bank

accounts or otherwise disposing or encumbering the company’s assets), the Company will be bound by the single sig-
nature of any Manager. In any other case, the Company will be bound by the joint signature of any two Managers of the
Company (and if the Managers are split in two categories, by the joint signature of one A Manager and one B Manager),
or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the
board of managers or as the case may be by the Managers (and if the Managers are split in two categories, by one A
Manager and one B Manager acting together).

Art. 16. No personal obligation. Any manager does not contract in his function any personal obligation concern-

ing the commitments regularly taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for
the execution of his mandate.

Title IV.- General Meeting of the Shareholders

Art. 17. The shareholders shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section

XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the general meeting of the sharehold-

ers. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a

general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers.

No decision is deemed validly taken until it has been adopted by a majority in number of the shareholders represent-

ing at least three quarters (3/4) of the share capital vote in favour of the resolution.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Art. 18. Annual dividends and Interim dividends. In accordance with the provisions of Article 10, the Managers

may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed prof-
its realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and sums to be allocated to a reserve
to be established by law or by these articles of association. The balance may be distributed to the shareholders upon
decision of a meeting of the board of Managers.

Title V.- Financial Year - Profits - Reserves

Art. 19. Financial year. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December

of each year. Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31st,
2006.

Art. 20. Un-audited interim accounts. On a quarterly basis and for information purposes only, the company will

prepare un-audited interim accounts which do not require to be approved by the general meeting of shareholders.

115990

Art. 21. Balance sheet and profit and loss account. Each year, as of December 31st, the board of managers

will draw up the balance sheet, which will contain a record of the property of the company together with its debts and
liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and debts of the managers to
the company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 22. Inspection. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the

profit and loss account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 23. Legal reserve. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,

amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital. It must be resumed until the re-
serve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it no longer amounts to one tenth of the
share capital.

Art. 24. Dissolution. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more

liquidators who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by ar-
ticle 142 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 25. General reference to applicable law. For all matters not provided for in the present articles of associ-

ation, the parties refer to the existing laws.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as fol-

lows: 

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of GBP 12,500.- (twelve thousand five

hundred Pounds Sterling) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 2,000.- (two thousand Euro). 

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at EUR 18,510.8 (exchange rate of 22 No-

vember 2006: 1 GPB=1.48087 EUR).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at three (3).
2) Are appointed as «managers» for an unlimited period:
- Rolf Caspers, banker, born in Trier, Germany, on 12 March 1968, professionally residing at 2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg, as B Manager

- Vincent De Rycke, banker, born in Gent, Belgium, on 22 March 1973, professionally residing at 2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg, as B Manager and

- Tom Verheyden, banker, born in Diest, Belgium, on 14 August 1974, with professional address at 2, boulevard Kon-

rad Adenauer, L-1115 Luxembourg, as B Manager.

3) The company shall have its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

BONOHURST GP LIMITED, une société exemptée organisée et existante sous le droit des Iles Caïman, immatriculée

auprès du registre des sociétés des Iles Caïman sous le numéro 152253 et ayant son siège social à chez WALKERS SPV
LIMITED, Walker House, 87 Mary street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Iles Caïman, ici représentée par
M

e

 Cécile Jager, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée délivrée aux

Iles Caïman, le 21 novembre 2006.

Shares

BONOHURST GP LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

115991

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant la comparante susnommée et

le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I

er

.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Forme légale. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre
1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Dénomination sociale. La dénomination de la société est ARTEMIS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. Siège social. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. Objet social. La société a pour objet principal d’investir dans des investissements des valeurs actives finan-

cières.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets, participations dans des sociétés du Delaware
et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et accorder garantie par son actif pour son passif et pour celui de

ses associés. 

La société peut ouvrir et maintenir des filiales ou des établissements permanents soit au Luxembourg soit à l’étranger.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre Il.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à GBP 12.500,- (douze mille cinq cents Livres Sterling) divisé en 625 (six

cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 20,- EUR (vingt Livres Sterling) chacune, entièrement
souscrites et libérées.

En plus du capital social, les parts sociales peuvent être émises avec une prime d’émission.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.

Art. 8. La société conserve un registre des associés de la société. Ce registre renseigne sur le nom et le domicile de

l’associé, le nombre de parts sociales qu’il détient dans la société, la date d’acquisition des parts sociales ainsi que tout
transfert de parts sociales à des associés existants ou nouveaux, toute augmentation du capital social et tout autre chan-
gement affectant la propriété des parts sociales. 

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert des parts sociales entre vifs à des non associés ne sera valable qu’avec l’accord des associés représentants

trois-quarts pourcents du capital social de la société.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu’un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas rachetables.

Art. 9. Classes de parts sociales. Le capital social de la société pourra être représenté par des classes de parts

sociales.

Les parts sociales pourront être émises avec une prime d’émission. La prime d’émission payée par les associés d’une

classe sera versée sur un compte de prime d’émission spécifique à cette classe.

A moins que le contexte ne le prévoit autrement, le terme «parts» tel que repris dans les présents statuts se réfère

aux parts sociales de classe A et de classe B.

Sauf disposition contraire contenue dans les présents statuts, les classes de parts sociales ont les mêmes droits, pri-

vilèges, restrictions et obligations.

Art. 10. Droit au dividende et au dividende de liquidation pour chaque classe de parts sociales. Les as-

sociés ont droit au paiement d’un dividende (le «Dividende»), ainsi qu’au produits de liquidation, à un taux proportionnel
à leur investissement, i.e. le capital social émis augmenté de la somme sur le compte de la prime d’émission de ces parts
sociales et de la réserve légale.

115992

Le Dividende est égal aux profits disponibles et distribuables et est payable mensuellement, le onzième (11) jour du

mois subséquent ou à tout autre moment jugé approprié par le conseil de gérance.

Art. 11. Fin de la société. La faillite, l’insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un associé ne mettent pas fin à la so-

ciété.

Art. 12. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent,

sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer d’une quelcon-
que manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

TITRE II.- Administration

Art. 13. Conseil de gérance. La société est administrée par un conseil de gérance composé de deux membres au

moins, associés ou non, qui peuvent être «Gérants A» soit «Gérants B». Le conseil de gérance doit toujours être com-
posé de sorte que au moins un (1) gérant soit résident fiscal luxembourgeois et qu’aucun soit résident au Royaume-Uni.
Si, à un moment quelconque ces critères de résidence fiscale ne sont pas remplis, le gérant en question cessera immé-
diatement ses fonctions et sera remplacé par une décision de l’assemblée des associés. Les gérants sont nommés et
révoqués par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité du capital et qui détermine leurs pouvoirs et la
durée de leur mandat. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux des membres du conseil, y compris

un Gérant A lorsqu’un Gérant A est nommé au conseil, sont physiquement présents ou représentés à Luxembourg. En
cas d’égalité entre les votes des gérants, le vote des gérants A sera prépondérant.

De plus, tout membre du conseil de gérance qui participe à la réunion du conseil de gérance prenant part aux déli-

bérations dudit conseil par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres
membres du conseil de gérance présents (en personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre)
d’entendre et d’être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins
de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l’ordre du jour de la réunion, à condition que ce/ces gérant(s) soient
physiquement présents au Luxembourg.

Sous réserve de ce qui précède, une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence télé-

phonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Chaque gérant est en droit de nommer un autre gérant de la société comme son mandataire pour valablement par-

ticiper et voter à toute réunion du conseil de gérance.

Art. 14. Pouvoirs des gérants. Vis-à-vis des tiers le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir

au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de
la société.

Le conseil de gérance a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les

statuts à l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place au conseil de gérance, les gérants restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 15. Pouvoir de signature. Pour toute activité administrative (dépôt de documents administratifs, correspon-

dances, etc. ne concernant pas les comptes bancaires ou autres dépôts ou hypothèque des actifs de la Société), la Société
sera engagée par la seule signature de tout gérant. Dans tous les autres cas, la Société est valablement engagée par la
signature conjointe de deux gérants de la Société (et si deux catégories de gérants existent, par la signature conjointe
d’un gérant A et d’un gérant B), ou par la seule signature de tout personne ou personnes auxquelles de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil de gérants ou, dans certains cas par les Gérants (et si deux catégories
de gérants existent, par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B).

Art. 16. Pas de responsabilité personnelle. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 17. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale

ou par consultation écrite à l’initiative de la gérance.

Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Art. 18. Dividendes ordinaires et Acomptes sur Dividendes. Conformément à l’article 10, les gérants peuvent

décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les gérants montrant que des

115993

fonds suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier exercice social, la date de constitu-
tion, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire. Le solde peut être distribué aux associés par décision
prise par le conseil de gérance.

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 19. Année comptable. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année,

à l’exception du premier exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

Art. 20. Comptes intérimaires non audités. Chaque trimestre et uniquement à titre d’information, la société

dresse des comptes intérimaires non audités qui ne feront pas l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des
associés.

Art. 21. Etat financier et compte de profits et pertes. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un

état financier qui contiendra un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un compte de pertes et profits,
accompagné d’une annexe contenant un résumé de tous les engagements et dettes contractés par le conseil de gérance.

En même temps, le conseil de gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée générale

des associés en même temps que le bilan. 

Art. 22. Chaque associé aura le droit de consulter, au siège social, l’inventaire, le bilan ainsi que le compte de pertes

et profits, pendant la quinzaine précédent l’assemblée générale annuelle.

Art. 23. Réserve légale. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital. Il devra toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve n’atteint plus le
dixième du capital.

Art. 24. Dissolution. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de GBP 12.500,- (douze mille cinq cents Livres

Sterling) par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment
tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à EUR 2.000,- (deux mille euro). Pour
les besoins de l’enregistrement, le montant du capital est évalué à EUR 15.510,8 (cours de change du 23 novembre 2006:
1GBP=1,48087 EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire et il a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Rolf Caspers, banquier, né à Trêves, Allemagne, le 12 mars 1968, demeurant professionnellement à 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Gérant B;

- Vincent De Rycke, banquier, né à Gent, Belgique, le 22 mars 1973, demeurant professionnellement à 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Gérant B et

- Tom Verheyden, banquier, né à Diest, Belgique, le 14 août 1974, demeurant professionnellement à 2, boulevard

Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Gérant B.

3) Le siège social de la société est établi à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, lesdits

comparants ont signés avec le notaire le présent acte.

Parts sociales

de classe A

BONOHURST GP LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

625

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

625

115994

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 45, case 4. – Reçu 185,21 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128843.3/202/397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

itmedia, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 6, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 111.535. 

Il résulte d’une décision des associés prise en date du 25 octobre 2006 que le siège de la société est transféré au 6,

rue Beck, L-1222 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07066. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118297.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

WPP LUXEMBOURG GAMMA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.-.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 108.483. 

In the year two thousand and six, on the thirtieth of October.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG GAMMA

TWO, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at
6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B 108.483 (the Company), incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Association n

o

 1124 of 31 October 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been amend-

ed several times and for the last time on 14 February 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association n

o

 1019 of 24 May 2006.

There appeared WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 79.018 (the Sole Shareholder), hereby represented by Olivier Wui-
dar, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 24 October
2006.

The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the 250 shares of USD 100.- each in the share capital of the Company amounting

to USD 25,000.-.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment of article 14 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on 31st October of

each year and as a result the current financial year of the Company, having started on 1st March 2006, shall be closed
on 31st October 2006; and

3. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder

waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Senningerberg, le 27 novembre 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Signature.

115995

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves (i) to set the date of the closing of the Company’s financial year on 31st October of

each year and as a result to close the current financial year of the Company, having started on 1st March 2006, on 31st
October 2006 and (ii) to amend article 14 of the Articles accordingly.

As a consequence, article 14 of the Articles will henceforth have the following wording:
«Art. 14. Financial year. The Company’s financial year begins on 1st November each year and ends on 31st Oc-

tober of the following year.»

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de WPP LUXEMBOURG GAMMA

TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.483 (la
Société), constituée le 26 mai 2005 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1124 du 31 octobre 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois
le 14 février 2006 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxem-
bourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1019 du 24 mai 2006.

A comparu WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec

siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 79.018 (l’Associé Unique), ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

La procuration de l’Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de

l’Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps
avec celui-ci.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les 250 parts sociales de USD 100,- chacune dans le capital social de la Société

s’élevant à USD 25.000,-;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 14 des Statuts afin que l’exercice social de la Société se termine le 31 octobre de chaque

année et en conséquence, l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1

er

 mars 2006, prendra fin le 31

octobre 2006; et

3. Divers.
III. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique renonce aux

formalités de convocation, l’Associé Unique représenté à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqué et
déclarant avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique décide (i) de fixer la date de clôture de l’exercice social de la Société au 31 octobre de chaque

année et par conséquent de clôturer l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1

er

 mars 2006, au 31

octobre 2006 et (ii) de modifier en conséquence l’article 14 des Statuts.

Par conséquent, l’article 14 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 novembre de chaque année et se termine

le 31 octobre de l’année suivante.»

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par

la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la requête de la même partie comparante, en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.

115996

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire,

l’original du présent acte.

Signé: O. Wuidar, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 7 novembre 2006, vol. 471, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126626.3/5770/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

WPP LUXEMBOURG GAMMA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 108.483. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22

novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126627.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

IWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.416. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07966, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(118302.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 117.399. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the 17th of October.
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TAROS CAPITAL HOLDING B.V., a private limited liability Company incorporated under the laws of The Nether-

lands, with registered office at Strawinskylaan 377, (1077X) Amsterdam, The Netherlands,

here represented by the company of limited liability (S.A.) of Luxembourg law with denomination MANACOR (LUX-

EMBOURG) S.A., 46a, avenue J.F. Kennedy, represented by Mr Wim José August Rits, employee, residing in Luxem-
bourg, 46a, avenue J.F. Kennedy,

by virtue of a proxy given on 12th and 17th October, 2006, which will remain attached to the present deed,
hereafter named «the sole partner»,
Which appearing people, have requested the notary to state as follows
That the company TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l., with registered office in Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin,

R.C.S. Luxembourg B n

o

 117399, was incorporated by deed of M

e

 Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg-

City, on June 15th 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C on August 28th 2006, page
78054.

That the corporate capital of TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l., amounts to EUR 12,500.-, divided into 500

corporate units with a nominal value of EUR 25.- each, entirely paid-up.

That the undersigned, TAROS CAPITAL HOLDING B.V. is the sole owner of all the corporate units representing

the corporate capital of the company TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l.,

That the undersigned has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities;
That the undersigned TAROS CAPITAL HOLDING B.V. is to be appointed as liquidator of the Company;
That the undersigned herewith declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect and its

putting into liquidation;

Remich, le 17 novembre 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 17 novembre 2006.

M. Schaeffer.

Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour ordre
Signature
<i>Administrateur

115997

That it is witnessed that the undersigned is vested with all the assets of the Company and that the undersigned shall

guarantee payment of all liabilities of the Company even if unknown at present;

That the liquidation of the Company is completed and that the Company is to be construed as definitely terminated

and liquidated;

The declarations of the liquidator have been verificated, pursuant to a report that remains attached as appendix, by

Mr Wim José Auguste Rits, residing at 46a, av. J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, acting as «commissaire to the disso-
lution»;

That full and entire discharge is granted to the incumbent Managers for the performance of their respective assign-

ments;

That the corporate documents shall be kept at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg for the duration of five

years.

That MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. is authorized in the name and on behalf of the sole shareholder to file any

tax declaration, notice to the trade register and any other documents necessary or useful for the finalisation of the
liquidation;

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and

registration.

Drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of the presents.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his

surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the
present deed.

Follows the translation in French: 

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

TAROS CAPITAL HOLDING B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social au 377, Strawinskylaan,

(1077X) Amsterdam, The Netherlands,

ici représentée par la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., 46a,

avenue J.F. Kennedy, elle-même représentée par Mr Wim José August Rits, employé privé, demeurant à Luxembourg,
46a, avenue J.F. Kennedy,

en vertu d’une procuration donnée le 12 et 17 octobre 2006, laquelle procuration reste annexée au présent acte,
ci-après nommée «l’associé unique».
Laquelle comparante a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
Que la Société dénommée TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin,

inscrite au R.C.S. Luxembourg B n

o

 117399, a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger,

notaire de résidence à Luxembourg, le 15 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C de 2006,
page 78054.

Que le capital social de la Société TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l. est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, toutes entièrement libérées.

Que le soussigné, TAROS CAPITAL HOLDING B.V. est le seul propriétaire de toutes les parts sociales représentant

l’intégralité du capital social de TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l.

Que l’associé unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
Que l’associé unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
Que l’associé unique est investi de tout l’actif et par rapport au passif actuel ou inconnu à la date de ce jour, il assume

irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif.

Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par Mr Wim José Auguste Rits, demeurant au 46a, av. J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, désigné «commissaire à la
liquidation»;

Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société pour l’exécution de leurs mandats.
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans au 2, rue Joseph Hackin à Luxembourg.
Que la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. est autorisée, en nom et pour compte de l’associé unique, a faire

toutes déclarations d’impôts, notification au Registre de Commerce ou tous autres documents nécessaires ou utiles à
la clôture de la liquidation.

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.

115998

Lecture faite en langue du pays au comparant, tous connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeu-

re, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: W. J. A. Rits, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126378.3/208/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

TRIDENT LI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LIG LUX LIMITED, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 120.319. 

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of October.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of LIG LUX LIMITED, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 12, rue Léon Thyes in L-2636 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120.319 (the Company). The Company has
been incorporated on September 29, 2006 pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, not
yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

There appeared:

TRIDENT III, L.P., having its registered office at WALKERS SPV LIMITED, Walkers House, Mary Steet, P.O. Box 908

GT, George Town, Gran Cayman, Cayman Islands, incorporated under the laws of the Cayman Islands as a Limited Part-
nership (the Sole Shareholder), hereby represented by Ms Habiba Boughaba, Attorney at Law, with professional address
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 24th, 2006, which proxy, after having been signed ne varietur by
the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the Company’s name into TRIDENT LI, S.à r.l., and subsequent amendment of article 1 of the Articles;

and

2. Miscellanous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First and sole resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name into TRIDENT LI, S.à r.l., and resolves to amend and

hereby amends article 1 of the Articles, which will henceforth read as follows:

«Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

TRIDENT LI, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present ar-
ticles of association (hereafter the Articles).»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately seven hundred euro (700.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de LIG LUX LIMITED, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxem-
bourg, ayant un capital social de EUR 12.500,00, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 120.319 (la Société). La Société a été constituée le 29 septembre 2006 par acte de M

e

 Gérard Lecuit,

notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

J. Delvaux.

115999

A comparu:

Trident III, L.P., ayant son siège social à WALKERS SPV LIMITED, Walkers House, Mary Steet, P.O. Box 908 GT,

George Town, Gran Cayman, Cayman Islands, constituée sous les lois des Iles Cayman comme un Limited Partnership
(l’Associé Unique), ici représentée par M

e

 Habiba Boughaba, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration donnée le 24 octobre 2006.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en TRIDENT LI, S.à r.l., et modification subséquente de

l’article 1

er

 des Statuts;

2. Divers
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première et unique résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 1

er

 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination TRIDENT LI, S.à

r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui pourraient incomber à la Société à la suite du pré-

sent acte sont estimés à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergen-
ces entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec Nous, le notaire.
Signé: H. Boughaba, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 31 octobre 2006, vol. 471, fol. 14, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126645.3/5770/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

JRJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3788 Tétange, 26, rue du Soleil.

R. C. Luxembourg B 50.449. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04103, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(118372.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

NESEY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.455. 

Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social

à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118732.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Remich, le 23 novembre 2006.

M. Schaeffer.

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature

<i>Pour NESEY HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

116000

BRITISH VITA (LUX IV), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.581. 

EXTRAIT

Les associés de la Société ont décidé en date du 17 octobre 2006 de révoquer M. David Spuria et M. William Price

de leurs fonctions de gérant de classe A et de nommer les gérants suivants pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de classe A:

- M. John Oliver, demeurant au 51, Buckingham Gate, Londres SW1E 6AF;
- M. Michael Browning Farnell, Jr., demeurant au 301 Commerce Street, Suite 3300, Forth Worth, Texas 76102;
- M. Norman Walker, demeurant à Hölzistrasse 56, 4102 Binningen, Suisse.

<i>Gérant de classe B:

- Mme Pascale Nutz, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118430.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

COREFI-FINANCE S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 68.668. 

L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COREFI-FINANCE S.A., avec

siège social à L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 68.668, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 février 1999, publié au Mémorial C, numéro 359 du 20 mai 1999 et
dont les statuts ont été modifiés suivant résolution de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du
1

er

 juin 2001, publiée au Mémorial C, numéro 26 du 5 janvier 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Heynen, indépendant, demeurant à Hondelange (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Elsen, indépendant, demeurant à Steinfort.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et trois cents (EUR

37.184,03), représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille cinq cents (1.500) actions de la société sont présentes

ou représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valable-
ment sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Jean-Marie Heynen, indépendant, né à Arlon (Belgique),

le 14 mars 1954, demeurant à B-6780 Hondelange, rue des Rochers, 103.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Pour la société
Signature

116001

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION,

S.à r.l., avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 26.096, comme
commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à huit cents euros (EUR 800,-), sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent

acte.

Signé: J.-M. Heynen, J.-M. Weber, J. Elsen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 31 octobre 2006, vol. 437, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(127482.3/236/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

PROMETHEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.704. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social, le 4 octobre 2006

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. L’Assemblée accepte la démission de son poste d’Administrateur:
- Madame Carine Ribeiro-Belaroussi, employée privée, née le 18 décembre 1967 à Berchem-Sainte Agathe, demeu-

rant rue de l’Ermitage, 354, B-6717 Heinstert.

- L’Assemblée prend connaissance et accepte la démission de Madame Jacqueline Delaruelle, pensionnée, née le 22

septembre 1942 à Ixelles, demeurant au 122, rue de la Meuse, B-6700 Arlon.

- Election du Conseil d’Administration pour une nouvelle période de six ans:
Sont élus Administrateurs:
- Monsieur Serge Ribeiro, Administrateur de sociétés, né le 14 octobre 1959 à Anvers (Belgique), demeurant rue des

Deux Luxembourg, 39, B-6700 Arlon.

- Monsieur Simon Ribeiro, étudiant, né le 18 mars 1988 à Bruxelles, demeurant rue des Deux Luxembourg, 39,

B-6700 Arlon.

- Mademoiselle Rosine Werbrouck, étudiante, née le 19 juin 1985 à Douala (Cameroun), demeurant rue Saint Dié,

40, B-6700 Arlon.

2. L’Assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes:
- Madame Corinne Chantereau, comptable, née le 6 août 1963 à Roubaix (France), demeurant à L-3376 Leudelange,

36 domaine Op Hals.

L’Assemblée élit en remplacement:
- LAMPERTSBIERGER BROUTKESCHT, S.à r.l., société avec siège social au 19, avenue Pasteur, L-2982 Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés n

°

 B 65.326.

3. Le Conseil d’Administration décide de réélire Monsieur Serge Ribeiro, aux fonctions d’Administrateur-Délégué

avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

4. Les mandats des nouveaux membres du Conseil d’Administration, du Commissaire aux Comptes et de l’Adminis-

trateur-Délégué prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

5. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et la Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01600. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(119101.3//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

Bascharage, le 14 novembre 2006.

A. Weber.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur 

116002

IBERTRANS (LUXEMBOURG) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1530 Luxembourg-Bonnevoie, 55, rue Anatole France.

R. C. Luxembourg B 31.122. 

EXTRAIT

Suite à la cession d’une (1) part sociale de la société IBERTRANS (LUXEMBOURG), S.à r.l. par la société TREVUS

MANAGEMENT SERVICES S.A., société anonyme, immatriculée à Belize, I.B.C. 39 558, à la société CENDIRA INTER-
NATIONAL LTD, société anonyme, immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, I.B.C. 1148 560, en date du 20 septem-
bre 2006:

- La société TREVUS MANAGEMENT SERVICES S.A., société anonyme, immatriculée à Belize, I.B.C. 39 558, n’est

plus associé de la société mentionnée sous rubrique;

- La société CENDIRA INTERNATIONAL LTD, société anonyme, immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, I.B.C.

1148 560, détient vingt mille six cent soixante-treize (20.673) parts sociales de la société IBERTRANS (LUXEMBOURG),
S.à r.l. et en devient l’associé unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118499.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

INCOMEX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.775. 

Par la présente, nous dénonçons le siège social de la société INCOMEX S.A. avec effet immédiat.

Le 30 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07900. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118526.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

LENS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 99.938. 

Par la présente, nous dénonçons le siège social de la société LENS S.A., avec effet immédiat.

Le 30 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07902. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118528.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

PEGUFORM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.244. 

Suite à la résolution de l’associé unique de RIVER INVESTMENTS, S.à r.l. en date du 17 août 2006:
RIVER INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée

R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 97.587, associé unique de La Société, a changé sa dénomination sociale en PEGU-
FORM LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05041. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(119834.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

116003

TIME INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 74.087. 

Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social

à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07739. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118761.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2006.

NEW TERRA-NOVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1272 Luxembourg, 20, rue de Bourgogne.

R. C. Luxembourg B 106.513. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02387, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119215.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

EUROPEAN MIDDLE EAST INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.545. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’ assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2005

<i>Quatrième résolution

L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs:
Nom: Monsieur Henry Y. Obegi, né le 24 juin 1926 à Alep Syrie;
Fonction: Président du conseil d’administration;
Adresse: Immeuble Esseily, Place Riad El Solh, Beyrouth/Liban.

Nom: Monsieur Issam Kabbani, né le 10 octobre 19234, en Arabie Saoudite;
Fonction: Administrateur;
Adresse: National Marketing, 21464 Jeddah, Arabie Saoudite.

Nom: Monsieur Béchara Y. Obegi, né le 12 octobre 1922, en Syrie;
Fonction: Administrateur;
Adresse: Immeuble Esseily, Place Riad El Solh, Beyrouth/Liban.

Nom: Monsieur Ara Hrechdakian, né en 1924, au Liban;
Fonction: Administrateur;
Adresse: Immeuble Esseily, Place Riad El Solh, Beyrouth/Liban.

Expiration: la date de l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Elle prend acte avec regret du décès de Monsieur Pierre Khoury, administrateur. Elle pourvoira à son remplacement

lors d’une assemblée ultérieure.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société PricewaterhouseCoopers AUDIT, Fran-

ce;

Adresse: 34, Place des Corolles, Tour AIG, F-92908 Paris la Defense;
Expiration: la date de l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09083. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(119352.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

<i>Pour TIME INVEST HOLDING, S.à r.l.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pétange, novembre 2006.

Signature.

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

116004

COMPAGNIE HOLDING FINANCIERE HIRSCH SNCA, Société en Commandité par Actions.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 79.599. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03044, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119277.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

IMMOBILIERE BUCHHOLTZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 44, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 8.003. 

Constituée suivant acte sous seing privé, en date du 16 juin 1968, acte publié au Mémorial C n

°

 125 du 27 août 1968,

modifiée par-devant M

e

 Carlo Funck en date du 6 juin 1974, acte publié au Mémorial C n

°

 177 du 5 septembre

1974, modifiée par acte sous seing privé en date du 20 novembre 1975, modifiée par-devant M

e

 Carlo Funck en

date du 7 mars 1978, acte publié au Mémorial C n

°

 112 du 30 mai 1978, modifiée par-devant M

e

 Paul Friederes en

date du 28 avril 1982, acte publié au Mémorial C n

°

 159 du 14 juillet 1982, modifiée par-devant M

e

 Paul Friederes

en date du 10 octobre 1983, publié au Mémorial C n

°

 344 du 25 novembre 1983, modifiée par-devant le même

notaire en date du 25 juin 1986, acte publié au Mémorial C n

°

 271 du 24 septembre 1986, modifiée par-devant M

e

Jacques Delvaux en date du 30 avril 1992, publié au Mémorial C n

°

 443 du 5 octobre 1992, modifée par acte sous

seing privé en date du 29 mai 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 569 du 13 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00100, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2006.

(119281.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

REDBOX WINE AND FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 21, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 96.412. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08814, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(119459.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

AGEFI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.337. 

La soussignée AGEFI LUXEMBOURG S.A., R.C. Luxembourg B 28.850, en tant que domiciliataire de la société EDIFI

(LUXEMBOURG) S.A., R.C. Luxembourg B 39.337, avec siège social 111B, route d’Arlon, L-8311 Capellen, déclare par
la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01290. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(119482.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IMMOBILIERE BUCHHOLTZ
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

<i>Pour la société
Signature

AGEFI LUXEMBOURG S.A.
Adelin Rémy
<i>Administrateur Délégué

116005

DVL.TV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 56.229. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 13 septembre 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 13 septembre 2006 que le conseil d’adminis-

tration de la société a été élargi à 11 membres et est composé dorénavant - pour un terme venant à échéance à l’as-
semblée générale annuelle ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2010 - de M. Jean Stock, Président et
Administrateur-délégué, demeurant à L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg, Mme Marie-Thérèse Arnoux-
Stock, demeurant à L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg, Mme Anne-Claire Stock-Berg, demeurant à NY
10005 New York, 10 Liberty Street (USA), M. Jean-Baptiste Stock, Directeur général, demeurant à L-2311 Luxembourg,
47, avenue Pasteur, M. Gust Graas, demeurant à L-1638 Senningerberg, 45, rue du Golf, M. Jacques Neuen, demeurant
à L-1420 Luxembourg, 286, avenue Gaston Diderich, M. David Henderson-Stuart, demeurant à 125009 Moscou (Rus-
sie), 23, bldg. 1, Bolshaya Dmitrovka str., M. Charles Ruppert, demeurant à L-5433 Niederdonven, 59, rue des Romains,
M. Helmut Thoma, demeurant à D-50354 Hurth-Berrenrath, Burg Schallmauer, M. Freddy Thyes, demeurant à L-2551
Luxembourg, 47, avenue du X Septembre, M. Nathanaël Karmitz, demeurant à F-75012 Paris, 55, rue Traversière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01477. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(119441.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

P-BUILD HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. APOTECA S.A.).

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 120.187. 

In the year two thousand six, on the twenty six of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of APOTECA S.A., a société anonyme, having its reg-

istered office at Luxembourg, in process of registration at the Trade Register of Luxembourg section B, incorporated
by deed dated on September 6th 2006, in process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Pierre-Olivier Wurth lawyer, residing in L-2449 Luxembourg 25B, boulevard Royal.
The chairman appoints as secretary Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Julien Boeckler, Maître en droit, residing at L-1725 Luxembourg 26, rue Henri VII
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 310 (three hundred and ten) shares, representing the whole capital

of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the name of the Company from APOTECA S.A. to P-BUILD HOLDING S.A.
2.- Change of the registered office of the company to L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.
3.- Dismiss of the Directors and discharge.
4.- Nominations of four new Directors.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the company from APOTECA S.A. to P-BUILD HOLDING S.A.
The meeting decides to amend the first article of the articles of incorporation to reflect this resolution.

<i>Second resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal

to L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

<i>Third resolution

The meeting decides to accept the dismiss of the following directors in place and gives them discharge for their

activities during their mandate:

1.- Mr. Jim Penning
2.- Mr. Pierre Olivier Wurth
3.- Mr. Philippe Penning

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Mandataire

116006

<i>Fourth resolution

The meeting decides to nominate for an unlimited period as new directors:
- Mister Bart Berten, born in Kuurne on the 24 December 1964, residing in B-3941, Hechtel-Eksel, Overpelterbaan,

28.

- Mister Gerrit Veltrup, born in Borken, on the 10 November 1980, residing in D-22559 Hamburg, Adebarweg, 8.
- Mister Norbert Biesemann, born in Bottrop on the 14 August 1946, residing in D-46485 Wesel, Quadenweg, 46.
- Mister Walter Missorten, born in Antwerpen on the 4 March 1938, residing in B-1785 Merchtem, Weyenberg, 28.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt-six octobre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme APOTECA S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, en cours d’immatriculation au R.C.S. de Luxembourg section B constituée suivant acte reçu
le 6 septembre 2006, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal
Le président désigne comme secrétaire Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Julien Boeckler Maître en Droit demeurant à L-1725 Luxembourg, 26, rue

Henri VII

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale d’APOTECA S.A. en P-BUILD HOLDING S.A.
2.-Transfert du siège social à L- 1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich
3.- Démission et décharge accordée aux administrateurs en place.
4.- Nomination de quatre nouveaux administrateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en P-BUILD HOLDING S.A., et de modifier en conséquence

le premier article des statuts.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 25 B, boulevard Royal à L-1450 Luxembourg,

28, Côte d’Eich.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prend acte de la démission des administrateurs en place suivants et leur consent décharge pour leurs

activités dans le cadre de leur mandat:

1.- Monsieur Jim Penning
2.- Monsieur Pierre-Olivier Wurth
3.- Monsieur Philippe Penning

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer quatre nouveaux administrateurs pour une durée indéterminée:
- M. Bart Berten, né à Kuurne le 24 décembre 1964, demeurant à B-3941, Hechtel-Eksel, Overpelterbaan, 28.
- M. Gerrit Veltrup, né à Borken le 10 novembre 1980, demeurant à D-22559 Hamburg, Adebarweg, 8.
- M. Norbert Biesemann, né à Bottrop le 14 août 1946, demeurant à D-46485 Wesel, Quadenweg, 46.
- M. Walter Missorten, né à Antwerpen le 4 mars 1938, demeurant à B-1785 Merchtem, Weyenberg, 28.

116007

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: P.-O. Wurth, F. Gibert, J. Boeckler, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, vol. 155S, fol. 88, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126212.3/211/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

HAAG FRERES, MENUISERIE MODERNE DE MEUBLES ET DE CONSTRUCTIONS, TRANSPORTS, 

Société en nom collectif (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 7, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 5.212. 

Assemblée générale extraordinaire des associés de la société en nom collectif HAAG FRERES, MENUISERIE MO-

DERNE DE MEUBLES ET DE CONSTRUCTIONS, TRANSPORTS, ayant eu son siège social à Luxembourg, 7, Montée
de Clausen (numéro d’identité: 19422000 022), constituée suivant acte reçu par notaire Edmond Reiffers à cette époque
notaire à Luxembourg juillet 1942 (en liquation).

Madame Marie Josée Caroline Haag, sans état particulier, née à Luxembourg, le 28 avril 1938 (numéro d’identité:

19380428 280), demeurant à Luxembourg, 18, rue Jean Pierre Pier,

ayant hérité de toutes les parts sociales de la société de ses parents Monsieur Joseph Haag est décédé le 21 avril 1989

et Madame Louise Theisen décédée le 29 novembre 2005,

et son époux Monsieur Alfred Joseph Maximilien dit Fred Berchem, kinésithérapeute, né à Luxembourg, le 17 no-

vembre 1934 (numéro d’identité: 19341117 014), demeurant avec elle à Luxembourg, 18, rue Jean Pierre Pier,

avec lequel elle déclare être mariée sous le régime de la communauté universelle de biens,
décident à l’unanimité de se nommer liquidateurs de la société avec pouvoir de l’engager en toutes circonstances sous

leurs signatures conjointes.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(119649.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

SPX FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 97.386. 

In the year two thousand and six, on the 16th of October.
Before M

e

 Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SPX CANADA PARTNER II CO, with registered office at 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax B3J2X2, Nova

Scotia, Canada,

here represented by the duly mandated Mr Gregor Berke, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on October 5th 2006, which proxy will remain annexed o this document

to be filed with the registration authorities.

The appearing party declares to be the sole associate of the company SPX FINANCE, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée under Luxembourg law with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy in L-1855 Luxembourg.

The company is registered in the Trade Register of Luxembourg under the number B 97.386, and was incorporated

pursuant to a deed of the notary Paul Bettingen on December 1, 2003, residing in Niederanven (Grand Duchy of Lux-
embourg) published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of January, 13, 2004 Number 42. The Ar-
ticles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the aforementioned notary M

e

 Paul

Bettingen on December 28, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of April 26, 2006,
Number 835.

The associate requests the notary to document the following resolutions

<i>First resolution

In compliance with the Law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended, the sole associate resolves

to dissolve the company.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

J. Elvinger.

Signatures.

116008

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole associate resolves to appoint as liquidator the company:
ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet with registered in the Trade Register of

Luxembourg under the number B 88.074.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of 10 August, 1915 on

Commercial Companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the sole associate

in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically, renounce all the real rights, preferential

rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille six, le seize octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SPX CANADA PARTNER II CO, ayant son siège social au 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax B3J2X2, Nova

Scotia, Canada,

ici représentée par M Gregor Berke, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 5 octobre 2006, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante déclare être la seule associée de la société luxembourgeoise SPX FINANCE, S.à r.l., avec siège

social à L1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

La société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le B n

o

 97.386, et a été cons-

tituée suivant acte reçu par M

e

 Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 1

er

 décembre 2003 publié au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 42 du 13 janvier 2004. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le susmentionné notaire M

e

 Paul Bettingen en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations du 26 avril 2006, numéro 835.

L’associée unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’associé unique

décide de dissoudre la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’associé unique décide de nommer comme liquidateur la société:
ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

à Luxembourg sous le numéro B 88.074.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les

cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droit réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

116009

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état et

demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Berke, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 4, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126240.3/208/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

KAUPTHING LIFE &amp; PENSION, LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 40.460. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 mai 2006:
- a mis fin au mandat des administrateurs suivant:
* M. Johnie Brogger, résidant au 8, rue des Nations Unies, L-7270 Walferdange, Luxembourg;
* M. Sigurdur Einarsson, résidant au 7 Coleridge Square, 552 Kind Road, London SW10 ORT, Royaume-Uni;
- a élu comme nouveaux admistrateurs:
* M. Orn Gustafsson, résidant au Gljufrasel 1, IS-109 Reykjavik, Iceland;
* M. Eggert J. Hilmarsson, résidant professionnellement à KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., 35A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg;

* M. Bjorn Jonsson, résidant professionnellement à KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., 35A, avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg;

et comme commissaire aux comptes KPMG AUDIT, S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemboug;
- a décidé du transfert du siège social à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 6, rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg à sa nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à comp-
ter du 24 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(119510.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

BISTRO 88, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 88, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 93.584. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07047, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(119672.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2006.

MEDIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.257. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00928, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119854.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

J. Delvaux.

KAUPTHING LIFE &amp; PENSION, LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
M. Welter
<i>La Gérante

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Signature.

116010

BRESSOLES DECORATION S.A., Société Anonyme,

(anc. BRESSOLES INVEST S.A.).

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 98.524. 

L’an deux mille six, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRESSOLES INVEST S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2003,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 221 du 24 février 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Karine Arroyo, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Putzeys, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Benoît Castelain, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 18, rue Michel Rodange.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision relative au changement de dénomination sociale de BRESSOLES INVEST S.A. en BRESSOLES DECORA-

TION S.A.

2.- Décision relative à la modification de l’objet social.
3.- Modification de l’article 1

er

 et de l’article 2 des statuts pour les mettre en concordance avec le changement de

dénomination sociale.

4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de BRESSOLES INVEST S.A. en BRESSOLES DECORATION

S.A.

Le premier alinéa de article 1

er

 des statuts est modifié en conséquence comme suit:

II existe une société anonyme, sous la dénomination de:
BRESSOLES DECORATION S.A.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la Société et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts

comme suit:

«La société a pour objet principal le commerce en général ainsi que toutes activités se rapportant directement ou

indirectement à cet objet.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La société a aussi pour objet la détention, l’exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles, de

terrains et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi qu’à toutes les opérations financières, mobilières et
immobilières y rattachées directement ou indirectement.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de

placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.

La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-

sances de dettes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

116011

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: K. Arroyo, L. Putzeys, B. Castelain, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 octobre 2006, vol. 438, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127477.3/242/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

BRESSOLES DECORATION S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 98.524. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127478.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

NTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 20, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 64.548. 

<i>Procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 2006

L’an 2006, le vingt-neuf août, à 18 heures, au siège social, 20, route de Thionville, L-6791 Grevenmacher, les admi-

nistrateurs de la société NTEL S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de l’administra-
teur-délégué.

Ils reconnaissent avoir été régulièrement convoqués.
- Madame Michèle Liardet, préside l’Assemblée,
- Monsieur Thierry Richon, est désigné comme secrétaire, 
- Monsieur James Morlaix, est appelé pour remplir les fonctions de scrutateur.
La totalité des actions composant le capital social est représentée, et Madame Michèle Liardet en sa qualité d’admi-

nistrateur-délégué, préside la séance. Elle constate que conformément à la législation en vigueur sur les sociétés, l’As-
semblée peur valablement délibérer à la majorité de la moitié des actions.

Le Président rappelle les points inscrits à l’ordre du jour et propose de passer aux discussions et au vote:

<i>Ordre du jour:

1. Démission d’un administrateur, nomination d’un nouveau administrateur.
2. Révocation du Commissaire aux Comptes, nomination du nouveau commissaire aux comptes.

<i>Décisions

Après discussion et délibération, l’assemblée générale, à l’unanimité, décide: 
1. Nomination d’un nouveau administrateur: 
Administrateur:
La société GLENN MCRICH INTERESTS, INC (#P96000040431) avec siège social à Clearwater, 2189 Logan Street,

FL-33765 Etats-Unis.

En remplacement de l’administrateur démissionnaire: Monsieur Thierry Richon, prédit.
2. Nomination du nouveau commissaire aux comptes:
AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., Expert-Comptable, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire: 
- La Société INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H., 20, route de Thionville, L-6791 Grevenmacher.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 18 heures 18.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal en 2 exemplaires lequel après lecture a été signé par

les membres du bureau pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Luxembourg, le 29 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00128. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(119810.3//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Mersch, le 6 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 6 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
M. Liardet / Th. Richon / J. Morlaix
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur 

116012

MEDIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.257. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00931, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119855.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

FÜRLEHRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 50.054. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06390, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120204.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

PACOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 53.521. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01385, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(120278.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

CCom HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 25.000,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 106.978. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 

15 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 758 du 29 juillet 2005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02110, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120479.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

ING REEIF SOPARFI B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.112. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00883, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120510.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Signature.

Strassen, le 27 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature

CCom HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

116013

KOCH HC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 2,226,450.-.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 108.198. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of the month of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KOCH EQUITY INVESTMENTS HOLDING (BERMUDA), L.P. («KEIHBLP»), a limited partnership established under

the laws of Bermuda, having its registered office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, 

here represented by Ms Laure Gérard, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established on August 22, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxem-

bourg under the name of KOCH HC, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 108.198,
incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg) on May 9, 2005, published in the Mémorial C No 1017 of October 11, 2005 and whose articles of association
have been last amended pursuant to a deed of the same notary on June 2, 2005, published in the Mémorial C No 1103
of October 27, 2005.

- The share capital of the Company presently amounts to two million two hundred twenty-six thousand four hundred

and fifty Euro (EUR 2,226,450.-) represented by eighty-nine thousand and fifty-eight (89,058) shares with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

- The appearing party is currently the sole owner of all the shares of the Company.
- The appearing party, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated

dissolution and liquidation of the Company.

- The appearing party, as the liquidator of the Company, declares that all known third party liabilities of the Company

have been settled.

- The appearing party, as the sole shareholder of the Company, declares that the activity of the Company has ceased

and all assets of the Company, including amongst others loan agreement by and between the Company and KEIHBLP
whereby KEIHBLP acquired the Company’s partnership interest in KOCH REGIONAL C.V., a limited partnership es-
tablished in The Netherlands with registered office at Teleportboulevard 140, NL-1043 EJ Amsterdam, for an amount
equal to the loan amount which is hereby transferred to its sole shareholder, who is personally liable for all liabilities
and engagements of the Company, even those actually unknown, in the same way as the latter was liable; accordingly,
the liquidation of the Company is considered to be closed.

- The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of

today.

- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

Company’s former registered office.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholder meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KOCH EQUITY INVESTMENTS HOLDING (BERMUDA), LP., («KEIHBLP»), un «limited partnership» constitué et

existant en vertu des lois des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11,
lles Bermudes,

ici représenté par Mademoiselle Laure Gérard, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 22 août 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

116014

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- Le comparant est actuellement le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la

dénomination de KOCH HC, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 108.198, constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 9
mai 2005, publié au Mémorial C n

°

 1017 du 11 octobre 2005 et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu par acte

du même notaire le 2 juin 2005, publié au Mémorial C n

°

 1103 du 27 octobre 2005.

- La Société a actuellement un capital social de deux millions deux cent vingt-six mille quatre cent cinquante euros

(EUR 2.226.450,-) représenté par quatre-vingt-neuf mille cinquante-huit (89.058) parts sociales d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

- Le comparant est actuellement propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- Par la présente le comparant prononce la dissolution et liquidation anticipée de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif connu de la Société vis-à-vis de

tiers est réglé.

- L’activité de la Société a cessé; l’associé unique est investi de tout l’actif, comportant entre autres un contrat de

prêt entre la Société et KEIHBLP sur base duquel HEIHBLP a acquis la participation de la Société dans KOCH REGIO-
NAL C.V., une société en commandite établie aux Pays-Bas ayant son siège social à Teleportboulevard 140, NL-1043 EJ
Amsterdam, pour un montant identique au contrat de prêt, laquelle participation est par la présente transférée au seul
associé qui répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle, de la
même manière que celle-ci y était tenue; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l’ancien siège social de

la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date du dessus. 
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Gérard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, vol. 155S, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127485.3/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

EYE.MAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange, 48, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 80.958. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05063, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120728.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

IMMO-OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5692 Elvange, 16, rue d’Ellange.

R. C. Luxembourg B 88.986. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05720, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120738.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Signature.

Elvange, le 10 novembre 2006.

Signature.

116015

SOCIETE IMMOBILIERE BELLEVUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 28.142. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00030, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(120561.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

BORLETTI GROUP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 116.174. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 22 septembre 2006

Monsieur Marco Sterzi, employé privé, résident 18, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, a démissionné de ses

fonctions d’administrateur. M. Maurizio Borletti, entrepreneur, résident Hanoverstreet 10 à Londres (Grande-Breta-
gne), est nommé administrateur, il terminera le mandat de M. Sterzi.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120650.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

LYX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.408. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the thirteenth of September.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ILYX S.A., a company with registered office in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, registered in the Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 95.985, represented by Mr Lennart Stenke, managing
director, with professional address in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and

statements:

That the company LYX, S.à r.l., with registered office in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, registered in the

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 74.408 has been incorporated by deed of
the notary Gérard Lecuit, before residing in Hesperange, dated February 2nd, 2000, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 393, dated May 31st, 2000.

That the issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented

by one hundred (100) shares of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each, fully subscribed and paid-up.

That ILYX S.A. prenamed, is and will continue to be the owner of all the issued parts of the Company.
That in its quality of sole participant of the company, ILYX S.A. hereby expressly states to proceed to the dissolution

and the liquidation of the Company, as per to day.

The Company declares further on to take over on his own account, all the assets and liabilities whether known or

unknown of the company LYX, S.à r.l. and that it will undertake under its own liability any steps which are required to
fulfil said commitments taken by itself in relation with the assets and liabilities of the Company.

That full and entire discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates until

the dissolution.

That the books and corporate documents relating to the Company will remain at the registered office, where they

will be kept in custody during a period of five years.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the

present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
entity and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

<i>Pour SOCIETE IMMOBILIERE BELLEVUE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

116016

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le treize septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société ILYX S.A. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 95.985, représentée par Monsieur Lennart Stenke, directeur-délégué,
demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui

suit:

Que la société à responsabilité limitée LYX, S.à r.l., ayant son social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare,

inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 74.408, a été constituée suivant acte reçu par
le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 2 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 393 du 31 mai 2000.

Que le capital social de la Société s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par

cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

Que la comparante ILYX S.A. prénommée, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales de ladite Société.
Qu’en tant qu’associée unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de

la susdite Société, avec effet à ce jour.

La Société déclare, en outre, prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société LYX,

S.àr.l. et qu’il entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l’engagement
qu’il a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leur mandat jusqu’au moment de la

dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq (5) années.

Pour les dépôts et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Stenke, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 20 septembre 2006, vol. 470, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127489.3/5770/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

Remich, le 16 octobre 2006.

M. Schaeffer.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Maripe Holding S.A.

Unibanco-União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A.

Mirror International Holding, S.à r.l.

ICGRedStone, S.à r.l.

ICGRedStone, S.à r.l.

Hitchard, S.à r.l.

Hitchard, S.à r.l.

Unibanco-União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A.

Matrix German Portfolio One Kaiserslautern, S.à r.l.

Matrix German Portfolio One Kaiserslautern, S.à r.l.

REDK 1, S.à r.l.

Unibanco-União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A.

LCI Lux, S.à r.l.

Unibanco-União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A.

Artemis Investments, S.à r.l.

itmedia, S.à r.l.

WPP Luxembourg Gamma Two, S.à r.l.

WPP Luxembourg Gamma Two, S.à r.l.

Iwa S.A.

Taros Capital II SLP MLP, S.à r.l.

Trident LI, S.à r.l.

JRJ S.A.

Nesey Holding S.A.

British Vita (Lux IV), S.à r.l.

Corefi-Finance S.A.

Prométhée S.A.

Ibertrans (Luxembourg) S.à r.l.

Incomex S.A.

Lens S.A.

Peguform Luxembourg, S.à r.l.

Time Invest Holding, S.à r.l.

New Terra-Nova, S.à r.l.

European Middle East Investment Corporation

Compagnie Holding Financière Hirsch SNCA

Immobilière Buchholtz, S.à r.l.

Redbox Wine and Food S.A.

Agefi Luxembourg S.A.

DVL.TV S.A.

P-Build Holding S.A.

Haag Frères, Menuiserie Moderne de Meubles et de Constructions, Transports

SPX Finance, S.à r.l.

Kaupthing Life &amp; Pension, Luxembourg S.A.

Bistro 88, S.à r.l.

Media Management S.A.

Bressoles Decoration S.A.

Bressoles Decoration S.A.

NTEL S.A.

Media Management S.A.

Fürlehre, S.à r.l.

Pacolux S.A.

CCom Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

ING REEIF Soparfi B, S.à r.l.

Koch HC, S.à r.l.

Eye.Mail, S.à r.l.

Immo-Office S.A.

Société Immobilière Bellevue, S.à r.l.

Borletti Group Management S.A.

LYX, S.à r.l.