logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

105649

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2202

24 novembre 2006

S O M M A I R E

MATAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 43.828. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2006, réf. DSO-BV00100, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110125.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2006.

ABB Realty, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

105650

Jokari Finance S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105682

Accelior S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105692

Jokari Finance S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105685

Akompa, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

105689

Karlix S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105681

Batiprojet, S.à r.l., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105694

Lexan Trade S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105673

Batiprojet, S.à r.l., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105694

Lexan Trade S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105674

Beim Laange Veit, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . 

105676

LHEDCO,  Logement  Habitat  Etudes  et  Déve-

Cadami Finance S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

105675

loppement   Coopératif   Soc.   Coop.,   Luxem-

Cadami Finance S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

105679

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105688

Cadima Family, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

105689

Lumière (Lux 1), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

105692

Credit Suisse Bond Fund Management Company 

Lydion S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105688

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105695

Matafi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105649

Credit Suisse Nova (Lux), Sicav, Luxembourg . . . 

105695

Max Participations II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

105650

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux), Sicav, Lu-

MEPV Finance Company, S.à r.l., Luxembourg . . 

105685

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105693

MEPV Finance Company, S.à r.l., Luxembourg . . 

105686

D.S.L., S.à r.l., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105693

Nordiska   Apotekarföreninge,   S.à r.l.,   Luxem-

D.S.L., S.à r.l., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105693

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105684

Décharge Friidhaff, S.à r.l., Colmar-Pont  . . . . . . . 

105691

Nordmazout S.A., Oberfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . 

105692

Difrulux, S.à r.l., Breidweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105691

Orion Developpement S.A., Luxembourg  . . . . . . 

105675

Dimex Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105674

Padouhann S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

105695

Dimex Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105692

R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüftung,

Eurosquare (Lux 1), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

105689

Haustechnik, Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105650

Fondation Alzheimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105676

R Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

105694

Fondation Home St Jean, Dudelange . . . . . . . . . . . 

105696

Regency Global Business, S.à r.l., Luxembourg  . . 

105687

GAGFAH S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105651

Tanzanite, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

105691

GAGFAH S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105673

Triplus Finance S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

105675

<i>Pour MATAFI S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

105650

ABB REALTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 116.965. 

RECTIFICATIF

Dans l’acte de constitution de société dressé par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du

29 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1531 du 10 août 2006, le nom d’un des
administrateurs a été indiqué erronément, à savoir au lieu de lire Monsieur Rishi Amit Bhansali, il faut lire:

Monsieur Rishikumar Bhansali.
Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110763.3/220/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6834 Biwer, 4, Buergaass.

R. C. Luxembourg B 101.923. 

<i>Déclaration

Il est déclaré par les présentes que la société anonyme BAUMEISTER-HAUS LUXEMBOURG S.A., avec siège social

à L-5365 Munsbach, 9A, Parc d’Activité Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sec-
tion B, sous le numéro 30.262, est actuellement encore inscrite, en tant qu’associé et propriétaire de cent (100) parts
sociales de la société à responsabilité limitée R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUS-
TECHNIK, audit Registre de Commerce et des Sociétés sous la dénomination sociale de BAUMEISTER HAUS LUXEM-
BURG.

Il est également déclaré que l’actuel associé BAUMEISTER HAUS LUXEMBURG a changé sa dénomination sociale en

BAUMEISTER-HAUS LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
en date du 22 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 58 du 20 janvier 2005. 

<i>Réquisition

La prédite modification relative au changement de la dénomination sociale de l’associé de la société R + N REIS UND

NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK est requise partout où cela s’avère nécessaire.

Junglinster, le 31 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00564. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106475.5//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.

MAX PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 612.500,-.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.062. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03151, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2006.

(111058.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

<i>Pour la société
G. Lecuit
<i>Notaire

<i>Pour la société
Pour Maître Jean Seckler, notaire
Par délégation
Ch. Dostert

<i>Pour MAX PARTICIPATIONS II, S.à r.l.
MERCURIA SERVICES
<i>Mandataire
Signature

105651

GAGFAH S.A., Société Anonyme, 

(anc. NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A.). 

Registered office: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 109.526. 

In the year two thousand six, on the twenty-ninth day of the month of September.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain

depositary of the present deed. 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A., a société

en commandite par actions - Kommanditgesellschaft auf Aktien governed by the laws of Luxembourg, with its registered
office at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Reg-
ister of Commerce and Companies under section B, number 109.526 (the «Company»), incorporated by deed of notary
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) of July 12, 2005, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») of 3rd December 2005, Number 1323.

The articles of incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed of Maître

Joseph Elvinger of 29 September 2006 not yet published in the Mémorial.

The meeting is declared open with M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary M

e

 Karl Pardaens, licencié en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M

e

 Miriam Schinner, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

(A) Securitisation through (i) commingling of the various compartments of securitised assets of the Company into a

sole compartment by the amendment of the terms of securitisations made by the issue of Class G, Class N, Class R and
Class W shares, (ii) the creation of a class of ordinary shares, to become the sole class of shares of the Company (other
than the class B management share) representing all the assets and liabilities of the Company forming the sole compart-
ment, and (iii) the conversion of all existing shares, other than the Class B share, into shares of that common class pur-
suant to the conversion ratios set forth herebelow so that all shares of the Company are shares of that common class:

One (1) Class G being 0.76334746 common share;
One (1) Class N share being 10.48454427 common shares;
One (1) Class R share being 0.11116244 common share;
One (1) Class W share being 13.72698613 common shares;
approval of the conversion ratio applicable to each class of share determined pursuant to the value of the securitised

assets of each compartment, the number of shares in issue in the each class and the share premium and legal reserve
allocated to each class, allocation of all the assets and liabilities (including share premium and legal reserve) of the dif-
ferent compartments within the Company related to the Class G, Class N, Class W and Class R shares to the common
pool of securitised assets and liabilities of the Company and cancellation of the compartments, so that the rights of all
shares (other than the B management class) are equal in the securitised assets and liabilities of the Company, acknowl-
edgement of the shareholding in the Company further to the conversion as set forth below so that after the above con-
version the issued share capital of the Company of a total amount of two hundred and eighty-one million two hundred
and fifty thousand one Euro twenty-five cents (EUR 281,250,001.25) is represented by one (1) class B management share
held by NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l. and two hundred and twenty-five million
(225,000,000) (common) shares, each of a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) held as follows: 

Name shareholder

Number of

Shares

NLG Acquisition Holdings Management, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund A) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25,767,424

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,403,452

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund C) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,589,964

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund D) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,874,048

Fortress Investment Fund III L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,939,957

Fortress Investment Fund III (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,933,782

Fortress Investment Fund III (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,240,805

Fortress Investment Fund III (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,847,910

Fortress Investment Fund III (Fund E) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200,046

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

648,365

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,273,802

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

328,072

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,563,650

Fortress Subsidiary (GAGACQ) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32,555,412

FABP Subsidiary (GAGACQ) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,378,007

Fortress Investment Fund III (GAGACQ Subsidiary) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13,721,572

Fortress Investment Fund III (Fund B) (GAGACQ Subsidiary) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,732,178

105652

(B) Change of the legal form of the Company by converting the Company from a société en commandite par actions

into a société anonyme (joint stock corporation),

(i) acknowledgment of the report on the net asset value of the Company by the independent auditors (réviseurs d’en-

treprises) GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.;

(ii) acknowledgement of the resignation by NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l. as manager

and commandité of the Company; 

(iii) appointment of (i) Mr Wesley R. Edens, born in Quincy, State of Washington, United States on 30 October 1961,

senior executive, with professional address at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, as director for a term ending at
the general meeting of shareholders approving the Company’s accounts for financial year 2011, (ii) Mr Robert I. Kauff-
man, born in New York, State of New York, United States of America on 22 October 1963, senior executive, with
professional address at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, as director for a term ending at the general meeting of
shareholders approving the Company’s accounts for financial year 2011 and (iii) Mr Randal A. Nardone, born in New
York, State of New York, United States of America on 22 June 1955, senior executive, with professional address at 14A,
rue des Bains, L-1212 Luxembourg, as director for a term ending at the general meeting of shareholders approving the
Company’s accounts for financial year 2011;

(iv) cancellation of the class B management share with reduction of the share capital from two hundred and eighty-

one million two hundred and fifty thousand one Euro twenty-five cents (EUR 281,250,001.25) to two hundred and
eighty-one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 281,250,000), represented by two hundred and twenty-
five million (225,000,000) shares without payment of the nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) which
will be allocated to the share premium;

(v) change of name of the Company into GAGFAH S.A.;
(vi) amendment of the object and article 4 of the articles of the Company to read as follows:
«The corporate object of the Company is to carry out one or several securitisation operations and any activity an-

cillary or related thereto and/or provided for under the law dated 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation
Law»).

The Company may in particular without limitation enter into any transactions by which it acquires or assumes, di-

rectly or through another undertaking of any kind, risks relating to claims, any other type of assets (including, without
limitation, any kind of securities, loans, receivables and other assets, including assets related to residential real estate in
Germany) or any kind of obligations assumed by third parties or inherent to all or part of the activities of third parties,
collectively referred to herein as the «Underlying Assets.»

The Company may issue, directly or indirectly through intermediary companies, any kind of securities of any form or

nature whatsoever including, without limitation, shares, notes and debt instruments as well as options or warrants giving
rights for additional shares, whose value, return or yield depend on the risks relating to the Underlying Assets. The
Company may also borrow or raise funds in the form of loans or otherwise from any entity in order to fund or partly
fund the acquisition or assumption of Underlying Assets and/or to comply with any payment or other obligation under
any of the securities issued by the Company or under any agreement to be entered into in the context of a securitisation.

The Company may sell, assign, re-acquire and dispose of any and all of the Underlying Assets through any means (in-

cluding by means of sale, assignment, exchange, conversion, contribution or through derivative or swap transactions).

Within the context of securitisations, the Company may (directly or indirectly) (i) acquire, hold and dispose in any

form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxem-
bourg and/or foreign companies or other entities active in any sector (including real estate assets); (ii) acquire or assume
risks by means of granting loans to Luxembourg and/or foreign entities; (iii) acquire by purchase, subscription, or in any
other manner, as well as transfer by sale, exchange or in any other manner stock, bonds, debentures, notes, units and
other securities or financial instruments of any kind and contracts on one or more thereon or related thereto; (iv) pro-
vide any financial assistance to the undertakings forming part of its group by providing, without limitation, guarantees or
securities or loans in any form; and (v) own, administer, develop and manage a portfolio (including, among others, the
assets referred to in (i), (ii) and (iii) in this paragraph). The Company may further acquire, hold and dispose of interests
in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

Fortress Investment Fund III (Fund C) (GAGACQ Subsidiary) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,453,300

Fortress Investment Fund III (Fund D) (GAGACQ Subsidiary) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,630,841

Fortress Investment Fund III (Fund E) (GAGACQ Subsidiary) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

395,528

Fortress Subsidiary (GAGACQ) Investors (Cayman) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,948,503

Fortress Subsidiary (GAGACQ) Co-Investors (Cayman) Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,679,326

Drawbridge Special Opportunities Fund Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,544,506

Drawbridge Special Opportunities Fund LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,937,181

ZG Holdings CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,136,145

CGI Phoenix Co D1 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

850,049

CG Phoenix E Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,013,832

CG Phoenix D Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,837,019

CGI Phoenix Co E1 Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814,288

CGI Phoenix Co D2 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,281,445

Tangentum Erste Vermögensbeteiligungs, GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479,591

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225,000,001

105653

To the fullest extend permitted by law, the Company may grant any kind of security interests on its assets under any

law to any investor, trustee, security trustee, security agent, fiduciary-representative, or any other person representing
investors or any other party involved in a securitisation or with whom the Company entered into agreements in con-
nection with a securitisation in order to secure its payment or other obligations under any security issued or agreement
entered into by the Company for the purpose of the securitisation of such assets. The Company may enter into any
agreement or instruments (including, without limitation, derivatives) and may issue, sign, approve or ratify any document
and may do and allow all things and acts which are necessary to prepare, carry out and wind up or are incidental to, a
securitisation.

The Company may sell, assign, transfer or otherwise dispose of part or all of the Underlying Assets in such manner

and for such compensation as the Board of Directors or any person appointed for such purpose shall approve at such
time.

The Company may perform all commercial, technical and financial or other operations, which are directly or indi-

rectly connected with, or are necessary or useful to facilitate the accomplishment of, its purpose (while however always
remaining within the scope of the Securitisation Law).

The Company may, from time to time, hold funds received from issuances of shares or other securities in the Com-

pany pending investment by means of securitization. In addition, the Company may retain certain funds not distributed
in accordance with the terms of its dividend policy.

The Board of Directors may decide to allocate funds to an account, or a reserve account, established by the Company

to hold at all times funds sufficient to cover the expenses and fees relating to the Company’s activities as determined
by the Board of Directors. Such activities include, in particular, ongoing management expenses (including overhead), re-
muneration of the Board members, out-of-pocket expenses of the Board members, insurance fees and service fees. Re-
serve account funds will be distributed to holders of shares in the Company if the Board of Directors determines that
incurrence of further short term operating costs or working capital expenditures is unlikely.»

(vii) Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company in order (i) to adapt the articles

to the new form of the Company and including without limitation, to amend its name, to adapt the share capital struc-
ture, to take into account the amendment of the object of the Company as per the above, and (ii) the agenda items
above and below, substantially in the form as set out in the proxies.

(C) Creation of an authorised un-issued share capital within the Company of an amount of ten billion Euro (EUR

10,000,000,000), represented by eight billion (8,000,000,000) shares with a nominal value of one point twenty-five Euro
(EUR 1.25) each, acknowledgement of the report pursuant to article 32-3(5) of Luxembourg Company law on the cir-
cumstances and prices of issues of shares against cash without pre-emptive subscription rights, waiver of, suppression
and authorisation to the Board of directors to waive, suppress or limit, any pre-emptive subscription rights in the case
of issues of shares within the authorised share capital, authorisation to the Board of Directors to proceed to further
securitisations and to issue shares within the authorised share capital against contributions in cash, in kind or by way of
incorporation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the
Board of Directors or its delegate(s) (including without limitation in relation to one or more public offerings of the
shares of the Company and in particular without limitation, the Board of Directors may issue shares in favour of direc-
tors, executives and employees of the Company and the group to which it belongs, directly or under the terms of an
option plan approved by the Board of Directors) while preserving, suppressing or limiting pre-emptive subscription
rights of existing shareholders, determination of the validity period of the authorised share capital of the Company start-
ing on the day of the extraordinary general meeting of shareholders recording the present authorisation and ending on
the fifth anniversary of the day of publication of the deed recording the minutes of said general meeting in the Mémorial. 

(D) Authorisation to the Company, or any wholly-owned subsidiary, to purchase, acquire or receive shares in the

Company up to 10% of the issued share capital from time to time, from time to time over the stock - exchange or in
privately negotiated transactions, and in the case of acquisition for value, at a purchase price being no less than EUR 10
and no more than EUR 40 and on such terms as shall be determined by the Board of Directors of the Company, pro-
vided such purchase is in conformity with Article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915 and with applicable
laws and regulations, such authorisation being granted for a period of 18 months.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions, each time with the consent

of the manager and general partner:

<i>First resolution

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to proceed to a securitisation

and to commingle the various compartments of securitised assets of the Company into a sole compartment by the
amendment of the terms of securitisations made by the issue of Class G, Class N, Class R and Class W shares and to
create a class of ordinary shares, to become the sole class of shares of the Company (other than the class B management
share) representing all the assets and liabilities of the Company forming the sole compartment, and (iii) to convert all

105654

existing shares, other than the Class B share, into shares of that common class pursuant to the conversion ratios set
forth herebelow so that all shares of the Company are shares of that common class:

One (1) Class G being 0.76334746 common share;
One (1) Class N share being 10.48454427 common shares;
One (1) Class R share being 0.11116244 common share;
One (1) Class W share being 13.72698613 common shares.
The Meeting resolved to approve the conversion ratio applicable to each class of share determined pursuant to the

value of the securitised assets of each compartment, the number of shares in issue in the each class and the share pre-
mium and legal reserve allocated to each class and to allocate all the assets and liabilities (including share premium and
legal reserve) of the different compartments within the Company related to the Class G, Class N, Class W and Class R
shares to the common pool of securitised assets and liabilities of the Company and cancel the compartments, so that
the rights of all shares (other than the B management class) are equal in the securitised assets and liabilities of the Com-
pany. The Meeting acknowledged the shareholding in the Company further to the conversion as set forth below so that
after the above conversion the issued share capital of the Company of a total amount of two hundred and eighty-one
million two hundred and fifty thousand one Euro twenty-five cents (EUR 281,250,001.25) is represented by one (1) class
B management share held by NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l. and two hundred and twenty-
five million (225,000,000) (common) shares, each of a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) held as
follows: 

<i>Second resolution

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to change the legal form of the

Company by converting the Company from a société en commandite par actions into a société anonyme (joint stock
corporation).

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to acknowledge the report on

the net asset value of the Company by the independent auditors (réviseurs d’entreprises) GRANT THORNTON RE-
VISION ET CONSEILS S.A. with the following conclusion:

«On the basis of the work undertaken as described above in accordance with recommendations of the Institut des

Réviseurs d’Entreprises and on the basis of the documents that we have received, we conclude as follows:

Name shareholder

Number of

Shares

NLG Acquisition Holdings Management, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,767,424

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,403,452

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,589,964

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,874,048

Fortress Investment Fund III L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,939,957

Fortress Investment Fund III (Fund B) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,933,782

Fortress Investment Fund III (Fund C) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,240,805

Fortress Investment Fund III (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,847,910

Fortress Investment Fund III (Fund E) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200,046

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund A) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

648,365

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund B) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,273,802

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund C) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328,072

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,563,650

Fortress Subsidiary (GAGACQ) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,555,412

FABP Subsidiary (GAGACQ) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,378,007

Fortress Investment Fund III (GAGACQ Subsidiary) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,721,572

Fortress Investment Fund III (Fund B) (GAGACQ Subsidiary) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,732,178

Fortress Investment Fund III (Fund C) (GAGACQ Subsidiary) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,453,300

Fortress Investment Fund III (Fund D) (GAGACQ Subsidiary) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,630,841

Fortress Investment Fund III (Fund E) (GAGACQ Subsidiary) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

395,528

Fortress Subsidiary (GAGACQ) Investors (Cayman) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,948,503

Fortress Subsidiary (GAGACQ) Co-Investors (Cayman) Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,679,326

Drawbridge Special Opportunities Fund Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,544,506

Drawbridge Special Opportunities Fund LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,937,181

ZG Holdings CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,136,145

CGI Phoenix Co D1 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

850,049

CG Phoenix E Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,013,832

CG Phoenix D Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,837,019

CGI Phoenix Co E1 Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814,288

CGI Phoenix Co D2 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,281,445

Tangentum Erste Vermögensbeteiligungs, GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479,591

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225,000,001

105655

Nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind on the trans-

formation of NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A. into NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.A., a «société
anonyme», is not at least equal to the number and the par value of the shares to be issued.

Our report is solely for the purpose set forth in the first paragraph of this report and for your information and is not

to be used for any other purpose or to be referred to or to distributed to any other parties without our prior consent.
Luxembourg, September 29, 2006.»

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to acknowledge the resignation

by NLG ACQUISITION HOLDING MANAGEMENT, S.à r.l. as manager and commandité of the Company. 

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to appoint Mr Wesley R. Edens,

born in Quincy, State of Washington, United States on 30 October 1961, senior executive, with professional address
at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, as director for a term ending at the general meeting of shareholders approv-
ing the Company’s accounts for financial year 2011, (ii) Mr Robert I. Kauffman, born in New York, State of New York,
United States of America on 22 October 1963, senior executive, with professional address at 14A, rue des Bains, L-
1212 Luxembourg, as director for a term ending at the general meeting of shareholders approving the Company’s ac-
counts for financial year 2011 and (iii) Mr Randal A. Nardone, born in New York, State of New York, United States of
America on 22 June 1955, senior executive, with professional address at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, as
director for a term ending at the general meeting of shareholders approving the Company’s accounts for financial year
2011 so that the Board of Directors of the Company is composed by Wesley R. Edens, Robert I. Kauffman, and Randal
A. Nardone.

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to cancel the class B management

share with reduction of the share capital from two hundred and eighty-one million two hundred and fifty thousand one
Euro twenty-five cents (EUR 281,250,001.25) to two hundred and eighty-one million two hundred and fifty thousand
Euro (EUR 281,250,000) represented by two hundred and twenty-five million (225,000,000) shares and to allocate the
nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) of such share to the share premium.

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to change of name of the Com-

pany into GAGFAH S.A.

The general meeting, with the consent of the, manager and general partner, resolved to amend the object and article

4 of the articles of the Company to read as follows:

«The corporate object of the Company is to carry out one or several securitisation operations and any activity an-

cillary or related thereto and/or provided for under the law dated 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation
Law»).

The Company may in particular, without limitation, enter into any transactions by which it acquires or assumes, di-

rectly or through another undertaking of any kind, risks relating to claims, any other type of assets (including, without
limitation, any kind of securities, loans, receivables and other assets, including assets related to residential real estate in
Germany) or any kind of obligations assumed by third parties or inherent to all or part of the activities of third parties,
collectively referred to herein as the «Underlying Assets.»

The Company may issue, directly or indirectly through intermediary companies, any kind of securities of any form or

nature whatsoever including, without limitation, shares, notes and debt instruments as well as options or warrants giving
rights for additional shares, whose value, return or yield depend on the risks relating to the Underlying Assets. The
Company may also borrow or raise funds in the form of loans or otherwise from any entity in order to fund or partly
fund the acquisition or assumption of Underlying Assets and/or to comply with any payment or other obligation under
any of the securities issued by the Company or under any agreement to be entered into in the context of a securitisation.

The Company may sell, assign, re-acquire and dispose of any and all of the Underlying Assets through any means (in-

cluding by means of sale, assignment, exchange, conversion, contribution or through derivative or swap transactions).

Within the context of securitisations, the Company may (directly or indirectly) (i) acquire, hold and dispose in any

form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxem-
bourg and/or foreign companies or other entities active in any sector (including real estate assets); (ii) acquire or assume
risks by means of granting loans to Luxembourg and/or foreign entities; (iii) acquire by purchase, subscription, or in any
other manner, as well as transfer by sale, exchange or in any other manner stock, bonds, debentures, notes, units and
other securities or financial instruments of any kind and contracts on one or more thereon or related thereto; (iv) pro-
vide any financial assistance to the undertakings forming part of its group by providing, without limitation, guarantees or
securities or loans in any form; and (v) own, administer, develop and manage a portfolio (including, among others, the
assets referred to in (i), (ii) and (iii) in this paragraph). The Company may further acquire, hold and dispose of interests
in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

To the fullest extend permitted by law, the Company may grant any kind of security interests on its assets under any

law to any investor, trustee, security trustee, security agent, fiduciary-representative, or any other person representing
investors or any other party involved in a securitisation or with whom the Company entered into agreements in con-
nection with a securitisation in order to secure its payment or other obligations under any security issued or agreement
entered into by the Company for the purpose of the securitisation of such assets. The Company may enter into any
agreement or instruments (including, without limitation, derivatives) and may issue, sign, approve or ratify any document
and may do and allow all things and acts which are necessary to prepare, carry out and wind up or are incidental to, a
securitisation.

The Company may sell, assign, transfer or otherwise dispose of part or all of the Underlying Assets in such manner

and for such compensation as the Board of Directors or any person appointed for such purpose shall approve at such
time.

105656

The Company may perform all commercial, technical and financial or other operations, which are directly or indi-

rectly connected with, or are necessary or useful to facilitate the accomplishment of, its purpose (while however always
remaining within the scope of the Securitisation Law).

The Company may, from time to time, hold funds received from issuances of shares or other securities in the Com-

pany pending investment by means of securitization. In addition, the Company may retain certain funds not distributed
in accordance with the terms of its dividend policy.

The Board of Directors may decide to allocate funds to an account, or a reserve account, established by the Company

to hold at all times funds sufficient to cover the expenses and fees relating to the Company’s activities as determined
by the Board of Directors. Such activities include, in particular, ongoing management expenses (including overhead), re-
muneration of the Board members, out-of-pocket expenses of the Board members, insurance fees and service fees. Re-
serve account funds will be distributed to holders of shares in the Company if the Board of Directors determines that
incurrence of further short term operating costs or working capital expenditures is unlikely.»

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to amend and restate the articles

of incorporation of the Company in order (i) to adapt the articles to the new form of the Company and including with-
out limitation, to amend its name, to adapt the share capital structure, to take into account the amendment of the object
of the Company as per the above, and (ii) the agenda items above and below, as set forth hereunder under the third
resolution.

<i>Third resolution

The general meeting, with the consent of the manager and general partner, resolved to create an authorised un-issued

share capital within the Company of an amount of ten billion Euro (EUR 10,000,000,000), represented by eight billion
(8,000,000,000) shares with a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) each. The general meeting ac-
knowledged the report pursuant to article 32-3(5) of Luxemburg Company law on the circumstances and prices of is-
sues of shares against cash without pre-emptive subscription rights, waiver of, suppression and authorisation to the
Board of directors to waive, suppress or limit, any pre-emptive subscription rights in the case of issues of shares within
the authorised share capital and resolved to authorise the Board of Directors to proceed to further securitisations and
to issue shares within the authorised un-issued share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorpo-
ration of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the Board
of Directors or its delegate(s) (including without limitation in relation to one or more public offerings of the shares of
the Company and in particular, the Board of Directors may issue Shares in favour of directors, executives and employees
of the Company and the group to which it belongs, directly or under the terms of one or more option plans approved
by the Board of Directors) while preserving, suppressing or limiting pre-emptive subscription rights of existing share-
holders.

The general meeting resolved that the validity period of the authorised share capital of the Company shall start on

the day of the present extraordinary general meeting of shareholders recording the present authorisation and ending
on the fifth anniversary of the day of publication of the present deed recording the minutes of said general meeting.

Amended and Restated articles of incorporation of the Company pursuant to the resolutions above and in particular

the third resolution.

Art. 1. Form, denomination. Between those present this day and all persons who will become owners of the

shares mentioned hereafter a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name of GAGFAH S.A. (the
«Company») governed by the laws of Luxembourg and the present articles of incorporation (the «Articles» or the «Ar-
ticles of incorporation»).

Art. 2. Duration. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. Registered office. The Company shall have its registered office in Luxembourg-City in the Grand Duchy

of Luxembourg.

The Board of Directors shall also have the right to set up offices, administrative centres, agencies and subsidiaries

wherever it shall see fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the Company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors; the registered office may be transferred to
any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the general meeting of shareholders.

In the event that the Board of Directors determines that political, economic or social developments or events of

exceptional nature have occurred, threaten to occur or are imminent that are likely to affect normal working operations
at the registered office or easy communications with places abroad, the registered office may be declared provisionally
transferred abroad, until such time as circumstances have completely returned to normal. Such declaration of the reg-
istered office will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the transfer abroad of the
registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 4. Object, purpose. The corporate object of the Company is to carry out one or several securitisation oper-

ations and any activity ancillary or related thereto and/or provided for under the law dated 22 March 2004 on securiti-
sation (the «Securitisation Law»). The Company may in particular without limitation enter into any transactions by
which it acquires or assumes, directly or through another undertaking of any kind, risks relating to claims, any other
type of assets (including, without limitation, any kind of securities, loans, receivables and other assets, including assets
related to residential real estate in Germany) or any kind of obligations assumed by third parties or inherent to all or
part of the activities of third parties, collectively referred to herein as the «Underlying Assets.»

105657

The Company may issue, directly or indirectly through intermediary companies, any kind of securities of any form or

nature whatsoever including, without limitation, shares, notes and debt instruments as well as options or warrants giving
rights for additional shares, whose value, return or yield depend on the risks relating to the Underlying Assets. The
Company may also borrow or raise funds in the form of loans or otherwise from any entity in order to fund or partly
fund the acquisition or assumption of Underlying Assets and/or to comply with any payment or other obligation under
any of the securities issued by the Company or under any agreement to be entered into in the context of a securitisation.

The Company may sell, assign, re-acquire and dispose of any and all of the Underlying Assets through any means (in-

cluding by means of sale, assignment, exchange, conversion, contribution or through derivative or swap transactions).

Within the context of securitisations, the Company may (directly or indirectly) (i) acquire, hold and dispose in any

form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxem-
bourg and/or foreign companies or other entities active in any sector (including real estate assets); (ii) acquire or assume
risks by means of granting loans to Luxembourg and/or foreign entities; (iii) acquire by purchase, subscription, or in any
other manner, as well as transfer by sale, exchange or in any other manner stock, bonds, debentures, notes, units and
other securities or financial instruments of any kind and contracts on one or more thereon or related thereto; (iv) pro-
vide any financial assistance to the undertakings forming part of its group by providing, without limitation, guarantees or
securities or loans in any form; and (v) own, administer, develop and manage a portfolio (including, among others, the
assets referred to in (i), (ii) and (iii) in this paragraph). The Company may further acquire, hold and dispose of interests
in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

To the fullest extend permitted by law, the Company may grant any kind of security interests on its assets under any

law to any investor, trustee, security trustee, security agent, fiduciary-representative, or any other person representing
investors or any other party involved in a securitisation or with whom the Company entered into agreements in con-
nection with a securitisation in order to secure its payment or other obligations under any security issued or agreement
entered into by the Company for the purpose of the securitisation of such assets. The Company may enter into any
agreement or instruments (including, without limitation, derivatives) and may issue, sign, approve or ratify any document
and may do and allow all things and acts which are necessary to prepare, carry out and wind up or are incidental to, a
securitisation.

The Company may sell, assign, transfer or otherwise dispose of part or all of the Underlying Assets in such manner

and for such compensation as the Board of Directors or any person appointed for such purpose shall approve at such
time.

The Company may perform all commercial, technical and financial or other operations, which are directly or indi-

rectly connected with, or are necessary or useful to facilitate the accomplishment of, its purpose (while however always
remaining within the scope of the Securitisation Law).

The Company may, from time to time, hold funds received from issuances of shares or other securities in the Com-

pany pending investment by means of securitization. In addition, the Company may retain certain funds not distributed
in accordance with the terms of its dividend policy.

The Board of Directors may decide to allocate funds to an account, or a reserve account, established by the Company

to hold at all times funds sufficient to cover the expenses and fees relating to the Company’s activities as determined
by the Board of Directors. Such activities include, in particular, ongoing management expenses (including overhead), re-
muneration of the Board members, out-of-pocket expenses of the Board members, insurance fees and service fees. Re-
serve account funds will be distributed to holders of shares in the Company if the Board of Directors determines that
incurrence of further short term operating costs or working capital expenditures is unlikely.

Art. 5. Share Capital. The issued capital of the Company is set at two hundred and eighty-one million two hundred

and fifty thousand Euro (EUR 281,250,000), represented by two hundred and twenty-five million (225,000,000) shares
with a nominal value of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) each (the «Shares»), all of said Shares being fully paid. 

The authorised un-issued capital of the Company is set at ten billion Euro (EUR 10,000,000,000) to be represented

by eight billion (8,000,000,000) Shares. The authorised and un-issued share capital and the authorisation to issue Shares
thereunder is valid for a period starting on September 29, 2006 and ending five (5) years after the date of publication of
the minutes of the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on September 29, 2006 in the
Mémorial (unless amended or extended by the general meeting of shareholders).

The Board of Directors or delegate(s) duly appointed by the Board, may from time to time issue such Shares within

the authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board or
its delegate(s) may in its or their discretion resolve. In particular, the Board of Directors may issue Shares in favour of
directors, executives and employees of the Company and the group to which it belongs, directly or under the terms of
an option plan approved by the Board of Directors. The Board of Directors is authorised to suppress, limit or waive
any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent it deems advisable for any issue or issues of Shares
within the authorised capital.

In addition, the issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced one or several times

by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set
by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by law for any amendment of these Articles of Incorporation.

The Company may proceed to the repurchase of its own shares within the limits laid down by law.
The Company shall not issue fractional shares. The Board of Directors shall be authorised at its discretion to provide

for the payment of cash or the issuance of script in lieu of any fraction of a share.

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Association or by law. In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which
any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may
be used to provide for the payment of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholders, to offset

105658

any net realised losses, to make distributions to the Shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the
legal reserve.

Art. 6. Shares in registered form. The Shares are in registered form only.
Subject to the foregoing, registered share certificates may be issued for shares in such denominations as the Board

of Directors shall prescribe. The share certificates shall be in such form and shall bear such legends and such numbers
of identification as shall be determined by the Board of Directors. The share certificates shall be signed manually or by
facsimile by two directors of the Company.

Lost, stolen or mutilated share certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and

indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated share certificates shall be delivered
before new share certificates are remitted.

A register of shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by

any shareholder. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. A transfer of reg-
istered shares shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the said register, dated and signed
by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives. The Company may accept and enter
in the register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the
transferor and the transferee.

The Company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will be required to name a single proxy to represent the share vis-à-vis the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such share until one person has been so
appointed. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a
pledgor and a pledgee.

The Company may appoint registrars in different jurisdictions who will each maintain a separate register for the reg-

istered shares entered therein and the holders of shares may elect to be entered in one of the registers and to be trans-
ferred from time to time from one register to another register. The Board of Directors may however impose transfer
restrictions for shares that are registered, listed, quoted, dealt in, or have been placed in certain jurisdictions in compli-
ance with the requirements applicable therein. The transfer to the register kept at the Company’s registered office may
always be requested.

No entry shall be made in the register of shareholders and no notice of a transfer shall be recognised by the Company

or a registrar during the period starting on the fifth business day before the date of a general meeting and ending at the
close of that general meeting, unless the Company sets a shorter time limit.

The Company may consider the person in whose name the registered shares are registered in the register of share-

holders as the full owner of such registered shares. The Company shall be completely free from any responsibility in
dealing with such registered shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims
of such third parties in or upon such registered shares to be non-existent, subject, however, to any right which such
third party might have to demand the registration or change in registration of registered shares. In the event that a hold-
er of registered shares does not provide an address to which all notices or announcements from the Company may be
sent, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register(s) of shareholders and such holder’s
address will be deemed to be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered by
the Company from time to time, until a different address shall be provided to the Company by such holder. The holder
may, at any time, change his address as entered in the register(s) of shareholders by means of written notification to the
Company or the relevant registrar.

All communications and notices to be given to a registered shareholder shall be deemed validly made to the latest

address communicated by the shareholder to the Company.

Art. 7. Voting rights. Each Share shall be entitled to one vote at all general meetings of shareholders.

Art. 8. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of no less than

three (3) and no more than twelve (12) members who need not be shareholders of the Company (the «Directors»).

The Directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders by a simple majority of the votes cast for a

period not exceeding 6 years or until their successors are elected; provided however that any of the Directors may be
removed with or without cause by the general meeting of Shareholders by a simple majority of the votes cast at a general
meeting of shareholders. The Directors shall be eligible for re-election.

The Board of Directors shall be composed for as long as the Shares are listed on one or more regulated stock ex-

changes, so as to always (save in case of a vacancy for reasons of death, retirement, resignation, dismissal, removal or
otherwise until the appointment of a successor of the relevant prior independent Director) include three independent
Directors. Subject to any overriding reguirement under law or under stock exchange regulation applicable to the Com-
pany, an «independent Director» is a director who does not have a significant business relationship with the Company
that would create a conflict of interest which could impair the independence of such director’s judgment nor is an im-
mediate family member of any executive of the Company.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement, resignation, dismissal, removal or

otherwise, the remaining Directors may fill such vacancy and appoint a successor to act until the next meeting of share-
holders.

Art. 9. Procedures of the Board of Directors. The Board of Directors may appoint a chairman and one or more

vice chairman. The chairman of the Board of Directors will preside over all meetings of the Board of Directors and all
meetings of Shareholders. In the absence of the chairman, either the most senior vice chairman present, or (but only in
the event that there no vice chairman is present) a chairman ad hoc elected by the Board or the general meeting of
Shareholders, as the case may be, shall chair the Board of Directors’ meeting or the general Shareholders’ meeting.

105659

The Board may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the power to represent

the Company in its day to day business, individual directors or other officers or agents of the Company, who need not
be Shareholders. Any such delegation of daily management in favour of one or more Directors requires the prior au-
thorisation of the general meeting of shareholders.

The Board of Directors may set up committees including without limitation an audit committee, a compensation com-

mittee and a related party transactions committee. Each such committee shall be composed of at least three Directors,
one of them at least being an independent Director (or such greater number as the Board of Directors may determine).
The Board of Directors may also appoint persons who are not Directors to the committees.

The purpose of the audit committee shall be to assist the Board of Directors in fulfilling its oversight responsibilities

relating to the integrity of the financial statements, including periodically reporting to Board on its activities and the ad-
equacy of internal controls systems over financial reporting; and to make recommendations for the appointment, com-
pensation, retention and oversight of, and consider the independence of, the external auditors and perform such other
duties imposed by applicable laws and regulations of the regulated market or markets on which the Shares may be listed,
as well as any other duties entrusted to the committee by the Board of Directors.

The purpose of the compensation committee shall be to review the compensation policy, make proposals as to the

remuneration of executive Directors and senior management, and advice on any benefit or incentive schemes.

The purpose of the related party transaction committee shall be to review transactions involving the Company or its

affiliates where a director, officer or employee of the Company or one of its affiliates has a financial interest. 

The Board of Directors may appoint a secretary of the Company, who need not be a member of the Board of Di-

rectors, and determine his responsibilities, powers and authorities.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or

any two Directors. Notice of any meeting must be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission,
telex or e-mail advice to each Director seven days before the meeting, except in the case of an emergency, in which
event a twenty-four hours notice shall be sufficient.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing by letter or by cable, telegram,

facsimile transmission, telex or e-mail another Director as his proxy. A meeting of the Board of Directors duly called
to consider the issues on the agenda indicated in the notice of meeting shall be deemed to have the required quorum
if at least a majority of the Directors is present or represented.

Decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast by the Directors present or rep-

resented at the meeting.

Meetings of the Board of Directors may be validly held at any time and in all circumstances by means of telephonic

conference call, videoconference or any other means, which allow the identification of the relevant Director and which
are continuously on-line. A Director attending in such manner shall be deemed present at the meeting.

The Board of Directors may also in all circumstances with unanimous consent pass resolutions by circular means and

written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly con-
vened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letters, cables, facsimile transmission, telexes or e-mail.

Copies or extracts of board minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the Company or two Directors or the Company secretary.

Art. 11. Power of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage

the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the
purposes of the Company.

All powers not expressly reserved by the law or by the Articles of Incorporation of the Company to the general

meeting shall be within the competence of the Board of Directors.

Except as otherwise provided herein or by law, the Board of Directors of the Company is hereby authorised to take

such action (by resolution or otherwise) and to adopt such provisions as shall be necessary or convenient to implement
the purpose of the Company.

Art. 12. Binding Signature. The Company shall be bound by the joint signatures of two Directors or by the sole

or joint signature(s) of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board
of Directors.

Art. 13. Conflict of Interest. No Director shall, solely as a result of being a director, be prevented from contract-

ing with the Company, either with regard to his tenure of any office or place of profit or as vendor, purchaser or in any
other manner whatsoever, nor shall any contract or other transaction between the Company and any other corporation
or entity or in which any Director is in any way interested be affected or invalidated by the fact that any one or more
of the Directors» or officers of the Company is or are interested in such contract or transaction or is or are a director,
officer or employee of such other corporation or entity. Any Director or officer of the Company who serves as direc-
tor, officer or employee of any corporation or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not solely by reason of such affiliation with such other corporation or entity be prevented from consid-
ering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

No Director who is so interested shall be liable to account to the Company or the shareholders for any remunera-

tion, profit or other benefit realised by him by reason of the director holding that office or of the fiduciary relationship
thereby established.

In the event that any Director of the Company shall have any personal interest in any transaction of the Company,

such Director shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on

105660

such transaction, and such transaction and such Director’s interest therein shall be recorded and reported to the next
succeeding meeting of Shareholders. 

Art. 14. Director and Officer Indemnification. Subject to the exceptions and limitations listed below:
(i) Every person who is, or has been, a Director or officer of the Company shall be indemnified by the Company to

the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in con-
nection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved in as a party or otherwise by virtue of him
being or having been a director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.

(ii) The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil,

criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words «liability» and «expenses» shall include with-
out limitation attorneys’ fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any Director or officer against any liability to the Company or its Sharehold-

ers by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct
of his office or in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction
or by the Board of Directors. No indemnification will be provided in defending proceedings (criminal) in which that Di-
rector or officer is convicted of an offence.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon re-
ceipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this Article 14.

Art. 15. General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company

shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company. The general meeting is convened by the Board of Directors in
accordance with Luxembourg law.

The annual general meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or

at such other place as may be specified in the convening notice of the meeting, on 21 April at 2:00 p.m. If such day is a
legal holiday in Luxembourg the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other general meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective

convening notices of the meeting.

If the entire issued share capital of the Company is represented at a general meeting, no convening notice is reguired

for the meeting to be held and the proceedings at such general meeting will be deemed valid.

The Board of Directors may determine a date preceding the general meeting of Shareholders as the record date for

admission to the general meeting.

In case of Shares held through fungible securities accounts, a holders may exercise all rights attached to his share(s)

and in particular may participate in and vote at the general meeting of Shareholders of the Company, upon presentation
of a certificate issued by the financial institution or professional depositary holding the shares, evidencing such deposit
and certifying the number of Shares recorded in the relevant account. Such certificate must be filed with the Company
at its registered address or at the address stated in the convening notice no later than the day preceding the fifth business
working day before the date of the general meeting unless the Company fixes a shorter period. All proxies must be
received by the Company within the same time frame.

The Board of Directors may determine such other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of Shareholders in person or by proxy.

A Shareholder may be represented at a general meeting by a proxy who need not be a shareholder.

Art. 16. Majority and quorum at the general meeting. At any general meeting of shareholders other than an

extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Company’s Articles of Incorporation or voting
on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for amendment of the Articles of
Incorporation, no presence quorum is required and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares
represented, by a simple majority of votes cast.

At any extraordinary general meeting of shareholders for the purpose of amending the Company’s Articles of Incor-

poration or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for amendment
of the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said
quorum is not present, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order
for the proposed resolutions to be adopted at such a meeting, and save as otherwise provided by law, a two thirds (2/
3) majority of the votes of the Shareholders present or represented and voting is required at any such general meeting.

Art. 17. Audit. The audit of the Company’s affairs will be carried out by an independent auditor in accordance with

chapter 4 of the Securitisation Law. The auditor is appointed by the Board of Directors. Any auditor so appointed may
be removed with or without cause.

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall

terminate on December 31st of the same year.

105661

Art. 19. Distributions. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of, including by way of stock dividend.

Interim dividends may be declared and paid (including by way of staggered payments) by the Board of Directors sub-

ject to observing the terms and conditions provided by law either by way of a cash dividend or by way of an in kind
dividend.

Art. 20. Dissolution of the Company. In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or

whatever time, the liquidation will be performed by liquidators or by the Board of Directors then in office who will be
endowed with the powers provided by articles 144 et seq. of the Luxembourg Company Law of the tenth of August,
nineteen hundred and fifteen.

Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of

Shares in the Company.

Art. 21. Governing law. Except as otherwise provided herein the provisions of the Luxembourg Company Law of

10th August 1915, as amended and the Securitisation Law will apply.

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to authorise the Company, or any wholly-owned subsidiary, to purchase, acquire or receive

shares in the Company up to 10% of the issued share capital of the Company from time to time, from time to time over
the stock exchange or in privately negotiated transactions, and in the case of acquisition for value, at a purchase price
being no less than EUR 10 and no more than EUR 40 and on such terms as shall be determined by the Board of Directors
of the Company, provided such purchase is in conformity with Article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915
and with applicable laws and regulations. The authorisation is granted for a period of 18 months from the present day.

There being no further items on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-

crease are estimated at four thousand Euro.

(The Company refers to the law of 22 March 2004 on securitisation to benefit of a reduced capital duty).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with us, notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, den zweiundzwanzigsten September.
Vor uns, Maître Joseph Elvinger, Notar, mit Amtssitz in Luxembourg, der die vorliegende Urkunde künftig verwahren

wird.

Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft NLG ACQUISITION HOLDINGS

S.C.A., eine société en commandite par actions - Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts, mit Sitz in
14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregi-
ster Luxembourg Sektion B unter der Nummer 109.526 (die «Gesellschaft»), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen
durch den Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem (Großherzogtum Luxembourg) am 12. Juli 2005, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») vom 3. Dezember 2005, Nummer 1323,
statt.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals geändert, zuletzt gemäß einer Urkunde von Maître Joseph Elvinger vom

29. September 2006, die noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde. 

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg,

M

e

 Karl Pardaens, licencié en droit, wohnhaft in Luxembourg.
Die Versammlung wählte M

e

 Miriam Schinner, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg, zum Schriftführer.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar fol-

gendes zu beurkunden:

(i) Zweck dieser Versammlung ist das Festhalten der gemäß folgender Tagesordnung zu treffenden Beschlüsse:

<i>Tagesordnung:

(A) Verbriefung durch (i) Vereinigung von verschiedenen Teilvermögen des verbrieften Vermögens der Gesellschaft

in ein einziges Vermögen durch die Änderung der Bedingungen der Verbriefungen anlässlich der Emission von Aktien
der Kategorie G, der Kategorie N, der Kategorie R und der Kategorie W, (ii) die Bildung einer Kategorie von Stamm-
aktien, die zur einzigen Kategorie von Gesellschaftsaktien wird (außer der Kategorie B Management Aktie), die in Form
einer einzigen Vermögens die gesamten Aktiva und Passiva der Gessellschaft darstellen, und (iii) die Umwandlung aller
bestehenden Aktien, ausgenommen der Kategorie B Aktien, in Aktien der Stammkategorie gemäss den Umwandlungs-
verhältnis, wie nachfolgend festgesetzt, so dass alle Gesellschaftsaktien Aktien des Stammkategorie sind: 

Eine (1) Kategorie G Aktie sind 0,76334746 Stammaktien;

105662

Eine (1) Kategorie N Aktie sind 10,48454427 Stammaktien;
Eine (1) Kategorie R Aktie sind 0,11116244 Stammaktien;
Eine (1) Kategorie W Aktie sind 13,72698613 Stammaktien;
die Zustimmung zum Umwandlungsverhältnis anwendbar auf die jeweilige Aktienkategorie, bestimmt gemäss dem

Wert des verbrieften Vermögens des jeweiligen Teilvermögens, die Anzahl der in jeder Kategorie ausgegebenen Aktien
und die der jeweiligen Kategorie zugeordnete Agio und gesetzliche Rückstellung, die Zuteilung aller Aktiva und Passiva
(einschliesslich Agio und gesetzliche Rückstellung) der verschiedenen Teilvermögen innerhalb der Gesellschaft bezüglich
der Kategorie G, der Kategorie N, der Kategorie W und der Kategorie R Aktien zum Stammpool des verbrieften Aktiva
und Passiva der Gesellschaft und Annulierung des Teilvermögens, so dass die Rechte an allen Aktien (außer B Manage-
ment Kategorie) gleichwertig sind in den verbrieften Aktiva und Passiva der Gesellschaft, Anerkennung des Aktienbe-
sitzes in der Gesellschaft nach der Umwandlung, wie nachfolgend festgelegt, so dass nach der Umwandlung das
ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft zu einem Gesamtbetrag von zweihunderteinundachtzig Million zweihundert-
fünfzigtausendundeinem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 281.250.001,25), die durch eine (1) Kategorie B Manage-
ment Aktie repräsentiert werden, die von der NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l. gehalten wird
und zweihundertfünfundzwanzig Millionen (225.000.000) (Stamm-) Aktien, jede mit einem Nennwert von einem Euro
und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25), die wie folgt gehalten werden: 

(B)Wechsel der Rechtsform der Gesellschaft durch Umwandlung der Gesellschaft von einer société en commandite

par actions in eine société anonyme (Aktiengesellschaft),

(i) Anerkennung des Berichts über den Nettowert der Gesellschaft durch einen unabhängigen Rechnungsprüfer (ré-

viseur d’entreprises) GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.;

(ii) Anerkennung des Rücktritts von NLG ACQUISTION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l. als Geschäftsführer

und commandité der Gesellschaft;

(iii) die Bestellung von (i) Herrn Wesley R. Edens, geboren in Quincy, State of Washington, USA am 30. Oktober

1961, senior executive, mit Geschäftsadresse in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, als Verwaltungsratsmitglied
für einen Zeitraum endend mit der Hauptversammlung der Aktionäre, die die Gesellschaftkonten für das Geschäftsjahr
2011 entlastet, (ii) Herrn Robert I. Kauffman, geboren in New York, State of New York, USA, am 22. Oktober 1963,
senior executive, mit Geschäftsadresse in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, als Verwaltungsratsmitglied für einen

Name des Aktionärs

Anzahl der Akti-

en

NLG Acquisition Holdings Management, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.767.424

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.403.452

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.589.964

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.874.048

Fortress Investment Fund III L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.939.957

Fortress Investment Fund III (Fund B) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.933.782

Fortress Investment Fund III (Fund C) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.240.805

Fortress Investment Fund III (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.847.910

Fortress Investment Fund III (Fund E) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.046

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund A) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

648.365

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund B) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.273.802

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund C) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328.072

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.563.650

Fortress Subsidiary (GAGACQ) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.555.412

FABP Subsidiary (GAGACQ) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.378.007

Fortress Investment Fund III (GAGACQ Subsidiary) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.721.572

Fortress Investment Fund III (Fund B) (GAGACQ Subsidiary) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.732.178

Fortress Investment Fund III (Fund C) (GAGACQ Subsidiary) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.453.300

Fortress Investment Fund III (Fund D) (GAGACQ Subsidiary) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.630.841

Fortress Investment Fund III (Fund E) (GAGACQ Subsidiary) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

395.528

Fortress Subsidiary (GAGACQ) Investors (Cayman) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.948.503

Fortress Subsidiary (GAGACQ) Co-Investors (Cayman) Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.679.326

Drawbridge Special Opportunities Fund Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.544.506

Drawbridge Special Opportunities Fund LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.937.181

ZG Holdings CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.136.145

CGI Phoenix Co D1 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

850.049

CG Phoenix E Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.013.832

CG Phoenix D Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.837.019

CGI Phoenix Co E1 Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814.288

CGI Phoenix Co D2 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.281.445

Tangentum Erste Vermögensbeteiligungs, GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479.591

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225.000.001

105663

Zeitraum endend mit der Hauptversammlung der Aktionäre, die die Gesellschaftksonten für das Geschäftsjahr 2011 ent-
lastet und’ (iii) Herrn Randal A. Nardone, geboren in New York, State of New York am 22. Juni 1955, senior executive,
mit Geschäftsadresse in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, als Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum endend
mit der Hauptversammlung der Aktionäre, die die Gesellschaftkonten für das Geschäftsjahr 2011 entlastet;

(iv) Annulierung der Kategorie B Management Aktie mit Reduzierung des Aktienkapitals von zweihunderteinundacht-

zig Millionen zweihundertfünfzigtausendundeinem Euro und fünfundzwangzig Cent (EUR 281.250.001,25) auf zweihun-
derteinundachtzig Millionen zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 281.250.000) eingeteilt in
zweihundertfünfundzwanzig Millionen (225.000.000) Aktien ohne Zahlung des Nennwertes von einem Euro und fünf-
undzwanzig Cents (EUR 1.25), der dem Agio zugeteilt wird;

(v) Namenänderung der Gesellschaft in GAGFAH S.A.;
(vi) Änderung des Gesellschaftzweckes und des Artikles 4 der Satzung der Gesellschaft, wie folgend: «Der Gesell-

schaftszweck umfasst die Ausführung einer oder mehrerer Transaktionen auf dem Gebiet der Verbriefungen und jede
zusätzliche oder damit verbundene Tätigkeit, und/oder die im Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen vorgese-
hen sind (das «Verbriefungsgesetz»).

Die Gesellschaft kann insbesondere ohne Beschränkung Geschäfte eingehen, durch welche sie unmittelbar oder mit-

tels anderer Organismen jeglicher Art, Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, jeglicher Art von Vermö-
genswerten (einschliesslich, ohne Beschränkung, jegliche Art von Verbriefungen, Darlehen, Forderungen und anderen
Vermögenswerten, die mit in Deutschland gelegenen Wohnimmobilien verbunden Vermögenswerte beinhalten) oder
von Dritten übernommenen oder den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnenden Verbindlichkei-
ten verbunden sind, in dieser Urkunde zusammengefasst bezeichnet als die «Unterliegenden Vermögenswerte».

Die Gesellschaft kann, direkt oder indirekt, durch Zwischengesellschaften jede Art von Verbriefungen in jeglicher

Form und Natur ausgeben, einschließlich aller Aktien, Schuldscheine und Schuldverschreibungen sowie Optionen oder
garantiegebender Optionsscheine, welche Rechte auf zusätzliche Aktien gewähren, deren Wert, Ertrag oder Ausbeute
von den mit den Wertpapieren zusammenhängenden Risiken abhängen. Die Gesellschaft kann auch durch Darlehen
oder anderweitig von jedem Rechtsträger Kapital leihen oder beschaffen, um teilweise oder ganz den Erwerb und die
Übernahme der unterliegenden Vermögenswerte zu finanzieren und/oder jeder Zahlung oder anderweitigen Verpflich-
tung, die unter jeder der Verbriefungen, welche von der Gesellschaft ausgegeben wurde oder unter jeder Vereinbarung,
die in dem Zusammenhang mit einer Verbriefung eingegangen wurde, nachzukommen.

Die Gesellschaft kann durch jedes Mittel (einschliesslich mittels Verkauf, Zession, Austausch, Umwandlung, Einlage

oder durch Derivat- oder Swap-Transaktionen) die gesamten oder einen Teil der Unterliegenden Vermögenswerte ver-
kaufen, übertragen, rückerwerben und darüber verfügen.

Im Zusammenhang mit Verbriefungen kann die Gesellschaft (direkt oder indirekt) (i) Anteile, Rechte und Interessen

an, sowie Obligationen in luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften oder anderen Rechtsträgern, die auf
allen Sektoren tätig sind (einschliesslich Wohnimmobilieneigentum), erwerben, halten oder darüber verfügen, und zwar
in jeder Form und mit allen Mitteln, ob direkt oder indirekt; (ii) Risiken erwerben oder auf sich nehmen mittels Gewäh-
rung von Darlehen an luxemburgische und/oder ausländische Rechtsträger; (iii) Aktien, Obligationen, Schuldverschrei-
bungen, Schuldscheine, Fondanteile (units) und andere Verbriefungen oder Wertpapiere jeder Art und Verträge, über
oder im Zusammenhang mit einem oder mehreren der vorgenannten Instrumente, durch Kauf erwerben, zeichnen oder
auf jede andere Weise, auch durch Übertragung mittels Kauf oder Austausch oder in anderer Weise; (iv) den Organis-
men, die Teil ihrer Gruppe sind, finanzielle Hilfe zukommen lassen, durch die uneingeschränkte zur Verfügungstellung
von Garantien oder Verbriefungen oder Darlehen jeder Form; und (v) ein Portfolio (einschließlich u.a. der Vermögens-
werte auf die unter (i), (ii) und (iii) dieses Absatzes verwiesen wird) verwalten, entwickeln, führen und das Eigentum
daran besitzen. Die Gesellschaft kann darüberhinaus Rechte an Gesellschaften, Kommanditgesellschaften, Trust, Fonds
und anderen Rechtsträgern erwerben, besitzen und darüber verfügen.

Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich erlaubt, jede Art von dinglichen Sicherungsrechten auf ihre Vermögenswerte

gewähren, gemäß jeglichem Recht an jeden Investor, Treuhänder, Wertpapierverwalter, Wertpapieragent, Treuhand-
vertreter oder jede andere Person, die die Investoren oder jede andere in eine Verbriefung involvierte Partei oder Par-
tei, mit der die Gesellschaft eine Übereinkunft in Zusammenhang mit einer Verbriefung getroffen hat, vertritt, um ihre
Zahlungen oder andere Verpflichtungen unter allen ausgegebenen Effekten oder Übereinkünften, die von der Gesell-
schaft zum Zwecke der Sicherung solcher Vermögenswerte eingegangen wurden, zu sichern.

Die Gesellschaft kann jede Übereinkunft oder jeden Vertrag (einschließlich, ohne Beschränkung, Derivate) eingehen

und kann jedes Dokument ausgeben, unterzeichnen, billigen oder ratifizieren und kann alle Handlungen vornehmen, die
notwendig sind, um Verbriefungen vorzubereiten, auszuführen und abzuwickeln oder die damit zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann die Unterliegenden Vermögenswerte verkaufen, abtreten, übertragen oder darüber ganz oder

teilweise anderweitig verfügen, und zwar in der Weise und für die Vergütung, die der Verwaltungsrat oder jede für sol-
che Zwecke designierte Person, zu dieser Zeit genehmigt.

Die Gesellschaft kann alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen oder anderen Transaktionen vornehmen,

welche direkt oder indirekt zusammenhängen mit, oder notwendig oder nützlich sind, um die Erfüllung ihres Zwecks zu
erleichtern (jedoch immer im Anwendungsbereich des Verbriefungsgesetzes liegend).

Die Gesellschaft kann zeitweise Geldmittel besitzen, welche sie durch die Ausgabe von Aktien oder anderen Sicher-

heiten der Gesellschaft erworben hat, in Erwartung, dass sie investiert werden in Form von Verbriefungen. Zusätzlich
kann die Gesellschaft gewisse, nicht verteilte Geldmittel zurückhalten gemäß der ihrer Dividendenpolitik zugrundelie-
genden Bedingungen.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden, Geldmittel einem Konto oder einem Rücklagenkonto zuzuteilen, welches von

der Gesellschaft eingerichtet wurde, um jederzeit ausreichende Geldmittel zur Verfügung zu haben, um die Ausgaben
und Kosten, der im Zusammenhang mit den durch den Verwaltungsrat bestimmten Aktivitäten der Gesellschaft zu dek-

105664

ken. Solche Aktivitäten beinhalten insbesondere die Ausgaben der laufenden Geschäftsführung, (einschliesslich der fixen
Kosten), die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, die Barauslagen der Verwaltungsratsmitglieder, die Versiche-
rungs- und Verwaltungskosten. Rücklagenkontogelder werden an die Aktionäre der Gesellschaft verteilt, falls der Ver-
waltungsrat festlegt, dass die Entstehung weiterer kurzfristiger Betriebskosten oder Betriebskapitalausgaben
unwahrscheinlich ist.»

(vii) Satzungsänderung und Neufassung der Satzung der Gesellschaft um (i) die Satzung an die neue Form der Gesell-

schaft anzupassen und einschliesslich ohne Beschränkung, ihren Namen zu ändern, die Stammkapitalstruktur anzupassen,
die oben gemachte Änderung des Gesellschaftszwecks zu berücksichtigen, und (ii) die oben genannten sowie die nach-
folgenden Tagesordnungspunkte, substantziell in der Form, in der sie in den Vollmachten dargelegt ist.

(C) Bildung eines genehmigten, nicht ausgegebenen Aktienkapitals innerhalb der Gesellschaft in Höhe von zehn Mil-

liarden Euro (EUR 10.000.000.000), eingeteilt in acht Milliarden (8.000.000.000) Aktien mit einem Nennwert von jeweils
einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25), Kenntnisnahme des Berichts übereinstimmend mit den Artikeln 32-
3(5) des luxemburgischen Gesellschaftsrechts über die Umstände und Preise von Aktienausgaben gegen Bargeld ohne
Vorzugszeichnungsrechte, der Verzicht darauf, Aufhebung und Ermächtigung des Verwaltungsrates, jedes Vorzugszeich-
nungsrecht im Falle der Emission von Aktien innerhalb des genehmigten Aktienkapitals zu aufheben, begrenzen oder
darauf zu verzichten, Ermächtigung des Verwaltungsrates, mit weiteren Verbriefungen fortzufahren und Aktien innerhalb
des genehmigten Aktienkapitals gegen Bareinlagen auszugeben in der Art und Weise von Übernahme von verfügbaren
Prämien oder Reserven oder anderweitig gemäss den Geschäftsbedingungen, welche durch den Verwaltungsrat oder
seines/seiner Vertreter(s) festgelegt worden sind (einschliesslich ohne Beschränkung in Relation zu einem oder mehre-
rer öffentlicher Angebote der Gesellschaftsaktien und insbesondere kann der Verwaltungsrat, ohne Beschränkung, Ak-
tien zugunsten von Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten und Angestellten der Gesellschaft und der
Gruppe, zu der sie gehört, direkt oder unter den Bedingungen eines Bezugsrechtsplanes, der vom Verwaltungsrat ge-
nehmigt worden ist, ausgeben), jedoch unter Beibehaltung, Unterdrückung oder Beschränkung der Vorzugszeichnungs-
aktien existierende Aktionäre, Festlegung des Gültigkeitszeitraumes des genehmigten Aktienkapitals der Gesellschaft,
beginnend am Tag der ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, auf der die vorliegende Ermächtigung fest-
gehalten wird und endend am fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Urkunde, die das Protokoll der genannten
Hauptversammlung im Mémorial beurkundet, 

(D) Die Ermächtigung der Gesellschaft, oder jeder ihrer vollständig in ihrem Eigentum stehenden Tochtergesellschaf-

ten, Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10% des ausgegebenen Kapitals von Zeit zu Zeit, zu kaufen, zu er-
werben oder zu empfangen, von Zeit zu Zeit an der Börse oder durch privat verhandelte Transaktionen im Fall des
käuflichen Erwerbs, zum Kaufpreis von mindestens EUR 10 und höchstens EUR 40, gemäß der vom Verwaltungsrat der
Gesellschaft festgelegten Bedingungen, vorausgesetzt, dass ein solcher Erwerb in Übereinstimmung mit Artikel 49-2 des
luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 sowie der geltenden Gesetze und Verordnungen erfolgt. Eine solche
Ermächtigung wird für einen Zeitraum von 18 Monaten gewährt. (ii) Dass die anwesenden oder vertretenen Aktonäre,
die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Nummer ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet
werden; diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem
Versammlungsbüro der Hauptversammlung unterschrieben wird, werden an die vorliegende Urkunde angehängt und
werden zur gleichen Zeit bei den Registrierungsbehörden eingereicht.

(iii) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, die durch die erscheinenden Parteien mit ne varietur paraphiert

werden, ebenfalls an die vorliegende Urkunde angehängt werden.

(iv) Dass das gesamte Gesellschaftskapital, das bei der vorliegenden Hauptversammlung vertreten ist und alle anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie ordnungsgemäss geladen wurden und vor dieser Versammlung
Kenntnis von den Tagesordnungspunkten genommen haben. 

(v) Dass die vorliegende Hauptversammlung, auf der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ordnungsgemäss

zustandegekommen ist und über alle Tagesordnungspunkte gültig beraten kann.

Dann hat die Hauptversammlung nach Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst, jedesmal mit der Zu-

stimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftenden Gesellschafters: 

<i>Erster Beschluss

(E) Die Hauptversammlung hat mit der Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftenden Gesellschaf-

ters beschlossen, Verbriefungen vorzunehmen und die verschiedenen Teilvermögen der verbrieften Vermögenswerte
der Gesellschaft in einem einzigen Vermögen zu vereinen durch Änderung der bei Emission der Kategorie G-, Kategorie
N-, Kategorie R- und Kategorie W-Aktien festgesetzten Bedingungen für die Verbriefungen, und eine Kategorie von
Stammaktien zu bilden, die die einzige Aktienklasse der Gesellschaft darstellt (aussgenommen der Kategorie B Manage-
ment-Aktie) und die alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft repräsentiert und ein einziges Vermögen bildet, und (iii) die
Umwandlung aller bestehenden Aktien, ausgenommen der Kategorie B Aktien, in Aktien der Stammkategorie gemäss
den Umwandlungsverhältnis, wie nachfolgend festgesetzt, so dass alle Gesellschaftsaktien Aktien der Stammkategorie
sind:

Eine (1) Kategorie G Aktie sind 0,76334746 Stammaktien; 
Eine (1) Kategorie N Aktie sind 10,48454427 Stammaktien;
Eine (1) Kategorie R Aktie sind 0,11116244 Stammaktien;
Eine (1) Kategorie W Aktie sind 13,72698613 Stammaktien.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, diesem Umwandlungsverhältnis, welches auf jede Kategorie von Aktien an-

wendbar ist und festgelegt wurde übereinstimmend mit dem Wert der umgetauschten Vermögenswerte eines jeden
Teilvermögens, der Anzahl von in jeder Kategorie ausgegebenen Aktien und dem Emissionsagio sowie der rechtlichen
Rücklage, die jeder Kategorie zugeteilt wurde, zuzustimmen und alle Aktiva und Passiva (einschliesslich des Emissions-
agio und der rechtlichen Rücklage) der unterschiedlichen Teilvermögen innerhalb der Gesellschaft, die in Verbindung

105665

stehen mit den Kategorie G, Kategorie N, Kategorie W und Kategorie R Aktien dem Stammpool der umgetauschten
Aktiva und Passiva der Gesellschaft zuzuteilen und die Teilvermögen zu annullieren, so dass die Rechte an allen Aktien
(ausser der B Management Kategorie) gleich sind in den umgetauschten Aktiva und Passiva der Gesellschaft. Die Haupt-
versammlung hat den Aktienbesitz in der Gesellschaft als Folge der Umwandlung, wie unten folgt, anerkannt, so dass
nach dem obigen Umtausch des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft in Höhe von insgesamt zweihundertund-
einundachtzig Millionen zweihundertundfünfzigtausend und ein Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 281.250.001,25)
von einer (1) Kategorie B Aktie repräsentiert wird, die von NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l.
gehalten wird und zweihundertundfünfundzwanzig Millionen (225.000.000) (Stamm-) Aktien, die jeweils einen Nennwert
von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) haben und wie folgt gehalten werden: 

<i>Zweiter Beschluss 

Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters,

beschlossen, die Rechtsform der Gesellschaft zu ändern, indem die Gesellschaft von einer société en commandite par
actions in eine société anonyme (Aktiengesellschaft) umgewandelt wird. Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung
des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters, beschlossen, den Bericht über den Nettoinven-
tarwert der Gesellschaft der unabhängigen Rechnungsprüfer (réviseurs d’entreprises) GRANT THORNTON REVISI-
ON ET CONSEILS S.A., anzuerkennen, der zu folgendem Schluß kommt:

«Auf Grundlage der übernommenen Arbeit, entsprechend dem oben Beschrieben, und übereinstimmend mit den

Empfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer und den erhaltenen Dokumenten kommen wir zu folgendem Ergebnis:

Uns sind keine Gründe bekannt, die uns glauben lassen, dass der Wert der Sacheinlage bei der Umwandlung der NLG

ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A., in die NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.A., eine «société anonyme», nicht
zumindest der Anzahl und dem Nennwert der auszugebenden Aktien entspricht.

Unser Bericht wird lediglich zu dem Zweck angefertigt, dass den Anforderungen der Artikel 2, 6-1 und 32-1 (5) des

luxemburgischen Gesellschaftsrechts entsprochen wird. Der Bericht darf nicht für andere Zwecke benutzt werden,
kann nicht zur Verweisung herangezogen werden oder an andere Parteien weitergegeben werden ohne unsere vorhe-
rige Zustimmung. Luxemburg, den 29. September 2006».

Name des Aktionärs

Anzahl der Akti-

en

NLG Acquisition Holdings Management, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund A) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.767.424

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.403.452

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund C) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.589.964

Fortress Residential Investment Deutschland (Fund D) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.874.048

Fortress Investment Fund III L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.939.957

Fortress Investment Fund III (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.933.782

Fortress Investment Fund III (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.240.805

Fortress Investment Fund III (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.847.910

Fortress Investment Fund III (Fund E) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200.046

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

648.365

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.273.802

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

328.072

Fortress Investment Fund III (Coinvestment Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.563.650

Fortress Subsidiary (GAGACQ) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.555.412

FABP Subsidiary (GAGACQ) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.378.007

Fortress Investment Fund III (GAGACQ Subsidiary) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.721.572

Fortress Investment Fund III (Fund B) (GAGACQ Subsidiary) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.732.178

Fortress Investment Fund III (Fund C) (GAGACQ Subsidiary) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.453.300

Fortress Investment Fund III (Fund D) (GAGACQ Subsidiary) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.630.841

Fortress Investment Fund III (Fund E) (GAGACQ Subsidiary) LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

395.528

Fortress Subsidiary (GAGACQ) Investors (Cayman) Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.948.503

Fortress Subsidiary (GAGACQ) Co-Investors (Cayman) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.679.326

Drawbridge Special Opportunities Fund Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.544.506
Drawbridge Special Opportunities Fund LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.937.181
ZG Holdings CV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.136.145

CGI Phoenix Co D1 Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

850.049

CG Phoenix E Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.013.832

CG Phoenix D Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.837.019

CGI Phoenix Co E1 Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

814.288

CGI Phoenix Co D2 Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.281.445

Tangentum Erste Vermögensbeteiligungs, GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

479.591

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

225.000.001

105666

Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters,

beschlossen, den Rücktritt von NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l. als Geschäftsführer und
commandité der Gesellschaft anzuerkennen. 

Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters,

beschlossen, Herrn Wesley R. Edens, geboren in Quincy, State of Washington, USA am 30. Oktober 1961, senior exe-
cutive, mit Geschäftsadresse in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, als Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum
endend mit der Hauptversammlung der Aktionäre, die die Gesellschaftskonten für das Geschäftsjahr 2011 entlastet, (ii)
Herrn Robert I. Kauffman, geboren in New York, State of New York, USA, am 22. Oktober 1963, sseior executive, mit
Geschäftsadresse in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, als Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum endend
mit der Hauptversammlung der Aktionäre, die die Gesellschaftskonten für das Geschäftsjahr 2011 entlastet und (iii)
Herrn Randal A. Nardone, geboren in New York, State of New York, am 22. Juni 1955, senior executive, mit Geschäfts-
adresse in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, als Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum endend mit der
Hauptversammlung der Aktionäre, die die Gesellschaftskonten für das Geschäftsjahr 2011 entlastet, zu bestimmen, so
dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft wie folgt zusammengesetzt ist: Wesley R. Edens, Robert I. Kauffman, und Ran-
dal A. Nardone.

Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters,

beschlossen, die Kategorie B Management Aktie zu annullieren, mit Reduktion des Aktienkapitals von zweihundertund-
einundachtzig Millionen zweihundertundfünfzigtausend und ein Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 281.250.001,25) auf
zweihundertundeinundachtzig Millionen zweihundertundfünfzigtausend Euro (EUR 281.250.00), eingeteilt in zweihun-
dertundfünfundzwanzig Millionen (225.000.000) Aktien und den Nennwert dieser Aktie von einem Euro und fünfund-
zwanzig Cent (EUR 1,25) dem Emissionsagio zuzuteilen.

Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters,

beschlossen, den Namen der Gesellschaft in GAGFAH S.A. zu ändern.

Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters,

beschlossen, den Zweck und Artikel 4 der Gesellschaftssatzung abzuändern und wie folgt zu lesen:

«Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Ausführung einer oder mehrerer Transaktionen auf dem Gebiet der Ver-

briefungen und jede zusätzliche oder damit verbundene Tätigkeiten, welche im Gesetz vom 22. März 2004 über Ver-
briefungen vorgesehen sind (das «Verbriefungsgesetz»).

Die Gesellschaft kann insbesondere ohne Beschränkung Geschäfte eingehen, durch welche sie unmittelbar oder mit-

tels anderer Organismen jeglicher Art, Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, jeglicher Art von Vermö-
genswerten (einschliesslich, ohne Beschränkung, jegliche Art von Effekten, Darlehen, Forderungen und anderen
Vermögenswerten, die mit in Deutschland gelegenen Wohnimmobilien verbunden Vermögenswerte beinhalten) oder
von Dritten übernommenen oder den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnenden Verbindlichkei-
ten verbunden sind, in dieser Urkunde zusammengefasst bezeichnet als «Unterliegende Vermögenswerte».

Die Gesellschaft kann, direkt oder mittels Zwischengesellschaften, jede Form und Art von Verbriefungen, einschlies-

slich unbegrenzt Aktien, Schuldscheine und Schuldurkunden ebenso wie Optionen oder Bezugsrechte auf zusätzliche
Aktien, deren Wert, Umsatz oder Ertrag abhängig ist von den Risiken, die mit dem Grundlagenvermögen verbunden
sind, ausgeben. Die Gesellschaft kann ebenfalls von jedem Rechtsträger Darlehen aufnehmen oder Gelder aufbringen in
Form von Dahrlehen oder in anderer Form, um den Erwerb oder die Übernahme von Unterliegenden Vermögenswer-
ten ganz oder teilweise zu finanzieren und/oder jeder Zahlung oder anderen Verbindlichkeit unter jeder dieser Effekten
nachzukommen, welche von der Gesellschaft ausgegeben wurden oder unter jeglicher Übereinkunft, welche im Zusam-
menhang mit einer Verbriefung eingegangen wird. Die Gesellschaft kann durch jedes Mittel (einschliesslich mittels Ver-
kauf, Zession, Austausch, Umwandlung, Einlage oder durch derivative oder Swap-Transaktionen) das gesamte oder
einen Teil der Unterliegenden Vermögenswerte verkaufen, übertragen, rückerwerben und darüber verfügen. Im Zusam-
menhang mit Verbriefungen kann die Gesellschaft (direkt oder indirekt) (i) in jeder Form und mit jeden Mitteln, ob direkt
oder indirekt, Beteiligungen, Rechte und Interessen sowie Verbindlichkeiten an luxemburgischen und/oder ausländi-
schen Gesellschaften oder anderen Rechtsträgern, die auf allen Sektoren (einschliesslich unbewegliches Vermögen) tätig
sind, erwerben, bezitzen und darüber zu verfügen; (ii) mittels zur Verfügung Stellung von Darlehen an luxemburgische
und/oder ausländische Rechtsträger Risiken erwerben oder übernehmen; (iii) durch Kauf, Zeichnung oder in anderer
Art und Weise, sowie durch Transfer mittels Verkauf, Austausch oder in anderer Art und Weise, Aktien, Schuldver-
schreibungen, Obligationen, Schuldscheine, Fondanteile (units) oder andere Effekten oder finanzielle Übereinkünfte jeg-
licher Art und Verträge darüber oder diesbezüglich erwerben; (iv) die Organismen, die Teil ihrer Gruppe sind, mit
jeglicher finanziellen Unterstützung versehen, indem sie sie, ohne Beschränkung, mit Bürgschaften oder Sicherheiten
oder Darlehen in jeder Form versieht; und (v) ein Portfolio (einschliesslich u.a. die Vermögenswerte auf die unter (i),
(ii) und (iii) dieses Absatzes verwiesen wird) verwalten, entwickeln, führen und das Eigentum daran besitzen. Die Ge-
sellschaft kann darüberhinaus Rechte an Gesellschaften, Kommanditgesellschaften, Treuhand, Fonds und anderen
Rechtsträgern erwerben, besitzen und darüber verfügen. Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich erlaubt, jede Art von
dinglichen Sicherungsrechten auf ihre Vermögenswerte gewähren, unter jedem Recht und an jeden Investor, Treuhän-
der, Wertpapierverwalter, Wertpapieragent, Treuhandvertreter oder jede andere Person, die die Investoren oder jede
andere in eine Verbriefung involvierte Partei oder Partei, mit der die Gesellschaft eine Übereinkunft in Zusammenhang
mit einer Verbriefung getroffen hat, um ihre Zahlungen oder andere Verpflichtungen unter allen ausgegebenen Effekten
oder Übereinkünften, die von der Gesellschaft zum Zwecke der Sicherung solcher Vermögenswerte eingegangen wur-
den, zu sichern. Die Gesellschaft kann jede Übereinkunft oder Vertrag (einschliesslich, ohne Beschränkung, Derivate)
eingehen und kann jedes Dokument ausgeben, unterzeichnen, billigen oder ratifizieren und kann alle Handlungen vor-
nehmen, die notwendig sind, um Verbriefungen vorzubereiten, auszuführen und abzuwickeln oder die damit zusammen-
hängen. Die Gesellschaft kann die unterliegenden Vermögenswerte verkaufen, abtreten, übertragen oder darüber ganz

105667

oder teilweise anderweitig verfügen, und zwar in der Weise und für die Vergütung, die der Verwaltungsrat oder jede
für solche Zwecke designierte Person, zu dieser Zeit genehmigt. Die Gesellschaft kann alle wirtschaftlichen, technischen
und finanziellen oder anderen Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt zusammenhängen mit, oder not-
wendig oder nützlich sind, um die Erfüllung ihres Zwecks zu erleichtern (jedoch immer im Anwendungsbereich des Ver-
briefungsgesetzes liegend).

Die Gesellschaft kann zeitweise Fonds besitzen, welche sie durch die Ausgabe von Aktien oder anderen Verbriefun-

gen der Gesellschaft erworben hat, in Erwartung, dass sie investiert werden in Form von Verbriefungen. Zusätzlich kann
die Gesellschaft gewisse, nicht verteilte, Fonds zurückhalten in Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Übereinstimmung
mit den Bestimmungen ihrer Dividendenpolitik.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden, Fonds einem Konto oder einem Rücklagenkonto zuzuweisen, welches von der

Gesellschaft errichtet wurde, um jederzeit ausreichende Fonds zur Verfügung zu haben, um die Ausgaben und Kosten,
welche im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Gesellschaft, wie sie durch den Verwaltungsrat bestimmt sind, zu
decken. Solche Aktivitäten beinhalten insbesondere die Ausgaben der laufenden Geschäftsführung (einschliesslich fixe
Kosten), Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, Barauslagen der Verwaltungsratsmitglieder, Versicherungskosten
und Verwaltungskosten. Rücklagenkontofonds werden an die Aktionäre der Gesellschaft verteilt, falls der Verwaltungs-
rat festlegt, dass die Entstehung weiterer kurzfristiger Betriebskosten oder Betriebskapitalausgaben unwahrscheinlich
sind.»

Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters,

beschlossen, die Gesellschaftssatzung abzuändern und neuzufassen um (i) die Satzung der neuen Gesellschaftsform an-
zupassen und einschliesslich, ohne Beschränkung, ihren Namen zu ändern, die Stammkapitalstruktur anzupassen, die Ab-
änderung des Gesellschaftszwecks wie oben in Betracht zu ziehen, ebenso wie (ii) die obigen und folgenden
Tagesordnungspunkte, wesentlich in der Form, wie sie in den Vollmachten ausgelegt sind.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung hat, mit Zustimmung des Geschäftsführers und des persönlich haftendenden Gesellschafters,

beschlossen, ein genehmigtes, nicht ausgegebenes Aktienkapital innerhalb der Gesellschaft zu erschaffen, in Höhe von
zehn Milliarden Euro (EUR 10.000.000.000), eingeteilt in acht Milliarden (8.000.000.000) Aktien mit einem Nennwert
von jeweils eins Komma fünfundzwanzig Euro (EUR 1,25). Die Hauptversammlung hat den Bericht gemäss den Artikeln
32-3(5) des Luxemburgischen Gesellschaftsrechts über die Umstände und Preise von Aktienausgaben gegen Bargeld
ohne Vorzugszeichnungsrechte, deren Verzicht darauf, Aufhebung und Ermächtigung des Verwaltungsrates, jedes Vor-
zugszeichnungsrecht im Falle von Ausgaben von Aktien innerhalb des genehmigten Aktienkapitals aufzuheben, zu be-
grenzen oder darauf zu verzichten, anerkannt und hat beschlossen, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, mit weiteren
Verbriefungen fortzufahren und Aktien innerhalb des genehmigten Aktienkapitals gegen Bareinlagen auszugeben und
zwar durch Übernahme von verfügbaren Prämien oder Reserven oder anderweitig gemäss den Geschäftsbedingungen,
welche durch den Verwaltungsrat oder seines/seiner Vertreter(s) festgelegt worden sind (einschliesslich ohne Beschrän-
kung in Relation zu einem oder mehrerer öffentlicher Angebote der Gesellschaftsaktien und insbesondere kann der Ver-
waltungsrat, ohne Beschränkung, Aktien zugunsten von Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten und
Angestellten der Gesellschaft und der Gruppe, zu der sie gehört, direkt oder unter den Bedingungen eines Bezugsrechts-
planes, der vom Verwaltungsrat genehmigt worden ist, ausgeben), jedoch unter Beibehaltung, Unterdrückung oder Be-
schränkung der Vorzugszeichnungsaktien der bestehenden Aktionäre.

Abgeänderte und Neugefasste Gesellschaftssatzung übereinstimmend mit den oben gefassten Beschlüssen und insbe-

sondere des dritten Beschlusses.

Art. 1. Form, Name. Zwischen den an diesem Tag Anwesenden und allen Personen, die Eigentümer der nachfol-

gend benannten Aktien werden, wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Na-
men GAGFAH S.A. (die «Gesellschaft») gegründet, die den luxemburgischen Gesetzen (die «Gesetze») und den
Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegen.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 3. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg im Grossherzogtum von Luxemburg.
Der Verwaltungsrat hat das Recht, Büros, Verwaltungszentren, Agenturen und Zweigniederlassungen an den Orten

einzurichten, die er für geeignet hält, gleich ob innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg. 

Gesetzt den Fall, dass der Gesellschaftssitz durch Vertrag mit Dritten vereinbart wurde, kann der Sitz, unbeschadet

der allgemeinen Rechtssätze, welche auf Vertragsbedingungen Anwendung finden, aufgrund eines Beschlusses des Ver-
waltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden; der Gesellschaftssitz kann aufgrund
eines Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.

Ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer

Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschafts-
sitz oder die Kommunikation mit anderen Orten im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vor-
übergehend, bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese
vorübergehende Massnahme hat keinerlei Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, welche unbeschadet der
provisorischen Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt.

Art. 4. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Ausführung einer oder mehrerer Transaktionen auf dem

Gebiet der Verbriefungen und jede zusätzliche oder damit verbundene Tätigkeit, und/oder die im Gesetz vom 22. März
2004 über Verbriefungen vorgesehen sind (das «Verbriefungsgesetz»). 

105668

Die Gesellschaft kann insbesondere ohne Beschränkung Geschäfte eingehen, durch welche sie unmittelbar oder mit-

tels anderer Organismen jeglicher Art, Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, jeglicher Art von Vermö-
genswerten (einschliesslich, ohne Beschränkung, jegliche Art von Verbriefungen, Darlehen, Forderungen und anderen
Vermögenswerten, die mit in Deutschland gelegenen Wohnimmobilien verbunden Vermögenswerte beinhalten) oder
von Dritten übernommenen oder den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnenden Verbindlichkei-
ten verbunden sind, in dieser Urkunde zusammengefasst bezeichnet als die «Unterliegenden Vermögenswerte».

Die Gesellschaft kann, direkt oder mittels Zwischengesellschaften, jede Form und Art von Verbriefungen, einschlies-

slich unbegrenzt Aktien, Schuldscheine und Schuldurkunden ebenso wie Optionen oder Bezugsrechte auf zusätzliche
Aktien, deren Wert, Umsatz oder Ertrag abhängig ist von den Risiken, die mit den Unterliegenden Vermögenswerten
verbunden sind, ausgeben. Die Gesellschaft kann ebenfalls von jedem Rechtsträger Darlehen aufnehmen oder Gelder
aufbringen in Form von Dahrlehen oder in anderer Form, um den Erwerb oder die Übernahme von Unterliegenden
Vermögenswerten ganz oder teilweise zu finanzieren und/oder jeder Zahlung oder anderen Verbindlichkeit unter jeder
dieser Effekten nachzukommen, welche von der Gesellschaft ausgegeben wurden oder unter jeglicher Übereinkunft,
welche im Zusammenhang mit einer Verbriefung eingegangen wird.

Die Gesellschaft kann durch jedes Mittel (einschliesslich mittels Verkauf, Zession, Austausch, Umwandlung, Einlage

oder durch derivative oder Swap-Transaktionen) das gesamte oder einen Teil der Unterliegenden Vermögenswerte zu
verkaufen, übertragen, rückerwerben und darüber verfügen.

Im Zusammenhang mit Verbriefungen kann die Gesellschaft (direkt oder indirekt) (i) in jeder Form und mit jeden

Mitteln, ob direkt oder indirekt, Beteiligungen, Rechte und Interessen sowie Verbindlichkeiten an luxemburgischen und/
oder ausländischen Gesellschaften oder anderen Rechtsträgern, die auf allen Sektoren (einschliesslich unbewegliches
Vermögen) tätig sind, erwerben, bezitzen und darüber zu verfügen; (ii) mittels zur Verfügung Stellung von Darlehen an
luxemburgische und/oder ausländische Rechtsträger Risiken erwerben oder übernehmen; (iii) durch Kauf, Zeichnung
oder in anderer Art und Weise, sowie durch Transfer mittels Verkauf, Austausch oder in anderer Art und Weise, Ak-
tien, Schuldverschreibungen, Obligationen, Schuldscheine, Fondanteile (units) oder andere Effekten oder finanzielle
Übereinkünfte jeglicher Art und Verträge darüber oder diesbezüglich erwerben; (iv) die Organismen, die Teil ihrer
Gruppe sind, mit jeglicher finanziellen Unterstützung versehen, indem sie, ohne Beschränkung, mit Bürgschaften oder
Sicherheiten oder Darlehen in jeder Form versieht; und (v) ein Portfolio (einschliesslich u.a. die Vermögenswerte auf
die unter (i), (ii) und (iii) dieses Absatzes verwiesen wird) verwalten, entwickeln, führen und das Eigentum daran besit-
zen. Die Gesellschaft kann darüberhinaus Rechte an Gesellschaften, Kommanditgesellschaften, Treuhand, Fonds und an-
deren Rechtsträgern erwerben, besitzen und darüber verfügen.

Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich erlaubt, jede Art von dinglichen Sicherungsrechten auf ihre Vermögenswerte

gewähren, unter jedem Recht und an jeden Investor, Treuhänder, Wertpapierverwalter, Wertpapieragent, Treuhand-
vertreter oder jede andere Person, die die Investoren oder jede andere in eine Verbriefung involvierte Partei oder Par-
tei, mit der die Gesellschaft eine Übereinkunft in Zusammenhang mit einer Verbriefung getroffen hat, um ihre Zahlungen
oder andere Verpflichtungen unter allen ausgegebenen Effekten oder Übereinkünften, die von der Gesellschaft zum
Zwecke der Sicherung solcher Vermögenswerte eingegangen wurden, zu sichern.

Die Gesellschaft kann jede Übereinkunft oder Vertrag (einschliesslich, ohne Beschränkung, Derivate) eingehen und

kann jedes Dokument ausgeben, unterzeichnen, billigen oder ratifizieren und kann alle Handlungen vornehmen, die not-
wendig sind, um Verbriefungen vorzubereiten, auszuführen und abzuwickeln oder die damit zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann die Unterliegenden Vermögenswerte verkaufen, abtreten, übertragen oder darüber ganz oder

teilweise anderweitig verfügen, und zwar in der Weise und für die Vergütung, die der Verwaltungsrat oder jede für sol-
che Zwecke designierte Person, zu dieser Zeit genehmigt.

Die Gesellschaft kann alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen oder anderen Transaktionen vornehmen,

welche direkt oder indirekt zusammenhängen mit, oder notwendig oder nützlich sind, um die Erfüllung ihres Zwecks zu
erleichtern (jedoch immer im Anwendungsbereich des Verbriefungsgesetzes liegend).

Die Gesellschaft kann zeitweise Fonds besitzen, welche sie durch die Ausgabe von Aktien oder anderen Verbriefun-

gen der Gesellschaft erworben hat, in Erwartung, dass sie investiert werden in Form von Verbriefungen. Zusätzlich kann
die Gesellschaft gewisse, nicht verteilte, Fonds zurückhalten in Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Übereinstimmung
mit den Bestimmungen ihrer Dividendenpolitik.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden, Fonds einem Konto oder einem Rücklagenkonto zuzuweisen, welches von der

Gesellschaft errichtet wurde, um jederzeit ausreichende Fonds zur Verfügung zu haben, um die Ausgaben und Kosten,
welche im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Gesellschaft, wie sie durch den Verwaltungsrat bestimmt sind, zu
decken. Solche Aktivitäten beinhalten insbesondere die Ausgaben der laufenden Geschäftsführung, (einschliesslich fixe
Kosten), Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, Barauslagen der Verwaltungsratsmitglieder, Versicherungskosten
und Verwaltungskosten. Rücklagenkontofonds werden an die Aktionnäre der Gesellschaft verteilt, falls der Verwaltungs-
rat festlegt, dass die Entstehung weiterer kurzfristiger Betriebskosten oder Betriebskapitalausgaben unwahrscheinlich
sind.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebende Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertachtzig Millionen

zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 281.250.000), eingeteilt in zweihundertfünfundzwanzig Millionen (225.000.000)
Aktien mit einem Nennwert von jeweils eins Komma fünfundzwanzig Euro (EUR 1,25) und ist vollständig eingezahlt.

Das genehmigte, nicht ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zehn Milliarden Euro (EUR 10.000.000.000), ein-

geteilt in acht Milliarden (8.000.000.000) Aktien. Das genehmigte und nicht ausgegebene Gesellschaftskapital und die Ge-
nehmigung darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 29. September 2006 und endend
fünf (5) Jahre nach dem Datum der Veröffentlichung der Protokolle der ausserordentlichen Generalversammlung der
Aktionnäre der Gesellschaft vom 29. September 2006 im Mémorial (falls nicht geändert oder erweitert durch die Ge-
neralversammlung der Aktionnäre).

105669

Der Verwaltungsrat oder vom Verwaltungsrat Bevollmächtigte können zeitweise solche Aktien zu den Zeiten und

unter den Geschäftsbedingungen einschliesslich des Ausgabepreises, innerhalb des genehmigten Gesellschaftskapitals
ausgeben, wie es der Verwaltungsrat oder sein(e) Bevollmächtigter(n) in seinem oder ihrem Ermessen beschliesst. Ins-
besondere kann der Verwaltungsrat Aktien zugunsten von Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten und An-
gestellten der Gesellschaft und der Gruppe, zu der sie gehört, direkt oder unter den Bedingungen eines vom
Verwaltungsrat gebilligten Bezugsrechtsplanes ausgeben. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedes Vorzugszeichnungsrecht
der Aktionäre zu unterdrücken, begrenzen oder auszuschlagen bis zu dem Punkt, der als ratsam gilt hinsichtlich der Aus-
gabe von Aktien innerhalb des genehmigten Kapitals.

Zusätzlich kann das ausgegebene und/oder genehmigte Kapital der Gesellschaft ein oder mehrere Male durch Be-

schluss der Hauptversammlung der Aktionäre, die in Erfüllung der Quorum- und Mehrheitsregeln angenommen wurden,
die durch diese Satzung oder, gesetzt den Fall, durch Gesetz hinsichtlich jeglicher Abänderung dieser Satzung festgelegt
worden sind, erhöht oder verringert werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen innehalb der Grenzen, welche durch das Gesetz bestimmt

werden.

Die Gesellschaft darf keine Bruchteils-Aktien ausgeben. Der Verwaltungsrat ist in seinem Ermessen befugt, Barzah-

lungen oder die Ausgabe von Originalen anstatt von Bruchteils-Aktien vorzuschreiben.

Die Rechte und Verpflichtungen, welche an den Aktien hängen, sind identisch, ausser wenn anderes durch diese Sat-

zung oder die Gesetze vorgeschrieben wird. Zusätzlich zum ausgegebenen Kapital kann ein Prämienkonto festgesetzt
werden, in welches jede auf eine Aktie gezahlte Prämie zusätzlich zu dem Nennwert übertragen wird. Der Betrag auf
dem Prämienkonto kann dazu benutzt werden, für die Zahlung der Aktien zu sorgen, die die Gesellschaft von ihren Ak-
tionären zurückkaufen kann, jeden realisieten Nettoverlust auszugleichen, Ausschüttungen an die Aktionäre auszugeben
in Form von Dividenden oder Fonds der gesetzlichen Rücklage zuzuteilen.

Art. 6. Namensaktien. Die Aktien lauten nur auf den Namen.
Gemäss dem vorher Gesagten, können Namensaktenzertifikate für Aktien mit dem Aktiennennbetrag ausgegeben

werden, wie es der Verwaltungsrat vorschreibt. Die Aktienzertifikate werden durch den Verwaltungsrat in der von ihm
benannten Form ausgestellt und tragen die von ihm benannte Legende und Identifikationsnummern. Die Aktienzertifi-
kate werden handschriftlich oder mittels Fax von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft unterschrieben.

Verlorene, gestohlene oder beschädigte Aktienzertifikate werden von der Gesellschaft aufgrund solcher Beweise, Zu-

sicherungen und Entschädigung ersetzt, die von der Gesellschaft als zufriedenstellend beurteilt werden, vorausgesetzt
dass beschädigte Aktienzertifikate übergeben werden bevor neue Aktienzertifikate erneut ausgegeben werden.

Ein Aktienregister wird am Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es zur Einsichtnahme der Aktionnäre zur Verfügung ge-

halten wird. Das Eigentum an Namensaktien wird bei Einschreibung in das genannte Register begründet. Jede Übertra-
gung von Namensaktien wird im benannten Aktienregister mittels einer dahinein gegebenen, datierten und vom
Übertragenden und Übertragungsempfänger oder seinem/ihren befugten Vertretern unterzeichneten Erklärung, ausge-
führt. Die Gesellschaft darf eine Übertragung, auf die in Korrespondenzen oder in anderen Dokumenten Bezug genom-
men wird, und die die Zustimmung vom Übertragenden und Übertragungsempfänger enthält, annehmen und in das
Aktienregister eintragen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; im Falle dass eine Aktie von mehr als einer Person gehalten

wird, ist es erforderlich, dass die Personen, welche das Eigentum an der Aktie beanspruchen, einen einzelnen Vertreter
benennen, um die Aktie gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft hat das Recht die Ausübung aller
Rechte, die an einer solchen Aktie hängen, auszusetzen, bis eine Person designiert worden ist. Die gleiche Regel gilt für
den Fall eines Konfliktes zwischen einem Niessbrauch-Eigentümer und einem Inhaber oder einem Verpfänder und einem
Pfandnehmer.

Die Gesellschaft kann Registerführer in verschiedenen Gerichtsbarkeiten benennen, die jeweils ein separates Register

für die darin eingetragenen Namensaktien führen und die Aktionnäre können wählen, in welches Register sie eingetragen
werden und von Zeit zu Zeit von einem Register in ein anderes Register übertragen zu werden. Der Verwaltungsrat
kann jedoch Übertragungseinschränkungen auferlegen für Namensaktien, verzeichnete, notierte, gehandelte Aktien
oder Aktien, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten in Erfüllung mit den hier aufgeführten Anforderungen plaziert worden
sind. Die Übertragung in das am Gesellschaftssitz aufbewahrte Register kann immer verlangt werden.

Im Zeitraum beginnend am fünften Geschäftstag vor einer Hauptversammlung und endend bei Beendigung der Haupt-

versammlung, ausser im Fall, dass die Gesellschaft eine kürzere Zeitspanne bestimmt, kann keine Eintragung in das Ak-
tienregister ausgeführt werden und keine Übertragungsmitteilung wird von der Gesellschaft oder einem Registerführer
annerkannt.

Die Gesellschaft kann die Person, in deren Namen die Namensaktien im Aktienregister registriert sind, als alleinigen

Eigentümer dieser Namensaktie ansehen. Die Gesellschaft ist von jeder Haftung betreffend solcher Namensaktien hin-
sichtlich Dritter befreit, und ist dazu berechtigt, jedes Recht, Interesse oder Forderungen dieser Dritter in oder auf diese
Namensaktien als nicht bestehend anzusehen, jedoch vorbehaltlich solcher Rechte, die der Dritte besitzen könnte, um
eine Eintragung oder eine Abänderung in der Registrierung der Namensaktien zu verlangen. Im Falle dass ein Namens-
aktieninhaber keine Anschrift hinterlässt, an die alle Benachrichtigungen und Verkündungen der Gesellschaft gesendet
werden können, kann es die Gesellschaft zulassen, dass eine wirksame Benachrichtigung in das Aktienregister eingetra-
gen wird und die Anschrift eines solchen Aktionärs als am Gesellschaftssitz liegend angesehen wird oder eine andere
Anschrifte, wie sie von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft eingetragen werden kann, bis der Gesellschaft eine andere
Adresse von diesem Aktionär angegeben wird. Der Aktionär kann jederzeit seine in dem(n) Aktienregister(n) eingetra-
gene Anschrift mittels schriftlicher Benachrichtigung an die Gesellschaft oder dem betreffenden Registerführer ändern.

Alle Kommunikationen und Benachrichtigungen, die einem Namensaktieninhaber mitgeteilt werden, sollen als gültig

angesehen werden, wenn sie an die letzte, durch den Aktionär an die Gesellschaft mitgeteilte Anschrift gerichtet ist.

105670

Art. 7. Stimmrechte. Jede Aktie besitzt eine Stimme in jeder Hauptversammlung der Aktionäre. 

Art. 8. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat geführt, der aus nicht weniger als drei (3) und

nicht mehr als zwölf (12) Mitgliedern besteht, die nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen (die «Verwal-
tungsratsmitglieder»).

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre durch einfache Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen gewählt für einen Zeitraum von nicht mehr als sechs Jahren oder bis ihre Nachfolger gewählt wur-
den; jedoch unter der Massgabe, dass jedes Verwaltungsratsmitglied unter Angabe von Gründen oder grundlos von der
Hauptversammlung der Aktionäre durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen in einer Hauptversammlung der
Aktionäre abgesetzt werden kann. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Der Verwaltungsrat bleibt in der Weise zusammengesetzt, dass ihm immer (ausser im Falle unbesetzter Stellen auf-

grund von Todesfällen, Ausscheiden, Rücktritt, Entlassung, Entfernung oder anderweitig bis zur Bestimmung eines Nach-
folgers für das betroffene vorherige unabhängige Verwaltungsratsmitglied) drei unabhängige Verwaltungsratsmitglieder
angehören, und zwar so lange, wie die Aktien an einem oder mehreren Börsen gelistet sind. Vorbehaltlich jedem vor-
gehenden gesetzlichen Erfordernis oder der Börsenordnung unterliegend, die auf die Gesellschaft Anwendung findet, ist
ein «unabhängiges Verwaltungsratsmitglied» ein Verwaltungsratsmitglied, das weder bedeutende Geschäftsbeziehungen
mit der Gesellschaft hat, die einen Interessenkonflikt auslösen könnten, welche die Unabhängikeit der Beurteilungsfä-
higkeit dieses Direktors zur Folge haben könnte, noch ein direktes Familienmitglied einer der leitenden Angestellten der
Gesellschaft ist.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes aufgrund von Tod, Ausscheiden, Rücktritt, Entlas-

sung, Entfernung oder anderweitig, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diese unbesetzte Stelle ausfül-
len und einen Nachfolger bestimmen, der bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre handelt.

Art. 9. Vorgehen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vorsitzende wählen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates steht allen Verwaltungsratssitzungen und
allen Hauptversammlungen der Aktionäre vor. In Abwesenheit des Vorsitzenden übernimmt entweder der älteste stell-
vertretende Vorsitzende oder (jedoch nur für den Fall, dass kein stellvertretender Vorsitzender anwesend ist) ein ad
hoc Vorsitzender dieses Funktion in der Verwaltungsratssitzung oder in der Hauptversammlung.

Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft, ebenso wie die Stellvertretungsmacht in sei-

nem täglichen Geschäft, an einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder andere Vertreter der Gesellschaft übertragen, die
keine Aktionäre sein müssen. Jegliche Übertragung der täglichen Geschäftsführung zugunsten eines oder mehrerer Ver-
waltungsratsmitglieder erfordert eine vorherige Genehmigung der Hauptversammlung der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat kann Kommittees einrichten, einschliesslich eines Rechnungsprüfungskommittees, eines Kom-

pensationskommittees und eines Verwandte-Parteien-Transaktions-Kommittees. Jedes dieser Kommittees ist zusam-
mengesetzt aus mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern, von denen mindestens eines (oder mehr, wenn es der
Verwaltungsrat bestimmt) ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ist. Der Verwaltungsrat kann ebenfalls Personen in
die Kommittees bestellen, die keine Verwaltungsratsmitglieder sind.

Der Zweck des Rechnungsprüfungskommittees ist die Unterstützung des Verwaltungsrates in Erfüllung seiner Auf-

sichtsverantwortung, die in Zusammenhang stehen mit der Integrität der Finanzaufstellung, einschliesslich der periodi-
schen Information an den Verwaltungsrat über seine Aktivitäten und die Zweckdienlichkeit interner Kontrollsysteme
über Finanzberichterstattung; und Empfehlungen abzugeben bezüglich der Ernennung, Vergütung, Belassung im Dienst
und Aufsicht über die externen Rechnungsprüfer und die Berurteilung von deren Unabhängikeit, ebenso wie die Aus-
führung anderer Aufgaben, die von den anwendbaren Gesetzen und Regelungen über den regulierten Markt bzw. die
regulierten Märkte an denen die Aktien aufgeführt sind, auferlegt werden, ebenso wie andere Aufgaben, mit dem das
Kommittee vom Verwaltungsrat betraut wird.

Der Zweck des Kompensationskommittees ist die Überprüfung der Kompensationspolitik, die Unterbreitung von

Vorschlägen hinsichtlich der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und der Führungskräfte, und die Erteilung von
Ratschlägen bezüglich aller Zuwendungen oder Leistungsprämienaufstellungen.

Der Zweck des Verwandte-Parteien-Transaktions-Kommittees ist die Überprüfung von Transaktionen, in denen die

Gesellschaft oder ihre Filialen involviert ist und an der ein Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder Ange-
stellter der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen ein finanzielles Interesse hat.

Der Verwaltungsrat kann einen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellen, der kein Mitglied des Verwaltungsrates

sein muss, und dessen Aufgabenbereich, Vollmachten und Genehmigungen bestimmen.

Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat tritt nach Aufforderung des Vorsitzenden

oder zweier anderer Verwaltungsratsmitglieder zusammen. Die Benachrichtigung hinsichtlich jeder Versammlung muss
per Brief-, Kabel-, Telegramm-, Telephon-, Fax-, Telex- oder E-mail-Benachrichtigung an jedes Verwaltungsratsmitglied
sieben Tage vor der Versammlung erfolgen, ausser in einem Notfall, bei dem eine Benachrichtigung vierundzwanzig Stun-
den vorher ausreichend ist.

Jedes Verwaltungsratsmitlglied kann bei jeder Verwaltungsratsversammlung handeln, indem es ein anderes Verwal-

tungsratsmitglied schriftlich mittels Brief oder Kabel, Telegramm, Fax, Telex oder E-mail als seinen Stellvertreter be-
stellt. Eine ordnungsgemäss einberufene Verwaltungsratsversammlung, die die Punkte auf der Tagesordnung, welche in
der Benachrichtigung über die Versammlung enthalten sind, berücksichtigt, hat das erforderliche Quorum, wenn min-
destens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertre-

tenen Verwaltungsratsmitglieder angenommen. 

Verwaltungsratsversammlungen können jederzeit und unter allen Umständen wirksam gehalten werden mittels Te-

lephonkonferenz, Videokonferenz oder allen anderen Mitteln, die es erlauben, die relevanten Verwaltungsratsmitglieder

105671

zu identifizieren und die ununterbrochen on-line sind. Ein Verwaltungsratsmitglied, das auf diese Weise teilnimmt, soll
als anwesend bei der Versammlung gelten.

Der Verwaltungsrat kann auch jederzeit und unter allen Umständen einstimmig Resolutionen verabschieden durch

Rundschreiben; und schriftliche Resolutionen, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind gültig
und rechtswirksam, wenn sie in einer ordnungsgemäss einberufenen und gehaltenen Versammlung verabschiedet wer-
den. Diese Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Kopien ein und derselben Re-
solution erscheinen und können durch Briefe, Kabel, Fax, Telexes oder E-mails bestätigt werden.

Kopien oder Auszüge von Verwaltungsratsprotokollen, die in Gerichts- oder anderweitigen Verfahren vorgelegt wer-

den können, müssen vom Vorsitzenden der Gesellschaft oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder dem Ge-
schäftsführer der Gesellschaft unterzeichnet werden.

Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausge-

stattet, um die Geschäfte der Gesellschaft zu führen und alle Handlungen hinsichtlich Verfügung und Verwaltung, die in
die Ziele der Gesellschaft fallen, zu genehmigen und/oder durchzuführen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung der Gesellschaft oder die Gesetze nicht ausdrücklich der Hauptversammlung

übertragen haben, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Ausser anderweitig hierin oder durch Gesetz bestimmt, ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft hiermit befugt, solche

Handlungen (durch Resolution oder anderweitig) vorzunehmen, und solche Bestimmungen anzunehmen, die notwendig
oder zweckmässig sind, um die Zwecke der Gesellschaft zu erfüllen. 

Art. 12. Verbindliche Unterschrift. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei

Verwaltungsratsmitgliedern oder durch alleinige oder gemeinsame Unterschrift einer oder aller Person(en) verpflichtet,
der/denen die Befugniss zur Unterzeichnung durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist.

Art. 13. Interessenkonflikt. Kein Verwaltungsratsmitglied kann nur aufgrund der Tatsache, dass er Verwaltungs-

ratsmitglied ist, davon abgehalten werden, Vertragsbeziehungen mit der Gesellschaft einzugehen, entweder hinsichtlich
seiner Amtsführung oder Verkäufer, Käufer oder in jeder anderen Weise, noch soll ein Vertrag oder eine andere Trans-
aktion zwischen der Gesellschaft und jeder anderen Körperschaft oder Rechtsträger oder an welchem der der Verwal-
tungsrat in irgendeiner Weise interessiert ist, aufgrund der Tatsache als beeinträchtigt oder als ungültig betrachtet
werden, dass eines oder mehrere der Verwaltungsratsmitglieder oder leitenden Angestellten der Gesellschaft an sol-
chen Verträgen oder Transaktionen interessiert ist/sind oder ein Verwaltungsratmitglied oder leitender Angestellter
oder Angestellter einer solchen andern Körperschaft oder Rechtsträger ist/sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied oder lei-
tender Angestellter der Gesellschaft, der Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder Angestellter einer der
Körperschaften oder Rechtsträger ist, mit der die Gesellschaft Vertragsbeziehungen eingeht oder anderweitig Ge-
schäftsbeziehungen eingeht, wird nicht nur aufgrund einer solchen Zugehörigkeit zu einer solchen Körperschaft oder
Rechtsträger davon abgehalten, über diese Sachen hinsichtlich solcher Verträge oder anderer Geschäfte zu erwägen,
wählen oder handeln.

Art. 14. Schadloshaltung von Verwaltungsratsmitgliedern und leitenden Angestellten. Den unten aufge-

führten Ausnahmen und Beschränkungen sind unterworfen:

(i) Jede Person, die ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, soll von

der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche übli-
cherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er
als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter ist
oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schad-
los gehalten werden.

(ii) Die Begriffe «Klage», «Streitsache», «Prozess» oder «Verfahren» finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden

Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschliesslich
Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe «Verbindlichkeit» und «Ausgaben» beinhalten ohne Beschränkung Anwalts-
kosten, Prozesskosten,

Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Verwaltungsratsmitglied oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gegen Verbindlichkeiten ge-

genüber der Gesellschaft oder ihrer Aktionnäre gewährt, aufgrund von vorsätzlich begangenen Delikten, Bösgläubigkeit,
grober Vernachlässigung oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung oder im Falle einer
Beilegung, enthalten sind, es sei denn, die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder vom
Verwaltungsrat genehmigt worden. Keine Schadloshaltung wird in (Straf-) Verfahren gewährt, in denen das Verwaltungs-
ratsmitglied oder der leitende Angestellte aufgrund eines Verstosses verurteilt wird.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine andern Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der
Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die
Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Verwaltungsratsmitglieder und leitende An-
gestellte Anspruch haben könnten aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Verwaltungsratsmitglieds vorge-
streckt werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf
Schadloshaltung unter diesen Artikel 14 hat.

105672

Art. 15. Hauptversammlung der Aktionäre. Jede ordnungsgemäss einberufene Versammlung der Aktionäre der

Gesellschaft repräsentiert die Gesamtheit aller Aktionäre der Gesellschaft. Sie besitzt die weitestgehenden Befugnisse,
hinsichtlich der gesellschaftlichen Geschäftsvorgänge Anordnungen zu treffen, Handlungen auszuführen oder zu ratifizie-
ren. Die Einberaumung der Hauptversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat entsprechend dem luxemburgischen
Recht.

Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre soll am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfinden oder an einem

solchen anderen Ort, der in der Einberufungsbekanntmachung der Versammlung, am 21. April um 14 Uhr festgelegt
werden kann. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag in Luxemburg, soll die jährliche Hauptversammlung an dem darauf
folgenden Werktag stattfinden.

Alle weiteren Hauptversammlungen der Aktionäre können an den Orten und zu den Zeiten stattfinden, die in den

jeweiligen Einberufungsbekanntmachungen zu den Versammlungen angegeben werden.

Wird das gesamte ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft in einer Hauptversammlung anwesend, ist keine Ein-

berufungsbekanntmachung für das Abhalten der Versammlung erforderlich. Das Verfahren dieser Hauptversammlung
gilt als gültig.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt als Stichtag für die Aufnahme der Hauptversammlung ein Datum anzusetzen, das

dem Tag der Hauptversammlung der Aktionäre vorangeht.

In dem Fall, dass Aktien in vertretbare Verbriefungskonten gehalten werden, kann der Aktionär alle seine mit den

Aktien verbundenen Rechte ausüben und im Besonderen an der Hauptversammlung der Aktionäre dieser Gesellschaft
teilnehmen und seine Stimme abgeben, unter Vorlage eines Zertifikats, ausgegeben durch das Finanzinstitut oder einen
gewerblichen Treuhänder, die(der) im Besitz der Aktien sind(ist), ein solches Depot nachweisen und die Anzahl der in
diesen relevanten Konten aufgenommenen Aktien nachweisen. Dieses Zertifikat muss eingebracht werden und den Ge-
sellschaftssitz oder die Anschrift der Gesellschaft ausweisen, die in der Einberufungsbekanntmachung ausgegeben wor-
den ist und darf nicht später erfolgen, als an dem Tag der dem fünften Werktag vor der Hauptversammlung vorangeht,
wenn nicht die Gesellschaft einen kürzeren Zeitraum bestimmt. Sämtliche Vollmachten müssen innerhalb desselben
Zeitrahmens von der Gesellschaft empfangen werden.

Der Verwaltungsrat kann die Voraussetzungen bestimmen, die von den Aktionären zu erfüllen sind, um an der Ver-

sammlung der Aktionäre persönlich oder verteten durch einen Bevollmächtigten teilnehmen zu können.

Die Aktionäre können während einer Hauptversammlung von einem Bevollmächtigten vertreten werden, der selbst

kein Aktionär sein muss.

Art. 16. Mehrheit und Quorum in der Hauptversammlung. Wird die Hauptversammlung der Aktionäre, die

keine ausserordentliche Hauptversammlung ist, zum Zwecke der Satzungsänderung oder der Abstimmung über Reso-
lultionen, deren Annahme von den Quorum- und Mehrheitsregeln bezüglich Satzungänderungen abhängt, einberufen, ist
kein Präsenz-Quorum erfoderlich und die Resolutionen werden, unabhängig von der repräsentierten Anzahl von Aktien,
durch eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, angenommen.

In jeder ausserordentliehen Hauptversammlung der Aktionäre zum Zwecke einer Satzungsänderung oder einer Ab-

stimmung durch Beschluss, dessen Annahme von der Bedingung der Erreichung desjenigen Quorums oder Mehrheits-
erfordernisses abhängt, das für die Satzungsänderung bestimmt ist, soll das Quorum jedenfalls die Hälfte aller
ausgestellten und ausgegebenen Aktien erreichen. Ist das bezeichnete Quorum nicht anwesend, soll eine zweite Ver-
sammlung einberufen werden, bei der keine bestimmten Anforderungen an das Quorum gestellt werden. Die Annahme
vorgeschlagener Beschlüsse in diesen Versammlungen, ausgenommen sonstiger gesetzlicher Vorgaben, erfordert in je-
der Hauptversammlung eine zwei Drittel (2/3) Mehrheit aller teilnehmenden oder vertretenen Aktionärsstimmen.

Art. 17. Rechnungslegung. Die Rechnungsprüfung der Gesellschaftsangelegenheiten wird von einem unabhängigen

Rechnungsprüfer vorgenommen in Übereinstimmung mit Kapitel 4 des Verbriefungsgesetzes. Der Rechnungsprüfer
wird von dem Verwaltungsrat ernannt und kann mit oder ohne Angabe von Gründen abgesetzt werden.

Art. 18. Geschäftsjahr. Das gesellschaftliche Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am

31. Dezember desselben Jahres.

Art. 19. Distribution. Von dem gesellschaftlichen Jahresüberschuss sollen fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorge-

schriebenen Rücklage zugeteilt werden. Das Erfordernis dieser Zuteilung endet solange und soweit sich die Deckungs-
reserve auf zehn Prozent (10%) des begebenen gesellschaftlichen Aktienkapitals (Stammkapitals) beläuft.

Die Hauptversammlung der Aktionäre setzt auf Empfehlung des Verwaltungsrats fest, wie der Restbestand des Jah-

resüberschusses verkauft wird, einschliesslich in Form von Aktiendividenden.

Vorläufige Dividenden könnnen vom Verwaltungsrat ausgewiesen und bezahlt werden (hiervon umfasst ist auch der

gestaffelte Zahlungsverkehr), welche hierbei die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und Konditionen, nämlich
entweder in der Form der Barausschüttung oder als Sachdividende, berücksichtigen.

Art. 20. Auflösung der Gesellschaft. Für den Fall der Auflösung der Gesellschaft, unabhängig von den Gründen

oder dem Zeitpunkt, erfolgt die Durchführung der Liquidation durch einen Liquidator oder dem im Amt befindlichen
Verwaltungsrat, denen die Rechte aus Art. 144 et seq. des Luxemburgischen Gesellschaftsrechts vom zehnten August
neunzehnhundertfünfzehn, übertragen werden.

Sobald alle Schulden, Ausgaben und Liquidationskosten getilgt sind, wird der übriggebliebene Ausgleich an die Akti-

eninhaber der Gesellschaft ausgezahlt.

Art. 21. Gerichtsstand. Ausgenommen anderer hierin vorgesehener Bestimmungen, finden die Vorschriften des

Luxemburgischen Gesellschaftsrechts vom 10. August 1915, in der jeweils geltenden Fassung, und das Verbriefungsge-
setz Anwendung. Nachdem kein weiterer Punkt auf der Tageordnung stand, wurde die Versammlung geschlossen.

105673

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und Lasten, die der Gesellschaft infolge der zuvor beschriebenen Kapitalerhöhung erwachsen,

werden auf ungefähr viertausend Euro geschätzt.

Die Gesellschaft nimmt ausdrücklich Bezug auf das Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefung, um in den Genuss

einer verminderten Einlagegebühr zu kommen.

Hierauf wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg verfasst, an dem zu Anfang dieses Dokuments genannten Tage.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der

oben genannten erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer
deutschen Übersetzung; auf Anfrage derselben Personen ist im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, der englische Text maßgebend.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Personenstand und

Wohnsitz bekannt sind, haben diese Personen zusammen mit Uns, dem Notar, diese Originalurkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Hoss, K. Pardaens, M. Schinner, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Müller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(111981.3/211/1427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.

GAGFAH S.A., Société Anonyme, 

(anc. NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A.).

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 109.526. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44323 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 18 octobre 2006.

(111980.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.

LEXAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.876. 

L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEXAN TRADE S.A., ayant

son siège social à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous
le numéro B 103.876,

constituée suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 31 octobre

1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1995 page 31588,

modifiée suivant actes reçus par le notaire instrumentant, alors de résidence à Wiltz, en date du 14 décembre 2000,

publié audit Mémorial C numéro 592 du 1

er

 août 2001,

modifiée suivant assemblée générale extraordinaire des acctionnaires sous seing privé portant conversion du capital

en euros en date du 27 mars 2001, publié audit Mémorial C numéro 1126 du 25 juillet 2002.

L’assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Roger Brondelet, employé privé, demeurant

à L-4930 Bascharage, 12, boulevard JF Kennedy,

qui désigne comme secrétaire, Madame Nancy Querinjean, employée privée, demeurant à B-4960 Malmedy (Belgi-

que), 23, Chemin du Lefa.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Véronique Fink, employée privée, demeurant à B-4960 Malmedy

(Belgique), 6, rue des Princes Abbés. Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’ac-
ter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège de la société de Diekirch à L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon, et la modification afférente de l’ar-

ticle 1

er

 alinéa 2 première phrase des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. (alinéa 2 première phrase). Le siège social est établi à Windhof.»

2) Démission de l’administrateur Patrick Massaert.
3) Nomination de Monsieur Jean-Pierre Lefebvre en qualité de d’administrateur et renouvellement du mandat des

administrateurs Roger Brondelet et Catherine Schoesetters, le mandat des administrateurs expirant à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire de l’an 2012.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur»

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

105674

par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée. Resteront pareillement an-
nexées le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des

voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Diekirch à L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon, et de modifier

subséquemment l’article 1

er

 alinéa 2 première phrase des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. (alinéa 2 première phrase). Le siège social est établi à Windhof.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur Patrick Massaert.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme en qualité d’administrateur Monsieur Jean-Pierre Lefebvre, employé privé, demeurant à B-6761

Latour (Belgique), 25, rue du 24 août, né à Uccle (Belgique), le 5 mai 1956,

et renouvelle le mandat des administrateurs Roger Brondelet et Catherine Schoesetters,
le mandat des administrateurs expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2012.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.45 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 900,- EUR.

Fait et passé à Clervaux, 7, route de Marnach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Brondelet, N. Querinjean, V. Fink, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, vol. 155S, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): illisible.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(113177.3/241/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

LEXAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.876. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

(113180.3/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

DIMEX HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 103.349. 

FIDOMES dénonce avec effet immédiat la convention de domiciliation du siège de la société avenue le 23 novembre

2004.

Wiltz, le 12 octobre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2006, réf. DSO-BV00092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(112394.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

Hesperange, le lundi 16 octobre 2006.

M. Decker.

<i>Pour la société
M

e

 M. Decker

Pour FIDOMES, S.à r.l.
Signature

105675

CADAMI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 120.452. 

<i>Extrait du procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 26 septembre 2006

Est désigné administrateur-délégué, Monsieur Pierre Henri Leijder, administrateur de société, demeurant à B-1180

Uccle (Belgique), 114A, rue Basse, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de
cette gestion, ayant tous pouvoirs d’engager la société par sa seule signature dans ce cadre, et dont la signature est obli-
gatoire dans tous les autres cas.

(. . . )

Signé: P. H. Leijder, N. Querinjean, V. Fink.
Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2006, réf. DSO-BV00007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Le 19 octobre 2006.

(113122.5//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

TRIPLUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 120.454. 

<i>Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 26 septembre 2006

Est désigné administrateur-délégué, Monsieur Pierre Henri Leijder, administrateur de société, demeurant à B-1180

Uccle (Belgique), 114A, rue Basse, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de
cette gestion, ayant tous pouvoirs d’engager la société par sa seule signature dans ce cadre, et dont la signature est obli-
gatoire dans tous les autres cas.

( ... )

Signé: P. H. Leijder, N. Querinjean, V. Fink.

Le 4 octobre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2006, réf. DSO-BV00005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(113145.5//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

ORION DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.681. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 septembre 2006

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 34.766, avec siège social au 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 51.100, avec siège

social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, ont été nommés administrateurs, en rempla-
cement de Messieurs Bastiaan Schreuders et Colm Smith, administrateurs démissionnaires. Les mandats des nouveaux
administrateurs viendront à échéance à l’issue de la prochaine assemblée générale statutaire.

Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111110.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Pour copie certifiée conforme à l’original
M. Decker
<i>Notaire

Pour copie certifiée conforme à l’original
M. Decker
<i>Notaire

<i>Pour ORION DEVELOPPEMENT S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

105676

BEIM LAANGE VEIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 39, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 101.776. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02873, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113394.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

FONDATION ALZHEIMER, Etablissement d’Utilité Publique.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Conformément au mandat qui nous a été donné, nous avons contrôlé les comptes annuels cijoints de la FONDA-

TION ALZHEIMER pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2005. Les comptes annuels relèvent de la responsabilité
du Conseil d’Administration. Notre responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d’exprimer une opinion sur
ces comptes annuels.

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent

que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages,
les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les comptes annuels. Elle consiste également
à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil d’Adminis-
tration pour l’arrêté des comptes annuels ainsi qu’à effectuer une revue de leur présentation d’ensemble. Nous estimons
que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en

vigueur au Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDATION ALZHEIMER
au 31 décembre 2005 ainsi que des résultats de l’exercice se terminant à cette date.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Annexes:
- Comptes annuels au 31 décembre 2005

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005

(<i>exprimé en euros)

Diekirch, le 17 octobre 2006.

Signature.

<i>Pour MAZARS
P. Slendzak / J. Hobscheid
<i>Associé / Directeur de mission

Notes

31.12.2005

31.12.2004

EUR

EUR

<i>Actif

note 2.6.

note 2.6.

<i>Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

963.633,76

 941.586,32

Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1., 3

963.633,76

941.586,32

Titres ayant le caractère d’immobilisations   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

963.633,76

941.586,32

<i>Actif circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.893,93

933.306,68

Créances   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417.562,11

426.741,75

Créances résultant de l’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.000,00

400.000,00

dont à plus d’un an   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

dont à moins d’un an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.000,00

400.000,00

Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.562,11

26.741,75

dont à moins d’un an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.562,11

26.741,75

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en-

caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

603.331,82

506.564,93

<i>Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.984.527,69

1.874.893,00

<i>Passif

<i>Capitaux propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.868.910,47

 1.788.552,04

Résultats reportés

4

1.868.910,47

1.788.552,04

<i>Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.912,00

 3.640,00

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.912,00

3.640,00

Autres provisions pour charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.912,00

3.640,00

<i>Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.578,45

2.117,53

Dettes envers des établissements de crédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

 0,00

105677

Les notes annexes font partie intégrante de ces comptes annuels.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2005

(<i>exprimé en euros)

Les notes annexes font partie intégrante de ces comptes annuels.

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2005

 (<i>montants exprimés en euros)

Note 1. Généralités
La Fondation Alzheimer a été constituée le 31 janvier 1992 sous forme d’Etablissement d’utilité publique de droit

luxembourgeois. La Fondation Alzheimer a pour objet de soutenir toute initiative pour regrouper les familles et les pro-
ches des malades atteints de la maladie d’Alzheimer ou de toute autre démence, de créer un réseau d’entraide destiné
à soutenir l’entourage des malades, de mettre en oeuvre des actions d’informations auprès des professions de santé et
du grand public et de contribuer, sur tous les plans, à l’amélioration des conditions de vie et d’existence des malades
déments de notre pays.

Note 2. Résumé des principales politiques comptables
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux

pratiques comptables généralement admises.

2.1. Actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont évalués au prix d’acquisition historique. Pour obtenir le prix d’acquisition tous les frais

accessoires sont rajoutés au prix d’achat.

2.1.1. Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont enregistrées individuellement au plus bas de leur coût d’acquisition ou de leur

valeur estimée de réalisation (prix du marché), sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles.

dont à moins d’un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Dettes résultant de l’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,01

1.274,74

dont à moins d’un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,01

1.274,74

Autres dettes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.178,44

842,79

dont à moins d’un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.178,44

842,79

<i>Comptes de Régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

225,00

<i>Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.126,77

80.358,43

Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.984.527,69

1.874,893,00

Notes

31.12.2005

31.12.2004

EUR

EUR

note 2.6.

note 2.6.

<i>Produits d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206.079,47

207.041,02

Dons reçus et autres revenus similaires   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206.079,47

207.041,02

Montant net des dons reçus et autres revenus similaires  . . . . . . . . . . . . .

2.4.

206.079,47

207.041,02

<i>Charges d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-156.130,14

-150.102,99

Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-126.817,34

-121.550,26

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

-26.400,80

-24.912,73

Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-23.464,99

-22.152,26

Charges sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.935,81

-2.760,47

Dotations aux amortissements et aux provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.912,00

-3.640,00

Sur risques et charges: dotations aux provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

-2.912,00

-3.640,00

Autres charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

<i>Résultat d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.949,33

56.938,03

<i>Amortissements des subventions d’investissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

 0,00

<i>Produits financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.672,77

51.475,24

Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif

immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.000,00

0,00

Intérêts et produits assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.152,00

11.478,58

Reprise de corrections de valeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.520,77

39.996,66

<i>Charges financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.223,33

-28.054,84

Corrections de valeur sur immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . .

-4.223,33

-27.454,53

<i>Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.449,44

23.420,40

<i>Résultat avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.398,77

80.358,43

<i>Produits exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

728,00

0,00

<i>Résultat exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

728,00

0,00

<i>Total des produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.480,24

258.516,26

<i>Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-160.353,47

-178.157,83

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.126,77

80.358,43

105678

Le prix d’acquisition d’un titre est déterminé sur base de la cotation et du taux de change en vigueur le jour de la clôture
du premier exercice au cours duquel le titre est entré dans les immobilisations financières. Une correction de valeur
est pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure au prix d’acquisition.

2.2. Créances
Les créances de l’actif circulant sont évaluées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque

la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale.

2.3. Dettes
Les dettes s’inscrivent au passif du bilan à leur valeur de remboursement.
2.4. Dons reçus et revenus similaires
Les dons, ainsi que les produits des successions en faveur de la Fondation, sont comptabilisés sous le poste «produits

d’exploitation». 

2.5. Provisions pour risques et charges
A la clôture de chaque exercice, des provisions sont constituées pour couvrir tous les risques et charges prévisibles.

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont deve-
nues sans objet.

2.6. La présentation des comptes annuels a été adaptée à celle retenue par l’ASSOCIATION LUXEMBOURG

ALZHEIMER, a.s.b.l.. II s’agit du schéma prévu par le contrat signé entre l’Association et l’organisme gestionnaire de
l’assurance dépendance.

Note 3. Immobilisations financières

Note 4. Résultats reportés

Note 5. Autres provisions
Le poste «Autres provisions» est constitué d’une provision pour charges de EUR 2.800.

Note 6. Autres dettes

Note 7. Personnel
La Fondation Alzheimer employait à la fin de l’exercice un employé à temps partiel. L’effectif moyen en équivalent

temps plein a été de 0,5 durant l’exercice 2005 (en 2004: 0,5). 

Note 8. Impôts
La Fondation Alzheimer n’est pas soumise aux impôts sur le résultat et à l’impôt sur la fortune. Les revenus de la

Fondation Alzheimer ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Note 9. Engagements hors bilan
II n’y a pas d’engagements hors bilan de la Fondation Alzheimer au 31 décembre 2004.
Note 10. Rémunération du Conseil d’Administration
Aucune rémunération n’a été allouée aux membres du Conseil d’Administration à raison de leurs fonctions au sein

de la Fondation Alzheimer.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07490. – Reçu 26 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089976.2//171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

<i>Valeur d’acquisition

Valeur au

Acquisitions

Cessions

Valeur au

1.1.2005

31.12.2004

Portefeuille titres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.014.678,46

0,00

-20.032,97

994.645,49

<i>Amortissements

Valeur

Valeur au

Dotation

Reprise

Valeur au

 nette

1.1.2005

31.12.2005

31.12.2005

Portefeuille titres  . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.092,14

4.223,33

-37.520,77

39.794,70

954.850,79

31.12.2005

31.12.2005

EUR

EUR

Résultats reportés au début de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.788.552,04

2.103.895,91

Résultat de l’exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80.358,43

-315.343,87

Resultats reportés à la fin de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.868.910,47

1.788.552,04

Provisions au 1 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.640,00

2.800,00

Utilisation provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4.368,00

-2.800,00

Reprise de provision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

728,00

0,00

Dotations de l’année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.912,00

3.640,00

Provisions au 31 décembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.912,00

3.640,00

dont à moins d’un an:
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

975,41

871,94

Dettes diverses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203,03

-29,15

1.178,44

 842,79

105679

CADAMI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 120.452. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange,

Ont comparu:

1.- La société de droit des British Virgin Islands MELODINA COMPANY LIMITED LTD, dont le siège est à Tortola

(B.V.I.), Beaufort House P.O. Box 438, Road Town, enregistrée sous le numéro 221440,

ici représentée par Madame Véronique Fink, employée privée, demeurant à B-4960 Malmedy (Belgique), 6, rue des

Princes Abbés, agissant en sa qualité d’administrateur dûment habilité en vertu d’une résolution du Conseil d’Adminis-
tration du 21 juillet 2005, de la société MELODINA COMPANY LIMITED LTD.

2.- La société de droit des British Virgin Islands PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, dont le siège est à Tortola

(B.V.I.), Beaufort House P.O. Box 438, Road Town, enregistrée sous le numéro 221438,

ici représentée par Madame Nancy Querinjean, employée privée, demeurant à B-4960 Malmedy (Belgique), 23, Che-

min du Lefa, agissant en sa qualité d’administrateur dûment habilité en vertu d’une résolution du Conseil d’Administra-
tion du 21 juillet 2005, de la société PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD.

Lesquelles comparantes, telles que représentées, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CADAMI FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée des action-

naires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pour-
ra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objets:
- l’organisation et le financement d’évènements sportifs au moyen du sponsoring,
- le conseil d’assistance et de maintenance de systèmes informatiques,
- toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme

que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces partici-
pations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres, brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques com-

merciales, financières, civiles, mobilières et immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet
ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en en mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la

forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne peut excéder
six ans. Ils sont toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

105680

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président; en cas d’empêchement du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur
vote par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par les membres présents. Les pro-

curations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par deux adminis-

trateurs.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée soit par les signatures conjointes de deux administra-

teurs dont celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué à la gestion
journalière dans le cadre de cette gestion. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représen-
ter la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne peut excéder six
ans. Ils sont toujours révocables par elle.

Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art.13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 14.00 heures,

au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales; de tel-

les assemblées doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans le délai d’un mois si les actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.

Art.14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre

moyen de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux ad-

ministrateurs.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration dresse un inventaire, établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Au moins un mois avant la date de l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport
sur les opérations de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes en se conformant aux condi-

tions prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques

ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

105681

Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures, trouvera ap-

plication partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes préqualifiées, déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société et mis à sa charge en raison de

sa constitution, s’élève à environ 1.550,- EUR.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Pierre Henri Leijder, administrateur de société, né à Uccle (Belgique), le 22 septembre 1961, demeurant

à B-1180 Uccle (Belgique), 89, avenue Guillaume Herinckx,

b) Madame Nancy Querinjean, employée privée, née à Malmédy (Belgique), le 5 décembre 1983, demeurant à B-4960

Malmedy (Belgique), 23, Chemin du Lefa,

c) Madame Véronique Fink, employée privée, née à Malmedy (Belgique), le 29 décembre 1983, demeurant à B-4960

Malmedy (Belgique), 6, rue des Princes Abbés.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, Monsieur Jean-Louis Posson, employé privé, né à Etterbeek

(Belgique), le 13 mars 1949, demeurant à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2012.

5) L’adresse du siège social est fixé à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
6) Le mandat des administrateurs est gratuit.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec nous, notaire le présent acte.

Signé: V. Fink, N. Querinjean, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, vol. 155S, fol. 60, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): illisible.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(113122.4/241/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

KARLIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.887. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03202, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111057.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

1) La société MELODINA COMPANY LIMITED LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . .

999

2) La société PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total des actions: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Hesperange, le jeudi 19 octobre 2006.

M. Decker.

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Signature.

105682

JOKARI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 120.451. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange,

Ont comparu:

1.- La société de droit des British Virgin Islands MELODINA COMPANY LIMITED LTD, dont le siège est à Tortola

(B.V.I.), Beaufort House P.O. Box 438, Road Town, enregistrée sous le numéro 221440,

ici représentée par Madame Véronique Fink, employée privée, demeurant à B-4960 Malmedy (Belgique), 6, rue des

Princes Abbés, agissant en sa qualité d’administrateur dûment habilité en vertu d’une résolution du Conseil d’Adminis-
tration du 17 juillet 2005, de la société MELODINA COMPANY LIMITED LTD.

2.- La société de droit des British Virgin Islands PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, dont le siège est à Tortola

(B.V.I.), Beaufort House P.O. Box 438, Road Town, enregistrée sous le numéro 221438,

ici représentée par Madame Nancy Querinjean, employée privée, demeurant à B-4960 Malmedy (Belgique), 23, Che-

min du Lefa, agissant en sa qualité d’administrateur dûment habilité en vertu d’une résolution du Conseil d’Administra-
tion du 17 juillet 2005, de la société PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD.

Lesquelles comparantes, telles que représentées, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JOKARI FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée des action-

naires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pour-
ra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres, brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en en mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la

forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne peut excéder
six ans. Ils sont toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président; en cas d’empêchement du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

105683

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur
vote par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par les membres présents. Les pro-

curations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par deux adminis-

trateurs.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée soit par les signatures conjointes de deux administra-

teurs dont celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué à la gestion
journalière dans le cadre de cette gestion. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représen-
ter la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne peut excéder six
ans. Ils sont toujours révocables par elle.

<i>Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 16.00 heures,

au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales; de tel-

les assemblées doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans le délai d’un mois si les actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre

moyen de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux ad-

ministrateurs.

<i>Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration dresse un inventaire, établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Au moins un mois avant la date de l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport
sur les opérations de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes en se conformant aux condi-

tions prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

<i>Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques

ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

<i>Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures, trouvera ap-

plication partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

105684

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes préqualifiées, déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société et mis à sa charge en raison de

sa constitution, s’élève à environ 1.550,- EUR.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Pierre Henri Leijder, administrateur de société, né à Uccle (Belgique), le 22 septembre 1961, demeurant

à B-1180 Uccle (Belgique), 89, avenue Guillaume Herinckx,

b) Madame Nancy Querinjean, employée privée, née à Malmedy (Belgique), le 5 décembre 1983, demeurant à B-4960

Malmédy (Belgique), 23, Chemin du Lefa,

c) Madame Véronique Fink, employée privée, née à Malmedy (Belgique), le 29 décembre 1983, demeurant à B-4960

Malmedy (Belgique), 6, rue des Princes Abbés.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, Monsieur Jean-Louis Posson, employé privé, né à Etterbeek

(Belgique), le 13 mars 1949, demeurant à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2012.

5) L’adresse du siège social est fixé à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
6) Le mandat des administrateurs est gratuit.

Dont acte, fait et passé Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec nous, notaire le présent acte.

Signé: V. Fink, N. Querinjean, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, vol. 155S, fol. 60, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Illisible.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(113119.4/241/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

NORDISKA APOTEKARFÖRENINGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.111. 

Suite aux résolutions de l’actionnaire unique du 5 octobre 2006, le siège social de la société a été transféré du 54,

boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02775. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111115.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

1) La société MELODINA COMPANY LIMITED LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . .

999

2) La société PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total des actions: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Hesperange, le jeudi 19 octobre 2006.

M. Decker.

<i>Pour NORDISKA APOTEKARFÖRENINGE, S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

105685

JOKARI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 120.451. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 26 septembre 2006

Est désigné administrateur-délégué, Monsieur Pierre Henri Leijder, administrateur de société, demeurant à B-1180

Uccle (Belgique), 114A, rue Basse, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de
cette gestion, ayant tous pouvoirs d’engager la société par sa seule signature dans ce cadre, et dont la signature est obli-
gatoire dans tous les autres cas.

Signé: P. H. Leijder, N. Querinjean, V. Fink.
Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2006, réf. DSO-BV00006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Le 19 octobre 2006.

(113119.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

MEPV FINANCE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MATRIX AUSTRIA HOLDINGS TWO, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 118.972. 

In the year two thousand six, on the eighteenth of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeard:

MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l., having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg,

being the sole shareholder of MATRIX AUSTRIA HOLDINGS TWO, S.à r.l., a company organised and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
(the «Company»), registered with the Luxembourg Trade and Companies’ register, under number B 118.972,

here represented by Mr Jacques de Patoul, employee, with professional address in Luxembourg, 20, rue de la Poste,
by virtue of a proxy hereto attached.
The Company MATRIX AUSTRIA HOLDINGS TWO, S.à r.l. has been incorporated and organised under the laws

of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of August 16, 2006, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The appearer declares to deliberate on the following: 

<i>Agenda:

1. Change of the corporate name of the Company in order to replace the current name by the following: MEPV

FINANCE COMPANY, S.à r.l.

2. Subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation in order to replace the current text by the

following:

Art. 4. The Company will assume the name: MEPV FINANCE COMPANY, S.à r.l.
3. Miscellaneous.
and takes the following resolution:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the corporate name of the Company in order to replace the current name

by the following: MEPV FINANCE COMPANY, S.à r.l.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend article 4 of the articles of incorporation in order to replace the current text

by the following:

Art. 4. The Company will assume the name: MEPV FINANCE COMPANY, S.à r.l.

<i>Costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 1,000.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in
case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.

Pour copie certifiée conforme à l’original
M. Decker
<i>Notaire

105686

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsechs, den achtzehnten September.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, handelnd als al-

leiniger Gesellschafter der MATRIX AUSTRIA HOLDINGS TWO, S.à r.l., eine Gesellschaft gegründet unter luxembur-
gischem Gesetz, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal (die «Gesellschaft»), eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister unter Nummer B 118.972,

hier vetreten durch Herrn Jacques de Patoul, Privatangestellter, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, 20, rue de la

Poste,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
Die Gesellschaft MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l. wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten

Notars vom 16. August 2006, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht
wurde (die Gesellschaft).

Der Gesellschafter beschliesst über folgende Tagesordnung abzustimmen: 
1) Abänderung des Namens der Gesellschaft um ihn wie folgt abzuändern: MEPV FINANCE COMPANY, S.à r.l.
2) Entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung um ihn durch folgenden Text zu ersetzen:

Art. 4. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung MEPV FINANCE COMPANY, S.à r.l.
3) Verschiedenes.
und fasst folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Abänderung des Namens der Gesellschaft wie folgt: MEPV FINANCE

COMPANY, S.à r.l.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel 4 der Satzung abzuändern um ihn durch folgenden Text zu ersetzen:

Art. 4. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung MEPV FINANCE COMPANY, S.à r.l.

<i>Kostenschätzung

Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesell-

schaft getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr
EUR 1.000,- geschätzt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten

ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deut-
schen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. De Patoul, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 septembre 2006, vol.438, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(110904.3/242/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

MEPV FINANCE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MATRIX AUSTRIA HOLDINGS TWO, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 118.972. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110906.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Mersch, den 29. September 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 9 octobre 2006.

H. Hellinckx.

105687

REGENCY GLOBAL BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 18, rue Münster.

R. C. Luxembourg B 120.450. 

STATUTS

L’an deux mille six, le cinq octobre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Mohamed Yasser Gacem, commerçant, né à Sousse (Tunisie), le 23 mai 1982, demeurant à L-4772 Pétan-

ge, 40, rue de la Piscine.

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il dé-

clare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite, et dont il a arrêté les
statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de REGENCY GLO-

BAL BUSINESS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objets:
- l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées,
- le commerce général, ainsi que l’import-export de toutes marchandises,
D’une façon générale, elle pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tout autre similaire ou connexe, ou sus-
ceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (12.600,- EUR), divisé en cent vingt-six (126) parts so-

ciales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique, Monsieur Yasser Gacem, de sorte

que la somme de douze mille six cents euros (12.600,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Art. 6. Les parts sont insaisissables.
En cas de pluralité d’associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou des

associés représentant l’intégralité des parts sociales. En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-
mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés réunis

en assemblée générale, qui fixe(nt) la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions

de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,

proportionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 11. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés survivants. Toutefois, le consentement du ou des associés survivants n’est pas requis lorsque les parts
sociales sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d’agrément, il est procédé comme prévu à l’article 6.

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année au 31 décembre, il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon

suivante:

105688

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du

capital social,

- le solde restant est à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils sont propriétaires.

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 950,- EUR.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse du siège social est fixée à L-2160 Luxembourg, 18, rue Münster.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Yasser Gacem, prénommé.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Y. Gacem, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, vol. 155S, fol. 66, case 5. – Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): illisible.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(113114.3/241/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

LYDION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4985 Sanem, 4, rue du Verger.

R. C. Luxembourg B 104.391. 

Il résulte d’une lettre du 6 octobre 2006, enregistrée à Luxembourg-Sociétés, en date du 16 octobre 2006, Réf. LSO-

BV03519, que Monsieur Richard Sturm, demeurant à L-4953 Hautcharage, 18, Cité Bommelscheuer, a démissionné, avec
effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme LYDION S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03811. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111116.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

LHEDCO, LOGEMENT HABITAT ETUDES ET DEVELOPPEMENT COOPERATIF,

Société Coopérative.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 69.715. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenue à Paris, le 17 mai 2006

Les membres du Conseil d’administration décident de transférer le siège social de la société du 61, avenue de la Gare,

L-1611 au 2, rue Benjamin Franklin, L-1540 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111127.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Hesperange, le mercredi 18 octobre 2006.

M. Decker.

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

R. Sturm.

Signature.

105689

AKOMPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 104.885. 

L’Associé Unique a décidé en date du 6 octobre 2006 de transférer le siège social de la société du 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02781. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111091.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

EUROSQUARE (LUX 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 116.181. 

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 31 août 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 1

er

 août 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 31 août 2006.

Les gérants de la Société font remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérants suivants de la Société est

désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- M. Alan Botfield;
- M. Robert Kimmels.

Luxembourg, le 31 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111109.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

CADIMA FAMILY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 40, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 120.449. 

STATUTS

L’an deux mille six, le deux octobre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlos Alberto E Silva Cadima, ouvrier, né à São Jorge de Arroios/Lisboa (Portugal), le 10 février 1971,

et 

2.- Madame Dorothée Blary, ouvrière, née à Denain (France), le 14 septembre 1973,
Tous deux demeurant à L-2430 Luxembourg, 45, rue Michel Rodange.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CADIMA FA-

MILY.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques. 
D’une façon générale, elle faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou tout autre similaire ou connexe, ou susceptible d’en faciliter la réa-
lisation.

<i>Pour AKOMPA, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

105690

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros chacune (125,- EUR) réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il n’y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables.
Entre associés les parts sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés.
En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en ces-

sion. 

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l’incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu’il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne

pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l’assemblée

générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société ; simples mandataires, ils ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, confor-

mément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, jusqu’à

ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 950,- EUR.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l’una-

nimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Carlos E Silva Cadima, cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Dorothée Blary, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total des parts: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

105691

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-2222 Luxembourg, 40, rue de Neudorf.
2.- Sont nommés pour une durée indéterminée:
- gérant technique: Madame Dorothée Blary, préqualifiée,
- gérant administratif: Monsieur Carlos E Silva Cadima, préqualifié,
3.- Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique pour toutes

opérations ne dépassant pas la valeur de deux mille euros (2.000,- EUR). Au-delà de cette valeur, la signature conjointe
du gérant administratif est requise.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. E Silva Cadima, D. Blary, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, vol. 155S, fol. 66, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff.: Illisible.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(113111.3/241/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2006.

DIFRULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 4, rue Hicht.

R. C. Luxembourg B 97.813. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05720, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 octobre 2006.

(112501.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

DECHARGE FRIIDHAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7738 Colmar-Pont, rue de Cruchten.

R. C. Luxembourg B 110.186. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03636, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 octobre 2006.

(112499.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

TANZANITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 113.278. 

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 31 août 2006

Le gérant de la Société a décidé en date du 31 août 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 31 août 2006.

Le gérant de la Société a fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérant suivants de la Société est

désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY.

Luxembourg, le 31 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111117.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Hesperange, le mercredi 18 octobre 2006.

M. Decker.

G. Leuchter
<i>Le gérant

R. Heirens / G. Wickler
<i>Les gérants

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

105692

ACCELIOR, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 103.319. 

FIDOMES dénonce avec effet immédiat la convention de domiciliation du siège de la société avenue le 24 août 2004.

Wiltz, le 12 octobre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2006, réf. DSO-BV00094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(112396.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

NORDMAZOUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 6, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 102.418. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00118, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 octobre 2006.

(112495.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

DIMEX HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.349. 

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire

Le 12 octobre 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) d’accepter la démission des administrateurs suivants:
La S.à r.l. SEREN 
La S.à r.l. DUNE 
La S.à r.l. MAZE
2) d’accepter la démission de DELMA &amp; CIE, S.à r.l. en tant qu’Administrateur-délégué.
3) d’accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes. 

Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2006, réf. DSO-BV00095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(112390.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

LUMIERE (LUX 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 116.182. 

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 31 août 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 1

er

 août 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 31 août 2006.

Les gérants de la Société font remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérants suivants de la Société est

désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- M. Alan Botfield;
- M. Robert Kimmels.

Luxembourg, le 31 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111112.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Pour FIDOMES, S.à r.l.
Signature

P. Binsfeld
<i>L’administrateur délégué

Certifié conforme
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

105693

D.S.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 97, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 101.424. 

L’an deux mille six, le douze octobre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

Monsieur Eckhard Jungst, commerçant, né à Burgsteinfurt, le 29 mai 1942, demeurant à D-54579 Uxheim-Niederehe,
seul et unique associé de la société à responsabilité limitée D.S.L., S.à r.l. avec siège social à L-9706 Clervaux, 21, route

de Bastogne,

constituée sous le nom D.V. LUX, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 octobre 1995,

publié au Mémorial C en date du 28 décembre 1995, numéro 659, RCS B101424,

- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social et modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 3.

2. Divers
L’associé a ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Première et dernière résolution

Le siège social est transféré de L-9706 Clervaux, 21, route de Bastogne à L-9753 Heinerscheid, 97 Haaptstrooss et

l’article 3 alinéa 1

er

 aura la teneur suivante: 

«Art. 3. alinéa 1

er

. Le siège social de la société est établi à Heinerscheid.» 

L’adresse est fixée à L-9753 Heinerscheid, 97 Haaptstrooss.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Jungst, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 13 octobre 2006, vol. 355, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Rodenbour.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112376.3/238/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

D.S.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 97, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 101.424. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112382.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 octobre 2006.

CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 69.054. 

Suite à la démission de Monsieur Ian Chimes, avec adresse à Londres EC3A7JJ, 15 Beaufort House St. Botolph Street

(United Kingdom), comme membre du Conseil d’Administration de la société CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST
(LUX), avec effet au 14 septembre 2006, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme suit: 

Mario Seris, Zurich, Président;
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président;
Luca Diener, Zurich;
Donald B. Rice, Luxembourg;
Germain Trichies, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02137. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111121.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Clervaux, le 16 octobre 2006.

M. Weinandy.

Clervaux, le 17 octobre 2006.

M. Weinandy.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger

105694

BATIPROJET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 8, rue de Peppange.

R. C. Luxembourg B 101.420. 

L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Monsieur Patrick Coelho, technicien en bâtiment, né à Les Ulis Essonne (France), le 22 mai 1977 (N

°

 Matricule

19770522350), demeurant à L-4622 Oberkorn, 52, rue Pierre Martin.

Lequel comparant déclare qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée BATIPROJET, S.à r.l.

(N

°

 Matricule 20042409384), avec siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 101.420;
constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 25 juin

2004, publié au Mémorial C de 2004, page 60.143;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Francis Kesseler, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 juillet 2005,

publié au Mémorial C de 2005, page 60.143;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 décembre 2005, publié au Mémorial C de

2006, page 32.866.

Lequel comparant s’est réuni en assemblée générale extraordinaire pour prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-3378 Livange, 8, rue de Peppan-

ge.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite au prédit transfert de siège le premier alinéa de article 2 des statuts est à lire comme suit:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Livange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale

s’élève approximativement à six cent vingt euros (620,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire, lequel certifie l’état civil des parties d’après
des extraits du registre de l’état civil, respectivement carte d’identité.

Signé: P. Coelho, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2006, vol. 907, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(111812.3/209/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.

BATIPROJET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 8, rue de Peppange.

R. C. Luxembourg B 101.420. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111815.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.

R CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 115.009. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(111411.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Bettembourg, le 29 septembre 2006.

Ch. Doerner.

Bettembourg, le 29 septembre 2006.

Ch. Doerner.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

P. Frieders.

105695

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.866. 

Suite à la démission de Monsieur Ian Chimes, avec adresse à Londres EC3A7JJ, 15 Beaufort House St. Botolph Street

(United Kingdom), comme membre du Conseil d’Administration de la société CREDIT SUISSE BOND FUND MANA-
GEMENT COMPANY avec effet au 14 septembre 2006, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme
suit:

Mario Seris, Zurich, Président;
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président;
Luca Diener, Zurich.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02142. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111125.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

CREDIT SUISSE NOVA (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 111.925. 

Suite à la démission de Monsieur Ian Chimes, avec adresse à Londres EC3A7JJ, 15 Beaufort House St. Botolph Street

(United Kingdom), comme membre du Conseil d’Administration de la société CREDIT SUISSE NOVA (LUX) avec effet
au 14 septembre 2006, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme suit:

Mario Seris, Zurich, Président;
Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président;
Luca Diener, Zurich.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111126.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

PADOUHANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 79.765. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 septembre 2006 que:
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, Maître Marianne Goebel,

avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, et Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, ont été réélus aux fonctions d’administrateur de la société, leurs mandats étant
arrivés à expiration;

- la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a

été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat étant arrivé à expiration.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en

2012 et le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02620. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111147.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

105696

FONDATION HOME ST JEAN, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-3503 Dudelange, 13, um Kräizbierg.

Fondation reconnue par arrêté grand-ducal du 19 mars 1992.

Statuts publiés au Mémorial C n° 297 du 6 juillet 1992.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005

PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2005

Les présents chiffres ressortent de nos livres et ont été approuvés par le Conseil d’Administration dans sa séance du

lundi, 6 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(115323.2//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

<i>Actif

<i>Passif

Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 0,00 EUR

CCP et comptes-courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.883,30 EUR

Livret d’épargne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.589,08 EUR

Terrains y compris frais d’acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45.096,79 EUR

Matériel et Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  831.649,33 EUR
Locations chalet à recevoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

686,11 EUR

Autres actifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

550,00 EUR

Acomptes reçus locations chalets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750,00 EUR

Réductions de valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155.631,19 EUR

Apport guides et scouts St Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

268.758,98 EUR

Fonds Home St Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

407.259,16 EUR

Avoirs propres au 1

er

 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58.773,50 EUR

Résultat de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

281,78 EUR

891.454,61 EUR  891.454,61 EUR

<i>Débit

<i>Crédit

Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,00 EUR

Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.349,32 EUR

Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68,42 EUR

Frais d’exploitation chalet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.087,79 EUR

Réductions de valeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.000,35 EUR

Autres frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76,10 EUR

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.686,42 EUR

Subsides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125,41 EUR

Intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97,20 EUR

Locations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.530,36 EUR

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

236,21 EUR

Reprise du fonds Home St Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33.198,16 EUR

Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

281,78 EUR

46.873,76 EUR

46.873,76 EUR

R. Lutgen
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Matafi S.A.

ABB Realty, S.à r.l.

R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüftung, Haustechnik

Max Participations II, S.à r.l.

NLG Acquisition Investments S.C.A.

NLG Acquisition Investments S.C.A.

Lexan Trade S.A.

Lexan Trade S.A.

Dimex Holding

Cadami Finance S.A.

Triplus Finance S.A.

Orion Developpement S.A.

Beim Laange Veit, S.à r.l.

Fondation Alzheimer

Cadami Finance S.A.

Karlix S.A.

Jokari Finance S.A.

Nordiska Apotekarföreninge, S.à r.l.

Jokari Finance S.A.

MEPV Finance Company, S.à r.l.

MEPV Finance Company, S.à r.l.

Regency Global Business, S.à r.l.

Lydion S.A.

LHEDCO, Logement Habitat Etudes et Développement Coopératif

Akompa, S.à r.l.

Eurosquare (Lux 1), S.à r.l.

Cadima Family

Difrulux, S.à r.l.

Décharge Friidhaff, S.à r.l.

Tanzanite, S.à r.l.

Accelior

Nordmazout S.A.

Dimex Holding

Lumière (Lux 1), S.à r.l.

D.S.L., S.à r.l.

D.S.L., S.à r.l.

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)

Batiprojet, S.à r.l.

Batiprojet, S.à r.l.

R Capital, S.à r.l.

Credit Suisse Bond Fund Management Company

Credit Suisse Nova (Lux)

Padouhann S.A.

Fondation Home St Jean