logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

102577

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2138

16 novembre 2006

S O M M A I R E

(L’)Abbaye S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

102611

Josy Welter, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

102608

Abes, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102620

Klever International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

102612

Aequitas Europe 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

102583

KPI Retail Property 10, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

102578

AFD Rivesaltes A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

102600

KPI Retail Property 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

102598

AFD Rivesaltes A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

102602

KPI Retail Property 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

102598

Agri Services Mariendall, S.à r.l., Marienthal  . . . . 

102607

KPI Retail Property 5, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

102590

Alpina Immobilière, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . 

102608

KPI Retail Property 7, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

102590

Ardeco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102621

KPI Retail Property 9, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

102584

Betafence Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

102618

Lunar Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

102599

BRE/Hamburg  Reichshof  Hotel  Holding,  S.à r.l., 

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg 

102599

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102584

MAZ Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

102621

BRE/Hamburg  Reichshof  Hotel,  S.à r.l.,  Luxem- 

Malderen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102611

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102578

Marcan, S.à r.l., Rollingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102621

Clemington Corporation, S.à r.l., Luxembourg  . . 

102598

Med Control S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

102610

CMH Vertriebs Service II S.A., Strassen . . . . . . . . 

102614

Mercury Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

102603

CMH Vertriebs Service II S.A., Strassen . . . . . . . . 

102616

Nastia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102616

Comptoir du Sel, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . . . 

102612

Navarac Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

102603

Darsella International S.A. Luxembourg, Luxem- 

Nordea Life & Pensions S.A., Luxembourg  . . . . . 

102621

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102608

One Park Lane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

102608

Deepinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

102622

One Park Lane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

102610

Euro Investment 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

102611

Oursin Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

102608

EuroLotto Systems AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . 

102617

Paradisa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

102622

Fezela Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

102599

Parque D. Pedro 1 B.V., S.à r.l., Luxembourg  . . . 

102619

Financière du Niagara S.A., Luxembourg . . . . . . . 

102612

Parque D. Pedro 1 B.V., S.à r.l., Luxembourg  . . . 

102619

Four Points S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

102610

Parque D. Pedro 2 B.V., S.à r.l., Luxembourg  . . . 

102619

Four Seas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102590

Parque D. Pedro 2 B.V., S.à r.l., Luxembourg  . . . 

102620

Gardizoo, S.à r.l., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102607

Picha, S.à r.l., Muenschecker  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102612

Gota Mar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

102619

Profirent S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102617

Gravolux, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102612

Santémedia Holding, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . 

102598

Grefa, S.à r.l., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102611

Serico Luxembourg, S.à r.l., Senningerberg . . . . . 

102622

HaLoMi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102613

Serico Luxembourg, S.à r.l., Senningerberg . . . . . 

102624

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.  

102602

Silver Rose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

102607

I.B.A., International Brokerage and Administration 

Slainte, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102616

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102618

SOK S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102622

I.B.A., International Brokerage and Administration 

Société  Financière  Betafence,  S.à r.l.,  Luxem- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102619

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102618

I.D. 20 Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

102611

Solar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

102599

Johann  Berger  Transporte  Luxemburg,  GmbH, 

Syntaxis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

102589

Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102610

Tee Off Promotions, S.à r.l., Aspelt. . . . . . . . . . . . 

102616

102578

KPI RETAIL PROPERTY 10, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 108.125. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00762, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107106.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 119.897. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-second day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, not
yet registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary on this day before the present deed,

here represented by Ms Virginie Lepage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 19 September 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,

lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three-quarters of the share capital.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

102579

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-

ments of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,

and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Com-

pany.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

102580

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three-quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The 500 shares have been subscribed as follows:
- 500 shares by BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL HOLDING, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register, under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-

pearing party, the present deed is worded in English, followed by a German translation and in case of divergences be-
tween the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den zweiundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL HOLDING, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, noch nicht eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden
Notar am heutigen Tage bevor der vorliegenden Urkunde,

hier vertreten durch Frau Virginie Lepage, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 19. September 2006.

102581

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-

ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften

und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,

die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb,
die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen

Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-

lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-

mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

102582

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-

nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsfüh-
rerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sit-

zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-

den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-

ßigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

102583

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 500 Anteile wurden von BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL HOLDING, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister un-
ter Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Gezeichnet: V. Lepage, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 septembre 2006, vol. 438, fol. 26, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt. 

(107623.3/242/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

AEQUITAS EUROPE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 225.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 92.772. 

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf.

LSO-BV00626, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(107132.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Mersch, den 3. Oktober 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour <i>AEQUITAS EUROPE 3, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant B
Signatures

102584

KPI RETAIL PROPERTY 9, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue A. Weicker.

R. C. Luxembourg B 108.788. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00760, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 119.898. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-second day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) BRE/GERMAN HOTEL HOLDING I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.685,

here represented by Ms Virginie Lepage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 19 September 2006.

2) ART HOTEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.744,

here represented by Ms Virginie Lepage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Chicago, on 19 September 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three-quarters of the share capital.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

102585

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-

ments of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members

a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need
not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and
of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Com-

pany.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

102586

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three-quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The 500 shares have been subscribed as follows:
- 450 shares by BRE/GERMAN HOTEL HOLDING I, S.à r.l., prequalified, 
- 50 shares by ART HOTEL HOLDING, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-

pearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences be-
tween the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den zweiundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

1) BRE/GERMAN HOTEL HOLDING I, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Han-
dels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114.685,

hier vertreten durch Frau Virginie Lepage, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 19. September 2006.

102587

2) ART HOTEL HOLDING, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzog-

tums Luxemburg, mit Sitz in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 115.744,

hier vertreten durch Frau Virginie Lepage, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Chicago, am 19. September 2006.

Die Vollmachten bleiben nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die

sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften

und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen

Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/HAMBURG REICHSHOF HOTEL HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-

lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-

mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

102588

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-

nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsfüh-
rerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sit-

zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-

den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-

ßigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

102589

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 450 Anteile wurden von BRE/GERMAN HOTEL HOLDING I, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet,
- 50 Anteile wurden von ART HOTEL HOLDING, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister un-
ter Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Gezeichnet: V. Lepage, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 septembre 2006, vol. 438, fol. 26, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt 

(107662.3/242/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

SYNTAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 89.201. 

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf.

LSO-BV00627, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(107135.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Mersch, den 3. Oktober 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour <i>SYNTAXIS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

102590

KPI RETAIL PROPERTY 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 108.363. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00758, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107108.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

KPI RETAIL PROPERTY 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 108.115. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00756, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107109.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

FOUR SEAS S.A., Société Anonyme de titrisation.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 119.902. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twelfth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., a company organized under the laws of Luxembourg and having its

registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

duly represented by Mr François Lanners residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 11th

of September 2006.

2) LOUV, S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-2086 Lux-

embourg, 23, avenue Monterey,

duly represented by Mr François Lanners residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 11th

of September 2006.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this deed and shall be registered therewith.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of association of a société

anonyme, which they declare organised among themselves:

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of FOUR SEAS S.A. (the Com-
pany) which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law of 22
March 2004 on securitisation (the Securitisation Law) and shall be subject to and governed by the Securitisation Law,
the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Law), as well as by the present
articles of association.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to enter into a securitisation transaction within the

meaning of the Securitisation Law, which shall exclusively relate to stocks of diamonds and the Company may, in this
context, assume risks, existing or future, relating to the holding of diamonds. The Company shall assume those risks by
acquiring the diamonds to be securitised. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of as-
sociation, dispose of such diamonds and of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or
more transactions or on a continuous basis.

The Company shall issue securities whose value or yield is linked to such diamonds, or whose repayment is subject

to the repayment of other instruments or of certain claims.

The Company may also within the context and for the purpose of the securitisation transaction:
(a) raise funds, including through the issue of bonds, notes, obligations and other evidences of indebtedness;
(b) grant security for funds;
(c) enter into agreements, including, but not limited to;
i. underwriting agreements, marketing agreements and selling agreements in relation to the raising of funds;
ii. interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in connection with the

objects mentioned above; and

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

102591

iii. bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements; credit insurance agreements and agree-

ments creating security in connection with the activities mentioned above.

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all

transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of direc-
tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by decision of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military events

have occurred or are imminent, which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 5. Share Capital. The subscribed capital is set at sixty thousand United States Dollars (USD 60,000.-) consist-

ing of six hundred (600) shares having a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of these articles of association.

Art. 6. Form of Shares. The shares of the Company are in bearer from or in registered form, according to the

shareholder’s decision.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by Article 39 of the Companies Law. Ownership of
registered shares will be established by registration in the said register. Certificates of such registration may be issued
and shall be signed by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person or if the

ownership of such share is disputed, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy
to represent such share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights
attached to that share until one person has been designated as the sole owner towards the Company.

Art. 7. General Meetings of the Shareholders of the Company. Any regularly constituted meeting of share-

holders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the powers to
order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-

holders representing at least one fifth (1/5) of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or rep-
resented at a meeting of shareholders, and if they all state  that  they  have  been  duly  informed  of  the  agenda  of  the
meeting, the meeting may be held without prior notice.

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or

at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday of April at 11.00
a.m. If such day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Luxem-
bourg business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the re-
spective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by the Companies Law shall govern the convening notices and the conduct of

the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. A shareholder may act at any meet-

ing of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, or facsimile. Except as otherwise required by
the Companies Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted by a simple majority of the
shareholders present or represented and voting.

The board of directors may determine any other reasonable conditions that must be fulfilled by shareholders for them

to take part in any meeting of shareholders.

Art. 8. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least

who need not be shareholders of the Company and who will be appointed either as category A or B directors. The
directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, which shall determine their number, re-
muneration and term of office as well as the category to which they pertain. The term of the office of a director may
not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors in office may be
reelected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders by a simple majority

vote of the shareholders of the Company.

In the event of a vacancy in the office of a director elected by the general meeting of shareholders because of death,

resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a resolution of the remaining directors elect-
ed by the general meeting of shareholders until the next meeting of shareholders, in compliance with the Companies
Law.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who

102592

need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place
indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside over all meetings of the shareholders and of the board of directors, but in his absence,

the board of directors may appoint another director as chairman or the shareholders pro tempore by vote of the ma-
jority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail, except in case of emergency, in which case the nature
and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice requirement may be dispensed in the
case of assent of each director in writing, by electronic mail, or facsimile, or any other similar means of communication.
A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a
prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by electronic mail, or fac-

simile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call, video conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-

munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors and at least a category

A and a category B director is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a simple majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting,

at least one category A and one category B directors having voted in favour of such decisions.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by electronic mail, facsimile or any other similar means of communication. The entirety of all such documents will form
the minutes giving evidence of the passing of the resolution. Resolutions in writing approved and signed by all directors
shall have the same effect as resolutions voted at a meeting of the board of directors.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, if any, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors. 

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts of administration and disposition within the Company’s purpose and the provisions of the Securitisation
Law. All powers not expressly reserved by the Companies Law or by these articles of association to the general meeting
of shareholders, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. Corporate Signature. The Company will be bound by the joint signature of a category A director and of

a category B director or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated to by
the board of directors.

Art. 12. Delegation of Powers. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the

daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and
its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or
corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of
directors and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers.

The Company may enter with any Luxembourg or foreign company into management or advisory agreements ac-

cording to which the above mentioned company or any other company previously approved by it will supply the Com-
pany with recommendations and advice with respect to the conduct of the Company’s business and the accomplishment
of its purpose, and according to which such company may, on a day-to-day basis and subject to the overall control and
ultimate responsibility of the board of directors of the Company, manage the Company’s assets. The management or
advisory agreements shall contain the rules governing the modification or expiration of such agreements which are oth-
erwise concluded for an unlimited period. The board may also confer special powers of attorney by notarial or private
proxy.

Art. 13. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or

firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of
the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall con-
tract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest

opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

Art. 14. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, exec-

utors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding
to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its
request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled

102593

to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 15. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an inde-

pendent auditor (réviseur d’entreprises) appointed by the board of directors and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Companies Law and the Securitisation Law.

Art. 16. Financial Year. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall

terminate on December thirty-first.

Art. 17. Profits. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the directors prepare an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation

shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company, as stated in Article 5 (Share Capital) or as increased or reduced from time to time as provided in Ar-
ticle 5.

The remainder of the annual net profits shall be distributed as dividends to the shareholders in accordance with the

Securitisation law. Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of share-
holders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall deter-
mine from time to time.

Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies

Law.

The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such

terms and conditions as prescribed by the general meeting.

Art. 18. Liquidation of the Company. The Company may be put into liquidation by a resolution of the general

meeting of the shareholders.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who

may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and fees.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 19. Applicable Law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accord-

ance with the Companies Law and the Securitisation Law.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2007.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2008. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter: 

All the shares have been entirely paid-in in cash so that the amount of sixty thousand United States Dollars (USD

60,000.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26

of the Companies Law and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation, are estimated at approximately five thousand Euro.

<i>General meeting of shareholders

The above mentioned persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully con-

vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of
the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed directors of the Company:
a) LOUV, S.à r.l., Director A, R.C.S. Luxembourg B 89.272, with registered offices at 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, represented by Mr Marc Limpens, professionally residing in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

599 shares

2) LOUV, S.à r.l., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600 shares

102594

b) DMC, S.à r.l., Director B, R.C.S. Luxembourg B 107.314, with registered offices at 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, represented by Mrs Saliha Boulhais, professionally residing in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

c) FIDIS, S.à r.l., Director B, R.C.S. Luxembourg B 107.312, with registered offices at 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, represented by Mrs Betty Prudhomme, professionally residing in L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey.

The term of office of the directors shall end at the general meeting called to approve the accounts as of 2011.
4. The registered address of the Company is 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of inconsistencies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day specified at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., une société organisée selon les lois de Luxembourg et ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

dûment représentée par Monsieur François Lanners, employé privé, demeurant professionnellement 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 septembre 2006.

2) LOUV, S.à r.l., une société organisée selon les lois de Luxembourg et ayant son siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg,

dûment représentée par Monsieur François Lanners, employé privé, demeurant professionnellement 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Les procurations, signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Nom. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées, une société anonyme sous la dénomination de FOUR SEAS S.A. (la Société) qui aura le statut d’une société de
titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la Loi sur la Titrisation) et sera régie par les dispo-
sitions de la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée
(la Loi sur les Sociétés) ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet exclusif de conclure une opération de titrisation conformément à la Loi sur

la Titrisation exclusivement relative à des stocks de diamants et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques,
existants ou futurs, liés à la possession de diamants. La Société assumera ces risques par l’acquisition des diamants à
titriser. Elle pourra aussi transférer, dans la mesure prévue par la loi et les présents statuts, ou disposer de ces diamants
et des biens qu’elle détient, qu’ils soient présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.

La Société devra émettre des titres dont la valeur ou le rendement est lié à ces diamants, ou dont le remboursement

est sujet au remboursement d’autres instruments ou de certaines créances. 

Dans le contexte et pour les besoins de la transaction de titrisation, la Société peut également:
(a) réunir des fonds, entre autre par l’émission de bonds, billets à ordre, obligations et autres moyens d’endettement;
(b) accorder des sûretés pour des fonds;
(c) conclure des contrats, comprenant, mais non limité à:
i. des contrats de garantie, des contrats de commercialisation et des contrats de vente en relation avec l’obtention

de fonds;

ii. des contrats d’échange d’intérêts ou de devises ou et d’autres contrats financiers de produits dérivés en relation

avec les objets susmentionnés; et

iii. des contrats de banque et d’administration d’espèces, contrats de lignes de crédits, contrats d’assurance de crédits

et des contrats créant des sûretés en relation avec les activités susmentionnées.

La Société pourra exercer tout investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique ou financière,

et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations
facilitant directement ou indirectement l’accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus. Les
actifs de la Société pourront seulement être transférés conformément aux termes des valeurs mobilières émises pour
financer l’acquisition de ces actifs.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social pourra être transféré dans la même commune par décision du conseil d’administration ou d’autres bureaux pour-
ront être établis soit à Luxembourg soit à l’étranger par décision du conseil d’administration. Les succursales ou les
autres bureaux pourront être établis soit à Luxembourg, soit à l’étranger par décision du conseil d’administration.

102595

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital social. Le capital souscrit est fixé à soixante mille dollars des Etats-Unis (USD 60.000,-), représenté

par six cents (600) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire. 
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce

registre contiendra toutes les informations prévues à l’Article 39 de la Loi sur les Sociétés. La propriété des actions
nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre peuvent
être délivrés et signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise ou litigieuse, les personnes

invoquant un droit de propriété sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant propriétaire à l’égard de la Société.

Art. 7. Assemblée Générale des Actionnaires de la Société. L’assemblée des actionnaires de la Société régu-

lièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite

des actionnaires représentant au moins le cinquième (1/5) du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou
représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se
tenir sans avis de convocation préalable.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre

endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 1

er

 lundi d’avril à 11:00. Si ce jour est un jour férié

légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires
pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi sur les Sociétés régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées

des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Tout actionnaire pourra

prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, ou télécopie, une autre personne comme son
mandataire. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi sur les Sociétés, les décisions d’une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés
et votant.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions raisonnables à remplir par les actionnaires pour

prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Art. 8. Administrateurs. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres

au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société et qui seront nommés en tant qu’administrateurs de
catégorie A ou B. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui fixe leur nom-
bre, leurs émoluments, la durée de leur mandat ainsi que la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les administrateurs
seront élus pour une durée qui n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient
été élus. Les administrateurs en fonction pourront être réélus.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans juste motif à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires prise à la majorité simple.

Au cas où le poste d’un administrateur élu par l’assemblée générale des actionnaires deviendrait vacant à la suite de

décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration
jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément à la Loi sur les Sociétés.

Art. 9. Réunions du Conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et

pourra également choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également choisir un secrétaire
qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et des réunions des actionnaires. Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président
ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions des actionnaires et du conseil d’administration; en son absence le conseil

d’administration pourra désigner un autre administrateur ou la réunion des actionnaires pourra désigner toute autre
personne pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions à la majorité des personnes présentes à la réunion. 

Un avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les
motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation
en cas d’assentiment de chaque administrateur par lettre, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen similaire
de communication. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant
à une heure et un endroit déterminés dans une résolution antérieure adoptée par le conseil d’administration.

102596

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre

ou par courrier électronique, ou télécopie, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, confé-

rence vidéo ou autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peu-
vent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en
personne à une telle réunion.

Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une

conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. 

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

et si au moins un administrateur de la catégorie A et un administrateur de la catégorie B, sont présents ou représentés
à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion

dans la mesure où au moins un administrateur de catégorie et un administrateur de catégorie B ce sont prononcés fa-
vorablement à ces décisions.

Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par lettre, courrier électronique, téléfax ou tout autre moyen de communication. L’ensemble de ces documents
constitueront les procès-verbaux faisant preuve de la décision intervenue. Les résolutions écrites approuvées et signées
par tous les administrateurs ont le même effet que les résolutions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en son ab-

sence, par le vice-président, s’il y en a un, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux, des-
tinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus lar-

ges pour passer tous actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société et des dispo-
sitions de la Loi sur la Titrisation. Tous pouvoirs que la Loi sur les Sociétés ou les présents statuts ne réservent pas
expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Pouvoir de Signature. La Société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur de la caté-

gorie A et d’un administrateur de la catégorie B ou par la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs

à la gestion journalière et à l’administration de la Société (incluant le droit d’agir en tant que signataire autorisé pour la
Société), et ses pouvoirs d’agir pour servir la politique et l’objet de la Société, à une ou plusieurs personnes physiques
ou morales, membres du conseil d’administration ou non, qui disposeront de pouvoirs déterminés par le conseil d’ad-
ministration et qui pourront, sur autorisation du conseil d’administration, sous-déléguer leurs pouvoirs. La Société pour-
ra conclure des contrats de gestion ou de conseil avec toute société luxembourgeoise ou étrangère selon lesquels la
société mentionnée ci-dessus ou toute autre société ayant été préalablement approuvée par elle fournira à la Société
des recommandations et conseils relatifs à la conduite des affaires de la Société et à l’accomplissement de son objet, et
suivant lesquels une telle société pourra gérer les biens de la Société, sur une base journalière et sujette au contrôle
général et à la responsabilité ultime du conseil d’administration de la Société. Ces contrats de gestion ou de conseil con-
tiendront les règles gouvernant leur modification et leur expiration, à défaut de quoi ils seront considérés comme con-
clus pour une durée illimitée. Le conseil d’administration peut également conférer tous mandats spéciaux par
procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Conflit d’Intérêt. Aucune convention ou autre transaction conclue entre la Société et toute autre société

ou entreprise ne sera affectée ou annulée par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société
auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu’ils seraient administrateur, associé,
directeur, employé ou mandataire de cette autre société ou entreprise. Tout administrateur ou directeur de la Société
qui agit en tant qu’administrateur, associé, directeur employé ou mandataire de toute société ou entreprise avec laquelle
la Société conclura des contrats ou est autrement en relations d’affaires, ne pourra pas être privé du droit de délibérer,
de voter ou d’agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires, en raison de son affiliation avec
cette autre société ou entreprise.

Au cas où un administrateur, directeur ou mandataire de la Société aurait dans une quelconque transaction effectuée

par la Société un intérêt opposé aux intérêts de la Société, cet administrateur, directeur, ou mandataire devra porter à
la connaissance du conseil d’administration cet intérêt opposé et devra s’abstenir de délibérer ou voter sur cette tran-
saction. Il devra être fait état de la transaction concernée ainsi que l’intérêt opposé y relatif lors de la toute prochaine
assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Indemnisation des Administrateurs. La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur,

et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes
actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur ou de directeur de la Société ou, à sa
demande, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier, et par laquelle il ne serait pas
indemnisé, sauf le cas où dans pareilles actions ou procès il serait finalement condamné pour négligence grave ou faute
grave; en cas de transaction extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son
conseil du fait que le membre du conseil d’administration en question n’a pas commis de manquement à ses devoirs. Ce
droit à indemnisation ne fait pas obstacle à tous autres droits dont il disposerait.

102597

Art. 15. Auditeurs. Les informations comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un

réviseur d’entreprises nommé par le conseil d’administration et rémunéré par la Société.

Le réviseur d’entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés et la Loi

sur la Titrisation.

Art. 16. Exercice Social. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se

terminera le trente et un décembre de la même année. 

Art. 17. Profits. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et les administrateurs dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs d’actif et de passif de la Société. Tout associé peut prendre connais-
sance de l’inventaire et du bilan au siège social.

Sur le profit annuel net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour allouer à la réserve légale et ce, jusqu’à

ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social, conformément à l’Article 5 (Capital social) ou tel
qu’augmenté ou réduit périodiquement, conformément à l’Article 5.

Le surplus des profits annuels nets sera distribué comme dividendes aux actionnaires conformément à la Loi sur la

Titrisation. Le paiement de distributions se fera aux actionnaires à leurs adresses figurant dans le registre des actionnai-
res. Les distributions seront payées dans la devise et aux moment et lieu que le conseil d’administration déterminera
périodiquement.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux conditions prévues par la Loi sur les Sociétés.
L’assemblée générale des actionnaires pourra décider de distribuer des dividendes en actions au lieu de dividendes

en espèces selon les conditions requises par l’assemblée générale.

Art. 18. Liquidation de la Société. La Société pourra être mise en liquidation par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront être des

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant de cette dissolution et qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du paiement du passif sera distribué aux actionnaires proportionnel-

lement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans chaque Compartiment de la Société.

Art. 19. Droit Applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dis-

positions de la Loi sur les Sociétés et de la Loi sur la Titrisation.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2007.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2008.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de soixante mille dollars des Etats-

Unis (USD 60.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la Loi sur les Sociétés

et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ cinq mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes susmentionnées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont réunies en assemblée générale des actionnaires. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
a) LOUV, S.à r.l., Administrateur A, R.C.S. Luxembourg B 89.272, ayant son siège au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, représentée par Monsieur Marc Limpens, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, ave-
nue Monterey.

b) DMC, S.à r.l., Administrateur B, R.C.S. Luxembourg B 107.314, ayant son siège au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, représentée par Madame Saliha Boulhais, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, ave-
nue Monterey.

c) FIDIS, S.à r.l., Administrateur B, R.C.S. Luxembourg B 107.312, ayant son siège au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, représentée par Madame Betty Prudhomme, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23,
avenue Monterey.

1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

599 actions

2) LOUV, S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600 actions

102598

3. Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes

au 2011.

4. Le siège social de la Société est établi au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Mersch, date qu’en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Lanners, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 septembre 2006, vol. 438, fol. 14, case 3. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107673.3/242/495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

KPI RETAIL PROPERTY 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 108.114. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00755, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107110.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

KPI RETAIL PROPERTY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 108.113. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00753, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107112.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

CLEMINGTON CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 103.355. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00750, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107113.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

SANTÉMEDIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.560.725,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.267. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 

17 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1098 du 18 juillet 2002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01059, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107137.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Mersch, le 3 octobre 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

SANTÉMEDIA HOLDING, S.À R.L.
Signature

102599

SOLAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 93.988. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04007, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107118.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

FEZELA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 93.362. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04008, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107123.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

LUNAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 94.242. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04013, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107124.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 70.258. 

<i>I. Nominations statutaires

L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2005, le terme du mandat des

Administrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre
2007:

M. Jean-Claude Finck, président, 
M. Michel Birel, vice-président, 
M. John Bour, administrateur, adresse professionnelle 48-50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, 
M. Gilbert Ernst, administrateur, 
M. Jean-Paul Kraus, administrateur, 
M. Jacques Mangen, administrateur, 
M. Nicolas Rollinger, administrateur, 
M. Guy Rosseljong, administrateur,
M. Paul Waringo, administrateur.

<i>II. Nomination du Commissaire aux Comptes

L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Michel Kieffer, a été fixé à un an, c’est-à-dire

jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Michel

Kieffer, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2007.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03180. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107261.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures

102600

AFD RIVESALTES A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,062,875.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 114.005. 

In the year two thousand and six, on the nineteenth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ArcIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée), having its registered office at 1, rue des Glacis in L-1628 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 112.938 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs Shao-Tchin Chan, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 19, 2006,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The appearer has requested the undersigned notary to record the following: 
I. That it is the Sole Shareholder of AFD RIVESALTES A, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (so-

ciété à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue des Glacis in L-1628 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 114.005, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary on January 25, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 860 of
May 2, 2006. 

The articles have been amended several times and for the last time by a deed of Maître André Schwachtgen, notary

residing in Luxembourg dated August 8th, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(the Company).

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 25,750 (twenty-five thousand seven hundred

and fifty Euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR 1,062,875 (one million sixty-two thou-
sand eight hundred seventy-five Euro) to EUR 1,088,625 (one million eighty-eight thousand six hundred and twenty-five
Euro) by way of the issue of 206 (two hundred and six) new shares of the Company, having a par value of EUR 125 (one
hundred twenty-five Euro) each, with an aggregate share premium of EUR 54 (fifty-four Euro).

2. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 1st above.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted

under item 1st.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any employee of MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

25,750 (twenty-five thousand seven hundred and fifty Euro) in order to bring the share capital from its former amount
of EUR 1,062,875 (one million sixty-two thousand eight hundred seventy-five Euro) to EUR 1,088,625 (one million
eighty-eight thousand six hundred and twenty-five Euro) by way of the issue of 206 (two hundred and six) new shares
of the Company, having a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each, with an aggregate share premium
of EUR 54 (fifty-four Euro).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company in the

amount of EUR 25,750 (twenty-five thousand seven hundred and fifty Euro) and it fully pays it up by a contribution in
cash in an aggregate amount of EUR 25,804 (twenty-five thousand eight hundred and four Euro) which is evidenced to
the notary by a certificate of blockage and which shall be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 25,750 (twenty-five thousand seven hundred and fifty Euro) is to be allocated to the nominal

share capital account of the Company, and

(ii) an amount of EUR 54 (fifty-four Euro) is to be allocated to the premium reserve of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows: 

ArcIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,709 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,709 shares

102601

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it

shall henceforth read as follows:

«5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 1,088,625 (one million eighty-eight thousand six hundred and

twenty-five Euro), represented by 8,709 (eight thousand seven hundred and nine) shares in registered form with a par
value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each, all subscribed and fully paid up.»

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any manager of the Company and any employee of MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERV-
ICES, S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register
of the Company.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ArcIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 1, rue des Glacis à L-1628 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.938,

ici représentée par Madame Shao-Tchin Chan, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 19 septembre 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

La comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Qu’elle est l’Associée Unique de AFD RIVESALTES A, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 1, rue des Glacis à L-1628 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.005, constituée suivant un acte du notaire instrumentaire
du 25 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 860 du 2 mai 2006.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître André

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 août 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Socié-
tés et Associations (la Société).

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 25.750 (vingt-cinq mille sept cent cinquante

euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.062.875 (un million soixante-deux mille huit cent
soixante-quinze euros) à EUR 1.088.625 (un million quatre-vingt-huit mille six cent vingt-cinq euros) par l’émission de
206 (deux cent six) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)
chacune, avec une prime d’émission de EUR 54 (cinquante-quatre euros).

2. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous le point 1

er

 ci-dessus.

3. Modification subséquente de l’article 5.1 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital spécifiée au point 1

er

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société et à tout employé de MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. de procéder au
nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la
Société.

5. Divers.
III. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de 25.750

(vingt-cinq mille sept cent cinquante euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.062.875 (un
million soixante-deux mille huit cent soixante-quinze euros) à EUR 1.088.625 (un million quatre-vingt-huit mille six cent
vingt-cinq euros) par l’émission de 206 (deux cent six) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription et la libération intégrale de l’augmentation du capital

social comme suit:

<i>Souscription - Libération

L’Associée Unique déclare souscrire à l’augmentation de capital de la Société d’un montant de EUR 25.750 (vingt-

cinq mille sept cent cinquante euros) et de la payer par un apport en numéraire d’un montant total de EUR 25.804 (vingt-

102602

cinq mille huit cent quatre euros) documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté de la manière
suivante:

(i) un montant de EUR 25.750 (vingt-cinq mille sept cent cinquante euros) sera affecté au compte capital nominal de

la Société, et 

(ii) un montant de EUR 54 (cinquante-quatre euros) sera affecté au compte prime d’émission de la Société.
Le montant de l’augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au

notaire instrumentant.

L’Assemblée décide d’acter que l’actionnariat de la Société suite à l’augmentation de capital est comme suit:  

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts de sorte qu’il

aura la teneur suivante:

«5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 1.088.625 (un million quatre-vingt-huit mille six cent vingt-cinq

euros) représenté par 8.709 (huit mille sept cent neuf) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de
EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-

dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de MANAGEMENT &amp; ACCOUN-
TING SERVICES, S.à r.l. de procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des parts sociales de la Société. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte est

établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre la
version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent

acte avec Nous, Notaire.

Signé: S.-T. Chan, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, vol. 155S, fol. 52, case 10. – Reçu 258,04 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107674.3/230/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

AFD RIVESALTES A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.062.845.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 114.005. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1358 du 19 septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107675.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 31.093. 

<i>Protokoll über die Außerordentliche Generalversammlung am 4. Februar 2005

<i>Tagesordnung:

3. Demission des Herrn Prof. Dr. Jörg-E. Cramer aus dem Verwaltungsrat der HAIG per 5. Februar 2005.
Zu Punkt 3:
Die Generalversammlung stimmt der Demission des Herrn Prof. Cramer aus dem Verwaltungsrat zu.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06639. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107307.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

ArcIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.709 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.709 parts sociales

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

J.-M. Schomer / H. Braun.

102603

MERCURY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 94.241. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04011, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107126.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

NAVARAC PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 119.904. 

 STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-second of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) The Company BALCHAN NOMINEES LIMITED, with registered office at Old Bank Chambers, P.O. Box 428, GYI

3WZ, Grande Rue, Saint Martin’s, Guernsey (N

°

 41297),

represented by Mélanie Ustache, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 20th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The Corporation’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name NAVARAC PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented

by five hundred (500) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

Signature.

102604

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of any one manager.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than 75% of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December, with the excep-

tion of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st
December 2006.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members;

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The 500 (five hundred) shares are subscribed as follows: 

The appearing parties, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation, are estimated at approximately 1,500.- EUR.

1) BALCHAN NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

102605

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
- The Company BALCHAN DIRECTORS LIMITED, with registered office at Old Bank Chambers, P.O. Box 428, GYI

3WZ, Grande Rue, Saint Martin’s, Guernsey (N

°

 37822);

2) The registered office of the Company is established at L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

1) La société BALCHAN NOMINEES LIMITED, avec siège social à Old Bank Chambers, P.O. Box 428, GYI 3WZ,

Grande Rue, Saint Martin’s, Guernsey (N

°

 41297),

ici représentée par Mélanie Ustache, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle

a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: NAVARAC PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

102606

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature individuelle d’un gérant.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant au
moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes;

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parties comparantes, représentées comme dit-est, ont déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement

libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la dis-
position de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

1) BALCHAN NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

102607

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 1.500,- EUR.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par la gérante suivante:
- La société BALCHAN DIRECTORS LIMITED, avec siège social à Old Bank Chambers, P.O. Box 428, GYI 3WZ,

Grande Rue, Saint Martin’s, Guernsey (N

°

 37822);

2) L’adresse de la Société est fixée à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. Ustache, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 56, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107700.3/211/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

AGRI SERVICES MARIENDALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7411 Marienthal, 3, rue de Keispelt.

R. C. Luxembourg B 110.784. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU01068, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107139.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

GARDIZOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, 2, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 38.273. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01518, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107163.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

SILVER ROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 62.126. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00670, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(107151.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

J. Elvinger.

AGRI SERVICES MARIENDALL, S.à r.l.
Signature

GARDIZOO, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>SILVER ROSE S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

102608

OURSIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 101.292. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00993, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107142.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

ALPINA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Béreldange, 4, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 20.167. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU01084, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107143.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

DARSELLA INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 84.481. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00989, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107144.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

JOSY WELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 8-10, rue Génistre.

R. C. Luxembourg B 29.641. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01535, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107145.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

ONE PARK LANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.618. 

L’an deux mille six, le vingt septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ONE PARK LANE S.A. (la «Société»), une so-

ciété anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg,

constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 19 janvier 2006, publié au Mémorial C numéro 771 du 15

avril 2006.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro

113.618.

L’Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Corinne Waldung, employée privée, avec adresse

professionnelle à Bertrange.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Dessart, employée privée, avec adresse professionnelle à Ber-

trange.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, avec adresse professionnelle à Bertrange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par cha-

cun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Signature.

ALPINA IMMOBILIERE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Signature.

JOSY WELTER, S.à r.l.
Signature

102609

représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) afin

de le porter de son montant actuel de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) divisé en mille cinq cents (1.500)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à un montant de trois cent mille euros (300.000,-
EUR) qui sera représenté par trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, par
la création et l’émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles ordinaires supplémentaires, chacune avec une va-
leur nominale de cent euros (100,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes
et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

2.- Acceptation à la souscription et à la libération intégrale en numéraire de ces mille cinq cents (1.500) actions nou-

velles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, par la société CRITERIA, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, les
actionnaires existants ayant, dans la mesure nécessaire, renoncé à leur droit de souscription préférentiel.

3.- Modification du premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de ca-

pital ci-avant décidée.

B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée Générale Extraordinaire aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à

concurrence d’un montant de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de
cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) divisé en mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune, à un montant de trois cent mille euros (300.000,- EUR) qui sera représenté par trois mille (3.000)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, par la création et l’émission de mille cinq cents (1.500)
actions nouvelles ordinaires supplémentaires, chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chaque ac-
tion avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour
de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont, dans la mesure nécessaire, re-
noncé à leur droit préférentiel de souscription et décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles,
la société suivante:

La société CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.199).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes:
Madame Corinne Waldung, préqualifiée, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial du seul souscripteur susnommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 15 septembre 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès dites qualités, a déclaré souscrire au nom et pour le compte de CRITERIA,

S.à r.l., prénommée, aux mille cinq cents (1.500) actions nouvellement émises par la Société et les libérer intégralement
par des versements en numéraire.

Le souscripteur susmentionné, par sa représentante susnommée, déclare en outre, et tous les actionnaires présents

à l’assemblée générale extraordinaire reconnaissent expressément, que chaque action nouvelle a été intégralement li-
bérée en numéraire, et que la somme totale de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) se trouve dès à présent à la
libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de refléter l’augmentation de capital ci-avant intervenue, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

décide de modifier l’article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société. L’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires décide de donner à cet alinéa premier de l’article cinq (5) des statuts de la Société, la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR) représenté par trois

mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

102610

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à la somme de deux mille six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Waldung, S. Dessart, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2006, vol. 907, fol. 29, case 10. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107705.3/239/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

ONE PARK LANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.618. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107707.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

MED CONTROL S.A., Société Anonyme,

(anc. DADA &amp; COMPANY PARTICIPATIONS S.A., Luxembourg).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 103.155. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00983, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107147.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

JOHANN BERGER TRANSPORTE LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.

R. C. Luxembourg B 94.220. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01531, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107148.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

FOUR POINTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.052. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00701, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(107153.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Belvaux, le 3 octobre 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 3 octobre 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Signature.

JOHANN BERGER TRANSPORTE LUXEMBURG, GmbH
Signature

<i>Pour FOUR POINTS S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

102611

I.D. 20 FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 89.192. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00979, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107149.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

L’ABBAYE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 58.721. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00697, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(107154.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

MALDEREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.058. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00694, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(107155.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

GREFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 30.586. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01527, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107157.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

EURO INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 98.566. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00692, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(107158.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Signature.

<i>Pour L’ABBAYE S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour MALDEREN S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

GREFA, S.à r.l.
Signature

<i>Pour EURO INVESTMENT S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

102612

GRAVOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 164, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.033. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01524, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107160.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

KLEVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.695. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00689, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

(107161.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

COMPTOIR DU SEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R. C. Luxembourg B 18.921. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01496, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107164.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

PICHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6858 Muenschecker, 7, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 85.504. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05754, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107180.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

FINANCIERE DU NIAGARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 16.844. 

Les comptes annuels au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00802, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2006.

(107271.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

GRAVOLUX, S.à r.l.
Signature

<i>Pour KLEVER INTERNATIONAL S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

COMPTOIR DU SEL, S.à r.l.
Signature

Signature.

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

102613

HaLoMi, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 96.440. 

DISSOLUTION

In the year two thousand six, on the twenty-first day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs Martine Kapp, employee, with professional address in Luxembourg,
acting as a special proxyholder of:
Mr Mikael Eriksson, company director, residing at Olympia Strasse 36, A-6094 Axams (Austria),
hereafter referred to as «the principal»,
by virtue of a proxy given in Axams (Austria), on 13 September 2006,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will be registered with this deed. 

The same proxyholder declared and requested the notary to act:
I.- That the company HaLoMi, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», established and having its registered office

at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, registered in the «Registre de Commerce et des Sociétés» in Luxem-
bourg, section B number 96.440, has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a notarial deed enacted
through the undersigned notary, on 17 October 2003, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 1200 of 14
November 2003.

The Articles of Association of said company have not been amended since.
II.- That the subscribed capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), divided

into one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, fully paid-up.

III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.
IV.- That the principal, being sole partner of the company HaLoMi, S.à r.l., has decided to proceed immediately to the

dissolution of said company.

V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the

company HaLoMi, S.à r.l., prementioned.

VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares that the business activity of the company

has ceased, that it, as sole shareholder, is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved company
committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.

VII.- That the principal fully grants discharge to the current managers of the dissolved company, for the due perform-

ance of their duties up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered

office.

IX.- That the principal commits itself to pay the cost of the present deed. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, records that on request of the proxyholder of the

above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the
same proxyholder and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary, by his sur-

name, first name, civil status and residence, said person signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
Monsieur Mikael Eriksson, directeur de société, demeurant à Olympia Strasse 36, A-6094 Axams (Autriche),
ci-après dénommé: «le mandant»,
en vertu d’une procuration lui donnée à Axams (Autriche), le 13 septembre 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle mandataire, agissant ès dites qualités, a déclaré et requis le notaire d’acter:
I.- Que la société HaLoMi, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 2, rue Carlo

Hemmer, L-1734 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le nu-
méro 96.440, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné, en date
du 17 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1200 du 14 novembre 2003.

Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis lors.

102614

II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, chaque part sociale étant in-
tégralement libérée.

III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société HaLoMi, S.à r.l., a décidé de procéder à la dissolution immé-

diate de ladite société.

V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société HaLoMi,

S.à r.l., prédésignée.

VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare que l’activité de la société a cessé, que lui, en tant

qu’associé unique est investi de tout l’actif et qu’il a réglé tout le passif de la société dissoute s’engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obli-
gation inconnue à l’heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants actuels de la société dissoute, pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

IX.- Que le mandant s’engage à payer les frais du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire du

comparant le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg. les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Kapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2006, vol. 907, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107709.3/239/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

CMH VERTRIEBS SERVICE II, Société Anonyme.

Registered office: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.550. 

In the year two thousand six, on the eighteenth day of the month of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CMH VERTRIEBS SERVICE II, a Luxembourg so-

ciété anonyme with registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
incorporated formerly under the name of SECURUM, following a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) on 27 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 41 of 13 January 2004, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,
Section B, under the number 97.550 and whose articles of association have been amended for the last time following a
deed of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed, on 30 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1058 of 31 May 2006 (the «Company»).

The extraordinary general meeting was declared open at 6.50 p.m. and was presided over by Mr Jean Kayser, expert-

comptable, with professional address in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary of the meeting Mrs Anca Iusco, lawyer, with professional address in Luxem-

bourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Manfred Müller, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To transfer the registered office of the Company from its current address to 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
2. To amend the Company’s articles of incorporation in order to reflect the resolution to be adopted under item 1st

of the agenda.

3. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies, the
bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the proxy holders, the board of the meeting and

the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

Belvaux, le 28 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

102615

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total share capital are represented at

the meeting, which is consequently regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which
the shareholders have been duly informed before this meeting.

The general meeting, after deliberation, adopted each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to transfer the registered office of the Company from its current ad-

dress to 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to amend article 2, paragraph 1 and 2 of the Company’s articles of

association which shall forthwith read as follows:

Art. 2. paragraph 1st and 2. «The Company will have its registered office in Strassen.
The registered office may be transferred to any other place in Strassen by a resolution of the Board of Directors.»
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed at 7.10 p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, have signed together with the Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-huitième jour du mois de septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CMH VERTRIEBS SERVICE II, une société ano-

nyme luxembourgeoise, avec siège social au 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxem-
bourg), constituée originairement sous la dénomination de SECURUM, suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire
de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), le 27 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Socié-
tés et Associations, numéro 41 du 13 janvier 2004, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, Section B, sous le numéro 97.550 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire
Jean-Joseph Wagner, prénommé, le 30 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1058 du 31 mai 2006 (la «Société»).

L’assemblée a été déclarée ouverte à 18.50 heures sous la présidence de Monsieur Jean Kayser, expert-comptable,

avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigna comme secrétaire de l’assemblée Madame Anca Iusco, juriste, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’assemblée nomma comme scrutateur Maître Manfred Müller, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président exposa et pria le notaire instrumentant d’acter:
I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
2. Modification des statuts de la Société afin de refléter la résolution adoptée conformément au point 1

er

 de l’ordre

du jour.

3. Divers.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions détenues par chacun d’eux, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires ou leurs mandataires ainsi que par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

III) Il ressort de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont repré-

sentées à l’assemblée, laquelle est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires ont été informés avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 23, route d’Arlon,

L-8009 Strassen.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 2, paragraphe 1

er

 et 2 des statuts de la Société qui auront doréna-

vant la teneur suivante:

Art. 2. paragraphe 1

er

 et 2. «Le siège social est établi à Strassen.

Il peut être transféré dans tout autre endroit à Strassen par décision du Conseil d’Administration.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19.10 heures.

102616

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Kayser, A. Iusco, M. Müller, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2006, vol. 907, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107715.3/239/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

CMH VERTRIEBS SERVICE II, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.550. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107716.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

TEE OFF PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5712 Aspelt, 2B, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 81.830. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05726, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107181.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

SLAINTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2738 Luxembourg, 13, rue Paul Wilwertz.

R. C. Luxembourg B 41.039. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05728, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107182.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

NASTIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.825. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00803, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2006.

(107274.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Belvaux, le 3 octobre 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 3 octobre 2006.

J.-J. Wagner.

<i>Pour le gérant
Signature

<i>Pour le gérant
Signature

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

102617

PROFIRENT S.A., Aktiengesellschaft (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 31.589. 

AUFLÖSUNG

<i>Auszug des Sitzungsprotokolls der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 30. August 2006

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der PROFIRENT S.A. (die SICAF), einer Investmentgesell-

schaft mit fixem Kapital (in Liquidation) hat am 30. August 2006 am Gesellschaftssitz nach Anhörung des Berichtes des
Liquidators und der Berichte des Wirtschaftsprüfers unter anderem folgende einstimmige Beschlüsse gefasst:

1) Abschluss der Liquidation;
2) Bestimmung des Sitzes der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., 308, route d’Esch, L-1471 Luxemburg als den Ort,

an dem die Bücher und Schriftstücke der SICAF für einen Zeitraum von fünf Jahren aufzubewahren sind;

3) Bestimmung, dass Gelder und Werte, welche den Gläubigern und Aktionären der SICAF nicht ausgezahlt werden

können ab dem 1. März 2007 bei der Caisse de Consignation zu hinterlegen sind.

Luxemburg, den 31. August 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106738.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

EuroLotto SYSTEMS AG, Aktiengesellschaft,

(anc. EURO LOTTO SYSTEMS A.G.).

Gesellschaftssitz: L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter.

H. R. Luxemburg B 104.414. 

Im Jahre zweitausendsechs, den einunddreißigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft EURO LOTTO SYSTEMS A.G. mit Sitz in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter, eingetragen
beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 104.414, gegründet gemäß Ur-
kunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. November 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 139
vom 15. Februar 2005,

mit einem Gesellschaftskapital von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien

von jeweils dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jean Bernard Zeimet, Wirtschaftsprüfer, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Sylvie Maiezza, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Klaus Benscheidt, Rechtsanwalt, wohnhaft in Grevenmacher.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, dieser Urkunde beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung der Gesellschaftsbezeichnung in EuroLotto SYSTEMS AG und dementsprechende Abänderung von Ar-

tikel 1 der Satzungen.

2.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaftsbezeichnung von EURO LOTTO SYSTEMS A.G. in EuroLotto

SYSTEMS AG abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschließt die Generalversammlung Artikel

1 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 1. Unter der Bezeichnung EuroLotto SYSTEMS AG besteht eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechtes.

PROFIRENT S.A.
Unterschrift
<i>Liquidator

102618

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundertfünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu

Lasten der Gesellschaft. 

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. B. Zeimet, S. Miezza, K. Benscheidt, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 septembre 2006, vol. 537, fol. 88, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107013.3/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

BETAFENCE LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 109.542. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique qui s’est tenue le 8 septembre 2006

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de la Société qui s’est tenue le 27 juillet 2006, il a été décidé

comme suit:

- D’accepter la démission de Michel van Krimpen résidant au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg comme Gérant

de la société avec effet immédiat.

- De nommer Doeke van der Molen, résidant au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, comme Gérant de la société

avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05830. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107017.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 109.543. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique qui s’est tenue le 8 septembre 2006

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de la société qui s’est tenue le 27 juillet 2006, il a été décidé

comme suit:

- D’accepter la démission de Michel van Krimpen résidant au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg comme gérant

de la société avec effet immédiat.

- De nommer Doeke van der Molen, résidant au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, comme gérant de la société

avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05828. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107027.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

I.B.A., INTERNATIONAL BROKERAGE AND ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 56.303. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02192,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106729.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Junglinster, den 25. September 2006.

J. Seckler.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Signature.

102619

PARQUE D. PEDRO 1 B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.200.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.463. 

Les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006,

réf. LSO-BV00478, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(106715.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

PARQUE D. PEDRO 1 B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.200.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.463. 

Les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006,

réf. LSO-BV00479, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(106716.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

PARQUE D. PEDRO 2 B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.200.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.464. 

Les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006,

réf. LSO-BV00481, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(106718.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

GOTA MAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 84, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 93.399. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01571, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107286.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

I.B.A., INTERNATIONAL BROKERAGE AND ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 56.303. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02190,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106730.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Signature.

102620

PARQUE D. PEDRO 2 B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.200.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.464. 

Les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006,

réf. LSO-BV00482, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(106719.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

ABES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

H. R. Luxemburg B 48.944. 

Im Jahre zweitausendsechs, den fünften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Sind erschienen:

1.- Herr Rotger Barich, Kaufmann, geboren in Siegen (Deutschland), am 20. August 1962, wohnhaft in D-54439 Saar-

burg, Portzer Strasse la (Deutschland). 

2.- Herr Lutz Barich, Kaufmann, geboren in Lüdenscheid (Deutschland), am 15. Dezember 1964, wohnhaft in D-57250

Netphen, Austrasse 20 (Deutschland). 

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden: 
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABES, S.à r.l., mit Sitz in L-7333 Steinsei, 50, rue des Prés, R.C.S.

Luxemburg Sektion B Nummer 48.944, gegründet wurde unter der Bezeichnung AUSSEN- UND BINNENHANDEL EI-
SEN UND STAHL VERTRIEBSGESELLSCHAFT, S.à r.l. (ABES) gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Edmond
Schroeder, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 14. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 19
vom 13. Januar 1995,

dass deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Edmond

Schroeder am 17. Oktober 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 82 vom 9. Februar 1998,

dass deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. April

2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 634 vom 6. September 2000,

dass deren Gesellschaftskapital in Euro umgewandelt wurde gemäss Beschluss der alleinigen Gesellschafterin vom 27.

Dezember 2001 und veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1292 vom 6. September 2002.

- Dass die Komparenten sub 1 und 2 einzige und alleinige Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft sind und

dass sie einstimmig folgende Beschlüsse genommen haben:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter stellen folgende Abtretungen vom 9. August 2006 von Gesellschaftsanteilen fest:
- Die Gesellschaft WALLIS TRADING LIMITED, mit Sitz in Tortola, Tropic Isle Building, Road Town (Britische Jung-

ferninseln) trat zweihundertfünfzig (250) Anteile der vorbezeichneten Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABES, S.à
r.l., an Herrn Rotger Barich, vorgenannt, ab.

- Die Gesellschaft WALLIS TRADING LIMITED, vorbezeichnet, trat zweihundertfünfzig (250) Anteile der vorbe-

zeichneten Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABES, S.à r.l., an Herrn Lutz Barich, vorgenannt, ab.

<i>Zweiter Beschluss

Nach diesen hiervor festgestellten Abtretungen von Gesellschaftsanteilen wird Artikel sechs (6) der Satzung abgeän-

dert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro und achtundsechzig cent

(12.394,68 EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile ohne Angabe des Nennwertes.

Die Anteile verteilen sich wie folgt: 

Jeder Anteil verleiht eine Stimme auf ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen.
Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sieben hundert Euro abgeschätzt.

<i>Pour la société
Signature

1.- Herr Rotger Barich, Kaufmann, geboren in Siegen (Deutschland), am 20. August 1962, wohnhaft in D-54439

Saarburg, Portzer Strasse la (Deutschland), zweihundertfünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Herr Lutz Barich, Kaufmann, geboren in Lüdenscheid (Deutschland), am 15. Dezember 1964, wohnhaft in

D-57250 Netphen, Austrasse 20 (Deutschland), zweihundertfünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

102621

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem No-
tar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Barich, L. Barich, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 septembre 2006, vol. 537, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106920.3/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

NORDEA LIFE &amp; PENSIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 35.996. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 

31 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 262 du 5 juillet 1991.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00188, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106721.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

MAZ PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.988. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 25 mai 2004, acte 

publié au Mémorial C n

°

 761 du 23 juillet 2004.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00325, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106722.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

MARCAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7516 Rollingen, 14, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 29.504. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04522,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106731.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

ARDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 18.987. 

Le bilan abrégé au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00090, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106732.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Junglinster, den 26. September 2006.

J. Seckler.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour MAZ PARTICIPATIONS, S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

102622

DEEPINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.505. 

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf.

LSO-BV00326, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(106723.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 43.366. 

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf.

LSO-BV00328, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(106724.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

SOK, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.046. 

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf.

LSO-BV00323, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(106725.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

SERICO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 108.960. 

In the year two thousand and six, on the nineteenth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

There appear:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability Company organized under the law of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade
and Company Register of Luxembourg section B, under number B 106.232,

here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established on April 17th, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing in Luxembourg under the name of SERICO LUXEMBOURG, S.à r.l. with registered office at 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 108.960,
incorporated by a deed of the undersigned notary of June 14, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1215 dated November 16, 2005.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Pour <i>DEEPINVEST S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour <i>PARADISA S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour <i>SOK
G. Birchen
<i>Administrateur

102623

III. The sole shareholder resolve to increase the Company’s corporate capital to the extent of four hundred eighteen

thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 418,875.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500.-) to four hundred thirty-one thousand three hundred seventy-five Euro (EUR 431,375.-) by
creation and issue of sixteen thousand seven hundred fifty-five (16,755) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vest-
ed with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, resolves to subscribe the sixteen thousand

seven hundred fifty-five (16,755) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of
four hundred eighteen thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 418,875.-) by contribution in kind consisting of
two receivables held towards the Company, corresponding to the amount due and payable under the terms and condi-
tions of an interest free loan agreement signed between the Company and LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., pre-
named on June 29, 2005 whereby LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, lent the principal amount of three
hundred thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 300,425.-) to the Company and the amount due and payable
under the terms and conditions of an interest free loan agreement signed between the Company and LBREP II EUROPE
HOLDINGS, S.à r.l., prenamed on November 24, 2005 whereby LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, lent
the principal amount of one hundred eighteen thousand four hundred fifty Euro (EUR 118,450.-) to the Company.

Proof of the existence and value of such receivables has been given to the undersigned Notary by the original of the

loan agreements executed between the Company and LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, on June 29,
2005 and on November 24, 2005.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

«Art. 6. The share capital of the Company is fixed at four hundred thirty-one thousand three hundred seventy-five

Euro (EUR 431,375.-) divided into seventeen thousand two hundred fifty-five (17,255) shares of twenty-five Euro (EUR
25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro (EUR
7,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le 19 septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisé selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 106.232,

ici représentée par Monsieur Gael Toutain, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 17 avril 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, sous la dénomina-

tion de SERICO LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 108.960, cons-
tituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 14 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1215 en date du 16 novembre 2005.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent dix-huit mille huit

cent soixante-quinze euros (EUR 418.875,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à quatre cent trente et un mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 431.375,-) par la création et l’émission
de seize mille sept cent cinquante-cinq (16.755) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

102624

<i>Souscription - Libération

L’associé unique, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précité, declare souscrire aux seize mille sept cent cinquan-

te-cinq (16.755) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et les libère
intégralement par un apport en nature consistant en deux créances détenues à l’encontre de la Société correspondant
au montant dû et exigible en vertu des conditions d’un contrat de prêt sans intérêt entre la Société et LBREP II EUROPE
HOLDINGS, S.à r.l., précité, en date du 29 juin 2005 en vertu duquel LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précité, a
accordé un prêt à la Société pour un montant de trois cent mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 300.425,-) et au
montant dû et exigible en vertu des conditions d’un contrat de prêt sans intérêt entre la Société et LBREP II EUROPE
HOLDINGS, S.à r.l., précité, en date du 24 novembre 2005 en vertu duquel LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l.,
précité, a accordé un prêt à la Société pour un montant de cent dix-huit mille quatre cent cinquante euros (EUR
118.450,-).

Preuve de l’existence et de la valeur de ces créances a été donnée au notaire instrumentant par l’original des contrats

de prêt entre la Société et LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précité, en date du 29 juin 2005 et du 24 novembre
2005.

V. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social émis de la Société est fixé à quatre cent trente et un mille trois cent soixante-quinze euros

(EUR 431.375,-) divisé en dix-sept mille deux cent cinquante-cinq (17.255) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 47, case 2. – Reçu 4.188,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107902.3/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

SERICO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 108.960. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 44193 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 9 octobre 2006.

(107903.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

KPI Retail Property 10, S.à r.l.

BRE/Hamburg Reichshof Hotel, S.à r.l.

Aequitas Europe 3, S.à r.l.

KPI Retail Property 9, S.à r.l.

BRE/Hamburg Reichshof Hotel Holding, S.à r.l.

Syntaxis, S.à r.l.

KPI Retail Property 7, S.à r.l.

KPI Retail Property 5, S.à r.l.

Four Seas S.A.

KPI Retail Property 3, S.à r.l.

KPI Retail Property 2, S.à r.l.

Clemington Corporation, S.à r.l.

Santémedia Holding, S.à r.l.

Solar Investments S.A.

Fezela Investments S.A.

Lunar Investments S.A.

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding

AFD Rivesaltes A, S.à r.l.

AFD Rivesaltes A, S.à r.l.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Mercury Investments S.A.

Navarac Properties, S.à r.l.

Agri Services Mariendall, S.à r.l.

Gardizoo, S.à r.l.

Silver Rose S.A.

Oursin Participations S.A.

Alpina Immobilière, S.à r.l.

Darsella International S.A. Luxembourg

Josy Welter, S.à r.l.

One Park Lane S.A.

One Park Lane S.A.

Med Control S.A.

Johann Berger Transporte Luxemburg, GmbH

Four Points S.A.

I.D. 20 Finance S.A.

L’Abbaye S.A.

Malderen S.A.

Grefa, S.à r.l.

Euro Investment 2000 S.A.

Gravolux, S.à r.l.

Klever International S.A.

Comptoir du Sel, S.à r.l.

Picha, S.à r.l.

Financière du Niagara S.A.

HaLoMi, S.à r.l.

CMH Vertriebs Service II

CMH Vertriebs Service II

Tee Off Promotions, S.à r.l.

Slainte, S.à r.l.

Nastia

Profirent S.A.

EuroLotto Systems AG

Betafence Luxembourg

Société Financière Betafence

I.B.A., International Brokerage and Administration S.A.

Parque D. Pedro 1 B.V.

Parque D. Pedro 1 B.V.

Parque D. Pedro 2 B.V.

Gota Mar, S.à r.l.

I.B.A., International Brokerage and Administration S.A.

Parque D. Pedro 2 B.V.

Abes, S.à r.l.

Nordea Life &amp; Pensions S.A.

MAZ Participations, S.à r.l.

Marcan, S.à r.l.

Ardeco S.A.

Deepinvest S.A.

Paradisa S.A.

SOK

Serico Luxembourg, S.à r.l.

Serico Luxembourg, S.à r.l.