This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
96001
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2001
25 octobre 2006
S O M M A I R E
ABN AMRO Investment Funds S.A., Luxembourg-
MG Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
96031
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96038
Montagu Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
96041
ABN AMRO Investment Funds S.A., Luxembourg-
Montagu Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
96043
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96038
MR & Co Promo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
96006
ACE Tourism & Entertainment S.A., Luxembourg
96031
Nafta Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
96015
Agemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96041
O.I. TE, O.I. TX et Colonnes Investment, S.e.n.c.,
Altawin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96006
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96014
Amarilys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
96041
O.I. TE, O.I. TX et Colonnes Investment, S.e.n.c.,
Ambisoll S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96007
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96014
An.so.fi. Holding S.A. (Amboise Société Financière),
O.I. TE, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96015
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96007
O.I. TE, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96015
AZ Fund 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96040
O.I. TX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
96015
Bass.Com. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96023
O.I. TX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
96015
Berlys Management, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
96027
Onsen Benelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
96037
Berlys, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96026
Orion Income Finance Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Beständigkeit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
96036
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96007
British Vita (Lux III), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
96037
Partition et Participation S.A., Luxembourg . . . . .
96034
C.M.P. Creative Marketing et Promotion, S.à r.l.,
Pimiento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
96014
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96023
Preinvestment Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
96023
Calchas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
96043
Princess Wilru, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
96016
CB Luxembourg IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
96044
Provimlux Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
96030
Charterhouseluxco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
96026
Russian Investment Company, Sicav, Luxembourg
96007
Coheris Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
96037
S.S.F.S., Standard Software and Firmware Services
Compagnie d’Investissements Luxembourgeoise
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96002
S.A., Petange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96002
Sanmina-SCI Luxembourg, S.à r.l., Münsbach. . . .
96038
Coparin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96048
Sanmina-SCI Luxembourg, S.à r.l., Münsbach. . . .
96040
Dentasmile, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
96046
SEB Fund 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96027
Euro 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96026
SEB Fund 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96023
Euroceanica Shipping Holding B.V./S.à r.l., Luxem-
SEB Fund 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96020
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96026
Sfeir Benelux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
96030
Fin & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96041
Shanks Lux Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
96016
Globalux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
96022
Sislark Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
96002
Harmonis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96046
Sloop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96031
Holding de Financements et d’Investissements S.A.,
Sodipro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
96016
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96002
Sodipro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
96016
hela Bettembourg S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . .
96029
Théâtre National du Luxembourg Productions,
IVG Logistics Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
96027
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96007
Mainoria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
96048
Trade Synergy International S.A., Luxembourg . .
96030
Mariva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
96046
96002
HOLDING DE FINANCEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 37.746.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juillet
2006 que:
- Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société:
Maître Charles Duro, Maître Marianne Goebel et Maître Lydie Lorang, tous trois avocats, résidant à L-1325 Luxem-
bourg, 3, rue de la Chapelle.
- A été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société:
La société FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort
Rheinsheim.
- Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes de la société prendront fin à l’issue de l’Assemblée
Générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06711. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(093227.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 90.496.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04587, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090467.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.
S.S.F.S., STANDARD SOFTWARE AND FIRMWARE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 17.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07215, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090759.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.
SISLARK PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 118764.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on twenty-third day of August.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Paul Decker, no-
tary, residing in Luxembourg-Eich, who shall remain depositary of the present deed
There appeared:
SANDLARK INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company having its registered
office at 73, Cote d’Eich, L-1450 Luxembourg, (RCS-L N
o
111.343)
here represented by Mrs Almira Licina, private employee, residing professionally in L-1450 Luxembourg
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 23rd, 2006.
Which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named party and the undersigned notary and
shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed
a limited liability company and to draw up the Articles of Association of it as follows:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pétange, août 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 août 2006.
Signature.
96003
Title I. - Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and espe-
cially by the law of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time.
Art. 2. The name of the private limited liability company is SISLARK PROPERTY, S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg-City.
It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg according to an agreement of the par-
ticipants.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-
embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio, the direct and indirect acquisition, the lease, rent
or use in any form of real estate property located in Germany or other countries.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.
Title II. - Capital - Parts
Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one
hundred and twenty five (125) parts of one hundred euro (EUR 100.-) each.
Art. 8. Parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos to non participants may only be
made with the prior approval of participants representing at least three quarters (3/4) of the capital.
For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.
Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III. - Management
Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest pow-
ers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except
those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties
and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company
by the manager(s).
They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or
not.
Title IV. - General meeting of participants
Art. 11. Decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of
the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more
than fifty per cent (50%) of the capital.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 12. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of
each year.
Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well
as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the
provisions constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.
Title VI. - Liquidation - Dissolution
Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the
realization of the assets and payment of the liabilities.
96004
Title VII. - Varia
Art. 15. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year shall begin today and end on December 31st, 2006.
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established, the sole shareholder, acting as foresaid, declares to subscribe the whole
capital which is fully paid in.
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is now at the disposal of the company as has been
certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation, are estimated at approximately 1,500.- EUR.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles of Association have thus been drawn up, the sole shareholder acting as foresaid took following
resolutions:
1) The registered office of the company is fixed at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
2) Have been elected as managers (gérants) of the company for an undetermined period:
- M. Patrick Lorenzato, private employee,
- M. Eric Vanderkerken, private employee, and
- M. Camille Paulus, consultant,
residing all three professionally in L-1450 Luxembourg 73, côte d’Eich
3) The company will be bound in any circumstances by the sole signature of each manager.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil sta-
tus and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the German version:
Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten August.
Vor Notar Martine Decker, mit Amtssitz in Hesperange, handelnd in Vertretung ihres verhinderten Amtskollegen
Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
SANDLARK INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (socié-
té à responsabilité limitée), mit Sitz in 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxemburg, (RCS-LN
o
111.343)
hier vertreten durch Fräulein Almira Licina, Privatangestellte, berufsansässig in L-1450 Luxembourg.
auf Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 23. August 2006.
Genannte Vollmachten werden ne varietur von dem Vertreter der Parteien und dem unterzeichneten Notar gezeich-
net und bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.
Die erschiene Partei, vertreten wie vorerwähnt, hat erklärt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu
wollen und deren Satzung wie folgt festzulegen:
Titel I. - Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden Gesetzen
und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen unter-
liegt.
Art. 2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung führt die Bezeichnung SISLARK PROPERTY, S.à r.l.
Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann an einen anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden auf Grund eines Beschlus-
ses der Gesellschafter.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung auf jede Art und Weise an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf,
Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wer-
ten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes, der direkte oder indirekte Erwerb,
die Anmietung und Vermietung, sowie die sonstige Nutzung in jeglicher Form von Grundstücken, Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen, welche sich in Deutschland oder anderen Ländern befinden.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Ge-
sellschaft beteiligen und Schwester- und Tochtergesellschaften alle Unterstützung geben, sei es durch Kredite, Garantien
oder auf andere Art.
Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen aufnehmen.
96005
Generell kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, be-
weglichen und unbeweglichen kommerziellen und industriellen Operationen tätigen, welche sie für notwendig hält zur
Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes.
Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit oder den Verlust der Geschäftsfä-
higkeit eines Gesellschafters aufgelöst.
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in einhun-
dertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (100,- EUR).
Art. 8. Die Anteile sind frei übertragbar unter Gesellschaftern. Eine Abtretung von Anteilen unter Lebenden an
Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals
vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf Artikel 189 und 190 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwie-
sen.
Art. 9. In keinem Fall kann ein Gesellschafter, seine Nachfolger und Vertreter oder Berechtigte und Gläubiger weder
einen Antrag auf Siegelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den nor-
malen Geschäftsgang der Gesellschaft beeinträchtigen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und
die Beschlüsse der Generalversammlungen beziehen.
Titel III. - Verwaltung
Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern (gérants) verwaltet, welche die weitest-
gehenden Befugnisse haben, um alle Handlungen durchzuführen, welche notwendig oder nützlich zur Erreichung des Ge-
sellschaftszwecks sind, ausser den Befugnissen, welche durch das Gesetz ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind. Der (die) Geschäftsführer vertritt (vertreten) die Gesellschaft gegenüber Dritten. Prozesse, welche
die Gesellschaft als Kläger oder als Beklagte betreffen, werden von dem (den) Geschäftsführer(n) im Namen der Ge-
sellschaft geführt.
Sie werden für unbestimmte Zeit von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt.
Besondere und beschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten können an eine oder mehrere Personen,
ob diese Gesellschafter sind oder nicht, übertragen werden.
Titel IV. - Generalversammlung der Gesellschafter
Art. 11. Beschlüsse der Gesellschafter werden in der Generalversammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung
auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig
Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Titel V. - Gesellschaftsjahr, Gewinn, Reserven
Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezember eines jeden
Jahres.
Art. 13. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Entwertungen und der
Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) dieses Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange
obligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt, er muss allerdings wieder bis
zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn dieser, zu welchem Zeitpunkt und aus wel-
chem Grund auch immer, angerührt wurde. Der verbleibende Betrag steht der Generalversammlung der Gesellschafter
zur Verfügung.
Titel VI. - Liquidation, Auflösung
Art. 14. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren aus-
geführt, welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, mit
der in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit. Der (die)
Liquidator(en) verfügt(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräusserung der Aktiva und Auszahlung der Ver-
pflichtungen.
Titel VII. - Verschiedenes
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden ge-
setzlichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnungi>
Nachdem die Satzung der Gesellschaft festgelegt wurde, hat die alleinige Anteilinhaberin, handelnd wie eingangs er-
wähnt, das gesamte Kapital gezeichnet und vollens eingezahlt.
Der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) steht der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung, so wie
dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.
96006
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Honorare oder Lasten aller Art, welche aus Anlass der Gründung von der Gesellschaft getra-
gen werden müssen, werden auf 1.500.- EUR abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gesellschaftsgründung hat die alleinige Anteilinhaberin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.
2) Es wurden zum Geschäftsführern (gérants) der Gesellschaft für unbestimmte Zeit ernannt:
- Herrn Patrick Lorenzato, Privatbeamte;
- Herrn Eric Vanderkerken, Privatbeamte; und
- Herrn Camille Paulus, Consultant;
alle drei berufsänssässig in L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.
3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers vertreten.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der
erschienenen Parteien die gegenwärtige Urkunde auf Englisch verfasst wurde, welcher eine deutsche Fassung folgt. Auf
Anfrage derselben erschienenen Parteien, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, soll die englische Version vorherrschen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Licina, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, vol. 155S, fol. 14, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Notar Martine Decker mit Amtsitz in Hesperange handelnd für ihren verhinderten Kollegen Notar Paul Decker.
(092429.3/206/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2006.
MR & CO PROMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St André.
R. C. Luxembourg B 60.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07508, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2006.
(090948.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.
ALTAWIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 82.528.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Bernard Ewen, demeurant 17, rue Raoul Follereau,
L-8027 Strassen, Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, Monsieur Arno Schleich, demeurant 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, et Monsieur Adrie Beere-
poot, demeurant 62, Kerkbuurt, NL-1608 En Wijdenes, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE
GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06593. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091869.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Luxemburg-Eich, den 29. August 2006.
M. Decker.
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
96007
RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.168.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04385, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090999.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
AN.SO.FI. HOLDING S.A. (AMBOISE SOCIETE FINANCIERE), Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 100.994.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02719, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091080.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
THEATRE NATIONAL DU LUXEMBOURG PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 194, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 70.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, réf. LSO-BT08220, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091174.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
AMBISOLL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.171.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07955, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091684.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
ORION INCOME FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 118.882.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of August.
Before Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replace-
ment of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depos-
itary of the original of the present deed.
There appeared the following:
ORION INCOME RETURN PARTNERS C.V., a limited partnership incorporated under Dutch law, having its regis-
tered office at 1, Locatellikade, NL-1076 A2, Amsterdam, represented by its general partner, ORION INCOME PART-
NER B.V., a private limited liability company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at 1,
Locatellikade, NL-1076 A2, Amsterdam and registered with the Amsterdam Trade Register under B.V. 1383345,
represented by M
e
Laurent Schummer, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on Monday, 21 August 2006.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Signature.
Signatures
<i>Administrateursi>
Signature.
Luxembourg, le 22 août 2006.
Signature.
96008
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a
limited liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société à responsabilité limitée which will
be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.
The Company will exist under the name of ORION INCOME FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meet-
ing of shareholders.
In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would inter-
fere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such
office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the
complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of
the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Com-
pany. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons
entrusted with the daily management of the Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Lux-
embourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well
as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are
members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-
formity with the provisions of the law.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Corporate capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for
the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attomey-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The
shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one
or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.
Chapter III. Board of managers
Art. 8. Management. The Company is managed by a board of at least three managers, shareholders or not, ap-
pointed by decision of the shareholders for a maximum period of six (6) years.
96009
Retiring managers are eligible for re-election. Managers may be removed with or without cause at any time by the
shareholders at a simple majority.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary of the Company and such other officers as it shall see fit.
None of these appointees need be members of the board of managers.
Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or
two members of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice convening it.
The board of managers may only proceed to business if a majority of its members are present or represented.
One or more managers may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
Managers unable to be present or deemed present at a meeting may delegate by letter or by fax another member of
the board to represent them and to vote in their name. Managers unable to be present may also cast their votes by
letter, by fax or by telegram.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Where the number of votes cast for and against a resolution are equal, the chairman has a casting vote.
A manager having an interest contrary to that of the Company, in a matter submitted for the approval of the board,
shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.
At the next general meeting of the shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall
be informed of the cases in which a manager has an interest contrary to that of the Company. In the event of a member
of the board of managers having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority of the other
members of the board present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.
In case of urgency, resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by a majority of the managers.
Copies or extracts are signed by the chairman or any two members of the board of managers.
Art. 10. Powers of the board of managers. The board of managers is vested with the broadest powers to per-
form all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or
by the present articles to the general meeting fall within the competence of the board of managers.
The board of managers may with the prior approval of the general meeting of shareholders entrust the day-to-day
management of the Company’s business to one of its members appointed managing manager.
The board may further delegate specific powers to managers or other officers.
It may appoint agents with definite powers, and revoke such appointments at any time.
Without prejudice to the foregoing powers, all acts binding the Company and all powers and mandates must be signed
by any two managers or by any person(s) to whom signatory authority has been delegated by the board of managers.
Any litigation, whether as plaintiff or as defendant, shall be conducted by the board of managers in the Company’s
name. All writs or judicial acts are validly issued in the name of the Company alone.
Art. 11. Indemnity of managers. The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the
request of the Company, of any other Company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is
not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit
or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be pro-
vided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Chapter IV. Shareholders resolutions
Art. 12. Powers of the shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company repre-
sents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law. Decisions by the shareholders may
be adopted by written resolutions signed by all the shareholders.
Art. 13. General meetings, Adoption of resolutions. General meetings are convened by the board of managers
at such place and with such agenda as determined by the board of managers. General meetings may be held abroad if,
in the judgement of the board of managers, which is final, circumstances of force majeure so require. The shareholders
may as well adopt resolutions in writing.
Art. 14. Procedure, Vote. A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or
by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder. Except as otherwise
required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by
anyone manager of the Company.
96010
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 15. Financial year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December in every year.
The board of managers shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and
accounting practice.
Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.
It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of managers may pay out an advance payment on dividends. The
board of managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 17. Dissolution. Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting
with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided
by law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII. Applicable law
Art. 18. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-
ance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-
olutions:
1. The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the
following as managers for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31
December 2006:
- Mr Bruce Charles Bossom, real estate investment manager, born on 22 August 1952 in London, residing at 34,
Princedale Road, London W11 4NJ, United Kingdom;
- Mr Aref Hisham Lahham, real estate investment manager, born on 15 February 1965 in Chicago, Illinois, United
States of America, residing at 5, Graces Mews, Abbey Road, London NW8 9AZ, United Kingdom;
- Mr Van James Stults, real estate investment manager, born on 30 September 1954 in Chicago, Illinois, United States
of America, residing at 200 South Wacker Drive, Suite 3100, Chicago, 60606 Illinois, USA.
2. The registered office shall be at: 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Shareholder
Subscribed capital
(EUR)
Number of shares
Amount paid-in (EUR)
ORION INCOME RETURN PARTNERS C.V.,
prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
12,500.-
96011
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-cinquième jour du mois d’août.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant
en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel
dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
ORION INCOME RETURN PARTNERS C.V., une société en commandite régie par le droit néerlandais, ayant son
siège social au 1, Locatellikade, NL-1076 A2, Amsterdam, représentée par son associé commandité ORION INCOME
PARTNER B.V., une société à responsabilité limitée régie par le droit néerlandais, ayant son siège social au 1, Locatelli-
kade, NL-1076 A2, Amsterdam et inscrite au registre du commerce de Amsterdam sous le numéro B.V. 1383345,
représentée par M
e
Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le lundi 21 août 2006.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins
de formalisation.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il va constituer par les présentes:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société à responsabilité
limitée (S.à r.l.) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination ORION INCOME FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des
associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront faites et portées à
la connaissance des personnes intéressées par l’une des personnes ou l’un des organes exécutifs de la Société ayant
qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit
et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la
gestion et la mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des entreprises dans
lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe.
La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts
et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de va-
leurs mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quel-
conques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte
quelle qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie
de prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assis-
tance sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de
manière privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement
quelconques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions
prévues par la loi.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-),
divisé en cinq cents (500) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société
et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
96012
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou ré-
duit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associées adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Chapitre III. Conseil de gérance
Art. 8. Gestion. La Société est administrée par un conseil de gérance composé d’au moins trois gérants, associés
ou non, nommés par l’assemblée générale des associés pour un terme de six (6) ans au plus.
Les gérants sortants sont rééligibles. Les gérants sont révocables à tout moment avec ou sans cause, par décision des
associés prise à la majorité simple.
Le conseil de gérance élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, les réunions du con-
seil sont présidées par un gérant présent.
Le conseil de gérance pourra désigner un secrétaire de la Société et tels autres agents qu’il jugera convenir.
Aucun de ceux-ci n’a besoin d’appartenir au conseil de gérance.
Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président du con-
seil ou de deux de ses membres.
Les conseils se tiennent au lieu, à la date et à l’heure indiqués dans la convocation.
Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement sur l’ordre du jour que si la majorité de ses membres sont pré-
sents ou représentés.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de
communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.
Tout gérant empêché peut par lettre écrite ou par facsimilé donner pouvoir à un autre membre du conseil pour le
représenter et pour voter en ses lieu et place. Les gérants empêchés peuvent également émettre leur vote par lettre,
par facsimilé ou par télégramme.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Un gérant ayant des intérêts opposés à ceux de la Société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil, sera
obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne
peut pas prendre part aux opérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des associés, avant de procéder au vote de toute autre question, les action-
naires seront informés des matières où un gérant a un intérêt contraire à celui de la Société. Au cas où un membre du
conseil de gérance a dû s’abstenir pour conflit d’intérêts, les résolutions prises à la majorité des autres membres du
conseil présents ou représentés a la réunion et qui votent seront tenues pour valables.
En cas d’urgence, les résolutions signées de tous les gérants seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été
prises lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs exemplaires d’une résolution identique.
Les décisions du conseil de gérance seront constatées dans des procès-verbaux qui seront signés par une majorité
de gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil de gérance ou par deux
gérants.
Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour
accomplir tous actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés, seront de la compétence
du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, de l’assentiment préalable de l’assemblée générale des associés, déléguer la gestion jour-
nalière de la Société à un de ses membres qui portera le titre de gérant-délégué.
Il peut aussi déléguer des pouvoirs spécifiques à des gérants et fondés de pouvoirs.
Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis, et les révoquer en tout temps.
Sans préjudice des pouvoirs de délégation susmentionnés, tous les actes qui engagent la Société, tous les pouvoirs et
toutes les procurations doivent, être signés par deux gérants, ou par la/les personne(s) à qui des pouvoirs de signature
auront été délégués par le conseil de gérance.
Tout procès, tant en demandant qu’en défendant, sera suivi par le conseil de gérance au nom de la Société. Tous les
exploits ou autres actes judiciaires seront valablement faits au nom de la Société seule.
Art. 11. Indemnisation des gérants. La Société s’engage à indemniser tout gérant ou fondé de pouvoir et leurs
successeurs, exécuteurs testamentaires et administrateurs, de tout et contre toutes dépenses raisonnablement expo-
sées par lui en rapport avec toutes demandes en justice, procès ou procédure à laquelle il devient partie pour être ou
avoir été gérant ou fondé de pouvoir de la Société ou, à la demande de la Société, de toute autre société de laquelle la
Société est un actionnaire ou un créancier et par laquelle if n’est pas en droit d’être indemnisé; le tout sauf pour ce qui
96013
est des demandes en justice, procès ou procédure dans lesquelles il sera jugé responsable pour négligence ou fraude.
Dans le cas d’une transaction, l’indemnité sera accordée uniquement en rapport avec des affaires couvertes par la tran-
saction dans lesquelles la Société est avisée par son conseiller juridique que la personne indemnisée n’a commis aucune
violation de ses obligations. Le présent droit à indemnités n’exclut pas l’exercice d’autres droits auxquels il peut préten-
dre.
Chapitre IV. Assemble générale des associés
Art. 12. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés. Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. Les décisions de l’assemblée gé-
nérale peuvent être prises par voie de résolutions écrites, signées de tous les associés.
Art. 13. Assemblée générale annuelle/Adoption de résolutions. Les assemblées générales sont convoquées
par le conseil de gérance en tel lieu et avec tel ordre du jour qui sera déterminé par le conseil de gérance. Les assemblées
générales peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront
appréciées souverainement par les gérants. Les associés peuvent également prendre des résolutions par écrit.
Art. 14. Procédure, Vote. Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur,
par câble, par télégramme ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être associé. Sauf disposition contraire de la
loi, les décisions sont prises à la majorité des votes émis, sans considération de la proportion de capital représenté. Les
copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant de la
Société.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Le conseil de gérance prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques
comptables.
Art. 16. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième (10%) du capital social.
L’assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.
Le conseil de gérance peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.
Le conseil de gérance détermine le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 17. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant
aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions
contraires de la loi. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs li-
quidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 18. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
espèces les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ mille cinq cents euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et décide en outre de nommer la personne sui-
vante comme Gérant pour une période prenant fin à la date d’approbation des comptes annuels pour l’année sociale se
terminant le 31 décembre 2006:
Associé
Capital souscrit (EUR)Nombre de parts so-
ciales
Libération
(EUR)
ORION INCOME RETURN PARTNERS C.V., pré-
qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
12.500,-
96014
- Monsieur Bruce Charles Bossom, gestionnaire d’investissement en biens immobilier, né le 22 août 1952 à Londres,
Grande-Bretagne, résidant au 34, Princedale Road, Londres W11 4NJ (Grande-Bretagne);
- Monsieur Aref Hisham Lahham, gestionnaire d’investissement en biens immobilier, né le 15 février 1965 à Chicago,
Illinois, Etats-Unis d’Amérique, résidant au 5, Graces Mews, Abbey Road, Londres NW8 9AZ (Grande-Bretagne);
- Monsieur Van James Stults, gestionnaire d’investissement en biens immobilier, né le 30 septembre 1954 à Chicago,
Illinois, Etats-Unis d’Amérique, résidant au 200 South Wacker Drive, Suite 3100, Chicago, 60606 Illinois, Etats-Unis
d’Amérique.
2. Le siège social est fixé au: 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Schummer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 août 2006, vol. 907, fol. 1, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094995.3/239/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.
O.I. TE, O.I. TX ET COLONNES INVESTMENT, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.827.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01123, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2006.
(091528.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
O.I. TE, O.I. TX ET COLONNES INVESTMENT, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.827.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01114, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2006.
(091530.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
PIMIENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 84.783.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle 18A, boule-
vard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle 18A, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, Monsieur Yvon Python, demeurant 57, rue de Lausanne, CH-1202 Genève et Maître Alexandre Davidoff, demeu-
rant 8, Chemin de Surville, CH-1213 Petit-Lancy, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à
r.l., ayant son siège social 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06600. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091893.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Belvaux, le 5 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
<i>Pour la société
i>Signature
96015
O.I. TX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.485.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01126, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2006.
(091533.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
O.I. TX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.485.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01124, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2006.
(091531.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
O.I. TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.484.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01133, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2006.
(091534.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
O.I. TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.484.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01131, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2006.
(091536.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06838, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091742.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 24 août 2006.
Signature.
96016
SODIPRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du dix septembre.
R. C. Luxembourg B 106.042.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11306, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091822.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SODIPRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du dix septembre.
R. C. Luxembourg B 106.042.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, réf. LSO-BT08447, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091825.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SHANKS LUX FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.750.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07841, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091758.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
PRINCESS WILRU, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1313 Luxembourg, 2A, rue de Capucins.
R. C. Luxembourg B 118.903.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on twenty-fourth day of August.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Paul Decker, no-
tary, residing in Luxembourg-Eich, who shall remain depositary of the present deed.
There appeared:
1. Mr William Schapira, student and his wife;
2. Mrs Rachel Schapira, housewife, residing together in 2 Danescroft Gardens, London NW4 2nd, United Kingdom;
here represented by Mrs Silke Dahlem, employee, residing professionally in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
by virtue of two proxies given in Jerusalem, on July 25, 2006.
Said proxies, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
familiy company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-
islation.
The name of the company is PRINCESS WILRU.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-
bers.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in
real estate, and those concerning the placement and management of money.
The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 18 août 2006.
Signature.
96017
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the
applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 5. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by one hun-
dred (100) shares of a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely
paid up.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at anytime as laid down in article 199 of the law concerning Com-
mercial Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-
bers is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least seventy-
five percent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members
is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer
to a non-member.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are ap-
pointed by the general meeting of members.
Towards third parties the managers have under their sole signature the most extensive powers to act on behalf of
the company in all circumstances.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the
capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three-quarters of the capital.
Art. 15. The Company’s financial year runs from the first of July to the thirtieth of June of the next year.
Art. 16. Every year on June 30th, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-
tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to
be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-
islation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on June 30th, 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The 100 shares are subscribed as follows:
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly
bears witness to it.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
Mr William Schapira, prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Mrs Rachel Schapira, prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
96018
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the general extraordinary meetingi>
The general extraordinary meeting of the shareholders, represented as above-mentioned, representing the whole of
the corporate capital, passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Are appointed managers, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
- Mr William Schapira, prenamed; and
- Mrs Rachel Schapira, prenamed.
The managers are elected for an undetermined period.
<i>Second resolutioni>
The company’s registered office is located at L-1313 Luxembourg, 2A, rue de Capucins.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Eich in the office of notary Paul Decker, on the day
indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the
notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us,
Notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same person appear-
ing and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den vierundzwanzigsten August.
Vor Notar Martine Decker, mit Amtssitz in Hesperange, handelnd in Vertretung ihres verhinderten Amtskollegen
Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1. Herr William Schapira, Student, und seine Ehegattin;
2. Dame Rachel Schapira, Hausfrau, beisammen wohnhaft in 2 Danescroft Gardens, London NW4 2nd, England,
hier vertreten durch Frau Silke Dahlem, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, auf
Grund von zwei Vollmachten gegeben in Jerusalem, am 25. Juli 2006.
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unter-
zeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorge-
legt.
Welche Komparentin, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden
Familiengesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung führt die Bezeichnung PRINCESS WILRU.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung
von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien be-
treffen, mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von
Geld und die Vermögensverwaltung betreffen.
Zweck der Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen,
kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Grün-
dung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaf-
ten, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es
permanent oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft
nach den Bestimmungen betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.
Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften
mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden
oder nützlich sind.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-
dert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle voll gezeichnet und in-
tegral eingezahlt.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
96019
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von
der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift von jeweils einem Geschäftsführer.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des nächsten Jahres.
Art. 16. Am 30. Juni eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. Juni 2007.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die 100 Anteile werden gezeichnet wie folgt:
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünf-
hundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der
dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise 1.500,- EUR.
<i>Beschlüsse der Ausserordentlichen Generalversammlungi>
Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter, vertreten wie eingangs vorerwähnt, welche das ge-
samte Gesellschaftskapital darstellen, haben sofort folgende Beschlüsse gefasst:
Herr William Schapira, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Dame Rachel Schapira, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
96020
<i>Erster Beschlussi>
Zu Geschäftsführern werden ernannt:
- Herr William Schapira, vorbenannt;
- Dame Rachel Schapira, vorbenannt;
mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Dauer ernannt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1313 Luxemburg, 2A, rue des Capucins.
Der amtierende Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit dass auf Wunsch der Komparentin
vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung, und dass im Falle von Unter-
schieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Eich in der Amtstube von Notar Paul Decker, am
Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, hat dieselbe mit dem Notar vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Dahlem, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, vol. 155S, fol. 14, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Notar Martine Decker mit Amtsitz in Hesperange handelnd für ihren verhinderten Kollegen Notar Paul Decker.
(095099.3/206/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.
SEB FUND 5, Fonds Commun de Placement.
—
Art. 1. The Fund.
1. The Fund SEB FUND 5 (hereafter «the Fund») is an undertaking for collective investment in transferable securities
(«UCITS»), set up as a mutual investment fund («fonds commun de placement»). The Fund’s assets composed of trans-
ferable securities and other eligible assets are managed by the Management Company.
2. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. has been appointed as Custodian Bank which is entrusted with the
custody of the Fund’s assets.
3. The Fund is set up for an undetermined period.
4. SEB ASSET MANAGEMENT S.A. has established segregated opposable accounts each constituting a Sub-Fund with-
in the meaning of article 133 of the Luxembourg law of December 20, 2002 (hereafter «Law»). The assets of each Sub-
Fund constitute the joint and undivided property of the unitholders of that Sub-Fund. In the portion of assets relating
to a Sub-Fund, each unitholder has an undivided right in proportion to the units he owns in that Sub-Fund.
5. Pursuant to article 133 (5) of the Law, the rights of the unitholders and creditors regarding a Sub-Fund or raised
by the incorporation, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of this Sub-Fund. The assets of a
Sub-Fund will be answerable exclusively for the rights of the unitholders relating to this Sub-Fund and for those of the
creditors whose claim arose in relation to the incorporation, operation or liquidation of this Sub-Fund.
6. The calculation of the net asset value is done separately for each Sub-Fund all in accordance with the rules set out
in article 9 of the Management Regulations (General Section).
7. The investment restrictions laid down in the General Section of the Management Regulations are applicable to each
Sub-Fund separately, unless otherwise provided for therein and/or in the Sales Prospectuses.
8. The Management Company may create at any time new Sub-Funds or unit classes. In accordance with the legal
requirements, existing Sub-Funds may be liquidated at any time.
In such case, the Sales Prospectuses will be updated.
Art. 2. Investment policy. The Fund’s portfolio will mainly include but not be limited to fixed interest securities
admitted to official listing on stock exchanges or dealt in on regulated markets or on other markets that are regulated,
operate regularly and are recognized and open to the public and money market instruments.
Furthermore, the Fund’s assets may be invested in all other eligible assets within the scope of legal possibilities laid
down by Law. A detailed description of the Fund’s investment policy is set out in the Sales Prospectuses.
The investment policy of each Sub-Fund is determined by the Management Company. A detailed description of the
investment policy of each Sub-Fund is set out in the Sales Prospectuses.
Art. 3. Units.
1. Units are issued either in registered form and recorded in a nominal account, or as bearer units. Bearer units will
be vested in as global certificate, which will be deposited with the custodian, with no claim of issue of physical securities.
Beneficial interests in the global certificate will be evidenced by, and transfers thereof will be effected only through
records maintained by participants in a first class clearing system.
The Management Company may provide for the issuance of fractional units. Fractional units may be issued up to three
decimal places.
Luxemburg-Eich, den 29. August 2006.
M. Decker.
96021
In connection with the purchase of units in registered form in a Sub-Fund, a unitholder account is opened in the in-
vestor’s name in the books of that Sub-Fund. This account is credited in respect of units held by the investor. Whenever
a transaction is registered in the account of a unitholder, the latter will receive a statement of his account.
2. In accordance with article 5 of the Management Regulations (General Section), units of several classes may be is-
sued. If applicable, this will be mentioned in the Prospectuses for the respective Sub-Funds.
For a Sub-Fund which has issued only one class of units, the net asset value of a unit is determined by dividing the net
assets of the relevant Sub-Fund by the total number of units in that Sub-Fund outstanding at that time. For a Sub-Fund
which has issued more than one class of units, the net asset value of one unit for each class of units will be determined
by dividing the net assets of the Sub-Fund attributed to this class of units by the total number of units of that same class
outstanding at that time.
Art. 4. Currency of the Fund, Valuation Day, Issue, Redemption and Conversion of units.
1. The Fund’s currency is the United States Dollar (USD).
2. The net asset value calculation as well as the calculation and the publication of the issue and redemption prices are
done in the currency, in which the respective Sub-Fund is denominated. This will be laid down in the Sales Prospectuses.
The net asset value may be expressed in other currencies than the base currency by using the same exchange rates than
those used for the net asset value calculation of that same Valuation Day.
The net asset value of a unit is determined by dividing the net assets of the relevant Sub-Fund by the total number of
units in the same Sub-Fund outstanding at that time.
3. The annual and semi-annual financial reports of the Fund include a consolidation of all Sub-Funds. These consoli-
dated figures are expressed in USD. For this purpose, all figures expressed in another currency than the USD will be
converted into USD by using the same exchange rates than those used for the net asset value calculation of that same
Valuation Day.
4. The net asset value calculation is done each day which is a Bank Business Day both in Luxembourg and in Sweden;
this day is called the Valuation Day.
5. Units are issued each Valuation Day.
Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses the following is applicable:
For a subscription order to be executed on a Valuation Day, written instructions must reach the Administrative
Agent and the corresponding money, in an immediately available form, must reach the subscription account before 15.30
hrs (Central European time) on a Valuation Day; otherwise, the order will be executed on the next following Valuation
Day.
6. The issue price of units in a Sub-Fund includes the net asset value of a unit in that Sub- Fund calculated in accordance
with article 9 of the Management Regulations (General Section), which may be increased by an issue commission, as laid
down in the Fund’s Prospectuses.
Fractions of units may be issued. If applicable, this will be mentioned in the Fund’s Prospectuses.
The Management Company may determine a minimum initial subscription amount, which will be laid down in the
Fund’s Prospectuses.
7. Owners of units may apply at any time for redemption of their units, which will be effected at the net asset value
ruling at that time, eventually decreased by a redemption fee, as laid down in the Fund’s Prospectuses.
Payment will be made in the currency of the relevant Sub-Fund or any other currency laid down in the Sales Prospec-
tus, within ten bank business days following the corresponding Valuation Day.
8. Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses the following is applicable:
In case a redemption order is to be executed at the redemption price ruling on a Valuation Day, the application for
redemption of units must reach the Administrative Agent before 15.30 hrs (Central European time) on the correspond-
ing Valuation Day; otherwise the order will be executed on the next following Valuation Day for execution at the re-
demption price then ruling.
9. Unless otherwise provided in the Sales prospectuses owners of units may convert all or part of the units they own
in a Sub-Fund into units in another Sub-Fund, or units of one class into units of another class. The conversion is executed
on the basis of the net asset value per unit in the relevant Sub-Funds and classes, applicable on the same date, which
may be increased by a conversion fee, as laid down in the Fund’s Prospectuses.
Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses the following is applicable:
To apply for conversion, the unitholder must send an irrevocable request in writing to the Management Company. If
received before 15.30 hrs (Central European time) on a Valuation Day, requests for conversion are executed on the
basis of the net asset value per unit of the relevant Sub-Funds and the relevant class, ruling on that same Valuation Day.
Requests for conversion received after that deadline will be held over to the next Valuation Day to be executed at the
prices ruling on that day.
Art. 5. Dividend policy. The Management Company will decide from time to time if and to what extent dividends
should be paid to unitholders of a respective Sub-Fund, respectively of the respective class of such a Sub-Fund.
Art. 6. Costs.
1. The respective Sub-Fund shall pay an all-in fee of maximum of 1.10% to the Management Company.
This fee is based on the average net assets of each Sub-Fund calculated daily during the relevant month. This fee shall
in particular serve as compensation for the administrator and the Fund manager, as well as for the distribution of the
Sub-Fund’s units and the services of the Custodian Bank. The fee shall generally be withdrawn from the Sub-Fund at the
end of each month.
2. Furthermore, the Management Company may be entitled to a performance fee. If applicable, the method of calcu-
lation and the respective amount are laid down in the Sales Prospectuses.
3. All taxes and duties owed on the Sub-Funds’ assets and income will be borne by the Sub-Fund.
96022
4. Bank and brokerage fees for transactions in securities making up the Fund’s portfolio as well as fees on transfers
referring to redemption of units will be borne by the Fund.
Art. 7. Financial year. The accounts of the Fund are closed on December 31 of each year.
Art. 8. Term and liquidation of the Sub-Funds.
1. The Management Company may at any time decide upon the liquidation of one or more Sub-Funds, particularly in
situations of a notable modification of the economic and/or political prevailing circumstances, or if the net assets of a
Sub-Fund fall under a certain level to be determined by the Management Company which will not allow an efficient and
rational management or in any other cases which will be in the unitholders’ interest.
In case the net assets of a Sub-Fund drop down to zero due to redemptions, the Management Company may decide
that this Sub-Fund is closed.
The decisions of the Management Company to liquidate a Sub-Fund must be announced by a notice published in a
Luxembourg newspaper and in newspapers of such countries, where the units are publicly sold. The registered unithold-
ers will be informed by registered mail.
2. No application for subscription or conversion of units will be accepted after the date of the event leading to the
dissolution and the decision to liquidate the Sub-Funds. If the equal treatment between unitholders is ensured, redemp-
tion requests may be treated.
Following the Management Company’s instruction, the Custodian Bank will liquidate each Sub-Fund’s assets in the
best interests of the unitholders and will apportion the proceeds of the liquidation, after deduction of liquidation costs,
amongst the unitholders of the relevant Sub-Fund according to the respective prorata.
Any amounts unclaimed by the unitholders at the closing of the liquidation of a Sub-Fund will be deposited during six
(6) months with the Custodian Bank and thereafter, if required by law, converted into euro and deposited by the Cus-
todian Bank with the Caisse des Consignations in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited
remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they shall be forfeited.
3. Liquidation and distribution of a Sub-Fund cannot be requested by an owner of units, his heirs or beneficiaries.
Art. 9. Merger of Sub-Funds. In accordance with the terms and conditions set out hereafter, the Management
Company may decide, at any time, to merge one or several Sub-Funds of the Fund with other Sub-Funds of the same
Fund or with another undertaking for collective investment (with or without Sub-Funds). Such a merger can only be
carried out, if the investment policy of the absorbing entity does not breach the investment policy of the entity to be
absorbed.
In case of a merger with another collective investment undertaking or any other Sub-Fund of the Fund, the subscrip-
tion price may be paid by contribution in kind of all assets and liabilities of the absorbed Sub-Fund, valued pursuant to
the rules laid down n article 9 of the Management Regulations (General Section). Units of the respective classes will be
issued at their respective net asset value against contribution in kind valued this way. All expenses related to this con-
tribution in kind will be charged to the contributor.
In such event, notice will be given in writing to registered unitholders and, if the Management Company so decides,
will be published in a Luxembourg newspaper and in newspapers of such countries, where the units are publicly sold.
Each unitholder of the relevant Sub-Fund shall be given the possibility, within a period of at least thirty (30) days, to
request either the redemption or the conversion of his units against units of the absorbing Sub-Fund at no cost for the
unitholder.
Luxemburg, 18th of August 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08112. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(092389.1//151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2006.
GLOBALUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.159.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Bonnevoie, en date du 11 février 2004, acte publié au
Mémorial C n
o
366 du 2 avril 2004. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire, en date du 5 avril
2004, acte publié au Mémorial C n
o
565 du 2 juin 2004 et en date du 9 juin 2004, acte publié au Mémorial C n
o
812
du 7 août 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07941, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091901.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. / SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>The Custodiani> / <i>The Management Company
i>Signatures / Signatures
<i>Pour GLOBALUX INVESTMENTS, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
96023
BASS.COM. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 101.079.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04279, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2006.
(091803.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
C.M.P. CREATIVE MARKETING ET PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bereldange.
R. C. Luxembourg B 20.594.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le14 août 2006, réf. LSO-BT04300, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Béreldange, le 29 août 2006.
(091804.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
PREINVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06555, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2006.
(091807.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SEB FUND 4, Fonds Commun de Placement.
—
Art. 1. The Fund.
1. The Fund SEB FUND 4 (hereafter «the Fund») is an undertaking for collective investment in transferable securities
(«UCITS»), set up as a mutual investment fund («fonds commun de placement»). The Fund’s assets composed of trans-
ferable securities and other eligible assets are managed by the Management Company.
2. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. has been appointed as Custodian Bank which is entrusted with the
custody of the Fund’s assets.
3. The Fund is set up for an undetermined period.
4. SEB ASSET MANAGEMENT S.A. has established segregated opposable accounts each constituting a Sub-Fund with-
in the meaning of article 133 of the Luxembourg law of December 20, 2002 (hereafter «Law»). The assets of each Sub-
Fund constitute the joint and undivided property of the unitholders of that Sub-Fund. In the portion of assets relating
to a Sub-Fund, each unitholder has an undivided right in proportion to the units he owns in that Sub-Fund.
5. Pursuant to article 133 (5) of the Law, the rights of the unitholders and creditors regarding a Sub-Fund or raised
by the incorporation, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of this Sub-Fund. The assets of a
Sub-Fund will be answerable exclusively for the rights of the unitholders relating to this Sub-Fund and for those of the
creditors whose claim arose in relation to the incorporation, operation or liquidation of this Sub-Fund.
6. The calculation of the net asset value is done separately for each Sub-Fund all in accordance with the rules set out
in article 9 of the Management Regulations (General Section).
7. The investment restrictions laid down in the General Section of the Management Regulations are applicable to each
Sub-Fund separately, unless otherwise provided for therein and/or in the Sales Prospectuses.
8. The Management Company may create at any time new Sub-Funds or unit classes. In accordance with the legal
requirements, existing Sub-Funds may be liquidated at any time.
In such case, the Sales Prospectuses will be updated.
Art. 2. Investment policy. The Fund’s portfolio will mainly include but not be limited to bonds and other debt
instruments admitted to official listing on stock exchanges or dealt in on regulated markets or on other markets that
are regulated, operate regularly and are recognised and open to the public and money market instruments.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
96024
Furthermore, the Fund’s assets may be invested in all other eligible assets within the scope of legal possibilities laid
down by Law. A detailed description of the Fund’s investment policy is set out in the Sales Prospectuses. The investment
policy of each Sub-Fund is determined by the Management Company.
A detailed description of the investment policy of each Sub-Fund is set out in the Sales Prospectuses.
Art. 3. Units.
1. Units are issued either in registered form and recorded in a nominal account, or as bearer units. Bearer units will
be vested in as global certificates, which will be deposited with the custodian, with no claim of issue of physical securities.
Beneficial interests in the global certificate will be evidenced by, and transfers thereof will be effected only through
records maintained by participants in a first class clearing system.
The Management Company may provide for the issuance of fractional units. Fractional units may be issued up to three
decimal places.
In connection with the purchase of units in registered form in a Sub-Fund, a unitholder account is opened in the in-
vestor’s name in the books of that Sub-Fund. This account is credited in respect of units held by the investor. Whenever
a transaction is registered in the account of a unitholder, the latter will receive a statement of his account.
2. In accordance with article 5 of the Management Regulations (General Section), units of several classes may be is-
sued. If applicable, this will be mentioned in the Prospectuses for the respective Sub-Funds.
For a Sub-Fund which has issued only one class of units, the net asset value of a unit is determined by dividing the net
assets of the relevant Sub-Fund by the total number of units in that Sub-Fund outstanding at that time. For a Sub-Fund
which has issued two or more classes of units, the net asset value of one unit for each class of units will be determined
by dividing the net assets of the Sub-Fund attributed to this class of units by the total number of units of that same class
outstanding at that time.
Art. 4. Currency of the Fund and the Sub-Funds, Valuation Day, Issue, Redemption and Conversion of
units. The following common rules apply to the Fund and the respective Sub-Funds:
1. The Fund’s currency is the US-Dollar (USD).
2. The net asset value calculation as well as the calculation and the publication of the issue and redemption prices are
done in the currency, in which the respective Sub-Fund is denominated. This will be laid down in the Sales Prospectuses.
The net asset value may be expressed in other currencies than the base currency by using the same exchange rates than
those used for the net asset value calculation of that same Valuation Day.
The net asset value of a unit is determined by dividing the net assets of the relevant Sub-Fund by the total number of
units in the same Sub-Fund outstanding at that time.
3. The annual and semi-annual financial reports of the Fund include a consolidation of all Sub-Funds. These consoli-
dated figures are expressed in USD. For this purpose, all figures expressed in another currency than the USD will be
converted into USD by using the same exchange rates than those used for the net asset value calculation of that same
Valuation Day.
4. The net asset value calculation is done each day which is a Bank Business Day in both Luxembourg and in Sweden;
this day is called the Valuation Day.
5. Units are issued each Valuation Day.
For a subscription order to be executed on a Valuation Day, written instructions must reach the Administrative
Agent and the corresponding funds, in an immediately available form, must reach the subscription account before 15.30
hrs (Central European time) on a Valuation Day; otherwise, the order will be executed on the next following Valuation
Day.
6. The issue price of units in a Sub-Fund includes the net asset value of a unit in that Sub-Fund calculated in accordance
with article 9 of the Management Regulations (General Section), which may be increased by an issue commission, as laid
down in the Fund’s Prospectuses.
Fractions of units may be issued. If applicable, this will be mentioned in the Fund’s Prospectuses.
The Management Company may determine a minimum initial subscription amount, which will be laid down in the
Fund’s Prospectuses.
7. Owners of units may apply at any time for redemption of their units, which will be effected at the net asset value
ruling at that time, eventually decreased by a redemption fee, as laid down in the Fund’s Prospectuses.
Payment will be made in the currency of the relevant Sub-Fund or any other currency laid down in the Sales Prospec-
tus, within ten bank business days following the corresponding Valuation Day.
8. Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses the following is applicable:
In case a redemption order is to be executed at the redemption price ruling on a Valuation Day, the application for
redemption of units must reach the Administrative Agent before 15.30 hrs (Central European time) on the correspond-
ing Valuation Day; otherwise the order will be executed on the next following Valuation Day for execution at the re-
demption price then ruling.
9. Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses owners of units may convert all or part of the units they own
in a Sub-Fund into units in another Sub-Fund, or units of one class into units of another class. The conversion is executed
on the basis of the net asset value per unit in the relevant Sub-Funds and classes, applicable on the same date, which
may be increased by a conversion fee, as laid down in the Fund’s Prospectuses.
Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses the following is applicable:
96025
To apply for conversion, the unitholder must send an irrevocable request in writing to the Management Company. If
received before 15.30 hrs (Central European time) on a Valuation Day, requests for conversion are executed on the
basis of the net asset value per unit of the relevant Sub-Funds and the relevant class, ruling on that same Valuation Day.
Requests for conversion received after that deadline will be held over to the next Valuation Day to be executed at the
prices ruling on that day.
Art. 5. Dividend policy. The Management Company will decide from time to time if and to what extent dividends
should be paid to unitholders of a respective Sub-Fund, respectively of the respective class of such a Sub-Fund.
Art. 6. Costs.
1. The respective Sub-Fund shall pay a fee of maximum 1.10% p.a. to the Management Company. This fee is based on
the average net assets of each Sub-Fund calculated daily during the relevant month. This fee shall in particular serve as
compensation for the administrator and the Fund manager, as well as for the distribution of the Sub-Fund’s units and
the services of the Custodian Bank. The fee shall generally be withdrawn from the Sub-Fund at the end of each month.
2. Furthermore, the Management Company may be entitled to a performance fee. If applicable, the method of calcu-
lation and the respective amount are laid down in the sales prospectuses.
3. All taxes and duties owed on the Sub-Funds’ assets and income will be borne by the Sub-Fund.
4. Bank and brokerage fees for transactions in securities making up the Fund’s portfolio as well as fees on transfers
referring to redemption of units will be borne by the Fund.
Art. 7. Financial year. The accounts of the Fund are closed on December 31 of each year.
Art. 8. Term and liquidation of the Sub-Funds.
1. The Management Company may at any time decide upon the liquidation of one or more Sub-Funds, particularly in
situations of a notable modification of the economic and/or political prevailing circumstances, or if the net assets of a
Sub-Fund fall under a certain level to be determined by the Management Company which will not allow an efficient and
rational management or in any other cases which will be in the unitholders’ interest.
In case the net assets of a Sub-Fund drop down to zero due to redemptions, the Management Company may decide
that this Sub-Fund is closed.
The decisions of the Management Company to liquidate a Sub-Fund must be announced by a notice published in a
Luxembourg newspaper and in newspapers of such countries, where the units are publicly sold. The registered unithold-
ers will be informed by registered mail.
2. No application for subscription or conversion of units will be accepted after the date of the event leading to the
dissolution and the decision to liquidate the Sub-Fund. If the equal treatment between unitholders is ensured, redemp-
tion requests may be treated.
Following the Management Company’s instruction, the Custodian Bank will liquidate each Sub-Fund’s assets in the
best interests of the unitholders and will apportion the proceeds of the liquidation, after deduction of liquidation costs,
amongst the unitholders of the relevant Sub-Fund according to the respective prorata.
Any amounts unclaimed by the unitholders at the closing of the liquidation of a Sub-Fund will be deposited during six
(6) months with the Custodian Bank and thereafter, if required by law, converted into euro and deposited by the Cus-
todian Bank with the Caisse des Consignations in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited
remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they shall be forfeited.
3. Liquidation and distribution of a Sub-Fund cannot be requested by an owner of units, his heirs or beneficiaries.
Art. 9. Merger of Sub-Funds. In accordance with the terms and conditions set out hereafter, the Management
Company may decide, at any time, to merge one or several Sub-Funds of the Fund with other Sub-Funds of the same
Fund or with another undertaking for collective investment (with or without Sub-Funds). Such a merger can only be
carried out, if the investment policy of the absorbing entity does not breach the investment policy of the entity to be
absorbed.
In case of a merger with another collective investment undertaking or any other Sub-Fund of the Fund, the subscrip-
tion price may be paid by contribution in kind of all assets and liabilities of the absorbed Sub-Fund, valued pursuant to
the rules laid down in article 9 of the Management Regulations (General Section). Units of the respective classes will be
issued at their respective net asset value against contribution in kind valued this way. All expenses related to this con-
tribution in kind will be charged to the contributor.
In such event, notice will be given in writing to registered unitholders and, if the Management Company so decides,
will be published in a Luxembourg newspaper and in newspapers of such countries, where the units are publicly sold.
Each unitholder of the relevant Sub-Fund shall be given the possibility, within a period of at least thirty (30) days, to
request either the redemption or the conversion of his units against units of the absorbing Sub-Fund at no cost for the
unitholder.
Luxembourg, 18th of August 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08115. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092385.2//150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2006.
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. / SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>The Custodiani> /<i>The Management Company
i>Signatures / Signatures
96026
EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 103.207.
—
Le bilan consolidé et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf.
LSO-BT05160, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2006.
(091813.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
CHARTERHOUSELUXCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 82.621.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08130, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2006.
(091846.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
BERLYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.428.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06843, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091873.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
EURO 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.641.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 13 juillet 2006
que:
1. Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés pour une nouvelle période de six ans:
- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Stéphane Hadet, né le 25 mai 1968 à Nancy, résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-
2163 Luxembourg;
- Madame Marianne Korving, née le 4 septembre 1967 à Utrecht, résidant professionnellement au 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. Le mandat du commissaire aux comptes suivant a été renouvelé pour une nouvelle période de six ans:
- La société CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., anciennement CORPORATE FINANCE BUSINESS S.A., ayant
son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 7 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03621. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092005.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
<i>EUROCEANICA SHIPPING HOLDING BV/S.à r.l.
i>P. van Denzen
<i>Géranti>
MERCURIA SERVICES
Signature
Le Conseil de gérance
Signatures
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
96027
BERLYS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06841, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091874.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
IVG LOGISTICS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 105.222.
Constituée par-devant M
e
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 24 décembre 2004, acte publié
au Mémorial C n
o
352 du 19 avril 2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07950, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091903.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SEB FUND 3, Fonds Commun de Placement.
—
Art. 1. The Fund.
1. The Fund SEB FUND 3 (hereafter «the Fund») is an undertaking for collective investment in transferable securities
(«UCITS»), set up as a mutual investment fund («fonds commun de placement»). The Fund’s assets composed of trans-
ferable securities and other eligible assets are managed by the Management Company.
2. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. has been appointed as Custodian Bank, which is entrusted with the
custody of the Fund’s assets.
3. The Fund is set up for an undetermined period.
4. SEB ASSET MANAGEMENT S.A. has established segregated opposable accounts each constituting a Sub-Fund with-
in the meaning of article 133 of the Luxembourg law of December 20, 2002 (hereafter «Law»). The assets of each Sub-
Fund constitute the joint and undivided property of the unitholders of that Sub-Fund. In the portion of assets relating
to a Sub-Fund, each unitholder has an undivided right in proportion to the units he owns in that Sub-Fund.
5. Pursuant to article 133 (5) of the Law, the rights of the unitholders and creditors regarding a Sub-Fund or raised
by the incorporation, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of this Sub-Fund. The assets of a
Sub-Fund will be answerable exclusively for the rights of the unitholders relating to this Sub-Fund and for those of the
creditors whose claim arose in relation to the incorporation, operation or liquidation of this Sub-Fund.
6. The calculation of the net asset value is done separately for each Sub-Fund all in accordance with the rules set out
in article 9 of the Management Regulations (General Section).
7. The investment restrictions laid down in the Management Regulations are applicable to each Sub-Fund separately,
unless otherwise provided for in the Sales Prospectuses.
8. The Management Company may create at any time new Sub-Funds or unit classes. In accordance with the legal
requirements, existing Sub-Funds may be liquidated at any time.
In such case, the Sales Prospectuses will be updated.
Art. 2. Investment policy. The Fund’s portfolio will mainly include but not be limited to equities and equity related
transferable securities and/or fixed interest securities admitted to official listing on stock exchanges or dealt in on reg-
ulated markets or on other markets that are regulated operate regularly and are recognised and open to the public.
Furthermore, the Fund’s assets may be invested in all other eligible assets within the scope of legal possibilities laid
down by Law. A detailed description of the Fund’s investment policy is set out in the sales prospectuses.
The investment policy of each Sub-Fund is determined by the Management Company.
A detailed description of the investment policy of each Sub-Fund is set out in the sales prospectuses.
Art. 3. Units.
1. Units are issued either in registered form and recorded in a nominal account, or as bearer units. Bearer units will
be vested in as global certificate, which will be deposited with the custodian, with no claim of issue of physical securities.
Beneficial interests in the global certificate will be evidenced by, and transfers thereof will be effected only through
records maintained by participants in a first class clearing system.
The Management Company may provide for the issuance of fractional units. Fractional units may be issued up to three
decimal places.
Le Conseil de gérance
Signatures
<i>Pour IVG LOGISTICS HOLDING S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
96028
In connection with the purchase of units in registered form in a Sub-Fund, a unitholder account is opened in the in-
vestor’s name in the books of that Sub-Fund. This account is credited in respect of units held by the investor. Whenever
a transaction is registered in the account of a unitholder, the latter will receive a statement of his account.
2. In accordance with article 5 of the Management Regulations (General Section), units of several classes may be is-
sued. If applicable, this will be mentioned in the Prospectuses for the respective Sub-Funds.
For a Sub-Fund which has issued only one class of units, the net asset value of a unit is determined by dividing the net
assets of the relevant Sub-Fund by the total number of units in that Sub-Fund outstanding at that time. For a Sub-Fund
which has issued two or more classes of units, the net asset value of one unit for each class of units will be determined
by dividing the net assets of the Sub-Fund attributed to this class of units by the total number of units of that same class
outstanding at that time.
Art. 4. Currency of the Fund, Valuation Day, Issue, Redemption and Conversion of units.
1. The Fund’s currency is the United States Dollar (USD).
2. The net asset value calculation as well as the calculation and the publication of the issue and redemption prices are
done in the currency, in which the respective Sub-Fund is denominated. This will be laid down in the Sales Prospectuses.
The net asset value may be expressed in other currencies than the base currency by using the same exchange rates than
those used for the net asset value calculation of that same Valuation Day.
The net asset value of a unit is determined by dividing the net assets of the relevant Sub-Fund by the total number of
units in the same Sub-Fund outstanding at that time.
3. The annual and semi-annual financial reports of the Fund include a consolidation of all Sub-Funds. These consoli-
dated figures are expressed in USD. For this purpose, all figures expressed in another currency than the USD will be
converted into USD by using the same exchange rates than those used for the net asset value calculation of that same
Valuation Day.
4. The net asset value calculation is done each day which is a Bank Business Day in both Luxembourg and in Sweden;
this day is called the Valuation Day.
5. Units are issued each Valuation Day.
Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses the following is applicable:
For a subscription orders to be executed on a Valuation Day, written instructions must reach the Administrative
Agent and the corresponding funds, in an immediately available form, must reach the subscription account before 15.30
hrs (Central European time) on a Valuation Day; otherwise, the order will be executed on the next following Valuation
Day.
6. The issue price of units in a Sub-Fund includes the net asset value of a unit in that Sub- Fund calculated in accordance
with article 9 of the Management Regulations (General Section), which may be increased by an issue commission, as laid
down in the Fund’s Prospectuses.
Fractions of units may be issued. If applicable, this will be mentioned in the Fund’s Prospectuses.
The Management Company may determine a minimum initial subscription amount, which will be laid down in the
Fund’s Prospectuses.
7. Owners of units may apply at any time for redemption of their units, which will be effected at the net asset value
ruling at that time, eventually decreased by a redemption fee, as laid down in the Fund’s Prospectuses.
Payment will be made in the currency of the relevant Sub-Fund or any other currency laid down in the Sales Prospec-
tus, within ten bank business days following the corresponding Valuation Day.
8. Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses the following is applicable:
In case a redemption order is to be executed at the redemption price ruling on a Valuation Day, the application for
redemption of units must reach the Administrative Agent before 15.30 hrs (Central European time) on the correspond-
ing Valuation Day; otherwise the order will be executed on the next following Valuation Day for execution at the re-
demption price then ruling.
9. Unless otherwise provided in the sales prospectuses owners of units may convert all or part of the units they own
in a Sub-Fund into units in another Sub-Fund, or units of one class into units of another class. The conversion is executed
on the basis of the net asset value per unit in the relevant Sub-Funds and classes, applicable on the same date, which
may be increased by a conversion fee, as laid down in the Fund’s Prospectuses.
Unless otherwise provided in the Sales Prospectuses the following is applicable:
To apply for conversion, the unitholder must send an irrevocable request in writing to the Management Company. If
received before 15.30 hrs (Central European time) on a Valuation Day, requests for conversion are executed on the
basis of the net asset value per unit of the relevant Sub-Funds and the relevant class, ruling on that same Valuation Day.
Requests for conversion received after that deadline will be held over to the next Valuation Day to be executed at the
prices ruling on that day.
Art. 5. Dividend policy. The Management Company will decide from time to time if and to what extent dividends
should be paid to unitholders of a respective Sub-Fund, respectively of the respective class of such a Sub-Fund. Without
prejudice to our intention to obtain UK distributor status, distributions may be paid entirely or partly in the form of
bonus units. Any remaining fractions of units may be paid out in cash or credited. Dividends not claimed within five years
from their due date will elapse and revert to the relevant fund, or the respective class.
Art. 6. Costs.
1. The respective Sub-Fund shall pay a fee of maximum 1.75% p.a. to the Management Company. This fee is based on
the average net assets of each Sub-Fund calculated daily during the relevant month. This fee shall in particular serve as
compensation for the administrator and the Fund manager, as well as for the distribution of the Sub-Fund’s units and
the services of the Custodian Bank. The fee shall generally be withdrawn from the Sub-Fund at the end of each month.
96029
2. Furthermore, the Management Company may be entitled to a performance fee. If applicable, the method of calcu-
lation and the respective amount are laid down in the Sales Prospectuses.
3. All taxes and duties owed on the Sub-Funds’ assets and income will be borne by the Sub-Fund.
4. Bank and brokerage fees for transactions in securities making up the Fund’s portfolio as well as fees on transfers
referring to redemption of units will be borne by the Fund.
Art. 7. Financial year. The accounts of the Fund are closed on December 31 of each year.
Art. 8. Term and liquidation of the Sub-Funds.
1. The Management Company may at any time decide upon the liquidation of one or more Sub-Funds, particularly in
situations of a notable modification of the economic and/or political prevailing circumstances, or if the net assets of a
Sub-Fund fall under a certain level to be determined by the Management Company which will not allow an efficient and
rational management or in any other cases which will be in the unitholders’ interest.
In case the net assets of a Sub-Fund drop down to zero due to redemptions, the Management Company may decide
that this Sub-Fund is closed.
The decisions of the Management Company to liquidate a Sub-Fund must be announced by a notice published in a
Luxembourg newspaper and in newspapers of such countries, where the units are publicly sold. The registered unithold-
ers will be informed by registered mail.
2. No application for subscription or conversion of units will be accepted after the date of the event leading to the
dissolution and the decision to liquidate the Sub-Funds. If the equal treatment between unitholders is ensured, redemp-
tion requests may be treated.
Following the Management Company’s instruction, the Custodian Bank will liquidate each Sub-Fund’s assets in the
best interests of the unitholders and will apportion the proceeds of the liquidation, after deduction of liquidation costs,
amongst the unitholders of the relevant Sub-Fund according to the respective prorata.
Any amounts unclaimed by the unitholders at the closing of the liquidation of a Sub-Fund will be deposited during six
(6) months with the Custodian Bank and thereafter, if required by law, converted into euro and deposited by the Cus-
todian Bank with the Caisse des Consignations in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited
remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they shall be forfeited.
3. Liquidation and distribution of a Sub-Fund cannot be requested by an owner of units, his heirs or beneficiaries.
Art. 9. Merger of Sub-Funds. In accordance with the terms and conditions set out hereafter, the Management
Company may decide, at any time, to merge one or several Sub-Funds of the Fund with other Sub-Funds of the same
Fund or with another undertaking for collective investment (with or without Sub-Funds). Such a merger can only be
carried out, if the investment policy of the absorbing entity does not breach the investment policy of the entity to be
absorbed.
In case of a merger with another collective investment undertaking or any other Sub-Fund of the Fund, the subscrip-
tion price may be paid by contribution in kind of all assets and liabilities of the absorbed Sub-Fund, valued pursuant to
the rules laid down in article 9 of the Management Regulations (General Section). Units of the respective classes will be
issued at their respective net asset value against contribution in kind valued this way. All expenses related to this con-
tribution in kind will be charged to the contributor.
In such event, notice will be given in writing to registered unitholders and, if the Management Company so decides,
will be published in a Luxembourg newspaper and in newspapers of such countries, where the units are publicly sold.
Each unitholder of the relevant Sub-Fund shall be given the possibility, within a period of at least thirty (30) days, to
request either the redemption or the conversion of his units against units of the absorbing Sub-Fund at no cost for the
unitholder
Luxembourg, 18th of August 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08117. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092384.2//153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2006.
HELA BETTEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.
R. C. Luxembourg B 32.950.
—
En vertu de l’article 256-1 LSC et de la garantie donnée par la société GESCHÄFTSFÜHRUNGSGESELLSCHAFT DIS-
TRIBUTA BETEILIGUNGSVERWALTUNG bmH en faveur de sa filiale hela BETTEMBOURG S.A., les comptes annuels
consolidés de la GESCHÄFTSFÜHRUNGSGESELLSCHAFT DISTRIBUTA BETEILIGUNGSVERWALTUNG bmH au 31
décembre 2005 et le rapport du réviseur sur ces comptes consolidés, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf.
LSO-BT07898, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091923.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. / SEB ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>The Custodiani> / <i>The Management Company
i>Signatures / Signatures
96030
TRADE SYNERGY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 86.831.
—
<i> Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2006i>
L’assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Monsieur Robert Gouzoukian, demeurant 173, rue de
Bagnolet, F-75020 Paris, et Monsieur Jacques Gavet, demeurant Vallon des Magnans, F-13170 Les Pennes Mirabeau, et
Monsieur Guy Benolier, demeurant 26, rue André Delieux, F-31500 Toulouse, ainsi que celui du commissaire aux
comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour
une période venant à l’échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de renommer Monsieur Jacques Gavet administrateur-délégué
également pour une même période.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 juin 2006i>
Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Jacques Gavet administrateur-délégué
pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06612. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091916.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
PROVIMLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.571.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 2 août 2006 que
les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2008:
- Madame Emanuela Brero, née le 25 mai 1970 à Bra (Cuneo), Italie, avec adresse professionnelle au 5, Place du
Théâtre, L-2613 Luxembourg;
- Monsieur Patrick Mouterde, né le 20 septembre 1967 à Lyon, France, avec adresse professionnelle au 43, Avenue
de l’Opéra, F-75002 Paris, France.
Il résulte du procès-verbal de la même assemblée générale des actionnaires que le mandat du commissaire aux
comptes suivant est renouvelé jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31
décembre 2006:
- FACTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrit au
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 98.790.
Il résulte du procès-verbal de la même assemblée générale des actionnaires que le mandat du réviseur d’entreprise
suivant est renouvelé jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes consolidés au 31 dé-
cembre 2005:
- DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrit au Registre de com-
merce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 67.895.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait `a Luxembourg, le 4 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02958. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091998.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SFEIR BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 32A, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 76.899.
—
Les comptes annuels au 31 mai 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08139, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094401.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
96031
MG IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 78.585.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration, réuni au siège de la prédite société, le 26 juillet 2006, a pris à l’unanimité la résolution
suivante:
1. «Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société de L-1941 Luxembourg, 241, route
de Longwy à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.»
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06369. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(092082.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
ACE TOURISM & ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 92.002.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration, réuni au siège de la prédite société, le 26 juillet 2006, a pris à l’unanimité la résolution
suivante:
1. «Le Conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de L-1941 Luxembourg, 241, route
de Longwy à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.»
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06372. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(092085.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SLOOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 118.930.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-sept août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.
Ont comparu:
1. RICARD LAKE PROPERTY INC, une société anonyme de droit panaméen ayant son siège social au Arango-Orillac
Building, 2nd Floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C. Panama, Republic of Panama, Public Deed 2004 N
°
11976, ici représentée par Monsieur Luc Wittner, demeurant professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé.
2. MORALES INVESTORS S.A., une société anonyme de droit panaméen ayant son siège social au Arango-Orillac
Building, 2nd Floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C. Panama, Republic of Panama, Public Deed 2005 N
°
37, ici représentée par Monsieur Luc Wittner, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing
privé.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-
tuer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SLOOP S.A.
Art. 2. Le siège de la société est à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
Pour extrait conforme
A. Id Hocine
<i>Administrateur déléguéi>
Pour extrait conforme
<i>ACE TOURISM & ENTERTAINMENT S.A.
i>M. Bucher
<i>Administrateur-déléguéi>
96032
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier
par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 100 (cent)
actions d’une valeur nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune.
Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
96033
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième mardi du mois de mars à 15.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription et paiement i>
Les 100 (cent) actions ont été souscrites comme suit par:
Chaque action a été libérée à hauteur de EUR 77,50 (soixante-dix-sept euros cinquante cents) de sorte que la somme
de EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve
en ayant été donnée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et, à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
1.- RICARD LAKE PROPERTY INC, prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- MORALES INVESTORS S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
96034
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2012:
(i) Maître Michaël Dandois, né le 15 janvier 1971 à Messancy (Belgique), Avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
(ii) Maître Antoine Meynial, né le 6 février 1966 à Paris 16
e
(France), Avocat à la Cour, demeurant professionnelle-
ment au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
(iii) Monsieur Stéphane Warnier, né le 25 mars 1966 à Watermael-Boitsfort (B), employé privé, demeurant profes-
sionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de l’an 2012:
Madame Sandrine Chantrain, née le 28 mars 1966 à Boitsfort (Belgique), demeurant au 14, rue Gilles Dagneau, B-1390
Hèze (Belgique).
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ce dernier a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: L. Wittner, M. Lecuit.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 août 2006, vol. 537, fol. 74, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095575.3/231/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
PARTITION ET PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 118.927.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Gernot Kos, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue
des Foyers.
2.- Monsieur Thierry Hellers, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3,
rue des Foyers.
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Christophe Mignani, expert-comptable, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de PARTITION ET PARTICIPA-
TION S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles, tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société a, en outre, pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Junglinster, le 6 septembre 2006.
M. Lecuit.
96035
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéocon-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2
e
jeudi du mois de juin à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
96036
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et, à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Philippe Leroy, directeur de sociétés, né à Enghien les Bains (France), le 26 septembre 1978, demeurant
professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal;
b) Monsieur Gernot Kos, administrateur de sociétés, né à Eisenstadt (Autriche), le 23 janvier 1970, demeurant pro-
fessionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;
c) Monsieur Thierry Hellers, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 13 septembre 1968, demeurant pro-
fessionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée ABROAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à L-1313 Luxembourg, 5, rue
des Capucins (R.C.S. Luxembourg section B numéro 107.654).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2010.
5.- Le siège social est établi à L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Mignani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2006, vol. 537, fol. 68, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095572.3/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.659.
—
Les comptes annuels au 30 novembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00484, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094514.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
1.- Monsieur Gernot Kos, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg,
3, rue des Foyers, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2.- Monsieur Thierry Hellers, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1537 Luxem-
bourg, 3, rue des Foyers, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Junglinster, le 5 septembre 2006.
J. Seckler.
F. Mangen.
96037
COHERIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.202.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie au siège de la prédite société, le 26 juillet 2006, a pris à l’unanimité la
résolution suivante:
1. «L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy à L-
1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.»
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06368. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(092086.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
ONSEN BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 110.920.
—
<i>Extrait de la résolution prise par le gérant de la société ONSEN BENELUX, S.à r.l. (la «Société») le 15 juilleti>
<i>Résolution uniquei>
Le Gérant décide de transférer - avec effet au 15 juillet 2006 - le siège social de la Société de 10, rue Sainte Zithe, L-
2763 Luxembourg au 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06805. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092216.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
BRITISH VITA (LUX III), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TPG SPRING (LUX III), S.à r.l.).
Capital social: EUR 1.470.480.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 107.582.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution écrite de l’associé unique de la Société du 4 août 2006 que le conseil de gérance de la
Société est composé comme suit avec effet au 4 août 2006:
<i>Gérants de classe A:i>
M. Stephen Mark Peel;
M. Howard Elliot Harris;
M. Todd Howard Morgan;
M. Ramzi Gedeon;
M. David Spuria;
M. William Price.
<i>Gérants de classe B:i>
Mme Noëlla Antoine;
Mme Bénédicte Herlinvaux;
Mme Ingrid Moinet.
L’adresse de M. William Price est modifiée comme suit: 345 Californie Street, Suite 3300, CA 94104 San Francisco,
Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05947. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094762.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour extrait conforme
J.-P. Creput
<i>Géranti>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliatairei>
Fait à Luxembourg, le 30 août 2006.
Signature.
96038
ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.239.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale des actionnairesi>
<i>d’ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A. (la «Société») du 19 juin 2006i>
1. Réélection de Messieurs Julian Kramer, avec adresse professionnelle au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg-Kirchberg, Richard Goddard, avec adresse professionnelle au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-
Kirchberg et Julian Ide, avec adresse professionnelle au 82 Bishopsgate EC2N 4BN London, aux postes d’administrateurs
de la Société pour une durée d’un an et ce jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la Société.
2. ERNST & YOUNG est nommée Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an et ce jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092099.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.239.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnairesi>
<i>d’ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A. (la «Société») du 10 août 2006i>
1. Ratification de la nomination de M. Derek Ramage avec adresse professionnelle au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg comme Administrateur avec effet au 10 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05861. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092100.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
SANMINA-SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 16,000.-.
Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 84.071.
—
In the year two thousand and four, on the fifteenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared SANMINA-SCI UK LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under Limited Partner-
ship Act 1907 of Scotland, having its principal place of business at 1, Crompton way, North Newmoor Industrial Estate,
Irvine, Scotland KA11 4HU, duly represented by its «General Partner» S.C.I. TECHNOLOGY INC., a company incor-
porated in the State of Alabama, having its principal place of business at 2101 West Clinton Avenue, Huntsville, Alabama
35805,
here represented by Mr Regis Galiotto, Notary’s clerk, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Huntsville (Alabama, USA), on October
12, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the
name of SANMINA-SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated pursuant to a deed of M
e
Edmond Schroeder, then notary
residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated October 10th, 2001, published in the Mémorial, Recueil Spécial
C n
°
276 dated February 19, 2002. The Company’s articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of
the undersigned notary dated June 19, 2002, published in the Mémorial, Recueil Spécial C n
°
1298 dated September 7,
2002.
II. The Company’s share capital is set at twelve thousand U.S. Dollars (USD 12,000.-) divided into one hundred twenty
(120) shares of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each.
III. The sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Leinkauf-Schiltz
<i>Legal & Compliance Assistanti>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Leinkauf-Schiltz
<i>Legal & Compliance Assistanti>
96039
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the Company’s share capital to the extent of four thousand U.S. Dollars
(USD 4,000.-), in order to raise it from its current amount of twelve thousand U.S. Dollars (USD 12,000.-) up to sixteen
thousand U.S. Dollars (USD 16,000.-) by creation and issuance of forty (40) new shares with a nominal value of one
hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each.
<i>Second resolution / Intervention - Subscription - Paymenti>
The sole shareholder, SANMINA-SCI UK LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under Limited
Partnership Act 1907 of Scotland, having its principal place of business at 1, Crompton way, North Newmoor Industrial
Estate, Irvine, Scotland KA11 4HU, duly represented by its General Partner SCI TECHNOLOGY INC., a company in-
corporated in the State of Alabama, having its principal place of business at 2101 West Clinton Avenue, Huntsville, Al-
abama 35805, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to forty (40) new shares, vested with the same
rights and obligations than the existing shares.
The sole shareholder declared to have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of four thousand
U.S. Dollars (USD 4,000.-).
The amount of four thousand U.S. Dollars (USD 4,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the
Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholder resolved to amend the article 6 of the Company’s
articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:
«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at sixteen thousand U.S. Dollars (USD 16,000.-) represented by one
hundred sixty (160) shares with a nominal value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, all fully paid-up and sub-
scribed.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at 1,300.- EUR.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SANMINA-SCI UK LIMITED PARTNERSHIP, une «limited partnership» constituée sous le «Limited Partnership Act
1907» d’Ecosse, ayant son siège de direction effective au 1, Crompton way, North Newmoor Industrial Estate, Irvine,
Ecosse KA11 4HU, dûment représentée par son «General Partner» SCI TECHNOLOGY INC., une société constituée
sous les lois de l’Etat d’Alabama, ayant son siège de direction effective au 2101 West Clinton Avenue, Huntsville, Ala-
bama 35805,
ici représentée par M. Regis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Huntsville (Alabama, Etats-Unis), le
12 octobre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de SANMINA-SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de ré-
sidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
276 en date du 19 février 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentaire en date
du 19 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
1298 en date du 7 septembre 2002.
II. Le capital social de cette Société est fixé à douze mille U.S. dollars (USD 12.000,-) divisé en cent vingt (120) parts
sociales d’une valeur nominale de cent U.S. dollars (USD 100,-) chacune.
III. L’associée unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre mille U.S. dollars (USD
4.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille U.S. dollars (USD 12.000,-) à seize mille U.S. dollars (USD
16.000,-) par la création et l’émission de quarante (40) nouvelles parts sociales, d’une valeur nominale de cent U.S. dol-
lars (USD 100,-) chacune.
96040
<i>Seconde résolution / Intervention - Souscription - Libérationi>
L’associée unique, SANMINA-SCI UK LIMITED PARTNERSHIP, une «limited partnership» constituée sous le «Limi-
ted Partnership Act 1907» d’Ecosse, ayant son siège de direction effective au 1, Crompton way, North Newmoor In-
dustrial Estate, Irvine, Ecosse KA11 4HU, dûment représentée par son «General Partner» SCI TECHNOLOGY INC.,
une société constituée sous les lois de l’Etat d’Alabama, ayant son siège de direction effective au 2101 West Clinton
Avenue, Huntsville, Alabama 35805, précité, par son mandataire, déclare souscrire à toutes les nouvelles parts sociales,
chacune jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
L’associée unique déclare les libérer intégralement au montant de quatre mille U.S. dollars (USD 4.000,-).
Le montant de quatre mille U.S. dollars (USD 4.000,-) a été intégralement libéré en espèce et se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’associée unique décide de modifier l’article 6 des statuts, afin de lui don-
ner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à seize mille U.S. dollars (USD 16.000,-) représenté par cent soixante
(160) parts sociales d’une valeur nominale de cent U.S. dollars (USD 100,-) chacune, toutes intégralement libérées et
souscrites.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.300,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il
a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 90, case 6. – Reçu 33,26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095669.3/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
SANMINA-SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 16.000,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 84.071.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41924, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 septembre 2006.
(095671.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
AZ FUND 1, Fonds Commun de Placement.
—
Suivant l’article 13(1) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif:
Les modifications au règlement de gestion de AZ FUND 1 au 18 juillet 2006, enregistrées à Luxembourg, le 9 août
2006, réf. LSO-BT03073, ont été déposées au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 6 septembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2006.
(094622.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
AZ FUND MANAGEMENT S.A.
Signature
96041
FIN & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 45.029.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06180, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094406.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
AMARILYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.089.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00467, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094444.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
AGEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.368.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00480, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094516.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
MONTAGU CAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. LEBAUDY HOLDING S.A.).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.637.
—
L’an deux mille six, le treize juillet
Par-devant Maître Joseph, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LEBAUDY HOL-
DING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro
98.637, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 2003 publié au Mémorial C numéro 255 du 3 mars 2004.
L’assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg,
et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Corinne Bitterlich, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les trente-deux (32) actions, représentant l’intégralité du capital social,
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la dénomination sociale en MONTAGU CAPITAL S.A. et modification afférente des statuts;
2) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une
société de participations financières (Soparfi) en modifiant l’article deux des statuts comprenant l’objet social ainsi que
l’article quinze comprenant les dispositions générales;
3) Démission des administrateurs en place et nomination de leurs remplaçants. Décharge spéciale aux administrateurs
démissionnaires;
4) Modification de l’exercice social et modification de la date de l’assemblée générale annuelle;
5) Modifications subséquentes des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
Luxembourg, le 4 septembre 2006.
Signature.
F. Mangen
<i>Administrateuri>
F. Mangen.
96042
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en MONTAGU CAPITAL S.A.
En conséquence le premier alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. (alinea 1
er
). «Il est formé une société anonyme dont la dénomination est MONTAGU CAPITAL S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
d’adopter le statut d’une société de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions relatives aux
sociétés dites usuellement «soparfi».
Afin de mettre les statuts en concordance, l’assemblée décide de remplacer l’article deux des statuts définissant l’ob-
jet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de
capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces par-
ticipations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, ac-
quérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres, les
réaliser par voie de vente, de cession, d’échange.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.
La Société peut également réaliser son activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son exten-
sion.».
D’autre part, l’article quinze est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d’administrateurs de:
- LOUV, S.à r.l.;
- DMC, S.à r.l.;
- EFFIGI, S.à r.l.
Les actionnaires décident d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires pour la période
du 1
er
avril 2005 à la date de leur démission effective.
L’assemblée nomme en remplacement aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Graham Hislop;
- Monsieur Sylvain Berger-Duquenne;
- Monsieur Quentin Bergot.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide que le nouvel exercice social débutera le premier janvier de chaque année pour s’achever le 31
décembre de chaque année.
L’assemblée générale annuelle se tiendra chaque troisième mardi du mois de juin à 11 heures.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier les articles 11 et 13 des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Galiotto, F. Gibert, C. Bitterlich, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, vol. 154S, fol. 68, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095605.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Luxembourg, le 11 août 2006.
J. Elvinger.
96043
MONTAGU CAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. LEBAUDY HOLDING S.A.).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.637.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43447, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 septembre 2006.
(095606.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
CALCHAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.503.
—
L’an deux mille six, le neuf août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALCHAS HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 62.503, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 241
du 15 avril 1998, et dont les statuts ont été modifiés:
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 156 du
10 mars 1999;
- suivant acte sous seing privé (article 5) en date du 2 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 928 du 26 octobre
2001.
L’assemblée est présidée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Lorenzo Gianello, juriste, demeurant professionnellement à
L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification du régime actuel de signature.
2.- Modification afférente du dernier alinéa de l’article 7 des statuts.
3.- Réorganisation des pouvoirs de signature.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société, laquelle sera désor-
mais valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de caté-
gorie B.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article sept des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
«Art. 7. (dernier alinéa). La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie
A et d’un administrateur de catégorie B.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réorganiser les pouvoirs de signature comme suit:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
Messieurs Alexis De Bernardi, Vincenzo Arno’ et Mohammed Kara.
<i>Administrateurs de catégorie B:i>
Messieurs Fabio Perini et Francesco Sarti.
J. Elvinger.
96044
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, L. Gianello, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2006, vol. 537, fol. 66, case 18. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095705.3/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
CB LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CINVEN BUYOUT IV, S.à r.l.).
Share capital: EUR 125,000.
Registered office: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 106.372.
—
In the year two thousand and six, on the nineteenth day of the month of June.
Before Maître Hellinckx, notary, residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of the associates of CINVEN BUYOUT IV, S.à r.l. (the «Company»), a
société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, incorporated on
21st February 2005 by deed of the prenamed notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on the 28th June 2005.
The meeting was presided by M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary M
e
Maryline Esteves, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer
M
e
Céline Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg. The chairman declared and requested the notary to state
that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all five thousand (5,000) shares in issue in the Company were represented
at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so
that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.
2. The agenda of the meeting was as follows:
<i>Agenda:i>
- Change of name of the Company to CB LUXEMBOURG IV, S.à r.l., and consequential amendment of the articles of
incorporation of the Company.
- Appointment, as additional managers of the Company, of Mr Benoît Valentin and of Mrs Danièle Arendt, with effect
on the 19th June 2006 and for an undetermined period, each as a new Class A board member.
After deliberation the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to change the name of the Company to CB LUXEMBOURG IV, S.à r.l., and to consequentially
amend article 1 of the articles of incorporation of the Company.
<i>Second resolutioni>
It was unanimously resolved to appoint Mr Benoît Valentin with address at 46 Lilyville Road, London SW6 5DW Unit-
ed Kingdom, born on 20th July 1968 in Saumur (France), as Class A Manager and Mrs Daniele Arendt with address at
42, Op Fankenacker, L-3265 Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg, born on 9th January 1961 in Luxembourg, as
Class A Manager of the Company, with effect on the 19th June 2006 and for an undetermined period,
so that the Board of Managers is composed by:
- Mrs Amélie Brossier (Class A Manager),
- Mr David Robert Barker (Class A Manager),
- Mr Alain Peigneux (Class B Manager),
- Mr Benoît Valentin (Class A Manager), and
- Mrs Danièle Arendt (Class A Manager).
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at one thousand Euro.
Junglinster, le 1
er
septembre 2006.
J. Seckler.
96045
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-neuvième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de CINVEN BUYOUT IV, S.à r.l. (la «Société»), une so-
ciété à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, constituée en date du
21 février 2005 par acte du notaire susmentionné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 28 juin
2005.
L’assemblée a été présidée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
M
e
Maryline Esteves, maître en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommée secrétaire et M
e
Céline Larmet, maî-
tre en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommée scrutateur. Le président a déclaré et prié le notaire d’acter ce
qui suit:
1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste
de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste
de présence restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Il apparaît de ladite liste de présence que toutes les cinq mille (5.000) parts sociales émises étaient représentées à
l’assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour de sorte
que l’assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
<i>Agenda:i>
- Changement du nom de la Société en CB LUXEMBOURG IV, S.à r.l., et modification consécutive des statuts de la
Société.
- Nomination, comme gérants supplémentaires de la Société, de M. Benoît Valentin et de Mme Danièle Arendt, avec
effet au 19 juin 2006 et pour une durée indéterminée, chacun comme gérant de Classe A.
Après délibération l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé de changer le nom de la Société en CB LUXEMBOURG IV, S.à r.l., et de modifier consécutive-
ment l’article 1
er
des statuts de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été unanimement décidé de nommer M. Benoît Valentin, demeurant 46 Lilyville Road, London SW6 5DW United-
Kingdom, né le 20 juillet 1968 à Saumur (France), comme gérant de Classe A et Mme Danièle Arendt demeurant 42,
Op Fankenacker, L-3265 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg, née le 9 janvier 1961 à Luxembourg, comme gé-
rant de Classe A de la Société avec effet le 19 juin 2006 et pour une durée indéterminée.
Ainsi, le Conseil d’administration est composé de:
- Mme Amélie Brossier (gérant de Classe A),
- M. David Robert Barker (gérant de Classe A),
- M. Alain Peigneux (gérant de Classe B),
- M. Benoît Valentin (gérant de Classe A), et
- Mme Daniele Arendt (gérant de Classe A).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été levée.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société sont estimés
à mille euros.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent procès-
verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; qu’à la demande desdits comparants, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, M. Esteves, C. Larmet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 juin 2006, vol. 437, fol. 33, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095732.3/242/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Mersch, le 16 août 2006.
H. Hellinckx.
96046
HARMONIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.080.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00479, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094518.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
MARIVA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.260.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00485, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094519.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
DENTASMILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 47, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 119.001.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Henri Diederich, médecin-dentiste, né à Luxembourg, le 13 mars 1958, demeurant à L-8140 Bridel, 42A,
route de Luxembourg.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va cons-
tituer.
Titre I
er
.- Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un laboratoire dentaire.
La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières
ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de DENTASMILE, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II.- Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre
les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
F. Mangen.
F. Mangen
<i>Administrateuri>
96047
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III.- Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-
gitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV.- Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-
lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V.- Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI.- Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-
signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Henri Diederich, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
96048
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Henri Diederich, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3.- Le siège social est établi à L-2311 Luxembourg, 47, avenue Pasteur.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Diederich, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 31 août 2006, vol. 435, fol. 85, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Leyers.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(097187.3/236/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.
COPARIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.554.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00471, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094527.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
MAINORIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.627.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00470, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094528.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Bascharage, le 11 septembre 2006.
A. Weber.
F. Mangen
<i>Administrateuri>
F. Mangen
<i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Holding de Financements et d’Investissements S.A.
Compagnie d’Investissements Luxembourgeoise S.A.
S.S.F.S., Standard Software and Firmware Services S.A.
Sislark Property, S.à r.l.
MR & Co Promo, S.à r.l.
Altawin S.A.
Russian Investment Company
An.so.fi. Holding S.A. (Amboise Société Financière)
Théâtre National du Luxembourg Productions, S.à r.l.
Ambisoll S.A.
Orion Income Finance Luxembourg, S.à r.l.
O.I. TE, O.I. TX et Colonnes Investment, S.e.n.c.
O.I. TE, O.I. TX et Colonnes Investment, S.e.n.c.
Pimiento Holding S.A.
O.I. TX, S.à r.l.
O.I. TX, S.à r.l.
O.I. TE, S.à r.l.
O.I. TE, S.à r.l.
Nafta Investments, S.à r.l.
Sodipro, S.à r.l.
Sodipro, S.à r.l.
Shanks Lux Finance, S.à r.l.
Princess Wilru
SEB Fund 5
Globalux Investments, S.à r.l.
Bass.Com. S.A.
C.M.P. Creative Marketing et Promotion, S.à r.l.
Preinvestment Holding S.A.
SEB Fund 4
Euroceanica Shipping Holding B.V./S.à r.l.
Charterhouseluxco S.A.
Berlys, S.à r.l.
Euro 2000 S.A.
Berlys Management, S.à r.l.
IVG Logistics Holding S.A.
SEB Fund 3
hela Bettembourg S.A.
Trade Synergy International S.A.
Provimlux Investments S.A.
Sfeir Benelux S.A.
MG Immobilier S.A.
ACE Tourism & Entertainment S.A.
Sloop S.A.
Partition et Participation S.A.
Beständigkeit Holding S.A.
Coheris Luxembourg, S.à r.l.
Onsen Benelux, S.à r.l.
British Vita (Lux III), S.à r.l.
ABN AMRO Investment Funds S.A.
ABN AMRO Investment Funds S.A.
Sanmina-SCI Luxembourg, S.à r.l.
Sanmina-SCI Luxembourg, S.à r.l.
AZ Fund 1
Fin & Co S.A.
Amarilys Holding S.A.
Agemar S.A.
Montagu Capital S.A.
Montagu Capital S.A.
Calchas Holding S.A.
CB Luxembourg IV, S.à r.l.
Harmonis S.A.
Mariva Holding S.A.
Dentasmile, S.à r.l.
Coparin S.A.
Mainoria S.A.