logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

92161

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1921

12 octobre 2006

S O M M A I R E

A.R.I.  Amusement  Rides  International  S.A.,  Lu- 

Link Logistics S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . 

92179

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92196

Lux-Forêts, S.à r.l., Beringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92176

Agrolux Engineering, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

92202

Mac-Philson Holding S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . 

92205

Amarile Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

92203

Mac-Philson Holding S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . 

92205

Aqsacom International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

92194

Metty Weyrich & Fils, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . 

92176

Association de Participants Holding S.A.,  Luxem- 

Nero S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . 

92205

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92177

Nero S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . 

92205

Association Européenne pour la Spécialisation en 

Net Holding S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

92201

Médecine Vétérinaire Clinique, A.s.b.l., Luxem- 

Nikolic, S.à r.l., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92164

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92179

Nikolic, S.à r.l., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92165

BB & MT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92187

Olivi Antonio, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . 

92195

BC TNLGY S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

92196

Omega Software S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

92179

Benelux Taxis, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

92196

Pitcairn S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92204

Capital Investissements Europe S.A., Luxembourg

92187

Pitcairn S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92204

Capital Investissements Europe S.A., Luxembourg

92187

Plein Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92167

Compagnie Piere Holding S.A., Luxembourg . . . . .

92178

PP Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92203

Controlsinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

92166

Pro-Hol S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

92208

Coopératives HMC, Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92167

Pro-Hol S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

92208

Copeco, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92195

Promotecnic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

92194

Crown Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

92204

Promoter, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

92205

Dematrans, S.à r.l., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92202

R.S.R. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92178

Dubelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92203

Regolo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

92203

E.K. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92186

Regolo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

92203

Easybox S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92208

Regolo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

92203

Entami Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

92202

(Le) Sot l’y Laisse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

92196

Européenne de Conseils S.A., Luxembourg  . . . . . .

92169

Springwater  Property  Investment  Holdings,  S.à 

F.N.S.A. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

92176

r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92197

Field Point PE VIII (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Struwwelbuscht, S.à r.l., Larochette. . . . . . . . . . . . 

92168

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92180

Sun Square, S.à r.l., Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . 

92195

Fondation Caritas Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

92162

Tandem Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

92204

Fondation Ligue HMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92166

Tarn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

92202

Fondation Pauline de Faillonnet, Luxembourg . . . .

92178

Tarrant Management - LU, S.à r.l., Luxembourg . 

92188

GDK S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

92195

TFAL Investments S.A.H., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . 

92169

Greenwich Investments, S.à r.l., Schuttrange . . . . .

92169

Transport et Logistique de la Viande  S.A.,  Wind- 

Intertechnology S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

92195

hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92204

Invest Corporation, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

92185

U.A.I. (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

92186

Itchiban S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92168

U.A.I. (Luxembourg) III, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

92207

Itchiban S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92168

VGL, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . 

92202

Jakobsberg Centrum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

92168

(La) Vieillotte S.C., Brouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92186

Kole Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92176

Wactrans Luxembourg, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . 

92196

Leminvest Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .

92169

«Hydro 50» Management, S.à r.l., Kautenbach . . . 

92162

Life Consulting Luxembourg S.A., Beckerich . . . . .

92168

92162

«HYDRO 50» MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9663 Kautenbach, 5, Op der Schleid.

R. C. Luxembourg B 101.917. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 2 août 2006, réf. DSO-BT00038, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 17 août 2006.

(986438.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2006.

FONDATION CARITAS LUXEMBOURG, Etablissement d’Utilité Publique.

R. C. Luxembourg G 38. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005

<i>(exprimé en euros)

COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2005 

<i>(exprimé en euros)

FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>ACTIF

Note(s)

2005

2004

EUR

EUR

Actif immobilisé
- immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.2, 3

7.127.878

7.259.878

Actif circulant
- créances coopération internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.3

374.955

290.198

- créances diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.3, 4

3.260.479

3.315.835

- avoirs en banque, avoirs en compte chèques postaux, chèques et encaisse . . . . 

865.120

883.919

4.500.554

4.489.952

Compte de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.159

139

Déficit de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

582.426

121.238

Total de l’actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.216.017 11.871.207

<i>PASSIF

Fonds propres
- fonds associatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.4, 5

4.561.462

4.561.462

 - autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.4, 5

1.126.425

1.247.663

Fonds disponibles pour projets futurs
- coopération internationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

3.069.295

2.837.716

- aide nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

773.840

906.483

- fonds pour projets à réaliser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

238.095

404.466

- fonds à destination de la Confédération CARITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

1.063.298

657.293

- aide à destination d’autres oeuvres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

15.580

17.916

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.5, 6

1.293.547

1.163.624

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74.475

74.584

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.216.017 11.871.207

Note(s)

2005

2004

EUR

EUR

Collectes de fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12 10.423.322 10.361.230

Projets réalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12 -10.373.348

-9.181.694

Transferts de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

294.940

-649

Remboursements de fonds à l’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

-8.680

-46.076

Variation des fonds disponibles pour projets futurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

-336.234

-1.132.811

Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

4.407.940

3.214.715

Autres charges externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8

-1.876.679

-1.457.333

Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9

-2.732.777

-2.100.652

Corrections de valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- sur immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

-400.926

-331.226

- sur subvention d’investissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

27.828

27.828

- sur éléments de l’actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-27.949

-5.705

Autres charges d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-7.637

-6.450

92163

BUDGET POUR L’EXERCICE 2006

RAPPORT DE GESTION 2005

La FONDATION CARITAS a pu compter en 2005 sur 58 membres du personnel, dont 41 femmes et 17 hommes,

s’engageant en cette année dans l’amélioration continue de leur travail en faveur des plus démunis, et ceci dans le cadre
de la mise en route d’une démarche qualité. Cet engagement fut pris en vue d’une certification ISO 9001 prévue pour
mars 2006. Pour ce faire, le personnel très motivé s’est mis ensemble lors d’un bon nombre de réunions formelles et
informelles afin de discuter de l’intégration de la qualité dans leur travail quotidien.

Une démarche de planification participative fut favorisée. Le personnel a participé en 2005 à 11 formations collectives

et à 25 formations individuelles, au total plus de 500 heures de travail ont été consacrées à la formation continue! A la
fin de l’année, l’administration du personnel fut confiée à la secrétaire générale.

La communication vers l’extérieur fut marquée en 2005 par une campagne de sensibilisation «Vivre la solidarité au

Luxembourg et en Europe» visant à sensibiliser le grand public et le monde politique au Luxembourg sur des thèmes
européens pendant la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union Européenne. L’organisation de maintes actions
autour des Objectifs du Millénaire pour le Développement, organisées au sein du projet nommé «Plaidons responsable»,
fut un des points forts de cette campagne. L’avenir du Kosovo, la cohésion sociale et l’immigration furent les trois autres
thèmes abordés lors de cette action unique et réussie. Le Service communication a été réorganisé et la responsabilité
déléguée à Madame Danièle Hengen à partir du 1

er

 septembre.

Relevons pour le domaine de la coopération internationale l’aide d’urgence réalisée cuite au raz-de-marée du 26 dé-

cembre 2004 ainsi que la planification et le démarrage des activités de réhabilitation en Asie de l’Est. Autres défis à sou-
lever ont été l’aide d’urgence mise en place suite au séisme au Pakistan du 8 octobre 2005 ainsi que l’engagement continu
dans la crise du Darfur. Dans le cadre de la mise en place d’un système qualité, deux processus différents ont pu être
identifiés et élaborés en détail: «Gérer les projets de coopération internationale» et «Mettre en place un projet d’édu-
cation au développement». La deuxième phase de l’accord cadre ayant comme stratégie le continuum (de l’urgence à
travers la réhabilitation vers le développement) conclu avec le Ministère des Affaires Etrangères est venu à terme. L’éva-
luation externe d’un des projets, en l’occurrence le projet de développement rural An Phu au Vietnam, ordonné par le
Ministère des Affaires Etrangères, a confirmé la cohérence et le bien-fondé de l’approche de Caritas. L’analyse du travail
humanitaire «Politik der Humanitären Hilfe», complétant l’engagement de Caritas au niveau d’une réflexion intense sur
le travail quotidien réalité, fut publié et présenté au grand public. Le Service de la Coopération internationale compte
en 2005 11 collaboratrices et collaborateurs. 115 projets ont été réalisés dans 37 pays différents, les efforts entrepris
se chiffrant à un volume total de 8.442.771,- EUR.

L’année 2005 a permis au Service Réfugiés d’atteindre la capacité maximale d’hébergement du Foyer St Antoine, cen-

tre d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile. Le projet Passepartout a poursuivi son travail. L’élaboration de
la nouvelle loi sur l’asile ainsi que l’évolution de la politique européenne en matière d’asile et d’immigration ont égale-
ment été suivies. Les groupes cibles particulièrement suivis en 2005 étaient les personnes dans papiers ainsi que les mi-
norités ethniques du Kosovo. Le service a intensifié son travail pour la mise en place d’un réseau de traduction dans le
domaine de la santé mentale pour les réfugiés, mais aussi pour une prise en charge adaptée de cette population aux
traumatismes spécifiques. Le nombre de consultations de 3.221 à la rue Michel Welter a encore augmenté par rapport

Résultat d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-610.200

-658.823

Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.333

16.359

Charges financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.366

-3.019

Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.967

13.340

Produits exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

23.670

524.265

Charges exceptionnelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

-19.863

-20

Résultat exceptionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.807

524.245

Déficit de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-582.426

-121.238

<i>CHARGES

1. Frais de fonctionnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.215.963
2. Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.074.148
3. Dépenses pour projets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.188.978
4. Charges financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250

5. Charges exceptionnelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-28.142

6. Autres charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.207

Total en EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.476.404

<i>PRODUITS

1. Résultat d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.085.778
2. Dons engagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.125.650
3. Subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.071.379
4. Résultats financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.000

5. Résultats exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

6. Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

178.597

Total en EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.476.404

92164

à l’année précédente. 13 collaboratrices et collaborateurs se sont engagés en 2005 au sein du service pour le bien des
réfugiés. Un groupe consultatif a été mis en place pour accompagner la planification et l’évaluation du travail du service.

Quant à l’aide accordée au plan national, 119 nouvelles demandes d’un secours financier ont été introduites en 2005;

le montant total des aides accordées est de 5.143,- EUR. Le service social pour immigrés accueille un nombre toujours
croissant de ressortissants portugais, capverdiens et brésiliens à la recherche d’un travail ou d’un logement ou bien cher-
chant de l’assistance concernant les démarches à faire auprès des organismes de la sécurité sociale. Les aides vestimen-
taires constituent toujours une activité importante de la Fondation: en 2005 des vêtements d’une valeur de 35.913,09
EUR ont été distribués à 3.064 clients.

Au niveau du service administratif, les processus suivants: «Accueillir les visiteurs», «Acheter et gérer le matériel et

les services» ainsi que «Mettre à disposition les locaux administratifs» ont été identifiés et élaborés dans le cadre de la
mise en place du système qualité. Au niveau de la gestion des finances il s’agit du processus «Gérer les finances» avec
les sous-rubriques: comptabilisation, gestion de la trésorerie, établissement des comptes annuels et rémunération du
personnel.

Finalement la sensibilisation à la sécurité a été poursuivie par le biais de formations et de création de documents de

sécurité.

Je tiens à remercier de tout coeur les membres du conseil d’administration de la FONDATION CARITAS ainsi que

le personnel pour leur engagement et l’excellent travail réalisé au cours de l’année 2005 au services des plus démunis.
Cet engagement sera honoré par une certification sans faille ISO 9001 en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02913. – Reçu 97 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065700.2//132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

NIKOLIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 424, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 52.284. 

L’an deux mille six, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,

Ont comparu:

1.- Monsieur Miroslav Nikolic, serrurier, demeurant à L-5884 Hesperange, 424, route de Thionville.
2.- Monsieur Mihail Malinov, ingénieur en mécanique, demeurant à L-2614 Luxembourg, 2, rue Pierre Thinnes.
3.- Madame Snezana Culevska, serveuse, épouse de Monsieur Miroslav Nikolic, demeurant à L-5884 Hesperange, 424,

route de Thionville.

Lesquels comparants sub 1+2) ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée NIKOLIC, S.à r.l., avec siège social à L-1731 Luxem-

bourg, 8, rue de Hesperange, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 52.284.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 septembre 1995,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 595 du 23 novembre 1995.

Que ladite société a été constituée originairement avec un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois

(LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales, qui sont réparties comme suit: 

Lesquels comparants ont ensuite requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Cessions de parts sociales

Monsieur Mihail Malinov cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit une (1) part sociale

pour le prix d’un euro (EUR 1,-) à Madame Snezana Culevska, ici présente et ce acceptant.

Madame Snezana Culevska est propriétaire de la part sociale lui cédée à partir d’aujourd’hui et elle a droit à partir de

ce jour, aux revenus et bénéfices dont cette part sera productive et elle sera subrogée dans tous les droits et obligations
attachés à la part sociale présentement cédée.

Le cédant Monsieur Mihail Malinov déclare avoir reçu de la part de Madame Snezana Culevska le montant d’un euro

(EUR 1,-) avant la passation des présentes et en l’absence du notaire instrumentant, ce dont quittance et titre.

Messieurs Miroslav Nikolic et Mihail Malinov, agissant en leur qualité de gérant administratif respectivement gérant

technique de la société NIKOLIC, S.à r.l. déclarent accepter au nom de la société la prédite cession de parts sociales
conformément à l’article 1690 du Code Civil avec dispense de signification.

Les associés de leur côté, déclarent accepter cette cession de parts sociales.
Ensuite les associés, à savoir Monsieur Miroslav Nikolic et Madame Snezana Culevska ont pris les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir constaté que, dans le cadre de la conversion en euros, le capital social.s’élève actuellement au montant

de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68), les associés décident

E. Gillen
<i>Président exécutif

1.- Monsieur Miroslav Nikolic, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Mihail Malinov, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

92165

d’augmenter le capital social de la société, à concurrence de cinq euros trente-deux cents (EUR 5,32) pour le porter de
son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) au
montant de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-).

Ensuite les associés décident de fixer la valeur nominale des parts sociales à cent vingt-quatre euros (EUR 124,-), de

sorte que le capital au montant de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-) est représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

Suite à la cession de parts sociales intervenue, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts afin de lui donner

la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé au montant de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les parts sociales sont réparties comme suit: 

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite

restauration.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de fixer l’adresse du siège de la société comme suit: L-5884 Hesperange, 424, route de

Thionville. 

<i>Cinquième résolution

La démission de Messieurs Miroslav Nikolic et Mihail Malinov, en tant que gérant administratif respectivement gérant

technique de la société est acceptée.

Pleine et entière décharge leur est accordée pour l’exécution de leur mandat.

<i>Sixième résolution

Est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Snezana Culevska, serveuse, épouse de Monsieur Miroslav Nikolic, demeurant à L-5884 Hesperange, 424,

route de Thionville.

Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Miroslav Nikolic, serrurier, demeurant à L-5884 Hesperange, 424, route de Thionville.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leur noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Nikolic, M. Malinov, S. Culevska, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 24 mai 2006, vol. 362, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(081971.3/201/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

NIKOLIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 424, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 52.284. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081973.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

1.- Monsieur Miroslav Nikolic, serrurier, demeurant à L-5884 Hesperange, 424, route de Thionville, quatre-vingt-

dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Madame Snezana Culevska, serveuse, épouse de Monsieur Miroslav Nikolic, demeurant à L-5884 Hesperange,

424, route de Thionville, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Echternach, le 24 juillet 2006.

H. Beck.

Echternach, le 24 juillet 2006.

H. Beck.

92166

FONDATION LIGUE HMC, Etablissement d’Utilité Publique.

R. C. Luxembourg G 42. 

<i>Conseil d’Administration FONDATION LIGUE HMC du 22 mars 2006

Monsieur Baldauff Roland, Directeur des Bâtiments Publics en retraite, 5, rue M. de Busbach, L-1269 Luxembourg,

Luxembourg

Monsieur Berna Jean, Kinésithérapeute, 15, rue Belair, L-5318 Contern, Luxembourg
Monsieur Bernard François, Fontionnaire de l’Etat en retraite, 5, rue du Kiem, L-8328 Capellen, Luxembourg
Madame Bintener Gina, 94, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Luxembourg
Madame Brasseur Anne, Député, 29, rue Marie-Adelaïde, L-2128 Luxembourg, Luxembourg
Madame Braun-Breck Lotty, sans état, 28, rue Belle-Vue, L-8013 Strassen, Luxembourg
Monsieur Bruck Corneille, Fonctionnaire de l’Etat en retraite, 16, rue Albert Philippe, L-2331 Luxembourg,

Luxembourg

Monsieur Ewen Norbert, Professeur psychologue, 145, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Fayot Ben, Député au Parlement Européen, 36, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Fischbach Marc, Ombudsman, B.P. 21, L-7501 Mersch, Luxembourg
Monsieur Gengler Jos, Fonctionnaire de l’Etat en retraite, 28, rue Dr. Klein, L-9054 Ettelbruck, Luxembourg
Monsieur Gregorius René, Instituteur en retraite, 62, rue Fr. Gangler, L-1613 Luxembourg, Luxembourg
Dr. Hastert Fernand, Médecin spécialiste en neuropsychiatrie, 8, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Heintz Norbert, 53A, allée P. de Mansfeld, L-2118 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Juncker Jean-Claude, Premier Ministre, 4, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg, Luxembourg
Madame Lepage-May Gaby, Sans état, 2, rue des Champs, L-7764 Bissen, Luxembourg
Monsieur Linster Roger, Fonctionnaire de l’Etat en retraite, 14, rue S. vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg,

Luxembourg

Madame Marx-Moerschbacher Maria, sans état, 6, val des Romains, L-8149 Bridel, Luxembourg
Dr. Michels André, Médecin spécialiste en psychiatrie, 55, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Morby Jean, 45, rue des Prés, L-8265 Mamer, Luxembourg
Monsieur Moulin Robert, Ingénieur commercial, 21, rue Aloyse Hoffmann, L-5913 Roodt/Syr, Luxembourg
Monsieur Pull John, L-2227 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Reuter Fernand, Lic. en sciences commerc. et financ. 12, rue André Chevalier, L-1357 Luxembourg,

Luxembourg

Monsieur Rieff Paul, Inspecteur des Ecoles Européennes, 15, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Ruppert Marcel, Technicien ppal d’Arbed en retraite, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg, Luxembourg

Dr. Sandt Georges, Médecin spécialiste en neurochirurgie, 65, rue Th. Eberhard, L-1451 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Santer Jacques, Député au Parlement Européen, 69, rue J.P. Huberty, L-1742 Luxembourg, Luxembourg
Mgr Schiltz Mathias, Vicaire Générale, B.P. 419 L-2014 Luxembourg, Luxembourg
Monsieur Schleder Guy, Ministère de la Justice, 16, boulevard Royal, L-2934 Luxembourg, Luxembourg
Dr. Schmit Marc, Médecin spécialiste en maladies internes, 18, rue de la Piscine, L-8508 Redange-Attert, Luxembourg
Monsieur Seywert John, 11, avenue Princesse Grace, MC-98000 Monaco, Monaco
Madame Vouel Marianne, Pédagogue, psychologue, 3, Op Dirbett, L-3916 Mondercange, Luxembourg
Madame Wurth-Polfer Lydie, Député au Parlement Européen, 5, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,

Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067457.7//47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.

CONTROLSINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 114.010. 

<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la société le 3 juillet 2006

Le gérant unique de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04951. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088871.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signatures

92167

COOPERATIVES HMC, Société Coopérative.

Siège social: L-8311 Capellen, 82, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.331. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03124, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 11 juillet 2006.

(067472.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.

PLEIN SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 66.504. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

A comparu:

HADLEY PROPERTIES INC. P.O. IBC N

°

 52 422, avec siège social à Jasmine Court, 35A, Regent Street, P.O. 1777,

Belize City, Belize,

ici représentée par Madame Andreline Birgen-Silva, commerçante, avec adresse professionnelle au 74, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg,

en vertu d’une procuration générale émise à Belize, le 30 juin 2006.
Laquelle procuration générale, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme PLEIN SUD S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.504, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire alors de résidence à Capellen, en date du 16 septembre 1998, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 895 du 10 décembre 1998. 

- Le capital social était antérieurement fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois

(LUF), représenté par cent (100) actions ayant eu une valeur nominale de douze mille cinq cents (12.500,-) francs luxem-
bourgeois (LUF) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la

situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge-tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 1, rue Philippe II,

L-2340 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux cerificats d’actions au porteur numéros 1 et 2

lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PLEIN SUD S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: A. Birgen-Silva, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 8, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083669.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

M. Biver-Wildgen
<i>Secrétaire

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

A. Schwachtgen.

92168

LIFE CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 94.516. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05224, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(989101.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2006.

ITCHIBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 37B, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 95.288. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 24 août 2006, réf. DSO-BT00165, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(989319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2006.

ITCHIBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 37B, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 95.288. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 août 2006, réf. DSO-BT00166, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(989316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2006.

STRUWWELBUSCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7610 Larochette, 7, place Bleiche.

R. C. Luxembourg B 57.540. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05515, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2006.

(989884.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2006.

JAKOBSBERG CENTRUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.805. 

DISSOLUTION

La liquidation de la société JAKOBSBERG CENTRUM, S.à r.l. (en liquidation) a été clôturée lors de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 6 février 2006. La mise en liquidation ayant été décidée par acte
du notaire Maître Joseph Elvinger en date 14 décembre 2004.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social du liquidateur ALTER DO-

MUS, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088876.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Signature.

92169

TFAL INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.915. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 août 2006, réf. DSO-BT00156, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(991106.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006.

LEMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.597. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 août 2006, réf. DSO-BT00154, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(991114.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006.

EUROPEENNE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.774. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00323, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(991129.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006.

GREENWICH INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 119.665. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the eleventh day of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Alex N.J. van Zeeland, a private employee with professional address at 64, rue Principale, L-5367, Schuttrange,

Grand Duchy of Luxembourg.

Such appearing party, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

GREENWICH INVESTMENTS, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in
particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopt-
ed in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Wiltz, le 28 août 2006.

Signature.

Wiltz, le 28 août 2006.

Signature.

Bigonville, le 23 août 2006.

Signature.

92170

Art. 3. Object
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by

500 (five hundred) shares in registered form with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers, composed of at least one A manager and one B manager,

appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their
office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

92171

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures

of at least an A manager and at least a B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by general meeting of the shareholders;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the

Company are not threatened.

92172

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Alex N.J. van Zeeland, prenamed declares to subscribe for 500 (five hundred) shares in registered form,

with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash
amounting to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro).

The amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
- Alex N.J. van Zeeland, born on 16 October 1970 in ‘s Gravenhage, The Netherlands, with professional address at

64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg;

2. The following entity is appointed as B manager of the Company for an indefinite period:
- SHRM CORPORATE SERVICES, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under the number B 78.100.

3. The registered office of the Company is set at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

M. Alex N.J. van Zeeland, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 64, rue Principale, L-5367,

Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle a

arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination GREENWICH INVEST-

MENTS, S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans

les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Le siège social peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société estime

92173

que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit,
le risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes tran-

sactions relatives à l’immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rappor-
tent à, la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1 Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés est soumise à l’accord préalable de l’as-

semblée générale des associés représentant au oins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle a été notifiée à la Société ou

acceptée par elle conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La Société pourra racheter ses parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé au moins d’un gérant A et d’un gérant B, nommés par

résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixe le terme de leur mandat. Les gérants ne
doivent pas nécessairement être associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plusieurs gérants, du conseil de gérance,
qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.

92174

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par
écrit, soit en original, par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix exprimées. Les résolutions
du conseil de gérance seront consignées en procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la
réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par les signatures

conjointes d’au moins un gérant A et au moins un gérant B, ou par la ou les signature(s) individuelles ou conjointes de
toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces en-
gagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales de la Société qu’il dé-

tient.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant toute

autre personne ou entité comme son mandataire par écrit que ce soit par courrier, télégramme, télex, téléfax ou par
courrier électronique.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par
courrier ou par téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social de la Société.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant unique ou le conseil

de gérance prépare le bilan et le compte des pertes et profits ainsi qu’un inventaire donnant une indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants,
du commissaire aux comptes (s’il y en a un) et des associés envers la Société.

14.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan mentionnés ci-dessus au siège social de la

Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

92175

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant. Elle pourra en

particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions

suivantes:

(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

(iii) L’assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d’acomptes sur dividen-

des;

(iv) La décision susvisée n’est adoptée que dans la mesure où la Société s’est assurée que les droits des créanciers de

la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes
de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-

tribué à l’associé ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales déte-
nues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, M. Alex N.J. van Zeeland., prénommé déclare souscrire à 500 (cinq cents) parts sociales sous forme nomina-

tive, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et de les libérer intégralement par versement en
numéraire d’un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros).

La somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, comme il en a été prouvé

au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille euros.

<i>Décision de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée gérant A de la Société pour une durée indéterminée:
- Alex van Zeeland, employée privée, né le 16 octobre 1970 à ‘s Gravenhage, Hollande, demeurant au 64, rue Prin-

cipale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg;

2. L’entité suivante est nommée gérant B de la Société pour une durée indéterminée:
- SHRM CORPORATE SERVICES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siege social au 64, rue Prin-

cipale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 78.100.

3. Le siège social de la Société est fixé au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, constate qu’à la demande du comparant ci-dessus, le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. N.J. van Zeeland, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 5, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104774.3/211/401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

J. Elvinger.

92176

KOLE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.816. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 août 2006, réf. DSO-BT00155, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(991158.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006.

METTY WEYRICH &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9416 Vianden, 6, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 102.060. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 17 août 2006, réf. DSO-BT00135, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(991480.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006.

LUX-FORETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7590 Beringen, 51, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.612. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07651, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(991555.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2006.

F.N.S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.883. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of the month of June.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

Appeared:

M

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg, 

acting as special proxy of RICHEMONT HOLDINGS S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg

and having its registered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (the «RHSA»), by virtue of a proxy
given under private seal which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
will be registered with the present deed.

The proxy declared and requested the notary to state:
I. That the société anonyme F.N.S.A. HOLDING (S.A.), having its registered office at 35, boulevard Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg, under number B 39.883
(the «Company»), has been incorporated by a deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, on 4th
March 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 376 on 2nd
September 1992. The articles of incorporation of the Company have been amended several times and for the last time
by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 21st December 2000, published in the Mémorial
number 715 on 3rd September 2001.

II. That the subscribed and paid-in capital of the Company is presently of one hundred and sixty million Euros (EUR

160,000,000.-) fully paid up, represented by three million six hundred and sixty-three thousand (3.663.000) shares with
no par value.

III. That RHSA declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the

Company.

IV. That RHSA has acquired all shares of the Company referred to above and that as the sole shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company. It assumes the function of liquidator.

V. That RHSA declares that all liabilities of the Company have been paid up, without prejudice to the fact that it will

be personally liable for all outstanding liabilities of the Company after its dissolution.

VI. That the shareholder’s register of the dissolved Company has been cancelled.

Wiltz, le 28 août 2006.

Signature.

Diekirch, le 29 août 2006.

Signature.

M. Dos Anjos Mota Dinis
<i>Le gérant

92177

VII. That RHSA fully discharges the board of directors and statutory auditor for the performance of their duties up

to this date.

VIII. That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the former registered

office of the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document, after having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huitième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

M

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de

RICHEMONT HOLDINGS S.A., une société constituée selon les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 35,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg («RHSA») en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir
été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le mandataire a déclaré et prié le notaire d’acter:
I. Que la société anonyme F.N.S.A. HOLDING (S.A.), ayant son siège social au 35, boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 39.883 (la «Socié-
té»), a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 4 mars 1992,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 376 du 2 septembre 1992. Les sta-
tuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, du 21 décembre 2000, publié au Mémorial numéro 715 le 3 septembre 2001.

II. Que le capital souscrit de la Société s’élève actuellement à cent soixante millions euros (EUR 160.000.000,-) en-

tièrement libéré, représenté par trois millions six cent soixante-trois mille (3.663.000) actions sans valeur nominale.

III. Que RHSA déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
IV. Que RHSA a acheté toutes les actions de la Société mentionnées ci-dessus et qu’en tant qu’actionnaire unique il

déclare expressément procéder à la dissolution de la Société. Elle assume la fonction de liquidateur.

V. Que RHSA déclare que toutes les dettes de la Société ont été payées, sans préjudice du fait qu’elle restera per-

sonnellement responsable des dettes de la Société qui interviendront après sa dissolution.

VI. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.
VII. Que RHSA a donné décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exécution de

leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de la Société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparant le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante

a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: K. Panichi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 juin 2006, vol. 437, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083320.3/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

ASSOCIATION DE PARTICIPANTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 22.753. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06309, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088405.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Mersch, le 6 juillet 2006.

H. Hellinckx.

Signature.

92178

FONDATION PAULINE DE FAILLONNET, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d’Anvers.

BILAN 2005

COMPTE RESULTAT 2005

BUDGET 2006

Conseil d’Administration:

Madame Annette Hutsch, Supérieure Provinciale des Soeurs de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg, Présidente
Madame Philomène Hoffmann, Présidente AGEDOC, A.s.b.l., Luxembourg
Madame Danière Faltz, Directrice de l’Ecole Privée Fieldgen, Luxembourg
Monsieur Robert Biever, Docteur en droit, Luxembourg
Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068179.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.

COMPAGNIE PIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 99.748. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06308, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088404.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

R.S.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 73.041. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02512, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2006.

(088525.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

<i>ACTIF

<i>PASSIF

Fonds social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.449.627,73

Disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.593.819,29

Débiteurs divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.234.773,95
Excédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

909.417,61

20.593.819,29

20.593.819,29

<i>CHARGES

<i>PRODUITS

Apport Agedoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297.949,40

Frais financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,98

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126.250,00

Excédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

909.417,61

Produits financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485.235,19

909.434,59

909.434,59

<i>CHARGES

<i>PRODUITS

Subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000,00

Produits financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450.000,00

Excédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000,00

450.000,00

450.000,00

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour R.S.R. S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

92179

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA SPECIALISATION EN MEDECINE VETERINAIRE 

CLINIQUE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg F 4.152. 

Suite aux décisions prises lors de l’assemblée générale du 11 juillet 2006, les modifications qui suivent ont été adop-

tées à l’unanimité des voix:

1. Le siège de l’association se trouve transféré au 1

er

 juin 2006 au 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

L’article 3 des Statuts se trouve modifié comme suit:

Art. 3. Siège Social. Le siège social est fixé au 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
II pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration.
2. Les membres ont approuvé le changement de l’alinéa 1

er

 de l’article 6 des statuts, concernant les Membres Fonda-

teurs et dispensés de cotisation, comme suit:

Art. 6. Les Membres
Sont Membres Fondateurs et dispensés de cotisation, les trois adhérents ci-dessous nommés:
- Cadot Pierre, Docteur Vétérinaire,
Clinique Vétérinaire Europa,
54-56, avenue Pierre Grenier, F-92100 Boulogne-Billancourt;

- Koch Hans-Joachim, Docteur Vétérinaire,
Tierärztliche Klinik,
Am Schönenwald, D-55765 Birkenfeld;

- Vandevelde Marc, Docteur Vétérinaire, Professeur, Université de Berne, Suisse,
Institute of Animal Neurology, University of Berne,
Bremgartenstrasse 109A, CH-3012 Berne.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03252. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(083911.5//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

LINK LOGISTICS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 45.964. 

<i>Auszug aus den Beschlüssen der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. April 2006 in Luxemburg

Folgende Verwaltungsratsmitglieder werden einstimmig gewählt: 
- Herr Alois Kettern (Kaufmann), Hautpstrasse, 19A, Heddert; 
- Herr Jean Link (Licencié H.E.C.), rue d’Olm, 18, L-8392 Nospelt;
- Herr Frank Grueber (Kaufmann), Wasserlochstucke, 2, D-67661 Kaiserslautern;
- Herr Jean-Paul Kieffer, rue des Jardins Fleuris, 15, F-57100 Veymerange. 
Die FIDUCIAIRE MARC MULLER wird einstimmig als Rechnungsprüfer für das Jahr 2006 ernannt.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087097.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

OMEGA SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 55.200. 

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02149, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088869.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR VETERINARY SPECIALIZATION
Signatures

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

92180

FIELD POINT PE VIII (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 119.208. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of August.
Before the undersigned Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., a société à reponsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register under No. B 11.4791,

duly represented by Ms Nadège Anen, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 24 August 2006.
This proxy, after having been signed 'ne varietur' by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-

lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and disposition of shares of stock, equity interests and other

equity securities, loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances, and other debt instruments and securities,
whether unsecured or secured by equipment, personal property, receivables and other collateral other than real estate,
issued or assumed by companies domiciled either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the manage-
ment of all operations relating to such shares, loans and other equity and debt instruments and securities, including the
direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies acting as debtors, borrowers or obli-
gors.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale, as well the holding, leasing, improving, managing

and mortgaging of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management
of all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxem-
bourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of FIELD POINT PE VIII (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only
be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

92181

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. The board shall be composed of at least one A manager and at least one B manager.

In that case, the company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A manager and one B man-

ager.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («'cause légi-

time»).

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or by two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of man-
agers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of
the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such
meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholders - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-

92182

tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by these articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., prenamed, for

a total price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro (EUR 1,900.00).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, the Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Victor Khosla, Manager A, born on 29 June 1958 in Delhi, India, residing at 80 Midwood Road, Greenwich, CT

06830, USA;

- Mr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing in 3, St.

Michael’s Mews, London SW1W8JZ, United Kingdom;

- Mr Michel Van Krimpen, Manager B, born on 19 February 1968 in Rotterdam, the Netherlands, residing in 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg; and

- Mr Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, residing in 14, rue Erasme, L-2010 Luxem-

bourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English ver-
sion will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said person proxyholder ap-

pearing signed together with Us the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den fünfundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht von Lu-

xemburg, mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxem-
burg unter der Nummer B 11.4791,

hier vertreten durch Fräulein Nadège Anen, wohnhaft zu Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 24. August 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Vertreterin der Erschienenen und den unterzeichneten

Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-

92183

schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung von Aktienanteilen, Kapitalbeteiligungen und

anderen Beteiligungstiteln, Darlehen, Obligationen, Schuldscheinen, Krediten und anderen Schuldtiteln und Wertpapie-
ren, ob ungesichert oder gesichert durch Einrichtungen, persönliches Eigentum, Forderungen und andere Sicherheiten,
bei denen es sich nicht um Grundstücke handelt, die von Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg oder im Ausland ausge-
geben oder übernommen werden, sowie die Verwaltung aller Geschäfte in Zusammenhang mit solchen Anteilen, Dar-
lehen und anderen Eigenkapitalinstrumenten, Schuldtiteln und Wertpapieren, einschließlich der direkten oder indirekten
Beteiligungen in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die als Schuldner oder Kreditnehmer handeln.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung,

die Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie
die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in lu-
xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Ver-
kauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus Garantien übernehmen für Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indi-

rekte Beteiligung hält oder die derselben Gruppe angehören wie die Gesellschaft, und kann diesen Gesellschaften Dar-
lehen gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FIELD POINT PE VIII (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den. Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Aus-
land eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapital bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die minde-

stens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder

Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müs-

sen.

Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch

die Dauer ihres Mandates.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus minde-

stens einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer, verwaltet.

In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und

einem B Geschäftsführer verpflichtet.

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 13. Der Geschäftsführerrat kann aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch

einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates
sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

92184

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Im Falle einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebenen Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes
kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sit-
zungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen sei-
ner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-

den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung erfordert die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zu-
stehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-

ßigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-

92185

fugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., vorgenannt, für

einen Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet;

Alle Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500),

der vollständig dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde, von nun an der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro (EUR 1.900,00) geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Lu-

xemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt:
- Herr Victor Khosla, Manager A, geboren am 29. Juni 1958 in Delhi, Indien, wohnhaft in 80 Midwood Road, Green-

wich, CT 06830, USA;

- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft in 3,

St. Michael’s Mews, London SW1W8JZ, Vereinigtes Königreich von England;

- Herr Michel Van Krimpen, Manager B, geboren am 19. Februar 1968 in Rotterdam, Niederlande, wohnhaft in 9, rue

Schiller, L-2519 Luxemburg; und

- Herr Pierre Beissel, Manager B, geboren am 25 April 1973 in Luxemburg, wohnhaft in 14, rue Erasme, L-2010 Lu-

xemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Vertreterin der vor-

genannten Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Vertreterin der Erschienene, hat dieselbe mit dem Notar

gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: N. Anen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, vol. 155S, fol. 24, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099907.3/230/347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

INVEST CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 113.977. 

<i>Extrait des résolutions prises par le gérant de la société, le 3 juillet 2006

Le gérant de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088874.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Luxembourg, den 18 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

TCG GESTION S.A.
Signatures

92186

E.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 60.217. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06314, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088406.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

U.A.I. (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.050.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.894. 

EXTRAIT

L’associé unique de la Société, U.A.I. (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., une société constituée et régie sous les lois du

Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a décidé en date du 9 août 2006:

- d’accepter la démission de Monsieur Troy William Thacker comme gérant de la Société à compter du 9 août 2006;
- de nommer, pour une durée illimitée et avec effet immédiat, Monsieur David R. Whiting, President and Chief Exe-

cutive Officer, né le 20 juillet 1954 à Toronto, Etats-Unis, ayant pour adresse professionnelle Burnaby Building, 16 Bur-
naby Street, PO Box HM 716, Hamilton, Bermuda HMCX, comme gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088455.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

LA VIEILLOTTE, Société Civile Particulière.

Siège social: L-7416 Brouch, 1, rue du Village.

R. C. Luxembourg E 2.577. 

Constituée par acte du notaire Robert Eltwer du 5 décembre 1980, statuts modifiés par acte sous seing privé du 21 juin

1999 déposé au rang des minutes du notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, le 15 novembre 1999, et
encore par acte sous seing privé du premier mars 2003 selon publications au Mémorial C 23 du 5 février 1981,
Mémorial C 902 du 29 novembre 1999 et non encore publié.

EXTRAIT

<i>Capital social

Il résulte des délibérations de l’assemblée générale des associés du 1

er

 mars 2003 que les deux premiers alinéas et la

première phrase du 3

e

 alinéa de l’article 5 des statuts a été modifié comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent quarante et un mille cinq cents (441.500,-) euros, représenté par dix-

sept mille six cent soixante (17.660) parts d’intérêt d’une valeur de vingt-cinq euros chacune.

Il est comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.
2) L’assemblée générale des associés du 1

er

 mars 2003 a, en outre, apporté aux statuts les modifications suivantes:

L’assemblée a décidé de proroger la durée de la société en une durée indéterminée et de modifier l’article 3 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. «La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision des associés

prise à la majorité de deux tiers des parts d’intérêt existantes.

L’année sociale commencera le premier janvier et de terminera le trente et un décembre de chaque année.
L’assemblée a décidé de modifier l’article 6 des statuts pour y remplacer les mots «à la majorité de trois quarts des

voix» par les mots «à la majorité de deux tiers des parts d’intérêt.»

L’assemblée a décidé de modifier l’article 10 des statuts pour remplacer au dernier alinéa les mots «une majorité de

soixante-seize pour cent (76%) «par les mots «une majorité de deux tiers des parts d’intérêt» et pour remplacer au

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour U.A.I. (LUXEMBOURG) II, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

1. Mme Gisela Rühl, 1, rue du Village, L-7416 Brouch (M), douze mille parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000

2. M. Jean-Claude Wolter, 153 Dufourstrasse, CH-2504 Bienne, Suisse, cinq mille six cents part sociales . .

5.600

Total: dix-sept mille six cent soixante parts d’intérêt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.660

92187

point 5 à la dernière ligne de l’article 10 des statuts le chiffre d’un million de francs par celui de vingt-cinq mille (25.000)
euros.

L’assemblée a décidé de modifier l’article 12 des statuts pour y biffer les mots «et pour la première fois en 1981». 
L’assemblée a décidé de modifier l’article 14 des statuts pour donner à la première phrase du troisième alinéa la te-

neur suivante:

«Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer, elle doit être composée d’associés représentant les deux tiers

au moins de toutes les parts.»

En outre elle a décidé de donner à la première phrase du dernier alinéa de l’article 14 la teneur suivante:
«Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentées, sauf ce qui est dit

aux articles six, dix et quinze.»

L’assemblée a décidé de donner à l’article 15 des statuts la teneur suivante:
«L’assemblée générale extraordinaire peut apporter des modifications aux statuts, quelles qu’en soit l’importance ou

la nature. Dans ce cas, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit des associés représentant
les deux tiers au moins de toutes les parts et ses délibérations doivent être approuvées à la majorité de deux tiers des
parts existantes.»

Changement d’adresse d’un associé-gérant:
L’adresse de M. Jean-Claude Wolter, préqualifié, depuis le 1

er

 janvier 2005 est: 232, rue Edith Cavell, B-1180 Bruxel-

les.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04371. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086518.3//55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

BB &amp; MT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 63.908. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02510, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2006.

(088528.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.122. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT06160, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089389.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.122. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT06157, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089390.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour la gérance
Signature

<i>Pour BB &amp; MT S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

Luxembourg, le 18 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 18 août 2006.

Signature.

92188

TARRANT MANAGEMENT - LU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 119.667. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of the month of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TARRANT PARTNERS L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Texas and having its

registered office at 301 Commerce St. Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102 and being registered under number 75-
2447913, acting through its general partner, TARRANT ADVISORS Inc., represented by M

e

 Céline Larmet, maître en

droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 26th July 2006 (such proxy to be registered together with the
present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company TARRANT MANAGEMENT - LU, S.à r.l. («société à responsabilité limitée»)
which is hereby established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name TARRANT

MANAGEMENT - LU, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In

a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further proceed to the purchase, or renting of real estate in any form, and sublease to, or put at

the disposal of, such real estate to companies, entities or undertakings which belong to, are related or affiliated with,
directly or indirectly, the group of companies to which the Company belongs, any companies, entities or undertakings
which are directly or indirectly under the same dominant influence through participations or interests held, agreement,
management or otherwise than the Company or the ultimate parent of the Company or the subsidiaries of such parent
and any companies, undertakings or entities which are connected to the Company through the holding of participations
or interests by the ultimate parent of the Company or its subsidiaries.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500,-) divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-
ment of these articles of association.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by

law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five
percent of the Company’s capital.

92189

Art. 7. Management, binding signature. The Company is managed by one or several managers who need not

be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a man-
ager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers [twenty-four hours] at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be
validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated
by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or any one of the managers or,
in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

Art. 8. Liability Managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As

agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all ex-
penses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all
claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words
«liability» and «expenses» shall include without limitation attorneys’ fees, costs, judgements, amounts paid in settlement
and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon re-
ceipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions and has a number of

votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

92190

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as

prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly con-
stituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent
the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on

the second Tuesday in May of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately
following business day.

Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on first of January of each year and ends on the thirty-first

December of the same year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by

the manager or as the case may be, the board of managers.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders
who will specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company

shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to

the relevant legislation.

<i>Subscription and Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and entirely paid-up the five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each. Payment of an amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) (being the equivalent of fifteen thousand
eight hundred and forty-four point six Euro (EUR 15,844.6) at the exchange rate published on oanda.com on 26th July
2006) was evidenced to the notary. An amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is allocated the
share capital and the remainder to the freely distributable premium.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

92191

2. The Company shall have a board of managers as set out hereafter for an undetermined period (subject to the

provisions of the articles). The following persons are named managers, each with sole signature power to bind the
Company:

(i) Mr David Bonderman, president, with professional address at 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth,

Texas 76102, born in New York City, United States on 27th November 1942.

(ii) Mr James George Coulter, vice-president, with professional address at 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort

Worth, Texas 76102, born in Buffalo, New York, United States on 1st December 1959.

(iii) Mr William Stanley Price III, vice-president, with professional address at 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort

Worth, Texas 76102, born in Los Angeles, CA, United States on 20th April 1956.

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on thirty-first of December

2006.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huitième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TARRANT PARTNERS L.P., une limited partnership créée et existante sous les lois du Texas et ayant son siège social

à 301 Commerce St. Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102 et étant enregistrée sous le numéro 75-2447913, agissant
par son partenaire général, TARRANT ADVISORS Inc, représentée par M

e

 Céline Larmet, maître en droit, demeurant

à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 26 juillet 2006 (cette procuration étant enregistrée avec le présent
acte).

Lequel comparant agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée TARRANT MANAGEMENT - LU, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TARRANT MANAGEMENT - LU, S.à r.l. (la «Société»). La
Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des so-

ciétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par
tout autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance,
notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de
son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité
par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

La Société peut procéder par ailleurs à l’acquisition ou à la location, de toute forme, d’immeubles et sous-louer, ou

mettre à disposition ces immeubles à des sociétés, entités ou organismes qui appartiennent, sont liés ou affiliés, de façon
directe ou indirecte, au groupe des sociétés auxquelles la Société appartient; à toutes sociétés, entités ou organismes
qui sont, de façon directe ou indirecte sous la même influence dominante à travers des participations ou intérêts, ac-
cords, gestion ou autrement que la Société ou la société faîtière ou des filiales d’une telle société faîtière et toutes so-
ciétés, entités et organismes qui sont liés à la Société à travers la détention de participations ou intérêts par la Société
faîtière ou ses filiales.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-
semblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée

92192

de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

divisé en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Le capital de la
Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification
des présents statuts.

Art. 6. Transfert des parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposi-

tions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agré-
ment donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite concernant chaque réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins 24

heures avant la date prévue pour à la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
doivent être mentionnés dans cette convocation. Cette convocation peut-être omise par l’assentiment de chacun des
gérants donné soit par écrit, par câble, par télégramme, télex, e-mail ou fax, ou par tout autre moyen similaire de com-
munication. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance si le lieu et l’endroit
ont été déterminés dans une résolution antérieurement adoptée par le conseil de gérance.

L’assemblée générale des associés peut décider de désigner des gérants de deux classes différentes, les gérants de

classe A et les gérants de classe B. Cette classification de gérants devra être dûment enregistrée dans le procès-verbal
de cette assemblée générale et les gérants devront être identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement par approbation à la majorité des gérants de la Société.

Au cas où l’assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants (notamment des gérants de classe
A et des gérants de classe B) chaque résolution du conseil de gérance ne sera valablement prise que si approuvé par la
majorité des gérants y incluant au minimum un gérant de classe A et un gérant de classe B (y inclus par voie de repré-
sentation).

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la seule signature au cas où il y a un seul gérant, et au cas où il y a un conseil de gérance,

par la signature de chacun des gérants, à condition que si l’assemblée générale des associés a désigné deux classes dif-
férentes des gérants (notamment des gérants de classe A et des gérants de classe B) la Société ne sera valablement en-
gagée que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B. En tout cas, la Société sera
valablement engagé par la seule signature d’une personne ou de personnes à laquelle/auxquelles des pouvoirs de signa-
ture auront été délégués par le gérant (s’il y en a qu’un) ou selon le cas, par le conseil de gérance ou par chacun des
gérants ou s’il y a des classes différentes de gérants par un gérant de classe A et par un gérant de classe B agissant de
concert.

Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne seront pas personnellement tenus responsables pour les dettes

de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs mandats.

Sous réserve des exceptions et limitations prévues à ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, un gérant ou un

fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la
responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celui-ci en relation avec une prétention,
action, poursuite ou procédure judiciaire qui le rend insolvable en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu’il est
ou a été Gérant ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu’il aurait payés ou supportés
afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes «prétention», «action», «poursuite» ou «procédure judiciaire»
s’appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les
appels) actuels ou possibles et les termes «responsabilité» et «dépenses» incluront sans limitation les honoraires d’avo-
cat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d’une transaction et autres montants dus par la Société.

92193

Aucune indemnisation ne sera due à un Gérant ou à un fondé de pouvoir:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d’un abus de pou-

voir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d’imprudence dans l’accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonc-
tion;

(ii) Pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non

dans l’intérêt de la Société; ou

(iii) En cas de transaction, à moins que la transaction n’ait été approuvée par une cour d’une juridiction compétente

ou par le conseil de gérance.

Le droit d’être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque gérant et n’affectera pas tout autre

droit dont un gérant ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l’égard
d’une personne ayant cessé d’être gérant ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentai-
res et administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n’affecteront aucun droit à indemnisation dont
pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les Gérants et fondés de pouvoir en vertu d’un contrat ou
autrement en vertu de la loi.

Les dépenses supportées en relation avec la préparation d’une défense et la représentation dans le cadre d’une pré-

tention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant
toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l’engagement par ou pour compte du
fondé de pouvoir ou le Gérant de rembourser ce montant s’il est finalement décidé qu’il n’aurait pas eu droit à une
indemnisation conformément au présent article.

Art. 9. Droit de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un por-
teur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues

par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors
d’assemblées. Toute assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis
par la loi le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convo-
cation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolu-
tions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées si

elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au deuxième mardi du mois de mai. Si ce
jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et

un décembre de la même année.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes

annuels au 31 décembre.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

92194

Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules

mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dis-

positions légales en vigueur.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les

cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Preuve du paiement d’un mon-
tant de vingt mille dollars US (USD 20.000,-) (équivalant à quinze mille huit cent quarante-quatre virgule six euros (EUR
15.844,6) au taux de change qui apparaît sur oanda.com le 26 juillet 2006) a été apportée au notaire instrumentant. Un
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est alloué au capital et le montant restant à la prime d’émission
librement distribuable.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au:
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
2. La Société aura un conseil de gérance composé comme suit pour une durée indéterminée (sous réserve des statuts

de la Société). Les personnes suivantes sont nommées gérant, chacune avec pouvoir de signature individuelle:

(i) M. David Bonderman, président, domicilié à 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, né à

New York-City, United States le 27 novembre 1942.

(ii) M. James George Coulter, vice-président, domicilié à 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas

76102, né à Buffalo, New York, United States le 1

er

 décembre 1959.

(iii) M. William Stanley Price III, vice-président, domiciliée à 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas

76102, né à Los Angeles, CA, United States le 20 avril 1956.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2006.
En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 21, case 11. – Reçu 158,45 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104777.3/211/414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PROMOTECNIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 46.608. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02146, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088873.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

AQSACOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 93.982. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02508, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2006.

(088531.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

<i>Pour <i>AQSACOM INTERNATIONAL S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

92195

SUN SQUARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9156 Heiderscheid, 4, Fuussekaul.

R. C. Luxembourg B 111.239. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02523, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2006.

(088545.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

COPECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.

R. C. Luxembourg B 37.017. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02522, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2006.

(088547.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

OLIVI ANTONIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1455 Howald, 19, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 27.259. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02520, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2006.

(088550.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

INTERTECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.181. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02144, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088877.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

GDK S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 29.784. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02142, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088879.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

<i>Pour <i>SUN SQUARE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour <i>COPECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour OLIVI ANTONIO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

92196

WACTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 105.051. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02519, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2006.

(088554.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

A.R.I. AMUSEMENT RIDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 25.574. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02140, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088881.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

BENELUX TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 218, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.165. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00030, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088882.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

BC TNLGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 90.253. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 20 juillet 2006 que, sur base de

l’article 1

er

 des statuts, il a été décidé de:

Transférer le siège social de la société BC TNLGY S.A.,
du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05772. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088971.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

LE SOT L’Y LAISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 105.984. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00027, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088891.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

<i>Pour <i>WACTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

92197

SPRINGWATER PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 119.727. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-fifth day of the month of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

FONTAINE INVESTMENT HOLDINGS LTD, a company incorporated under the laws of Malte, having its registered

office at 85, St John Street, Valletta VLT 09, Malte registered with Trade Register in Malta under number C36335, rep-
resented by Mr Martin Gruschka, with address in 34, Chemin de Grange Canal, 1224 Chenes Bougeries, Switzerland, in
his capacity as director of the company;

here represented by Mr François Manti, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given on 22nd September 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Art. 1. There exists established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

of SPRINGWATER PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l. (the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities, patents and to grant loans to its subsidiaries and to related companies.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the ob-
ligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) repre-

sented by one hundred (100) shares having a nominal value of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) per share.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-

holders will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meet-

ing of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which
he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the man-
agers present or represented at the board meeting.

92198

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or

telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one anoth-
er. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented
at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.

Art. 14. The Company’s year starts on the first day of January of each year and ends on the 31st of December the

same year.

Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act of 10 August 1915 on commercial companies,

as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All one hundred (100) shares have been subscribed by the company FONTAINE INVESTMENT HOLDINGS LTD.,

prenamed, and have been fully paid-up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro

92199

(12,500.- EUR) is as now at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned
notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately thousand four hundred euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1.- The number of managers is set at one (1).
Is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40.312).

2.- The registered office is established at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the same proxy holder signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinquième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

FONTAINE INVESTMENT HOLDINGS LTD., une société de droit maltais, avec siège social à 85, St. John Street,

Valletta VLT 09, Malte, enregistrée auprès du Registre des sociétés à Malte sous le numéro C 36335, représentée par
M. Martin Gruschka, avec adresse au 34, Chemin de Grange Canal, 1224 Chenes Bougeries, Switzerland, and M. Manilo
Marocco, avec adresse au 29, Lennox Gardens, London SW1X ODE, agissant en tant qu’administrateur de la société;

ici représentée par Monsieur François Manti, employé, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 22 septembre 2006.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de SPRINGWATER PROPERTY

INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l. (ci-après, la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer à la constitution, au développement et au
contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des va-
leurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour développer
ses valeurs mobilières, brevets et pour accorder des prêts à ses filiales et à des sociétés liées. La Société peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie
de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté

par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

92200

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de

gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants pré-
sents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L’assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réu-
nion de s’entendre mutuellement. La participation d’un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en per-
sonne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du
conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s’il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réu-
nion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d’une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réu-
nion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

92201

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par la société FONTAINE INVESTMENT HOLDINGS LTD., prénom-

mée et ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
taire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique prénommé, représentant la totalité du capital

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérant est fixé à un (1).
Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).

2.- Le siège social de la société est établi au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante

l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: F. Manti, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2006, vol. 907, fol. 33, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105563.3/239/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

NET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 26.938. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01101, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 août 2006.

(089338.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Belvaux, le 28 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature 

92202

AGROLUX ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2270 Luxembourg, 14, rue d’Orval.

R. C. Luxembourg B 96.247. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00026, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088893.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

ENTAMI TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 99.518. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088894.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

DEMATRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8826 Perlé, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 82.835. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00024, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088896.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

TARN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 84.029. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05824, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089407.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

VGL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 18, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 115.795. 

EXTRAIT

Il découle d’une assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 18 juillet 2006, enregistré à Luxembourg-So-

ciétés, en date du 2 août 2006, référence LSO-BT01137, que:

l’adresse de la société est fixée à L-4040 Esch-sur-Alzette, 18, rue Xavier Brasseur.
Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Esch-sur-Alzette, le 16 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06092. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088990.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

TARN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour le notaire
A. Biel

92203

DUBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.949. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

AMARILE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 27.775. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088899.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

PP GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 109.353. 

Le bilan au 31 juillet 2006, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07026, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088906.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

REGOLO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.340. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06303, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

REGOLO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.340. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06306, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088928.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

REGOLO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.340. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06307, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

92204

CROWN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 40.323. 

Les comptes annuels (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-

BT05336, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088994.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

TANDEM PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 115.074. 

Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 31 juillet 2006, le siège social de la société a été transféré

du 8, Op de Rousen, L-8398 Luxembourg au 16, rue Beck, L-1222 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05475. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088996.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

PITCAIRN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 99.794. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06499, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2006.

(089320.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

PITCAIRN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 99.794. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06501, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2006.

(089317.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE LA VIANDE, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.970. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03240, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Luxembourg, le 18 août 2006.

Signature.

<i>Pour TANDEM PARTNERS, S.à r.l.
C. Smith
<i>Gérant

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Strassen, le 16 août 2006.

Signature.

92205

NERO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 63.439. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01081, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 août 2006.

(089326.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

NERO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 63.439. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01119, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 août 2006.

(089328.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

MAC-PHILSON HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 51.198. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01087, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 août 2006.

(089330.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

MAC-PHILSON HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 51.198. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01090, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 août 2006.

(089333.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

PROMOTER, Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Stammkapital: 12.500,- EUR.

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 30, rue Marie-Adelaïde.

H. R. Luxemburg B 118.638. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, am zwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Martinus Leonard Zuiddam, geboren am 22. Mai 1971 in Rotterdam (Niederlande), wohnhaft in Schietspoel 31,

NL-1211DK Hilversum.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Ein-Personen-Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

92206

Art. 1. Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschließlich den Änderungsgesetzen und insbe-
sondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist:
1. Die Beteiligung in gleich welcher Form an sämtlichen bestehenden oder noch zu gründenden Gesellschaften und

Unternehmen, sowie jegliche Investitionen und Finanztransaktionen mit Ausnahme solcher Transaktionen, die den De-
positenbanken und Sparkassen vorbehalten sind.

2. Die Verwaltung eines aus Mobiliar- und Immobiliargütern zusammengesetzten Vermögens, die Wertsteigerung und

Erhaltung dieses Vermögens, vor allem durch Verwaltungshandlungen.

Unter Verwaltung ist in diesem Sinne zu verstehen, dass der Ankauf und die Veräußerung zulässig sind, sofern sie zu

einer günstigeren Zusammensetzung des Gesellschaftsvermögens zweckdienlich bzw. erforderlich sind oder dazu bei-
zutragen vermögen.

Zu diesem Zwecke darf die Gesellschaft sämtliche Mobiliar- und Immobiliargeschäfte sowie jegliche Finanztransaktio-

nen verrichten, wie unter anderem Mobiliar- und Immobiliargüter an- und verkaufen, Immobilien ausstatten, aufbessern,
neu gestalten und vermieten, und alle möglichen Immobiliargeschäfte im weitesten Sinne des Wortes tätigen, sowie den
Erwerb, die Veräußerung und die Anlage in Wertpapieren und in sonstigen Werten vornehmen.

Vorbehaltlich der ausdrücklichen Genehmigung der Kommission für das Bank- und Finanzwesen darf die Gesellschaft

keine Aktivitäten ausüben, die von Unternehmen für Vermögensverwaltung und Anlageberatung vorbehalten sind.

3. Die Führung eines Forschungs-, Organisations- und Beratungsbüros in wirtschaftlichen, Handels-, Steuer-, Rechts-

und Sozialangelegenheiten.

4. Jegliche Aktivitäten wie u.a. die Ausbildung, Beratung, Dienstleistung, Unterstützung und Einarbeitung in den vor-

stehend angeführten Angelegenheiten, sowie im Bereich des Managements, der Beratung und Ausbildung, der Personal-
politik, der Personalanwerbung und -auswahl, des Coachings, der Unternehmensorganisation und der allgemeinen
Unternehmenspolitik und Finanzverwaltung.

5. Das Auftreten als Vorstand, Geschäftsführer, Beauftragter, Bevollmächtigter, Treuhänder und Liquidator von Un-

ternehmen und Gesellschaften und, im Allgemeinen, die Vertretung Dritter sowie die Wahrnehmung und Vertretung
der Interessen Dritter im weitesten Sinne des Wortes.

6. Die Vertretung, das Auftreten als Zwischenhändler, die Förderung des internationalen Handelsverkehrs im Allge-

meinen, und die Absicherung gegen latente Risiken wie insbesondere Wechsel-, Debitoren-, Kredit- und Transportrisi-
ken usw.

7. Die Wahrung kommerzieller und finanzieller Interessen Dritter auf den internationalen Märkten. Dies alles sofern

vom Gesetz genehmigt und vorbehaltlich der gegebenenfalls erforderlichen Ermächtigungen für die betreffenden Ge-
schäfte.

Die Wahrnehmung und Ausübung von jeglichen Verwaltungs- und Führungsaufgaben und -mandaten. Die Gesellschaft

handelt auf eigene Rechnung, auf Kommissionsbasis, als Zwischenhändler oder als Vertreter.

Sie darf ihre Immobilien mit Hypotheken belasten und alle ihre sonstigen Güter, einschließlich des HandeIsgeschäfts,

verpfänden. Ferner darf sie für sämtliche Darlehen, Krediteröffnungen und sonstige Verpflichtungen sowohl für sich
selbst als auch für Dritte eine Bürgschaft leisten.

Die Gesellschaft darf jegliche finanziellen, kommerziellen oder industriellen Mobiliar- und Immobiliargeschäfte tätigen,

die direkt oder indirekt zur Umsetzung des Gesellschaftsgegenstands beitragen können oder ihren Handel und ihre ge-
werbliche Tätigkeit zu fördern vermögen.

Sie kann sich an jeglichen Gesellschaften, Unternehmen, Gruppen oder Organisationen sowohl im In- als auch im Aus-

land beteiligen oder sich auf andere Weise dafür interessieren.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung PROMOTER.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in ein-

hundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR), welche durch den vorgenannten Herr
Martinus Leonard Zuiddam, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro

(12.500.- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter

berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

92207

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthundert

Euro (800.- EUR) geschätzt.

<i>Anmerkung

Der amtierende Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesell-

schaft vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck sein muss, was der Komparenten ausdrücklich anerkannt hat.

<i>Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1. Zum alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird Herr Martinus Leonard Zuiddam, geboren am 22. Mai

1971 in Rotterdam (Niederlande), wohnhaft in Schietspoel 31, NL-1211DK Hilversum, ernannt.

2. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-2128 Luxemburg, 30, rue Marie Adelaïde.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. L. Zuiddam, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 21 juillet 2006, vol. 470, fol. 69, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089988.3/5770/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

U.A.I. (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.050,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.944. 

EXTRAIT

L’associé unique de la société, U.A.I. (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., une société constituée et régie sous les lois du

Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a décidé en date du 9 août 2006:

- d’accepter la démission de Monsieur Troy William Thacker comme gérant de la Société à compter du 9 août 2006;
- de nommer, pour une durée illimitée et avec effet immédiat, Monsieur David R. Whiting, President and Chief Exe-

cutive Officer, né le 20 juillet 1954 à Toronto, Etats-Unis, ayant pour adresse professionnelle Burnaby Building, 16 Bur-
naby Street, P.O. Box HM 716, Hamilton, Bermuda HMCX, comme gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088452.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Remich, le 21 août 2006.

M. Schaeffer.

<i>Pour U.A.I. (LUXEMBOURG) II, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

92208

PRO-HOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 48.963. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01097, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 août 2006.

(089334.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

PRO-HOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 48.963. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01093, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 août 2006.

(089335.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

EASYBOX S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.686. 

Constituée sous la forme d’une société en commandite simple suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2000,

publié au Mémorial C numéro 104 du 10 février 2001, et transformée en société en commandite par actions suivant
acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 22 décembre 2000, publié au
Mémorial C numéro 720 du 4 septembre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 avril 2001, acte
publié au Mémorial C numéro 1059 du 23 novembre 2001, en date du 16 août 2001, acte publié au Mémorial C
numéro 181 du 1

er

 février 2002, en date du 19 novembre 2001, acte publié au Mémorial C numéro 531 du 5 avril

2002, en date du 17 octobre 2002, acte publié au Mémorial C numéro 1073 du 28 novembre 2002, modifiée par-
devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date 24 mars 2004, acte publié au Mémorial C
numéro 555 du 28 mai 2004 et en date du 15 juillet 2004, acte publié au Mémorial C numéro 1073 du 26 octobre
2004.

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03879, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088429.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

<i>Pour EASYBOX S.C.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

«Hydro 50» Management, S.à r.l.

Fondation Caritas Luxembourg

Nikolic, S.à r.l.

Nikolic, S.à r.l.

Fondation Ligue HMC

Controlsinvest, S.à r.l.

Coopératives HMC

Plein Sud S.A.

Life Consulting Luxembourg S.A.

Itchiban S.A.

Itchiban S.A.

Struwwelbuscht, S.à r.l.

Jakobsberg Centrum, S.à r.l.

TFAL Investments

Leminvest Holding S.A.

Européenne de Conseils S.A.

Greenwich Investments, S.à r.l.

Kole Holding

Metty Weyrich &amp; Fils, S.à r.l.

Lux-Forêts, S.à r.l.

F.N.S.A. Holding

Association de Participants Holding S.A.

Fondation Pauline de Faillonnet

Compagnie Piere Holding S.A.

R.S.R. S.A.

Association Européenne pour la Spécialisation en Médecine Vétérinaire Clinique, Association sans but

Link Logistics S.A.

Omega Software S.A.

Field Point PE VIII (Luxembourg),, S.à r.l.

Invest Corporation, S.à r.l.

E.K. S.A.

U.A.I. (Luxembourg) II, S.à r.l.

La Vieillotte

BB &amp; MT S.A.

Capital Investissements Europe S.A.

Capital Investissements Europe S.A.

Tarrant Management - LU, S.à r.l.

Promotecnic S.A.

Aqsacom International S.A.

Sun Square, S.à r.l.

Copeco, S.à r.l.

Olivi Antonio, S.à r.l.

Intertechnology S.A.

GDK S.A. Holding

Wactrans Luxembourg, S.à r.l.

A.R.I. Amusement Rides International S.A.

Benelux Taxis, S.à r.l.

BC TNLGY S.A.

Le Sot l’y Laisse S.A.

Springwater Property Investment Holdings, S.à r.l.

Net Holding S.A.

Agrolux Engineering, S.à r.l.

Entami Technologies S.A.

Dematrans, S.à r.l.

Tarn Holding S.A.

VGL, S.à r.l.

Dubelux S.A.

Amarile Holding S.A.

PP Group S.A.

Regolo Finance S.A.

Regolo Finance S.A.

Regolo Finance S.A.

Crown Properties S.A.

Tandem Partners, S.à r.l.

Pitcairn S.A.

Pitcairn S.A.

Transport et Logistique de la Viande

Nero S.A.H.

Nero S.A.H.

Mac-Philson Holding S.A.H.

Mac-Philson Holding S.A.H.

Promoter

U.A.I. (Luxembourg) III, S.à r.l.

Pro-Hol S.A.

Pro-Hol S.A.

Easybox S.C.A.