logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

88753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1850

3 octobre 2006

S O M M A I R E

AFC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88781

MWH, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88760

Aikon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88780

Niche Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

88799

Amodo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88781

Nouveau  Comptoir de l’Optique 2  S.A.,  Luxem- 

Banque du Gothard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88793

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88754

Banque du Gothard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88794

Novator Telecom Poland II, S.à r.l., Luxembourg  

88758

Belfry, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88777

Orchestra Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

88758

Bifrost Asset Management, S.à r.l., Luxembourg . .

88783

Poly ART Trading (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

British Marine Holdings II S.A., Luxembourg . . . . .

88755

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88778

British Marine Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . .

88755

Polymed Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

88757

British Marine Luxembourg S.A., Luxembourg  . . .

88756

Porta Volta Developments S.C.A., Luxembourg  . 

88795

Bureau & Computercenter S.A., Clervaux . . . . . . .

88778

Prefueled.  com-Online  Music  Store,  S.à r.l.,  Lu- 

Bureau & Computercenter S.A., Clervaux . . . . . . .

88779

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88786

CMS S.A.,  Computer  Multimedia  Software,  Ma- 

Promoland Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

88796

mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88783

Providance Music S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

88794

Co-Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

88779

Pumastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88781

Cominholding, Compagnie Internationale Holding 

Racine Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . 

88770

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88795

Ranbiwa Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

88796

Eaton Holding II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

88759

S5 Finco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

88755

Farmland Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

88771

Sartable S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88759

Financière Hôtelière Européenne S.A.,  Luxem- 

Skyfield Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

88777

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88795

Soluna Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

88784

Financière Hôtelière Européenne S.A.,  Luxem- 

Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

88785

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88795

Sycomore Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . 

88757

Finpa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88784

System Europe Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . 

88785

Garfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

88794

Taxis des Trois Frontières, S.à r.l., Troisvierges . . 

88778

Gec Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88777

Techlink S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88771

Gioch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88795

Tecnovert Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

88777

Gustav 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

88783

Tropical Aquaculture Europe S.A., Luxembourg . 

88787

Hersteller-Vertretungen-Betriebs, GmbH, Luxem- 

Unevinc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88757

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88781

Unimex International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

88786

HLK Software S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . .

88795

Unimex International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

88786

Houston, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

88796

Unimex International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

88786

International A.C.P. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

88756

Unimex International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

88786

Intrasoft International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

88759

United  Administrative  Services,  S.à r.l.,  Luxem- 

Investcolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

88780

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88794

IPEF III Holdings N° 11 S.A., Luxembourg  . . . . . . .

88781

Valeres Konstruktioun S.A., Contern. . . . . . . . . . . 

88770

Luxembourg Finance House S.A., Luxembourg . . .

88780

Van Veen Overseas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

88796

Max Lease S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Luxembourg . . . .

88756

Vista Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

88784

Mediplan, GmbH, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88794

Winward International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

88754

Metal  Management & Finance  S.A.  Holding,  Lu- 

Wisniowy F Investors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

88758

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88785

Wizard, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88785

Metro International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

88780

Yeoman International Holdings S.A., Luxembourg

88800

Meximmo S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

88799

Z.D. Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

88796

Mistral Entertainment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

88786

Zafini Holding A.G., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . 

88782

Morana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

88787

Zafini Holding S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

88783

88754

WINWARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.114. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 juin 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 15 juin 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, de-

meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet immé-
diat.

En date du 15 juin 2006, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Pieter van Nugteren, avec

adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg;

- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080356.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.939. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 juin 2006

1. Les mandats d’Administrateurs des sociétés:
- EFFIGI, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;
- LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;
- FIDIS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;
sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société AUDIEX S.A., société anonyme ayant son siège social au

57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. 

Suit la traduction en anglais de ce qui précède:

<i>Extract of the resolutions taken at Annual General Meeting of June 30th, 2006

1. The mandates as Directors of the companies:
- EFFIGI, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg;

- LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg;

- FEDIS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg;

be re-conducted for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of the year 2007.
2. The mandate as Statutory Auditor of the company AUDIEX S.A., having its registered office at 57, avenue de la

Faïencerie, L-1510 Luxembourg, be re-conducted for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting
of the year 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080775.3//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme

Certified true copy
NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

88755

BRITISH MARINE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.495. 

Il résulte de l’Assemblée Générale et de la réunion du conseil d’administration de la Société qui se sont tenues en

date du 1

er

 juin 2006, que le conseil d’administration se compose comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080728.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

BRITISH MARINE HOLDINGS II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.234. 

Il résulte de l’Assemblée Générale et de la réunion du conseil d’administration de la Société qui se sont tenues en

date du 1

er

 juin 2006, que le conseil d’administration se compose comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080735.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

S5 FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 105.950. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11455, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081084.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

MM. Wheeler Brian, demeurant à Ludwell House, Ludwell Lane, Waltham Chase, Southampton, Hampshire SO32

2NP, United Kingdom, Président;
Johnston Robert, demeurant 9, Fawcett Street, SW 10 9HN London, United Kingdom, Administrateur;
Fenemore-Jones Claude Andrew, demeurant 173, Park Road, TW11 OBP Teddington, Middlesex, United Kin-
gdom, Administrateur;
Jensen Stig, demeurant 45, Gl. Strandvej à DK-3050 Humlebaek, Denmark, Administrateur;
Lehmann Holger, demeurant 37, Fahlenkampsweg, D-23562 Lübeck, BRD, Administrateur;
Reyland Nico, demeurant 18, rue de la Montagne, L-6136 Junglinster, Administrateur;
Pleimling René, demeurant 105A, rue Andethana, L-6970 Hostert, Administrateur;
Wainwright-Brown Andrew John, demeurant à High House, Baylham, Ipswich GB-IP68LD, Suffolk, United Kin-
gdom, Administrateur;
Olersky Victor, demeurant au 171-80 Moskovsky prospect, 196070 St. Petersburg, Russia, Administrateur.

Pour extrait conforme
Signature

MM. Wheeler Brian, demeurant à Ludwell House, Ludwell Lane, Waltham Chase, Southampton, Hampshire SO32

2NP, United Kingdom, Président;
Johnston Robert, demeurant 9, Fawcett Street, SW 10 9HN London, United Kingdom, Administrateur;
Fenemore-Jones Claude Andrew, demeurant 173, Park Road, TW11 0BP Teddington, Middlesex, United Kin-
gdom, Administrateur;
Jensen Stig, demeurant 45, Gl. Strandvej à DK-3050 Humlebaek, Denmark, Administrateur;
Lehmann Holger, demeurant 37, Fahlenkampsweg, D-23562 Lübeck, BRD, Administrateur;
Reyland Nico, demeurant 18, rue de la Montagne, L-6136 Junglinster, Administrateur;
Pleimling René, demeurant 105A, rue Andethana, L-6970 Hostert, Administrateur;
Wainwright-Brown Andrew John, demeurant à High House, Baylham, Ipswich GB-IP68LD, Suffolk, United Kin-
gdom, Administrateur;
Olersky Victor, demeurant au 171-80 Moskovsky prospect, 196070 St. Petersburg, Russia, Administrateur.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
<i>Un mandataire

88756

BRITISH MARINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.026. 

Il résulte de l’Assemblée Générale et de la réunion du conseil d’administration de la Société qui se sont tenues en

date du 1

er

 juin 2006, que le conseil d’administration se compose comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08712. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080753.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

INTERNATIONAL A.C.P. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.110. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 12 juillet 2006 à 15.00 heures 

<i>Résolution

«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat de MM. Francisco de Murga, Alaric de Murga, J-Claude Schmitz, Ber-

nard Timmery en tant qu’administrateur pour un terme devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2006.

L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer V.O. CONSULTING LUX S.A., 8, rue Haute, Clémency, en tant que

Commissaire aux Comptes de la société pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui exa-
minera les comptes clôturés au 31 décembre 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080766.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

MAX LEASE S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 100.062. 

Par résolution signée en date du 27 juin 2006, les associés ont décidé de renouveler le mandat de Pricewaterhouse-

Coopers, avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au poste de réviseur d’entreprise, pour une pé-
riode venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre
2006 et qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081650.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

MM. Wheeler Brian, demeurant à Ludwell House, Ludwell Lane, Waltham Chase, Southampton, Hampshire SO32

2NP, United Kingdom, Président;
Johnston Robert, demeurant 9, Fawcett Street, SW 10 9HN London, United Kingdom, Administrateur;
Fenemore-Jones Claude Andrew, demeurant 173, Park Road, TW11 OBP Teddington, Middlesex, United Kin-
gdom, Administrateur;
Jensen Stig, demeurant 45, Gl. Strandvej à DK-3050Humlebaek, Denmark, Administrateur;
Lehmann Holger, demeurant 37, Fahlenkampsweg, D-23562 Lübeck, BRD, Administrateur;
Reyland Nico, demeurant 18, rue de la Montagne, L-6136 Junglinster, Administrateur;
Pleimling René, demeurant 105A, rue Andethana, L-6970 Hostert, Administrateur;
Wainwright-Brown Andrew John, demeurant à High House, Baylham, Ipswich GB-IP68LD, Suffolk, United Kin-
gdom, Administrateur;
Olersky Victor, demeurant au 171-80 Moskovsky prospect, 196070 St. Petersburg, Russia, Administrateur.

Pour extrait conforme
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Signature.

88757

POLYMED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.437. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 février 2006

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs pour une du-
rée statutaire d’un an, en remplacement de Madame Antonella Graziano et de Messieurs Jean-François Cordemans et
Carlo Schlesser qui ne se représentaient plus aux suffrages. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme avec siège social au

26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une durée statutaire d’un an. Le mandat de la société FIN-
CONTROLE S.A., viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 7 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080774.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

UNEVINC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.064. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 avril 2006

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, et LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont nommées nouveaux Administrateurs en remplacement de
Messieurs François Mesenburg et Marc Limpens, qui ne souhaitaient plus se présenter aux suffrages, et ce pour une pé-
riode statutaire nouvellement fixée à trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Carlo Schlesser et Jean-Paul Reiland sont reconduits pour une période

statutaire de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny,

L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une période statutaire de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10468. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080779.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

SYCOMORE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 40.938. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11109, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081147.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Certifié sincère et conforme
<i>POLYMED HOLDING S.A.
MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

Certifié sincère et conforme
<i>UNEVINC S.A.
LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

<i>Pour la société
Signature

88758

WISNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.520.250,-.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 82.159. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associées de la Société prises en date du 2 juin 2006 que:
Les associées de la Société ont décidé de nommer en qualité de gérant avec effet en date du 24 mai 2006: 
- Matthew Fleming, ayant son adresse professionnelle au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin, Irlande;
- Romain Thillens, ayant son adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-

bourg.

Les associées ont également pris acte des démissions de leur mandat de gérant de la Société, avec effet au 25 mai

2005:

- Graham Kilbane, demeurant au 154, Effra Road Wimbledon, SW19 8PR Londres, Royaume-Uni;
- Karim Habra, demeurant au 15, Kozi, 11000 Prague 1, République Tchèque.
En conséquence, le Conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- M. Sansal Ozdemir, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché du

Luxembourg;

- M. Gordon Black, ayant son adresse professionnelle au 180, N. Lasalle Street, Suite 3600, Chicago, Illinois, 60601

Etats-Unis d’Amérique;

- M. Matthew Fleming, ayant son adresse professionnelle au 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande;
- M. Romain Thillens, ayant son adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché du

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 17 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(080822.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

ORCHESTRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 91.003. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05889, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juillet 2006.

(081124.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

NOVATOR TELECOM POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 108.272. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise en date du 20 mars 2006 que:
- La société PricewaterhouseCoopers ayant son siège social au 22 Colomberie, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE1

4XA a été nommée commissaire.

Le commissaire est nommé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081396.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour compte de ORCHESTRA LUXEMBOURG S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

88759

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 56.565. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2006

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2006:

- Monsieur Socrates P. Kokkalis, demeurant au 102-10, Diligianni street, GR - Kiffisia-Attique;
- Monsieur Vassilios Kritis, demeurant au 174, Aalstraat, B-9700 Oudernaarde;
- M. Athanasios Kotsis, employé privé, demeurant 74, rue Papenkasteel, B-1180 Uccle;
- Monsieur Dimitrios Klonis, demeurant au 70A, P. Kalliga Street, GR - Filothei.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2006:

- ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080824.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

EATON HOLDING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 416.300.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.077. 

<i>Cession de parts sociales

Suite à une cession de parts sociales par acte sous seing privé avec effet au 30 novembre 2005, 3.563 (trois mille cinq

cent soixante-trois) parts sociales de la société EATON HOLDING II, S.à r.l., appartenant à la société EATON B.V.,
société de droit néerlandais, ayant son siège social à Boeing avenue 11, 1119 OC Schiphol-Rijk, Pays-Bas, ont été cédées
à la société EATON INDUSTRIES MANUFACTURING, GmbH, société de droit suisse, ayant son siège social à avenue
de Lonay 2-2bis, 1110 Morges, VD, Suisse.

Dès lors, l’actionnariat est reparti de la façon suivante suite à cette cession:  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080861.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

SARTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 101.080. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05882, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, au mois de juillet 2006.

(081125.6//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

Signature.

Associés

Total parts sociales

EATON INDUSTRIES MANUFACTURING, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.563 parts sociales

Certifié sincère et conforme
<i>Pour EATON HOLDING II, S.à r.l.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour compte de SARTABLE S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

88760

MWH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 118.278. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourth day of July.
Before Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P. having its registered office at 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, registered

in Cardiff under registration number LP 6185.

The appearer for the above is here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name
There is formed a private limited liability company under the name MWH, S.à r.l. which will be governed by the laws

pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Arti-
cles»).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is au-

thorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object
3.1. The Company’s object is to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or for-

eign, commercial, industrial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities
and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way,
or financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2. The Company may in particular enter into the following transactions: 
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convert-
ible or not into shares of the Company, the use of financial derivatives or otherwise;

- advance, lend or deposit money or give credit to affiliates through, including but not limited to, the subscription to

bonds, notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convertible or not into shares of any affil-
iate;

- enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the affiliates, or any director, director
or other agent of the Company or any of the affiliates, and to render any assistance to the affiliates, within the limits of
the laws of Luxembourg;

- enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, market-

ing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services con-
tracts, selling agreements, connected directly or indirectly to the areas described above; and

- use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any

kind or form.

It being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions

and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions di-
rectly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate
object in all areas described above, however without taking advantage of specific tax regime organised by the law of July
31st, 1929 on holding companies.

Art. 4. Duration
The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Share capital
5.1. The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred

(500) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of
the Shares are together referred to as the «Shareholders».

88761

5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on

any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3. All Shares will have equal rights.
5.4. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares’ indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares
7.1. In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

7.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-

out the prior written consent of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers. 

Art. 8. Drag-along rights
8.1. Drag offer
A «Drag Offer» is an offer to buy all of the Shares then in issue which is conditional on acceptance in respect of all

the Shares then in issue within a specified time period being made;

at the same price per Share of the same class, and not made by a person who is Controlled by, under common Con-

trol with, or who Controls, a PALAMON Fund.

8.2. Acceptance of Drag Offer
A Drag Offer may be accepted at any time by a Shareholder or Shareholders who together hold more than 50 per

cent of the Shares (the «Majority Shareholders») in accordance with article 7.2. assuming that all options and warrants,
if any, to subscribe for Shares have been exercised.

A Drag Offer may not be accepted by a Shareholder who is not a Majority Shareholder, other than in accordance

with article 8.2. (§3) and with article 7.2.

If a Drag Offer is accepted by the Majority Shareholders in accordance with article 7.2. with respect to all their Shares

and each of the other Shareholders have accepted such Drag Offer in accordance with article 7.2. in respect of all its
Shares, the Majority Shareholders shall be and hereby authorised on behalf of such other Shareholders to notify the
person making the Drag Offer of such other Shareholders’ acceptance of the Drag Offer.

The transfer of Shares pursuant to the Drag Offer shall be completed in accordance with article 7.2. as follows:
The transfer of Shares shall be transferred free of encumbrances and with all rights attaching thereto;
The seller of the Shares (the «Seller») shall deliver to the purchaser of the Shares (the «Purchaser») a certificate rep-

resenting the relevant Shares or other evidence of title in respect of the Shares duly endorsed in the name of the Pur-
chaser or as directed by the Purchaser together with the necessary instrument of transfer and the other Shareholders
and the Company will ensure that such transfer shall promptly be entered in the shareholders’ register;

The Purchaser shall pay the aggregate transfer price in respect of the relevant Shares to the Seller by bankers’ draft

for value on the date of completion or in such other manner as may be agreed by the Seller and the Purchaser before
completion; and

The Seller shall do all such other acts and/or execute all such other documents in a form satisfactory to the Purchaser

as the Purchaser may reasonably require to give effect to the transfer of title to the Shares to it.

If a Shareholder fails or refuses to transfer any Shares in respect of which a Drag Offer has been accepted under the

present article against payment of the price for them;

the Company shall by written notice authorise any Manager to execute and deliver on such Shareholder’s behalf the

necessary instruments of transfer(s) and to do any other acts and/or execute any other deeds and documents on the
Shareholder’s behalf required to effect the transfer of title to the Shares; 

the Company shall receive the purchase money in trust for the Shareholder and the receipt by the Company for the

purchase money shall be a good discharge for the Transferee, who shall not be bound to see to the application of the
purchase money;

the Company shall cause the Transferee to be registered as holder of the relevant Shares; and once registration has

taken place in purported exercise of the power contained in this sub-clause, the validity of the proceedings shall not be
questioned by any person.

8.3. Options
The offer constituted by a Drag Offer shall extend to persons holding options or who are otherwise entitled to sub-

scribe for Shares at the time of completion of the share transfers being made pursuant to the Drag Offer or as a result
of the making of the Drag Offer or the completion of such share transfers. The provisions of article 8.2. shall apply to
the Shares issued as a result of the exercise of such options or other entitlement in the same manner as they apply to
Shares in issue at the time of the Drag Offer.

Chapter III.- Management

Art. 9. Management
9.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the «Board of Managers»).

9.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

88762

Art. 10. ERISA rights
10.1. For as long as an ERISA Fund or its nominees are directly or indirectly Shareholders of the Company, that ERISA

Fund will obtain certain management rights in the Company and its subsidiaries in a manner and to the extent permitting
such ERISA Fund to substantially influence or participate in the management of the Company and its subsidiaries. Ac-
cordingly, it is agreed for the benefit of each of the ERISA Funds individually that each ERISA Fund or its nominee shall
have the right (which rights shall belong solely to, and shall be exercised exclusively by, such ERISA Fund for its own
benefit and for its own account) from time to time and at any time by notice in writing to propose up to two persons
for election as managers of the Company and each of its subsidiaries and the Shareholders and the shareholders of the
subsidiaries shall vote and take such other action as may be necessary to ensure that in each case one person proposed
by each ERISA Fund shall hold office as a manager of the Company and each of its subsidiaries (collectively the «ERISA
Managers»).

10.2. The shareholders in each of the ERISA Funds include limited partners which are entities governed in the United

States of America by the Employee Retirement Income Security Act 1974 as amended from (ERISA). In order to permit
the limited partners governed by ERISA to treat each of the ERISA Funds as VCOC’s for the purposes of ERISA they
need to obtain certain management rights in companies in which they invest in a manner and to an extent that will permit
the Company to qualify as a VCOC. Accordingly, it is agreed that as long as an ERISA Fund directly or indirectly holds
any Shares in the Company, the Company and its subsidiaries and their designated representatives shall provide each
ERISA Fund (individually) with the following rights to the extent such rights are permissible under the apllicable statutory
laws (which rights shall belong solely to, and shall be exercised exclusively by, such ERISA Fund for its own benefit and
for its own account):

10.2.1. the right to visit and inspect any of the offices and properties of the Company and its subsidiaries and the right

to inspect and copy the books and records of the Company and its subsidiaries, at such times as the ERISA Fund shall
reasonably request;

10.2.2. the right to appoint a representative to attend as an observer each and every meeting of the Board of Man-

agers of the Company (and the board of directors of each subsidiary thereof). The appointment and removal of such a
representative shall be by written notice from the ERISA Fund to the Company and shall take effect upon the delivery
of written notice thereof at the Company’s registered office or at any meeting of the Board of Managers;

10.2.3. the right to receive, within a reasonable time after its written request therefore, any information relating to

the Company or its subsidiaries or associated companies as it in its sole discretion deems fit, including without limitation:
(i) within 30 days of the month end monthly consolidated financial information and statements, including but not limited
to a balance sheet, profit and loss and cash flow statements of the Company and each of its subsidiaries and associated
companies; (ii) within 90 days of the end of each accounting period end annual audited consolidated financial statements;
(iii) on an annual basis and no later than 30 days prior to the beginning of the Company’s financial year or, if so requested
on a more frequent basis, the business plan, budget and cash flow forecasts and projections of the Company and each
of its subsidiaries and associated companies; (iv) monthly reports including a narrative setting out the progress of the
group on matters materially affecting the business and affairs of the group; and (v) such additional financial or manage-
ment information as the ERISA Fund may reasonably request including any operating reports, budgets, other financial
reports and details of material developments or events or significant proposals;

10.2.4. the right to meet on a regular basis with the Managers or other personnel of the Company and its subsidiaries

and associated companies from time to time and upon reasonable notice to the Company (or the applicable subsidiary
or associated company) for the purpose of consulting with, rendering advice, recommendations and assistance to, and
influencing the Managers of the Company (or its subsidiaries and associated companies) or obtaining information re-
garding the Company’s or any of its subsidiaries’ (or associated companies’) business operations, financial condition, ac-
tivities and prospects and expressing its views thereon including, significant changes in management, personnel and
compensation of employees, introduction of new products or new lines of business, important acquisitions or disposi-
tions of plants and equipment, significant research and development programmes, the purchasing or selling of important
trademarks, licences or concessions or the proposed commencement or compromise of significant litigation;

10.2.5. the right to submit proposals and suggestions to the Board of Managers of the Company or to the board of

any of its subsidiaries, if not adopted by management; and

10.2.6. to the extent consistent with applicable law (and with respect to events which require public disclosure, only

following the Company’s public disclosure thereof through applicable securities law filings or otherwise), the right to
receive notice in advance with respect to any significant corporate actions, including, without limitation, extraordinary
dividends, mergers, acquisitions or dispositions of assets, issuances of significant amounts of debt or equity and material
amendments to the Articles, and the right to consult with the Company with respect to such actions.

10.3. For the purpose of this article, ERISA Fund means both or either of PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P.

Art. 11. Powers of the sole manager or of the board of managers
11.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, with-

out prejudice to articles 9 and 12 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

11.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 12. Representation of the company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Man-

ager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any one Manager or by the signature of any person to

88763

whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of managers,
by any one Manager.

Art. 13. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
13.1. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-

cific tasks to one or more ad hoc agents.

13.2. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

Art. 14. Meeting of the board of managers
14.1. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. No meet-

ing of the Board of Managers may validly be held in the United Kingdom.

14.2. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

14.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage except in case where such Manager is in the United Kingdom.

14.4. The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

14.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. No
Manager may participate in a telephone board meeting whilst being in the United Kingdom.

14.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

14.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 15. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes
15.1. The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
15.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of

the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collec-
tive decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

15.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V.- Business year

Art. 16. Business year
16.1. The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
16.2. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the sole Manager or, in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

16.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. Distribution right of shares
17.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

17.2. From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

17.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

17.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

17.5. Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the
amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

88764

Chapter VI.- Liquidation

Art. 18. Causes of dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Art. 19. Liquidation
19.1. The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.
19.2. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 20. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Chapiter VIII.- Definitions

Art. 21. Definitions
Control in relation to a body corporate means the ability of a person to ensure that the activities and business of that

body corporate are conducted in accordance with the wishes of that person, and a person shall be deemed to have
Control of a body corporate if that person possesses or is entitled to acquire the majority of the issued share capital
or the voting rights in that body corporate or the right to receive the majority of the income of that body corporate
on any distribution by it of all of its income or the majority of its assets on a winding-up or appoint directors with suf-
ficient votes to control the same and, for the avoidance of doubt, a person which is the general partner of a limited
partnership Controls that limited partnership and any derivative term or reference to «Controlling» shall be construed
accordingly. 

ERISA means Employee Retirement Income Security Act 1974.
ERISA Fund means PALAMON EUROPEAN EQUITY, L.P.
PALAMON FUNDS means PALAMON EUROPEAN EQUITY, L.P., PALAMON EUROPEAN EQUITY «B», L.P., PAL-

AMON EUROPEAN EQUITY «C», L.P., PALAMON EUROPEAN EQUITY «D», L.P., PALAMON EUROPEAN, GmbH
&amp; CO. BETEILIGUNGS KG, PALAMON EUROPEAN EQUITY II, L.P. and PALAMON EUROPEAN EQUITY II «BOA»,
L.P.

Plan Asset Regulations means the «plan assets» regulation (29 CFR 2510.3-101) under ERISA.
Transferee means any person to whom Shares are to be transferred.
Transferor means any Shareholder who wishes to transfer some or all of his Shares.
VCOC means «venture capital operating company» within the meaning of the Plan Asset Regulations».

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named entity, PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P.,

representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the fol-
lowing resolutions:

1.- Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
- Ron E. Bell, Chartered Accountant, born on 11 June 1956 at Worcestor, England, with professional address at Pal-

amon Capital Partners, 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, United Kingdom;

- Gérard Becquer, réviseur d’entreprise, born on 29 April 1956 at Briey, France, with professional address at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

In accordance with article 12 of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of any one Manager

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any one Manager.

2.- The Company shall have its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Shares:
PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

88765

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PALAMON EUROPEAN EQUITY, L.P. ayant son siège social au 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, enregistrée à

Cardiff sous le numéro d’enregistrement LP 6185.

La comparante ci-dessus est représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme - Dénomination

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MHW, S.à r.l. qui sera régie par les lois re-

latives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3. Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour objet l’acquisition, la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

autres entités commerciales, industrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères, au moyen, entre autre, d’ac-
quisition et de souscription de toutes sûretés et droits par voie de participation, d’apport, de contribution, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, ou des instruments de dette financière sous quel-
que forme que se soit, et d’administrer, développer et gérer de tels détention d’intérêts.

3.2. La Société peut en l’espèce, entrer dans les transactions suivantes:
- emprunter de l’argent sous toutes formes ou obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y

compris mais sans être limité, l’émission d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre, de certificats et tous autres
effets de commerce d’equity et de dettes convertibles ou non en Actions de la Société, l’utilisation de dérivés financiers
ou sinon;

- octroyer des avances, des prêts, de la monnaie scriptural ou accorder des crédits à ses sociétés liées à travers, y

compris mais sans être limité, la souscription d’obligations, de titres, de certificats et tous autres effets de commerce
d’equity et de dette, convertibles ou non en Parts Sociale de toute Société Liée;

- entrer dans toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté, soit par un engagement personnel ou par une hy-

pothèque ou charge sur tout ou partie des actifs (présents et futurs) de propriété de l’entreprise ou par toutes ou telles
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligation de la Société ou de ses Sociétés Liées ou tout directeur ou
autre agent de la Société ou de ses Sociétés Liées et pour apporter toute aide à ses Sociétés Liées, dans les limites pré-
vues par la Loi luxembourgeoise;

- entrer dans tout accord, y compris mais sans être limité aux accords d’association, accords de garantie, accords de

marketing, accords de management, accords consultatifs, accords d’administration et autre contrats de service, accords
de vente, connectés directement ou indirectement aux domaines décris au dessus; et

- employer ses fonds en investissement dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif

mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit;

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité

qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3. En plus de ce qui précède, la Société peut effectuer toutes opérations légales, commerciales, techniques et finan-

cières, et en générale toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet aussi bien que les opérations
directement ou indirectement liées aux activités décrites dans cet article, afin de faciliter la réalisation de l’objet social
dans tous les domaines décrits plus haut, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

88766

Titre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cinq cents (500)

parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR), chacune. Les détenteurs
de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2. Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Transfert des parts
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

7.3. De plus, chaque Associé s’engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales

qu’il détient sans le consentement préalable et écrit du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Art. 8. Droits d’attrait (drag-along)
8.1. «Drag Offer»
Une «Drag Offer» est une offre pour acheter la totalité des Parts Sociales alors émises qui est conditionnée à l’ac-

ceptation relative à toutes les Parts Sociales alors émises faite dans une période limités,

au même prix par Part Sociale de la même catégorie, et 
qui n’a pas été faite par une personne qui est Contrôlée par, ou qui Contôle conjointement avec, ou qui Contôle, un

Fonds PALOMON.

8.2. Acceptation d’une «Drag Offer»
Une «Drag Offer» peut être acceptée à tout moment par un ou des Associés qui détiennent ensemble plus de 50

pour cent des Parts Sociales (les «Associés Majoritaires») conformément à l’article 7.2, à condition que toutes les op-
tions ou certificats d’options, s’il en existe, à souscrire pour les Parts Sociales aient été exercées.

Une «Drag Offer» ne peut pas être acceptée par un Associé qui n’est pas un Associé Majoritaire, autrement que con-

formément à l’article 8.2 (§3) et à l’article 7.2.

Si une «Drag Offer» est acceptée par les Associés Majoritaires conformément à l’article 7.2 en rapport avec la totalité

de leur Parts Sociales et que chacun des autres Associés ayant accepté une telle «Drag Offer» conformément à l’article
7.2 en rapport avec la totalité de leurs Parts Sociales, les Associés Majoritaires doivent être et sont par la présente auto-
risés au nom de ces autres Associés à notifier la personne qui fait la «Drag Offer» de l’acceptation de cette «Drag Offer»
par ces autres Associés.

Le transfert des Parts Sociales relatives à la «Drag Offer» doit avoir lieu, conformément à l’article 7.2, comme suit:
le transfert des Parts Sociales aura lieu libre de toute charge et avec tous les droits qui y sont attachés;
le vendeur des Parts Sociales (le «Vendeur») remettra à l’acheteur des Parts Sociales (l’«Acheteur») un certificat re-

présentant les Parts Sociales concernées ou toute autre preuve ou titre en rapport avec les Parts Sociales dûment en-
dossées au nom de l’Acheteur ou telles que placées par l’Acheteur ensemble avec les instruments de transfert
nécessaires et les autres Associés et la Société fera en sorte qu’un tel transfert soit promptement enregistré dans le
registre d’associés;

le Vendeur paiera le prix total de transfert en rapport avec les Parts Sociales concernées au Vendeur par traite à la

valeur du jour de réalisation de la vente ou par tout autre procédé qui fera l’objet d’un accord entre le Vendeur et
l’Acheteur après réalisation de la vente; et

le Vendeur fera tous ces actes et/ou exécutera tous ces autres documents d’une manière acceptable par l’Acheteur,

celui-ci pouvant raisonnablement demander la mise en oeuvre du transfert de propriété des Parts Sociales à sa personne.

Si l’Associé manque ou refuse de transférer des Parts Sociales pour lesquelles une «Drag Offer» a été acceptée sous

le présent article en considération du paiement de leur prix:

a. la Société autorisera par notification écrite tout Gérant exécuter et transférer au nom et pour le compte de cet

Associé les instruments de transfert nécessaires et à faire tous les autres actes et/ou exécuter tous les autres actes no-
tariés et les documents au nom de l’Associé qui sont requis pour effectuer le transfert de propriété des Parts Sociales;

b. la Société recevra la somme d’achat en dépôt pour le compte de l’Associé et la quittance de la Société pour la

somme d’achat sera une décharge valable pour le Cessionnaire, qui ne sera pas obligé de voir l’affectation de la somme
d’achat;

c. la Société obligera le Cessionnaire à s’enregistrer comme détenteur des Parts Sociales concernées; et
d. une fois que l’enregistrement a eu lieu dans l’exercice prétendu du pouvoir contenu dans cette sous-clause, la va-

lidité de la procédure ne pourra être mise en cause par aucune personne.

8.3. Options
L’offre constituée par une «Drag Offer» s’étendra aux personnes détenant des options ou qui sont sinon autorisées

à souscrire des Parts Sociales à la date de la réalisation des transferts de parts sociales effectués en conséquence de la
«Drag Offer» ou résultant de la «Drag Offer» ou de la réalisation de ces transferts de parts sociales. Les dispositions

88767

de l’article 8.2 devront s’appliquer aux Parts Sociales émises en raison de l’exercice de telles options ou d’autres droits
de la même manière qu’elles s’appliquent aux Parts Sociales émises au moment de la «Drag Offer».

Titre III.- Gérance

Art. 9. Gérance
9.1. La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). En cas

de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

9.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 10. Droits ERISA
10.1. Aussi longtemps qu’un Fond ERISA ou ses candidats sont directement ou indirectement Associés, ce Fond ERI-

SA obtiendra certains droits de gestion dans la Société et ses filiales dans une manière et dans la mesure permettant à
ce Fond ERISA d’influencer substantiellement ou de participer dans la gestion de la Société et de ses filiales. Par consé-
quent, il est convenu au bénéfice de chaque Fond ERISA individuellement que chaque Fond ERISA et ses candidats aura
le droit (lesquels droits appartiendront seulement et seront exercés exclusivement par ce Fond ERISA à son profit et
pour son propre compte) de temps en temps et à tout moment avec un préavis par écrit de proposer jusqu’à deux
personnes pour la nomination de gérants de la Société et de chacune de ses filiales et les Associés et les associés des
filiales voteront et prendront toute autre part sociale qui serait nécessaire pour assurer que dans chaque cas ou une
personne proposée par chaque Fond ERISA aura la fonction de gérant de la Société et de chacune de ses filiales (con-
jointement les «ERISA Membres du Conseil»).

10.2. Les investisseurs dans chacun des Fonds ERISA comprennent les associés commanditaires qui sont des entités

régies aux Etats-Unis par la Loi de 1974 relative aux régimes de retraite et de couverture médicale ERISA. Dans le but
de permettre aux associés commanditaires régis par ERISA de considérer chaque Fond ERISA comme VCOC’s aux fins
de ERISA ils ont besoin d’obtenir certains droits de gestion dans les sociétés dans lesquelles ils investissent dans Une
manière et mes ure qui permettra à la Société de le qualifier comme VCOC. Par conséquent, il est convenu que aussi
longtemps qu’un Fond ERISA détient directement ou indirectement des parts sociales dans la Société, la Société et ses
filiales et leurs représentants désignés garantiront à chaque Fond ERISA (individuellement) les droits suivants (lesquels
droits appartiendront seulement et seront exercés exclusivement par ce Fond ERISA à son profit et pour son propre
compte):

10.2.1. Le droit de visiter et inspecter chacun des bureaux et propriétés de la Société et de ses filiales et le droit

d’inspecter et reproduire les livres et registres de la Société et de ses filiales, aux moments ou le Fond ERISA l’aura
raisonnablement requis;

10.2.2. Le droit de nommer un représentant pour participer comme observateur à chacune des réunions du Conseil

de Gérance de la Société (et chacune des filiales). La nomination et la révocation de ce représentant sera faite par préavis
écrit du Fond ERISA à la Société et prendra effet à la délivrance du préavis écrit au siège social de la Société ou à toute
réunion du Conseil de Gérance;

10.2.3. Le droit de recevoir, dans un temps raisonnable, après sa demande écrite, toutes les informations en relation

avec la Société ou ses filiales ou sociétés affiliées, qu’il considère, à sa seule discrétion, comme appropriées., comprenant
sans limitation sans limitation: (i) dans les 30 jours de la fin du mois les informations et déclarations financières conso-
lidées mensuellement, incluant mais sans y être limité les bilans, profits et pertes et les déclarations relatives au flux de
trésorerie de la Société et chacune de ses filiales et sociétés affiliées, (ii) dans les 90 jours de la fin de chaque période
comptable et des déclarations financières consolidées annuelles, (iii) sur une base annuelle et pas plus tard que dans les
30 jours qui précèdent le début de l’exercice social de la Société ou si requis sur une base plus fréquente, le plan d’af-
faires, le budget el les prévisions et les estimations du flux de trésorerie de la Société et de chacune de ses filiales et
sociétés affiliées; (iv) des rapports mensuels comprenant un cadre explicatif sur l’évolution du groupe dans des matières
affectant matériellement le commerce et les affaires du groupe; et (v) les informations supplémentaires financières ou
de gestion que le Fond ERISA peut raisonnablement requérir comprenant tous rapports d’exploitation, budgets, autres
rapports financiers et les détails des développements matérielles ou événements ou propositions significatives;

10.2.4. Le droit de rencontrer sur une base régulière les gérants ou autre personnel de la Société et de ses filiales et

ses sociétés affiliées de temps en temps et moyennant un préavis raisonnable à la Société (ou la filiale ou la société affiliée
en question) aux fins de consulter, donner un avis, des recommandations et assistance et influencer les gérants de la
Société (ou ses filiales et sociétés affiliées) ou d’obtenir des informations concernant les opérations commerciales, les
conditions financières, les activités et perspectives de la Société (ou de ses filiales ou de ses sociétés affiliées) et de don-
ner son point de vue à ce sujet comprenant, sans limitation, des changements significatifs dans la gestion, le personnel
et la rémunération des employés, l’introduction de nouveaux produits ou de nouvelles lignes d’affaires, des acquisitions
importantes ou des ventes d’usines et d’équipements, des recherches significatives et des programmes de développe-
ment, l’achat ou la vente d’importantes marques de fabrique, licences ou concessions ou le début proposé ou le com-
promis d’un litige important;

10.2.5. Le droit de soumettre des propositions et suggestions au Conseil de Gérance de la Société ou au conseil de

l’une quelconque de ses filiales, s’ils n’ont pas été adoptés par la gérance; et

10.2.6. Dans une mesure compatible avec la loi applicable (et au regard d’événements qui requièrent une divulgation

publique, seulement à la suite de la divulgation publique de la Société au moyen de dépôts légaux de garanties en question
ou autrement), le droit de recevoir un préavis en avance relatif à toutes parts sociales significatives, comprenant, sans
limitation, des dividendes extraordinaires, des fusions, des acquisitions ou des ventes d’actifs, des émissions de montants
significatifs de dette ou capital et des modifications matérielles aux Statuts, et le droit de se consulter avec la Société en
relation à ses parts sociales.

88768

10.3. Pour les besoins de cet article, Fonds ERISA signifie PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P.

Art. 11. Pouvoirs du conseil de gérance 
11.1. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 9 et 12 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstan-
ces et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social et pourvu que les termes du pré-
sent article aient été respectés.

11.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts se-

ront de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 12. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant

Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature unique de tout Gérant ou par la signature de toute personne
à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants,
par tout Gérant.

Art. 13. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance
13.1. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à

un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

13.2. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

Art. 14. Réunion du conseil de gérance
14.1. En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
14.2. Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous

les gérants sont présents ou représentés et s’ils ont renoncé aux formalités de convocation.

14.3. Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirma-
tion écrite ultérieure sauf dans l’hypothèse où le Gérant se trouve au Royaume-Uni.

14.4. Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses mem-

bres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple. 

14.5. L’utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en me-

sure d’entendre et d’être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit par-
ticipant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Aucun gérant
ne pourra participer à une réunion téléphonique du conseil alors qu’il se trouve au Royaume-Uni.

14.6. Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et valide pour autant qu’elle ait été adoptée à une

réunion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans
un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de
Gérance.

14.7. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou repré-

sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant
ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés
15.1. L’Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des Associés.
15.2. En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent.

15.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’As-

sociés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions lé-
gales.

Titre V.- Exercice social

Art. 16. Exercice social
16.1. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

16.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en

cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l’indication de la
valeur des actifs et passifs de la Société.

16.3. Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Droit de distribution des parts
17.1. Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

17.2. Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

88769

17.3. Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.

17.4. La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
17.5. Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d’une si-
tuation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le mon-
tant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes al-
louées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 18. Causes de dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite de

son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

Art. 19. Liquidation
19.1. La liquidation de la Société n’est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés.
19.2. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 20. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Titre VIII.- Définitions

Art. 21. Définitions
Cessionnaire signifie toute personne à qui les Parts Sociales seront transférées.
Cédant signifie tout Associé qui souhaite transférer une partie ou la totalité de ses Parts Sociales.
Contrôle signifie, en rapport avec une société, la capacité d’une personne à s’assurer que les activités et les affaires

d’une entreprise sont gérées conformément aux souhaits de cette personne, et une personne sera réputée avoir le Con-
trôle d’une entreprise si cette personne possède ou a le droit d’acquérir la majorité du capital social émis ou les droits
de vote de cette entreprise ou le droit de recevoir la majorité du revenu en cas de liquidation ou de nommer les direc-
teurs avec les votes suffisants pour contrôler le même et, afin d’éviter tout doute, une personne qui est l’associé com-
manditaire d’une société en commandite Contrôle cette société en commandite et toute référence à «Contrôlant»
devra être construite de la sorte.

ERISA signifie «Employee Retirement Income Security Act 1974». 
Fond ERISA signifie PALAMON EUROPEAN EQUITY, L.P.
Fonds PALAMON signifie PALAMON EUROPEAN EQUITY, L.P., PALAMON EUROPEAN EQUITY «B», L.P., PA-

LAMON EUROPEAN EQUITY «C», L.P., PALAMON EUROPEAN EQUITY «D», L.P., PALAMON EUROPEAN, GmbH
&amp; CO. BETEILIGUNGS KG, PALAMON EUROPEAN EQUITY II, L.P. et PALAMON EUROPEAN EQUITY II «BOA»,
L.P.

Plan de regulation des Actifs signifie le règlement des «Plans d’Actifs» (29 CFR 2510 3-101) sous ERISA.
VCOC signifie «venture capital operating company» selon la définition du Plan de Régulation des Actifs.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P.,

représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés Gérants de la Société pour une période indéterminée:
- Ron E. Bell, expert comptable, né le 11 juin 1956 at Worcestor, Angleterre, avec adresse professionnelle au Palamon

Capital Partners, 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, Royaume-Uni;

Parts Sociales:
PALAMON EUROPEAN EQUITY L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 Parts Sociales

Total: cinq cents Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 Parts Sociales

88770

- Gérard Becquer, réviseur d’entreprise, born on 29 April 1956 at Briey, France, with professional address at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de tout Gérant ou par

la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par tout Gérant.

2.- Le siège social de la Société est établi au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, vol. 154S, fol. 42, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084267.3/211/647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

RACINE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 108.298. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 mars 2006

- les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, de Monsieur Christian François et de Monsieur Pierre Mestdagh

de leur mandat d’Administrateur sont acceptées;

- les sociétés FINDI, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg et MADAS, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, sont nommées comme nouveaux Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080873.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

VALERES KONSTRUKTIOUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Z.A.E. Weiergewan.

R. C. Luxembourg B 81.984. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires réunie à Contern, le 14 juin 2006

«(...) Les démissions de M. Alex Deckers et de la société VALERES HOLDING N.V. sont acceptées.
(...) L’assemblée décide de nommer au sein du Conseil d’Administration pour une période de 6 ans s’achevant avec

la tenue de l’assemblée générale prévue en 2012:

- Marc Diver, né le 7 septembre 1963 à Mechelen (B), demeurant 20, rue de Canach à L-5368 Schuttrange;
- Nicolas Van Schap, né le 20 juillet 1971 à Bonheiden (Belgique), demeurant Schuttersvest 55/11 à B-2800 Mechelen;
- Godelieve Buyl, née le 11 décembre 1963 à Geraardsbergen (Belgique), demeurant J. Gansemansstraat 7 à B-3150

Haacht (...).»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081355.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

J. Elvinger.

Certifié sincère et conforme
<i>RACINE INVESTISSEMENT S.A.
LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

Signature
<i>Un mandataire

88771

FARMLAND CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 49.470. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01588, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081364.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

TECHLINK S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 117.693. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The Luxembourg Stock company VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A., with registered office in L-1251 Luxem-

bourg, 13, avenue du Bois, 

here duly represented by its delegated of the board of directors Mr Yvon Hell, chartered accountant, residing pro-

fessionally in Luxembourg.

2.- The Luxembourg Stock company C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-5943

Itzig, 6, rue Jean-Pierre Lanter,

here duly represented by its managing director Mr Dominique Delaby, chartered accountant, residing professionally

in Luxembourg.

Such appearing parties, represented as said before, request the officiating notary to enact the following Articles of

Association of a Stock Company («Aktiengesellschaft»), which they declare to have established as follows:

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those who might become owners of the shares created here-

after, is herewith formed a joint stock company («Aktiengesellschaft»), under the name of TECHLINK S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
By a simple decision of the board of directors, branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be es-

tablished in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision

of the shareholders’ meeting.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the import and export, the wholesale and retail trade as well as the other

commercial operations with products of all kind.

Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The company can moreover carry out all financial, industrial, commercial, movable or immovable operations, which

are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to further his development or extension. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), divided into one

hundred (100) shares with a par value of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprise
Signatures

88772

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election. 

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting desig-

nated to that effect by the board. 

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies

between directors being permitted, with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by

letter.

Written resolutions, approved and signed by all directors, shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board of directors are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposi-

tion in the company’s interest within the limits of the company’s purpose.

All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of August 10th, 1915, as subse-

quently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board
of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the company.

The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of sharehold-

ers.

The first delegate of the board of directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.

Art. 12. The company will be validly bound by the individual signature of the managing director of the company,

having the capacity to exercise the activities described in the previous purpose, in conformity with the rules fixed by the
Luxembourg «Mittelstandsministerium» or by the joint signatures of the said managing director and another director of
the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration; they can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify the acts concerning the company.
Its resolutions are binding even for the shareholders who are not represented, vote against or abstain from voting.
The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held on the 1st Thursday of June at 13.00 a.m. at the Company’s Head Office,

or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.
It must be convened at the written request of shareholders representing 20% percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% percent of the net profit of the financial year have to be allocated to the legal reserve fund; such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

88773

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. For any points, not covered by the present articles of incorporation, the parties refer to the provisions of

the law of August 10th, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory dispositions

1.- The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Estimation of costs

The amount of the expenses, for which the company is liable as a result of its formation, is approximately fixed at

one thousand six hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of Directors is fixed at three and that of the Auditors at one.
2.- The following have been appointed as Directors:
a) Mr Bhupinder Arora, businessman, born in Delhi (India), on the 4th of August 1960, residing in D-41352 Korschen-

broich, 13, Am Heyerhof (Germany);

b) Mr Paul Agnes, companies director, born in Ettelbruck, on the 25th of August 1941, residing in L-1661 Luxem-

bourg, 7, Grand-rue;

c) The Luxembourg Stock company C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-5943

Itzig, 6, rue Jean-Pierre Lanter, inscribed in the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, section B, under the
number 66.684.

3.- The following has been appointed as Statutory Auditor:
The limited liability company SOCIETE D’AUDIT &amp; DE REVISION, S.à r.l., with registered office in L-1251 Luxem-

bourg, 13, avenue du Bois, inscribed in the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, section B, under the number
108.281.

4.- The Company’s registered office shall be in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
5.- The mandates of the Directors and the Statutory Auditor will expire at the general annual meeting in the year

2011.

6.- Following the faculty offered by article eleven (11) of the Articles of Incorporation, the meeting delegates the daily

management of the company to Mr Bhupinder Arora, who has the widest powers to carry out all acts in the name of
the company, including all banking operations.

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the German version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, acting as said before, known to the notary, by their sur-

names, first names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the
present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zwei tausend sechs, den dreissigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

1.- The Luxembourg Stock company VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A., with registered office in L-1251

Luxembourg, 13, avenue du Bois, ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- The Luxembourg Stock company C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., with registered office in

L-5943 Itzig, 6, rue Jean-Pierre Lanter, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

88774

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1251 Luxemburg, 13, ave-

nue du Bois, 

hier rechtsmässig vertreten durch ihren Bevollmächtigten des Verwaltungsrates Herrn Yvon Hell, Chefbuchhalter,

beruflich wohnhaft in Luxemburg.

2.- Die Aktiengesellschaft C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1251 Luxemburg,

13, avenue du Bois, 

hier rechtsmässig vertreten durch ihren Bevollmächtigten des Verwaltungsrates Herrn Dominique Delaby, Chefbuch-

halter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Welche Komparentinnen, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzungen einer

von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung TECHLINK S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im

Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum

verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export, der Gross- und Einzelhandel sowie alle anderen handels-

üblichen Operationen mit Waren aller Art.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt

in einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. 

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-

machten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen
vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder e-mail abgeben, welche

schriftlich bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

88775

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegen-

heiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsrates.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, die

Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalver-

sammlung.

Die erste Person, der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung er-

nannt werden. 

Art. 12. Die Gesellschaft ist rechtsmässig vertreten durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmit-

gliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschaftszweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben,
gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Un-
terschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare, welche nicht Aktionäre sein

müssen, überwacht, welche von der Generalversammlung, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt, ernannt werden;
sie können beliebig abberufen werden.

Die Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von 6 Jahren nicht

überschreiten kann.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre.
Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 1. Donnerstag des Monats Juni um 13.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. 

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen

Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört,

hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, dem (den) Kommissar(en) zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden

zahlen.

Die Generalversammlung kann beschliessen Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu be-

nutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter, natür-

liche oder juristische Personen, durchgeführt, welche von der Generalversammlung, die ihre Aufgaben und Vergütungen
festlegt, ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen. 

88776

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2007 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparentinnen, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf unge-

fähr eintausendsechshundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Bhupinder Arora, Geschäftsmann, geboren in Delhi (Indien), am 4. August 1960, wohnhaft in D-41352

Korschenbroich, 13, Am Heyerhof (Bundesrepublik Deutschland);

b) Herr Paul Agnes, Gesellschaftsverwalter, geboren in Ettelbrück, am 25. August 1941, wohnhaft in L-1661 Luxem-

burg, 7, Grand-rue;

c) Die Aktiengesellschaft C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1251 Luxemburg,

13, avenue du Bois, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
66.684.

3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOCIETE D’AUDIT &amp; DE REVISION, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in

L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B,
unter der Nummer 108.281.

4.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois.
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2011.

6.- Gebrauch machend vom durch Artikel elf (11) der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung

Herrn Bhupinder Arora, vorgenannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft
durch seine Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämt-
liche Bankoperationen miteinbegriffen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der Komparenten
und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben
mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Y. Hell, D. Delaby, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juin 2006, vol. 536, fol. 89, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071086.3/231/347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.

1.- Die Aktiengesellschaft VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1251 Luxemburg,

13, avenue du Bois, neunundneunzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Die Aktiengesellschaft C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1251 Lu-

xemburg, 13, avenue du Bois, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Junglinster, den 14. Juli 2006.

J. Seckler.

88777

GEC LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.657. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2006

Nomination de la société MC CONSULTING, S.à r.l., comme Administrateur.
Elle est domiciliée au 81, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’an-

née 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10351. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077806.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

BELFRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.997. 

Précision quant à l’adresse et la durée du mandat d’un administrateur suivant:
ASH ANDREW DOUGLAS,
60, Circular Road,
GB-IM1 1SA Douglas,
Isle of Man;
Nomination le 14 août 1998.
Durée du mandat: Indéterminée.
Précision quant au siège social de l’associé:
AMBERCHAM LIMITED,
45-47, 3rd Floor, Corn Hill,
EC3V 3PD Londres,
Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078112.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

SKYFIELD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.137. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02018, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081182.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

TECNOVERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 24.039. 

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11098, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081152.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

<i>Pour la société GEC LUX S.A.
C. Marques
<i>Administrateur

Luxembourg, le 13 juillet 2006.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

88778

TAXIS DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, In den Allern.

R. C. Luxembourg B 103.309. 

EXTRAIT

Il découle d’un acte de cession de parts du 9 mai 2006, reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Al-

zette, enregistré à l’Enregistrement et des Domaines d’Esch-sur-Alzette en date du 10 mai 2006, vol. 916, fol. 90, case
8, que:

- Le capital de la société TAXIS DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., se trouve réparti de la manière suivante: 

Ensuite l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé:
- d’accepter à compter du 9 mai 2006 la démission de:
Madame Solange Mignon, commerçante, demeurant à B-6670 Gouvy, 34 Deiffelt, de sa fonction de gérante unique

de la prédite société TAXIS DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l.

- de nommer à compter du 9 mai 2006 pour une durée indéterminée:
Monsieur Carlos Manuel Morgado Lopes, indépendant, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 136, rue Victor Hugo,

dans la fonction de gérant unique.

- de préciser que vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et l’engager valablement par sa seule signature.

Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(078421.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

POLY ART TRADING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 36.202. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05876, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, au mois de juillet 2006.

(081128.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

BUREAU &amp; COMPUTERCENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9701 Clervaux, 4, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 95.693. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2001

A. Sont nommés Administrateurs pour une période d’un an - leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Marc Tafniez, demeurant à B-4830 Limbourg;
- Monsieur Herbert Weynand, demeurant à Medell, B-4770 Amel;
- Monsieur Norbert Eicher, demeurant à Hünningen, B-4780 St. Vith;
- Monsieur François Meyers, demeurant à L-Eselborn;
- Madame Mathilde Backes, demeurant à Hünningen, B-4780 St. Vith. 
B. Est nommé Commissaire aux Comptes pour une période d’un an - son mandat prenant fin lors de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Guido Lehnen, demeurant à B-4960 Malmedy.
C. Il a été décidé de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.250.000 LUF en 30.986,69 EUR.
D. Il a été décidé d’augmenter le capital social de 13,31 EUR pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 EUR

à 31.000 EUR par incorporation du bénéfice reporté.

E. Il a été décidé de supprimer la mention de valeur nominale des actions émises.

- TAXIS AMUBLANCES MORGADO, S.à r.l., avec siège à Esch-sur-Alzette, 136, rue Victor Hugo . . . .

100 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

A. Biel
<i>Notaire

<i>Pour compte de POLY ART TRADING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

88779

F. Il a été décidé d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR) divisé en cent (100) actions.

Diekirch, le 5 juillet 2006.

Enregistré à Diekirch, le 5 juillet 2006, réf. DSO-BS00039. – Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(965490.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 2006.

BUREAU &amp; COMPUTERCENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9701 Clervaux, 4, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 95.693. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2006

1. Sont nommés Administrateurs pour une période d’un an - leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006:

- Monsieur Marc Tafniez, demeurant à B-4830 Limbourg;
- Monsieur Herbert Weynand, demeurant à Medell, B-4770 Amel;
- Monsieur Norbert Eicher, demeurant à Hünningen, B-4780 St. Vith;
- Monsieur François Meyers, demeurant à L-9748 Eselborn;
- Madame Mathilde Backes, demeurant à Hünningen, B-4780 St. Vith.
L’assemblée décide de désigner Madame Mathilde Backes comme Présidente du Conseil d’Administration et comme

Administrateur-délégué. Elle peut engager la société par sa seule signature.

2. Est nommé Commissaire aux Comptes pour une période d’un an - son mandat prenant fin lors de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006:

- Monsieur Ronny Eicher, demeurant à L-1467 Howald.

Enregistré à Diekirch, le 8 juin 2006, réf. DSO-BR00068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(965492.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 2006.

CO-INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 81.360. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006

Le Conseil d’Administration nomme administrateur en remplacement de M. Schumacher Romain, 43, rue Emile La-

vandier, L-1924 Luxembourg:

- M

e

 Yves Kasel, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration nomme commissaire aux comptes en remplacement de ECOFTSC S.A., 43, rue Emile

Lavandier, L-1924 Luxembourg:

- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Le nouveau conseil d’administration est composé de trois administrateurs:
- M

e

 Georges Cloos, docteur en droit, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Yves Kasel, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Claude Pauly, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 

Commissaire aux comptes: 
- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assemblée géné-

rale statutaire de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10693. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081025.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Backes / M. Tafniez
<i>Administrateur-délégué / -

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Backes / Signature
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

Pour copie conforme
Signature

88780

INVESTCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 85.686. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juillet 2006.

(081127.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

METRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. METRO INTERNATIONAL LUXEMBOURG HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.790. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

(081176.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.589. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02015, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081184.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

AIKON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 95.582. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006

Le Conseil d’Administration nomme administrateur en remplacement de ECOFISC S.A., 43, rue Emile Lavandier,

L-1924 Luxembourg:

- M

e

 Georges Cloos, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration nomme commissaire aux comptes en remplacement de M. Schumacher Romain, 43, rue

Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg:

- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Le nouveau conseil d’administration est composé de trois administrateurs:
- M

e

 Georges Cloos, docteur en droit, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Yves Kasel, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Claude Pauly, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 

Commissaire aux comptes: 
- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assemblée géné-

rale statutaire de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081027.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

<i>Pour compte de INVESTCOLUX S.A. 
FIDUPLAN S.A.
Signature

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature.

Pour copie conforme
Signatures

88781

PUMASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.086. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081186.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

HERSTELLER-VERTRETUNGEN-BETRIEBS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.358. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09245, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(081210.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

AMODO, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 92.577. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081231.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

AFC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 92.227. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02005, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081234.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

IPEF III HOLDINGS N° 11 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.607. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 30 juin 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081764.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

88782

ZAFINI HOLDING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4031 Esch-sur-Alzette, 34, rue Zénon Bernard.

H. R. Luxemburg B 114.674. 

Im Jahre zweitausendsechs, am achtzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft ZAFINI

HOLDING mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 6. März 2006, veröffentlicht

im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1035 vom 27. Mai 2006,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer

114.674.

Die Versammlung wurde eröffnet um 15.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Max Mayer, Privatbe-

amter, mit professioneller Adresse in Luxemburg-Eich.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, mit professioneller Adresse in

Luxemburg-Eich.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Patrick Roemer, Privatbeamter, mit professioneller Adresse in

Luxemburg.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Prä-

senzliste angeführt sind. 

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die siebenhundert (700) bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschafts-

kapital darstellen, in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Ver-
sammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes und demzufolgte Abänderung vom ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung;
2.- Abberufung und Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern;
3.- Niederlegung des Mandats eines geschäftsführenden Verwaltungsrates;
4.- Abänderung von Artikel 12 der Satzung.
Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstim-

mig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz nach L-4031 Esch-sur-Alzette, 34, rue Zénon Bernard zu verlegen.
Demzufolge lautet der erste Absatz von Artikel 2 nunmehr folgendermassen: 

«Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Esch-sur-Alzette.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Roger Frick als geschäftsführender Verwaltungsrat an und erteilt

ihm für die Ausübung seines Mandates Entlast.

Desweiteren ernennt die Versammlung Herrn Gérard Raulet, Privatbeamter, geboren in Mont Saint Martin (Frank-

reich), am 8. Februar 1951, wohnhaft in F-54400 Cosnes-les-Romain, 87, rue du Dauphiné, zum neuen Verwaltungsrats-
mitglied.

Somit setzt sich der Verwaltungsrat nunmehr wie folgt zusammen:
- Herr Roger Frick;
- Herr Ronald Weber;
- Herr Thomas Schulz; und
- Herr Gérard Raulet.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Thomas Schulz in seiner Eigenschaft als mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsrats an und erteilt ihm Entlast für die Ausübung seines Mandates.

<i>Vierter und letzter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 12 der Satzung folgendermassen abzuändern:
«Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet

durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder durch die einzelne Unterschrift
der Person, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder
durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift von allen Personen welchen der Verwaltungsrat solche Unterschrifts-
befugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen ihrer Unterschriftsbefugnisse.»

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 15.15 Uhr.

<i>Bestätigung des Notars

Der amtierende Notar bestätigt ausdrücklich, dass die Bedingungen der Artikel 26, 32-1 des Gesetzes über die

Handelsgesellschaften, betreffend vorbenannte Kapitalaufstockungen, erfüllt sind.

88783

<i>Abschätzung, Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund der in gegenwärtiger Urkunde erfolgten

Kapitalerhöhungen erwachsen, werden abgeschätzt auf neunhundert Euro (EUR 900,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Mayer, C. Fondeur, P. Roemer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, vol. 154S, fol. 74, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(077284.3/206/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

ZAFINI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 34, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 114.674. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg- Eich, le 24 juillet 2006.

(077285.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

GUSTAV 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.085. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02004, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081235.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

BIFROST ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.129. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02003, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081239.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

CMS S.A., COMPUTER MULTIMEDIA SOFTWARE, Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 91.791. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081274.3/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Luxemburg-Eich, den 24. Juli 2006.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Signature.

Signature.

A. Biel
<i>Notaire

88784

FINPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 79.574. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006

Le Conseil d’Administration nomme administrateur en remplacement de ECOFISC S.A., 43, rue Emile Lavandier,

L-1924 Luxembourg:

- M

e

 Georges Cloos, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration nomme commissaire aux comptes en remplacement de M. Schumacher Romain, 43, rue

Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg:

- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Le nouveau conseil d’administration est composé de trois administrateurs:
- M

e

 Georges Cloos, docteur en droit, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Yves Kasel, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Claude Pauly, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg; 

Commissaire aux comptes: 
- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assemblée géné-

rale statutaire de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081029.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

SOLUNA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 86.926. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006

Le Conseil d’Administration nomme administrateur en remplacement de ECOFISC S.A., 43, rue Emile Lavandier,

L-1924 Luxembourg:

- M

e

 Yves Kasel avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration nomme commissaire aux comptes en remplacement de M. Romain Schumacher, 43, rue

Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg:

- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Le nouveau conseil d’administration est composé de trois administrateurs:
- M

e

 Georges Cloos, docteur en droit, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Yves Kasel, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Claude Pauly, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

Commissaire aux comptes: 
- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assemblée géné-

rale statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081031.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

VISTA FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.493. 

Les statuts coordonnés, suivant l’acte n

o

 40266 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 4 août 2006.

(081257.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour copie conforme
Signatures 

Pour copie conforme
Signatures

J. Elvinger
<i>Notaire

88785

METAL MANAGEMENT &amp; FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 23.962. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006

Le Conseil d’Administration nomme administrateur en remplacement de ECOFISC S.A., 43, rue Emile Lavandier,

L-1924 Luxembourg:

- M

e

 Yves Kasel, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration nomme commissaire aux comptes en remplacement de M. Schumacher Romain, 43, rue

Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg:

- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.
Le nouveau conseil d’administration est composé de trois administrateurs:
- M

e

 Georges Cloos, docteur en droit, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Yves Kasel, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg;

- M

e

 Claude Pauly, avocat, 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 

Commissaire aux comptes: 
- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg. 
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assemblée géné-

rale statutaire de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081036.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.975. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081261.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

WIZARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.431. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00143, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.373. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01018, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081339.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour copie conforme
Signature

Signature.

Signature.

SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A.
J.-M. Heitz / G. Diederich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

88786

PREFUELED. COM-ONLINE MUSIC STORE, Société à responsabilité limitée,

(anc. MANIS, S.à r.l.).

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 110.434. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

(081266.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 85.341. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00161, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081268.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 85.341. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00158, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081271.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.341. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00155, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081275.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.341. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00154, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081277.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

MISTRAL ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 95.827. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00189, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081286.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

88787

MORANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.831. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00304, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081343.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

TROPICAL AQUACULTURE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 118.280. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third of August.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. TROPICAL AQUACULTURE PRODUCTS, INC, a company incorporated under the laws of The United States

(USA), with registered office at 63 Grove St, Rutland, Vt 05701, The United States (USA), hereinafter represented by
M

e

 Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal to him in Luxembourg

on August 02, 2006, which will remain annexed hereto and registered with this deed.

2. Mr John K. Schramm, director, born in Rockland, Maine, The United States (USA), on June 12th, 1967, residing in

P.O. Box 6311 Rutland, Vt 05702-6311, The United States (USA), hereinafter represented by M

e

 Charles Duro, lawyer,

residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal to him in Luxembourg on the August 2, 2006,
which will remain annexed hereto and registered with this deed.

3. Mr Laurent Metivier, commercial agent, born in Bayeux (14), France, on April 6th, 1972, residing in La Chapelle

Grenieux, 42510 Nervieux, France, hereinafter represented by M

e

 Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg, by

virtue of a proxy given under private seal to him in Luxembourg on August 2, 2006, which will remain annexed hereto
and registered with this deed.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles

of incorporation of a company which they form between themselves:

Art. 1. Name - Form. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name TROPICAL AQUACUL-
TURE EUROPE S.A. (the «Company»).

Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined period.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or

other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. Object. The object of the company is the importing, marketing, sales and distribution of Farm Raised Tilapia

products, as well as other aquaculture products throughout Europe and the UK. 

Operations shall include development of a customer base for fresh farm raised Tilapia products, and other aquacul-

ture products, coordination of export from country of origin to the logical port of entry in Europe to meet the customer
needs and all market development requirements.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or oth-
erwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly con-

nected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. Share capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) consisting of three

thousand and one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) per share, entirely paid in.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Shares. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or

the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

MORANA HOLDING S.A.
A. Beltrame / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateur

88788

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Art. 7. Transfer of shares. Any shareholder (in this article also referred to as the applicant), who wishes to transfer

whole or part of his shares has to offer them in priority to the other shareholders by way of written notification sent
by registered letter to the Chairman of the Board of directors, by indicating the exact number of shares he wishes to
transfer.

The Chairman of the Board of directors informs each shareholder by registered letter within eight days starting from

the date of the acknowledgement of the notification made by the applicant.

The interested shareholder(s) has (have), within fifteen days starting from the date of notification of the registered

letter of the Chairman of the Board of directors, to inform the Chairman by registered letter of their intention to buy
or not to buy whole or part of the shares.

If the offer to purchase shares is accepted by more than one shareholder, shares shall be distributed between the

interested shareholders in proportion to the aggregate amount of their shares.

The purchase price of the shares shall be fixed by reference to the market value of these shares, or if such a value

cannot be determined, by reference to the book value of these shares. If a dissension occurs between the applicant and
the interested party (parties) about the determination of the price, the purchase price shall be determined by the Stat-
utory Auditor of the Company.

If no shareholder wishes to purchase shares, the Company shall, subject to the limitations set by the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and by the By-laws, be entitled
to purchase whole or part of the shares, if it fulfils the conditions required for the acquisition by a company of its own
shares.

If shareholders and the Company refuse to purchase the shares, the applicant shall be at liberty to transfer all shares

subject to the limitations set by the terms and conditions mentioned in the written notification made by the applicant
to the Chairman of the Board of directors.

Art. 8. Shareholders’ meetings - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify all acts relating to the operations of the Company.

Art. 9. Annual general meeting - Approval of annual accounts. The annual general meeting of shareholders

shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be
specified in the notice of meeting on the third Thursday of May at 2.00 p.m. and for the first time in the year 2007.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Art. 10. Other meetings. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified

in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. Composition of Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed

of three members at least, who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 12. Board meetings. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may

choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall
be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

88789

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 13. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts of administration and disposition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by law to
the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders
of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

Art. 14. Representation. The Company will be bound by the joint signature of two directors «including necessarily

the signature of the managing director» or by the single signature of the managing director duly authorised by the «Min-
istère des Classes Moyennes», or by the single signature of any persons to whom such signatory power shall be dele-
gated by the board of directors.

Art. 15. Supervision. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors,

which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall
determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall

terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the for-
mation of the Company and shall terminate on December 31st, 2006.

Art. 17. Allocation of profits. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to

the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 18. Dissolution. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 19. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-

ance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand Euro

(31,000.- EUR) is as of now available to the company

<i>Declaration - Evaluation

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred Euro.

<i>General meeting of shareholder

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditor at one.
2. Are appointed as directors:
- Mr John Kimball Schramm, company chairman, born in Rockland, Maine, The United States (USA), on June 12th,

1967, residing in P.O. Box 6311 Rutland, Vt 05702-6311, The United States (USA),

- Mr Laurent Metivier, company director, born in Bayeux (14), France, on April 6th, 1972, residing in La Chapelle

Grenieux, 42510 Nervieux, France,

- Mrs Nicole Maeck, company director, born in Belgium, residing in 15, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

Shareholders

Subscribed

Paid-in

Number

 capital

 Capital

 of shares

1) TROPICAL AQUACULTURE PRODUCTS, INC, prenamed   . . . . . . . . .

14,570.-

14,570.-

1,457

2) Mr John K. Schramm, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,810.-

15,810.-

1,581

3) Mr Laurent Metivier, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620.-

620.-

62

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

31,000.-

3,100

88790

3. Has been appointed statutory auditor:
The company FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., having its registered office at 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419

Luxembourg.

4. The address of the Company is set at 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders to be held in the year 2012, unless otherwise decided by a shareholders meeting.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 12 of the

by-laws.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

French version:

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. TROPICAL AQUACULTURE PRODUCTS, INC, une société anonyme constituée et existant sous la loi des Etats-

Unis (USA), ayant son siège social au 63 Grove St, Rutland, Vt 05701, Etats-Unis (USA), ici représentée par Maître Char-
les Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée le 2 août 2006, laquelle restera an-
nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

2. M. John K. Schramm, administrateur, né à Rockland, Maine, Etats-Unis (USA), le 12 juin 1967, demeurant à P.O.

Box 6311 Rutland, Vt 05702-6311, Etats-Unis (USA), ici représenté par M

e

 Charles Duro, avocat, demeurant à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration lui délivrée le 2 août 2006, laquelle restera annexée au présent acte pour être enre-
gistrée avec lui.

3. M. Laurent Metivier, agent commercial, né à Bayeux (14), France, le 6 avril 1972, demeurant à La Chapelle Gre-

nieux, 42510 Nervieux, France, ici représentée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration lui délivrée le 2 août 2006, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Dénomination - Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires

des actions ci-après créées, une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de TROPICAL
AQUACULTURE EUROPE S.A. (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Objet. La société a pour objet l’importation, la gestion, la vente et la distribution de produits d’élevage de

Tilapia, ainsi que l’importation, la gestion, la vente et la distribution de tout autre produit de pisciculture, et ce dans
toute l’Europe et au Royaume-Uni.

Les activités incluent le développement de la clientèle, la coordination entre la production des pays exportateurs des

produits et les besoins des clients européens, et la recherche de développement du marché.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté

par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de cent euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme,

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

88791

Art. 7. Cession d’actions. Tout actionnaire de la Société qui désire céder tout ou partie de ses actions doit les

offrir en priorité aux autres actionnaires de la Société par voie de notification écrite envoyée par lettre recommandée
au Président du Conseil d’administration, en indiquant le nombre exact d’actions qu’il désire transférer.

Le Président du Conseil d’administration informe chaque actionnaire par lettre recommandée dans un délai de huit

jours à partir de la date de réception de la notification faite par l’actionnaire cédant.

Les actionnaires doivent, dans un délai de quinze jours à partir de l’envoi recommandé du Président du Conseil d’ad-

ministration, informer ce dernier par lettre recommandée de leur intention ou non d’acheter tout ou partie des actions
qui leurs sont offertes. 

Au cas où l’offre d’acquérir les actions est acceptée par plus d’un actionnaire, les actions qui sont offertes seront

distribuées entre les actionnaires intéressés au prorata de leur participation respective dans le capital social de la Socié-
té.

Le prix de vente des actions qui sont offertes sera fixé par référence à la valeur réelle de ces actions, ou si une telle

valeur ne peut pas être déterminée, par référence à la valeur comptable de ces actions. Si un désaccord survient entre
le cédant et le(s) cessionnaire(s) au sujet de la détermination de la valeur des actions, le prix de vente de ces actions
sera déterminé par le Commissaire aux comptes de la société.

Au cas où aucun actionnaire ne désire acquérir les actions qui sont offertes, la Société peut, dans les termes et con-

ditions prévus par la loi et par les statuts de la Société, acquérir tout ou partie des actions offertes.

Seulement au cas où les actionnaires et la Société refusent d’acquérir les actions qui sont offertes, l’actionnaire qui

désire céder ses actions est libre de transférer les actions offertes au(x) tiers sous les termes et conditions mentionnés
dans la notification écrite faite par l’actionnaire au Président du Conseil d’administration.

Art. 8. Assemblée des actionnaires - Général. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement cons-

tituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 9. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L’assemblée générale annuelle

des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation,
le troisième jeudi du mois de mai à 14.00 heures, et pour la première fois en l’an deux mille et sept.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés

dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 11. Composition du Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration

composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 12. Réunions du Conseil d’administration. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un prési-

dent et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus lar-

ges de passer tous actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne ré-
serve pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

88792

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et

à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 14. Représentation. La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs «dont obli-

gatoirement celle de l’administrateur-délégué», soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dûment
autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir
de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 15. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comp-

tes qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comp-
tes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 16. Exercice social. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 dé-

cembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se
terminera le 31 décembre 2006.

Art. 17. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de

plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 19. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille huit cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- M. John Kimball Schramm, Président du Conseil d’administration, né à Rockland, Maine, Etats-Unis (USA), le 12 juin

1967, demeurant à P.O. Box 6311 Rutland, Vt 05702-6311, Etats-Unis (USA),

- M. Laurent Metivier, administrateur, né à Bayeux (14), France, le 6 avril 1972, demeurant à La Chapelle Grenieux,

42510 Nervieux, France,

- Mme Nicole Maeck, administrateur, née en Belgique, demeurant à L-2240, Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

 d’actions

1) TROPICAL AQUACULTURE PRODUCTS, INC, prénommée. . . . . . . . .

14.570,-

14.570,-

1.457

2) M. John K. Schramm; prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.810,-

15.810,-

1.581

3) Mr Laurent Metivier, prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620,-

620,-

62

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

3.100

88793

4. L’adresse de la société est fixée à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2012, sauf si une assemblée générale des actionnaires en décide
autrement.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 12

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Ch. Duro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, vol. 154S, fol. 92, case 6. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084270.3/211/375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

BANQUE DU GOTHARD.

Société mère: BANQUE DU GOTHARD S.A., CH-6901 Lugano.

R. C. Luxembourg B 17.598. 

La modification des rubriques suivantes est requise au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg:

<i>Conseil d’administration:

M. Felix R. Ehrat, président,
M. Gerold Bührer, vice-président,
M. Reto Himmel,
M. Bruno Pfister,
M. Renzo Respini.

<i>Succursale de Luxembourg: 

M. Ignatius Bundi, membre de la direction,
M. Henri Ernzen, membre de la direction,
M. Walter Frigerio, membre de la direction,
M. Cyrus Wardjawand, membre de la direction,
M. Guido Berresheim, membre des cadres,
Mme Ilona Friedrich-Müller, membre des cadres,
Mme Mara Galassi, membre des cadres,
Mme Manon Hertges, membre des cadres,
M. Muammer Kardelen, membre des cadres,
Mme Ursula Krämer-Schneider, membre des cadres,
M. Ulf Mennenkamp, membre des cadres,
Mme Gabriele Meter-Lehnen, membre des cadres,
M. Gregor Müller, membre des cadres,
M. Alexander Paulus, membre des cadres,
Mme Ariane Scholten, membre des cadres,
Mme Susan Scholz, membre des cadres,
M. Eric Staël, membre des cadres,
M. Satoshi Takato, membre des cadres,
M. Romain Thilmany, membre des cadres,
Mme Christiane Watgen, membre des cadres,
M. Ingo Werner, membre des cadres,
M. Martin Wozignoj, membre des cadres.
La présente publication remplace, et pour autant que de besoin, annule toutes les publications antérieures.

Luxembourg, le 21 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11390. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081172.3//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Luxembourg, le 9 août 2006.

J. Elvinger.

BANCA DEL GOTTARDO
J. Bundi / H. Ernzen
<i>Directeur de la succursale / Membre de la Direction

88794

BANQUE DU GOTHARD.

Société mère: BANQUE DU GOTHARD S.A., CH-6901 Lugano.

R. C. Luxembourg B 17.598. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081181.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

UNITED ADMINISTRATIVE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.634. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081290.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

PROVIDANCE MUSIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 78.335. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00180, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081296.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

MEDIPLAN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 30.738. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00184, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081300.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.

GARFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 73.326. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 26 juin 2006, a pris acte de la démission de Monsieur Henry

Peter de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Pietro Losi, domicilié au 6, Via Chiapponi, 29100 Piacenza, Italie a été nommé en son remplacement.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10828. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081770.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD
H. Ernzen / R. Thilmany
<i>Membre de la Direction / Membre des Cadres

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

88795

HLK SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 14, rue Saint Vincent.

R. C. Luxembourg B 69.518. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01030, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081334.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

COMINHOLDING, COMPAGNIE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.404. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01671 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081335.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

GIOCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.506. 

Le bilan au 31 mai 2006, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01668, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081336.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

PORTA VOLTA DEVELOPMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.221. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01666, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081337.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

FINANCIERE HOTELIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 100.048. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02040, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081698.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

FINANCIERE HOTELIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 100.048. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081701.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

J.-J. Holuka.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

88796

VAN VEEN OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.493. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01664, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081338.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Z.D. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.357. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01061, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081340.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

PROMOLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.470. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00302, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081342.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

RANBIWA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 113.260. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00309, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081344.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

HOUSTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1,000,000.-.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 109.278. 

In the year two thousand and six, on the ninth day of the month August.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HOUSTON, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one million euro (EUR
1,000,000.-), which has been incorporated by a deed of the undersigned notary on 5 July 2005, published in the Official
Luxembourg Gazette - Mémorial C, number 1230 on 18 November 2005, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies, section B, under number 109.278 and which has its registered office at 2, boulevard Konrad
Adenauer, L-1115 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), (the «Company»). The articles of incorporation of the

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

Z.D. FINANCE S.A.
V. Arnò / G. Diederich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour PROMOLAND HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

RANBIWA PROPERTIES S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

88797

Company have last been amended by a deed of the undersigned notary on the 2nd August 2005, published in the Official
Luxembourg Gazette - Mémorial C, number 1434 on 22 December 2005.

The meeting is declared open and is chaired by Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints Mrs Joëlle Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg as secretary of the meeting.
Mr Pierre-Alexandre Lechantre, lawyer, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer.
The bureau of this meeting being thus constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
(i) The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of the liquidator.
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidator’s remuneration.
4. Miscellaneous.
(ii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the

shares held by them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies, by the bureau
of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned

notary, will also remain annexed to the present deed.

(iv) It appears from the said attendance-list that all the forty thousand (40,000) shares representing the total sub-

scribed capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.

(v) The shareholders present or represented declare that they consider themselves as having been duly convened to

this extraordinary general meeting of shareholders and that they have been duly informed on the agenda before this
meeting.

(vi) The present meeting being regularly constituted, it may deliberate on the item of the agenda.
Thereupon, the meeting, each time unanimously, passes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The meeting resolves to appoint DB GALIL FINANCE INC., a company governed by the laws of Delaware, United

States of America, having its registered office at 1011 Centre Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19805-1266, Unit-
ed States of America, as liquidator.

<i>Third resolution

The meeting resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any

act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third par-

ties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary.

The meeting resolves to approve the liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourns the meeting.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française de la version anglaise qui précède:

L’an deux mille six, le neuf août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société HOUSTON, S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-), consti-
tuée suivant acte du notaire soussigné, le 5 juillet 2005, publié au Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C,
numéro 1230 du 18 novembre 2005 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dans la
section B, sous le numéro 109.278 et ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte du notaire soussigné, le 2 août 2005, publié au Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, numéro 1434 du
22 décembre 2005.

88798

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Joëlle Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre-Alexandre Lechantre, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée étant donc valablement constituée, Monsieur le Président déclare et demande au notaire

d’acter que:

(i) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
4. Divers.
(ii) Le nom des associés présents ou représentés, les pouvoirs des associés représentés et le nombre des parts so-

ciales détenues par eux sont indiqués sur une liste de présence signée par les associés ou leurs mandataires si ils sont
représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et par le notaire instrumentant, qui restera annexée aux pré-
sentes pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

(iii) Les pouvoirs des associés représentés signés ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant

resteront également annexés aux présentes pour être soumis à la formalité de l’enregistrement.

(iv) Il ressort de la dite liste de présence que toutes les quarante mille (40.000) parts sociales représentant l’intégralité

du capital social souscrit de la Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, celle-ci étant ainsi valablement
constituée et pouvant proprement statuer sur l’ordre du jour.

(v) Les associés présents ou représentés déclarent se considérer comme ayant été valablement convoqué à cette

assemblée générale extraordinaire et qu’ils furent dûment informés de l’ordre du jour de cette assemblée.

(vi) L’assemblée étant valablement constituée peut délibérer sur les points de l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée adopte, chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer DB GALIL FINANCE INC., une société constituée à Delaware, Etats-Unis, ayant son

siège social au 1011 Centre Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19805-1266, Etats-Unis, comme liquidateur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que, dans l’exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour

effectuer tous les actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou
l’importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,

il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu’il croit appropriés pour l’accomplissement de certains actes particuliers.

La société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la seule signature du liquida-

teur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L’assemblée décide d’approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des associés présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président ensuite clôture l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, J. Elvinger, P.A. Lechanter, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2006, vol. 905, fol. 90, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096747.3/239/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Belvaux, le 5 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

88799

NICHE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 90.381. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00310, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(081345.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

MEXIMMO S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg E 3.183. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Denis Antoine Zavatti, gérant de société, né à Villerupt (France), le 16 décembre 1963, demeurant à

L-5650 Mondorf-les-Bains, 29, route de Remich;

2.- La société FIMACO INTERNATIONAL S.A., prénommée, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,

3, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B
99.767, ici représentée par Monsieur Denis Antoine Zavatti, demeurant à L-5650 Mondorf-les-Bains, agissant en vertu
d’une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants déclarent constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1

er

. La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par achat, vente, échange,

location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers tant au Luxembourg qu’à
l’étranger.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirec-

tement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte
au caractère exclusivement civil de l’activité sociale. 

Art. 2. La société prend la dénomination de MEXIMMO S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision

de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (EUR 1.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés mais continuera entre le ou les

survivant(s) et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par un gérant, Monsieur Denis Antoine Zavatti, prénommé. Pour tout acte géné-

ralement quelconque, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts exis-

tantes.

Art. 11. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

NICHE INVEST S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateur

88800

<i>Souscription et libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter qu’ils souscrivent les cent parts comme suit: 

Le fonds social de mille euros (EUR 1.000,-) a été mis à disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rénumérations, sous quelques forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à sept cents euros (EUR 700,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se considérant comme réunis en assemblée générale ont pris à l’unanimité des voix la décision

suivante:

Le siège de la société est fixé à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: D.A. Zavatti, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2006, vol. 920, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(084226.3/219/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.248. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 29 juin 2006
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. W. Baertz, Bei den 5 Buchen 4, 8123 Bridel, Luxembourg;
- M. F. E. Belton, Spencer Villas, Glenageary, Dublin 15, Irlande;
- M. P. R. Coulson, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irlande;
- M. G. Moloney, Palmerston Road, Rathmines, Dublin 32, Irlande;
- M. L. W. Triay, Trafalgar House, 308 Rosia Road, Gibraltar, Royaume-Uni;
- M. H. R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081543.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

1.- Monsieur Denis Antoine Zavatti, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- La société FIMACO INTERNATIONAL S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . .

99

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Esch-sur-Alzette, le 10 août 2006.

F. Kesseler.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Winward International S.A.

Nouveau Comptoir de l’Optique 2 S.A.

British Marine Holdings S.A.

British Marine Holdings II S.A.

S5 Finco, S.à r.l.

British Marine Luxembourg S.A.

International A.C.P. S.A.

Max Lease S.à r.l. &amp; Cie. S.e.c.s.

Polymed Holding S.A.

Unevinc S.A.

Sycomore Investments S.A.

Wisniowy F Investors, S.à r.l.

Orchestra Luxembourg S.A.

Novator Telecom Poland II, S.à r.l.

Intrasoft International S.A.

Eaton Holding II, S.à r.l.

Sartable S.A.

MWH, S.à r.l.

Racine Investissement S.A.

Valeres Konstruktioun S.A.

Farmland Co. S.A.

Techlink S.A.

Gec Lux S.A.

Belfry, S.à r.l.

Skyfield Luxembourg S.A.

Tecnovert Holding S.A.

Taxis des Trois Frontières, S.à r.l.

Poly ART Trading (Luxembourg), S.à r.l.

Bureau &amp; Computercenter

Bureau &amp; Computercenter

Co-Invest Holding S.A.

Investcolux S.A.

Metro International S.A.

Luxembourg Finance House S.A.

Aikon S.A.

Pumastar S.A.

Hersteller-Vertretungen-Betriebs, GmbH

Amodo

AFC S.A.

IPEF III Holdings N˚ 11 S.A.

Zafini Holding

Zafini Holding

Gustav 1, S.à r.l.

Bifrost Asset Management, S.à r.l.

CMS S.A., Computer Multimedia Software

Finpa S.A.

Soluna Consulting S.A.

Vista Finance

Metal Management &amp; Finance S.A. Holding

Swallow Investment S.A.

Wizard, S.à r.l.

System Europe Soparfi S.A.

Prefueled. com-Online Music Store

Unimex International, S.à r.l.

Unimex International, S.à r.l.

Unimex International, S.à r.l.

Unimex International, S.à r.l.

Mistral Entertainment, S.à r.l.

Morana Holding S.A.

Tropical Aquaculture Europe S.A.

Banque du Gothard

Banque du Gothard

United Administrative Services, S.à r.l.

Providance Music S.A.

Mediplan, GmbH

Garfin International S.A.

HLK Software S.A.

Cominholding, Compagnie Internationale Holding

Gioch S.A.

Porta Volta Developments S.C.A.

Financière Hôtelière Européenne S.A.

Financière Hôtelière Européenne S.A.

Van Veen Overseas S.A.

Z.D. Finance S.A.

Promoland Holding S.A.

Ranbiwa Properties S.A.

Houston, S.à r.l.

Niche Invest S.A.

Meximmo S.C.I.

Yeoman International Holdings S.A.