This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
79249
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1652
31 août 2006
S O M M A I R E
24 Sport Village - Società Immobiliare S.A., Lu-
I & T Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
79261
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79291
International Global Fund Management (Luxem-
Alena Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
79277
bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79292
Alferweiher, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . .
79293
Interportfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79259
Alstrat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79253
Investrat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79253
Anterfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79251
Jalfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79293
Article S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79254
Kelti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79266
Assainissement Urbain Jean-Pierre Feidert et
Kelti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79266
Compagnie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
79262
L D R S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79292
Assurances Risch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
79296
Lexicon Marketing Operating Luxembourg, S.à r.l.,
Balta Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
79289
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79273
Balteire, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79266
Lexicon Marketing Operating Luxembourg, S.à r.l.,
Calimar Property AG, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . .
79257
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79276
Capital Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
79267
Lux. Financial Company Holding S.A., Luxembourg
79253
Celin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
79251
Luxpictures, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
79255
Ceratizit S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79289
Mason S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79263
Charme Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
79252
Mason S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79263
Charmont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79263
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A., Luxem-
Climmolux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79293
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79292
Compagnie Financière Van Wittenberge & Fils
Morgan Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
79252
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79253
Onet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
79295
Continental Pac Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
79254
Onet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
79295
Coravit AG & Co. II KG, S.e.c.s., Luxemburg . . . . .
79291
Participations Alpa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
79294
Coravit AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79291
Prisma Energy Turkey, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
79250
Delta Inter-Link S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79254
Sarazar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79252
Emerald First Layer «A» S.A., Luxembourg . . . . . .
79292
Sodemare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
79289
Equen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79296
Square Holdings (CDE), S.à r.l., Luxembourg . . . .
79277
Ernst & Young Tax Advisory Services, S.à r.l., Lu-
Tordell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79251
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79295
Tradehold Limited, Luxembourg Branch, Luxem-
Europrius Asset Management S.A., Luxembourg. .
79291
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79294
Ferrania Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
79272
Tradenet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79252
FFTW Funds Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . .
79264
Trading Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
79254
FFTW Funds Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . .
79266
Transocean Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
79266
Finalam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79252
Unicapital Investments II (Management) S.A., Lu-
Five Mounts Real Estate Investments, S.à r.l., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79290
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79294
Unicapital Investments III (Management) S.A., Lu-
France-Luxembourg Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
79289
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79293
GM Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79263
Unicapital Investments IV (Management) S.A., Lu-
Golden Square S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
79251
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79293
Golden Square S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
79251
VS Management Consulting, S.à r.l., Bridel . . . . . .
79260
Gummi-Roller, G.m.b.H., Ehlerange . . . . . . . . . . . .
79250
Witham Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
79253
Helios Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
79254
Wolfgang Schneider, S.à r.l., Luxembourg-Findel.
79262
Holmes Place 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79292
Wolfgang Schneider, S.à r.l., Luxemburg-Findel . .
79262
Humanitarian World Holding S.A., Luxembourg . .
79290
Xul S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79251
Humanitarian World Holding S.A., Luxembourg . .
79290
79250
GUMMI-ROLLER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-4385 Ehlerange, 6, Z.A.R.E. Est.
H. R. Luxemburg B 19.929.
—
Im Jahre zweitausendundvier, am neunten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft GUMMI-ROLLER, G.m.b.H, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deuschten Rechts, mit Sitz
in Eschborn, hier vertreten durch Herrn Hubert Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in D-72762 Reutlingen, Kammweg 32,
handelnd als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit Einzelzeichnungsrecht.
2. Die Gesellschaft EVERGREEN S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1531 Luxembourg, 17-
19, rue de la Fonderie, hier vertreten durch zwei Verwaltungsratmitglieder,
a) Herr Immanuel Kohn, Geschäftsmann, wohnhaft in D-72764 Reutlingen, Stämmesäckerstraße, 57;
b) Herr Hubert Reiff, vorgenannt.
Welche Komparenten erklären alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GUMMI-ROLLER
G.m.b.H. zu sein, mit Sitz in Luxemburg, gegründet laut Urkunde aufgenommen unter Privatschrift, am 11. Dezember
1954, veröffentlicht im Mémorial C vom 30. Dezember 1954, Nummer 93.
Die Satzungen der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den instru-
mentierenden Notar, am 17 Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1679 vom 22. November 2002.
Das Gesellschaftskapital beträgt siebenhundert fünfzig tausend Euros (EUR 750.000,-), eingeteilt in zweitausend
(2.000) Anteile von je dreihundertfünfundsiebzig Euros (EUR 375,-).
Die Geschäftsanteile sind aufgeteilt wie folgt:
Vorgenannte Komparenten erklären sich zu einer ausserordentichen Generalversammlung der GUMMI-ROLLER,
G.m.b.H., zusammenzufinden und beschliessen einstimmig folgenden Beschluß zu fassen:
<i>Einziger Beschlußi>
Die Komparenten beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-1531 Luxembourg, 17-19, rue de la Fonderie nach L-
4385 Ehlerange, Z.A.R.E. Est 6 zu verlegen.
Demzufolge wird Artikel drei (3) abgeändert und lautet wie folgt:
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Ehlerange.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch-sur-Alzette. Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die alten und neuen Gesellschafter, haben dieselben gegenwärtige
Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: H. Reiff, I. Kohn, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2006, vol. 894, fol. 51, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(007667.5/219/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
PRISMA ENERGY TURKEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 112.575.
—
Modification d’actionnaire
Capital USD 20.000,- représenté par 500 actions de USD 40,-.
En date du 18 novembre 2005, WING TURKEY LLC, actionnaire à concurrence de 495 actions, a subi les modifica-
tions suivantes:
Changement de désignation: PRISMA ENERGY TURKEY HOLDINGS, S.à r.l.
Changement du siège social: 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064477.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
1. Die Gesellschaft GUMMI-ROLLER, G.m.b.H., vorgenannt, eintausend sechshundert Anteile . . . . . . . . . . . . 1.600
2. Die Gesellschaft EVERGREEN S.A., vorgenannt, vierhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
Total: zweitausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 2004.
F. Kesseler.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
79251
TORDELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 112.909.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02037, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065567.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
XUL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 113.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02038, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065569.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CELIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.289.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00975, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065640.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ANTERFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 96.777.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00463, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065719.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
GOLDEN SQUARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 92.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00470, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065730.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
GOLDEN SQUARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 92.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00473, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065735.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
79252
SARAZAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 112.480.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09697, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065638.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CHARME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.674.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00502, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(065643.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
MORGAN RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 50.099.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-
BS00203, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
(065625.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
FINALAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 77.409.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01208, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065648.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
TRADENET EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 79.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01210, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065649.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
CHARME MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
79253
INVESTRAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.328.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01219, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065657.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ALSTRAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01222, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065661.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE VAN WITTENBERGE & FILS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.645.
—
Le bilan 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01240, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065665.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
WITHAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 98.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05781, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(065716.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
LUX. FINANCIAL COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 73.856.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00655, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(065809.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour WITHAM HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
79254
ARTICLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00466, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
DELTA INTER-LINK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00468, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CONTINENTAL PAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 64.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00656, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(065810.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
HELIOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.391.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf.
LSO-BR09585, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065826.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
TRADING INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 101.824.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s’est tenue i>
<i>en date du 29 juin 2006 au siège sociali>
L’Assemblée décide de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société GRANT THORNTON RE-
VISION ET CONSEILS S.A.
L’Assemblée décide de nommer la société ALEXANDER J. DAVIES, S.à r.l., 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxem-
bourg aux fonctions de commissaire aux comptes. Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00709. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065742.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Signature
<i>Administrateuri>
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
79255
LUXPICTURES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll.
H. R. Luxemburg B 117.482.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, am vierten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxem-
burg).
Ist erschienen:
Herr Rainer Söhnlein, Filmproduzent, geboren in Coburg (Deutschland), am 6. Mai 1941, wohnhaft in Lohschneider
1, D-84104 Tegernbach,
hier vertreten durch:
Herrn Peter Blaser, Filmproduzent, wohnhaft in Hochweitstrasse 9, CH-8802 Kilchberg,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht, ausgestellt am 24. Mai 2006.
Welche Vollmacht, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet
wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Vorgenannte Partei, vertreten wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihr zu grün-
denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die dies-
bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Produktion, Koproduktion, Ausstattung mit Finanzmitteln,
Verwertung, Vermarktung und der Vertrieb/Lizenzierung von Kino- und Fernsehproduktionen und anderen Medienpro-
jekten jeglicher Art und der Beteiligung an anderen Gesellschaften hierzu im eigenen und fremden Namen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen ge-
eignet sind. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, sowie Zweigniederlas-
sungen errichten.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen LUXPICTURES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Durch einfachen Beschluß der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative
Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in einhun-
dertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (100,- EUR).
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Ta-
gen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder Anteile davon oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von
der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden
Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-
schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.
Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
79256
Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember
desselben Jahres.
Art. 17. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des
Stammkapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden gezeichnet von dem alleinigen Gesellschafter, Herr Rainer
Söhnlein, vorgenannt.
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)
der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise tausenddreihundert Euro.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Zum alleinigen Geschäftsführer auf unbegrenzte Dauer wird ernannt:
Herrn Peter Blaser, Filmproduzent, geboren in Langnau im Emmental/Bern (Schweiz), am 23. April 1948, wohnhaft
in Hochweitstrasse 9, CH-8802 Kilchberg.
Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 12 der Statuten erwähnt.
Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet, durch die alleinige Unterschrift des vorgenann-
ten Geschäftsführers.
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.
<i>Bemerkungi>
Der amtierende Notar hat die auf die Notwendigkeit hingewiesen, vor Aufnahme jeglicher Tätigkeit, die hierzu gege-
benenfalls erforderlichen Genehmigungen und Ermächtigungen von den zuständigen Behörden einzuholen.
Worüber urkunde, aufgenommen zu Beles (Luxemburg), in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum
wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Blaser, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 5. Juli 2006, Band 905, Blatt, 32, Feld 6. – Erhalten 125 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für Gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066981.3/239/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Beles, den 6. Juli 2006.
J.-J. Wagner.
79257
CALIMAR PROPERTY AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Luxemburg B 117.481.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, am dritten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1. Herr Dr. Bernhard Rudolf Heiss, Rechtsanwalt, geboren am 8. Februar 1955 in Frankfurt/Main (D), wohnhaft in
D-81925 München, Flemingstrasse 15, hier vertreten durch den nachgenannten Herrn André Harpes, auf Grund einer
Vollmacht vom 22. Juni 2006, welche von den Komparenten und dem unterzeichneten ne varietur unterschrieben wurde
und gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt um mit dieser einregistriert zu werden.
2. Herr André Harpes, Rechtsanwalt, geboren am 17. März 1960 in Luxemburg, wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 55,
boulevard de la Pétrusse.
Die Parteien haben die folgenden Artikel des Gesellschaftervertrages betreffend einer zwischen ihnen zu gründenden
Aktiengesellschaft beschlossen:
Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den oben genannten Parteien und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend
aufgeführten Aktien erwerben werden, wird hierdurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktienge-
sellschaft gegründet.
Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung CALIMAR PROPERTY AG, hiernach die «Gesellschaft», an.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Großherzogtum Luxemburg sowie im Ausland
eingerichtet werden.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an eine andere Adresse in Luxemburg/
Stadt verlegt werden.
Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
eingetreten sind oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die
Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesell-
schaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange, wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Maßnahme hat
keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.
Die Bekanntmachung und Mitteilung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch das Organe zu erfolgen, das
mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt ist.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, der Verkauf, die Befrachtung, die Frachtung und die Verwaltung von
Hochseeschiffen jeglicher Art, des Weiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt
damit in Verbindung stehen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) Euro festgelegt. Es ist eingeteilt in fünfzig (50) Ak-
tien ein und derselben Art zu je tausend (1.000) Euro.
Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien nach Wahl des Aktieninhabers.
Das Aktienkapital kann in der Form einer Satzungsänderung erhöht oder herabgesetzt werden. Der Gesellschaft ist
es erlaubt, in Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eigene Aktien zu kaufen.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die nicht Ak-
tionäre sein müssen.
Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsmitglieder, welche zu jeder Zeit abrufbar sind, für die Höchst-
mandatsdauer von sechs Jahren.
Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratmitglieder ermächtigt,
die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes vorzunehmen. Dieser Beschluss ist durch die nächste Gesellschafterver-
sammlung zu ratifizieren.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern das geschäftsführende Verwaltungsratmitglied. Diese Wahl
obliegt zum ersten Mal der Generalversammlung der Aktionäre.
Sollte das geschäftsführende Mitglied des Verwaltungsrates nicht mehr handlungsfähig sein, so wird es durch ein durch
den Verwaltungsrat zu bezeichnendes Mitglied ersetzt.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind frei durch sein geschäftsführendes Mitglied oder durch zwei Mitglieder des
Verwaltungsrates einberufbar. Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn alle
seine Mitglieder erschienen oder vertreten sind. Dies gilt mit der Einschränkung, dass ein Mitglied des Verwaltungsrates
nur ein anderes Mitglied vertreten kann.
Ein Verwaltungsratmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben
oder Telekopie - die drei letztgenannten sind durch Brief zu bestätigen - Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung
bei einer Verwaltungsratsitzung erteilen.
79258
Schriftliche Beschlüsse, welche die Unterschrift von allen Verwaltungsratmitgliedern tragen, haben die gleiche binden-
de Kraft wie in Verwaltungsratsitzungen getroffene Entscheidungen.
Art. 8. Jeder Beschluss muss einstimmig durch die abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst
werden.
Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von allen anwesenden Mitgliedern abgezeichnet. Kopien
oder Auszüge von Sitzungsprotokollen sind durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates zu beglaubigen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, jedwede Handlung vorzu-
nehmen, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann einen Teil oder die Gesamtheit seiner Befugnisse bezüglich der täglichen Ge-
schäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein Ver-
waltungsratmitglied oder an Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, übertragen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversamm-
lung.
Art. 12. Die Gesellschaft ist Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von
drei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten
handelnden mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Mitgliedes des Verwaltungsrates.
Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterver-
sammlung, welche auch die Anzahl und die Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden. Die Mandatsdauer wird durch die
Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.
Gesellschafterversammlungen
Art. 14. Die Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäß zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der
Gesellschafter.
Sie hat sämtliche Befugnisse die Geschäfte der Gesellschaft zu bestimmen. Ihre Einberufung erfolgt gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung kommt jeweils am ersten Mittwoch im Monat November um 14 Uhr in
der Gemeinde Luxemburg, am Ort, der in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahre 2007, zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so kommt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag zusam-
men.
Art. 16. Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Kommissar sind befugt, außerordentliche Gesellschafterver-
sammlungen einzuberufen. Auf Verlangen von Gesellschaftern, welche mehr als ein Fünftel des Aktienkapitals halten,
muss eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen werden.
Art. 17. Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.
Geschäftsjahr - Gewinnverwendung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats
Dezember. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanzen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Dokumente werden
zusammen mit dem Geschäftsbericht mindestens einen Monat vor der jährlichen Gesellschafterversammlung an den
Kommissar überreicht.
Art. 19. Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus.
Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Ab-
zuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.
Die Verwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. Unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorrauszahlungen auf Dividenden veranlassen.
Die Gesellschafterversammlung kann Gewinne und aufgelöste Reserven zur Rückzahlung des Kapitals verwenden, ohne
dass dies einer Kapitalreduzierung gleichkommt.
Auflösung, Liquidation
Art. 20. Die Gesellschafterversammlung kann im Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung die Gesellschaft jederzeit auflösen.
Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-
sellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.
Andere Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf
das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze sowie den Luxem-
burger Hochseeschiffahrtsgesetzakt von 1990.
Vorübergehende Bestimmungen
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006. Die jähr-
liche Gesellschafterversammlung wird zum Datum, Zeit und Ort wie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen abgehalten
werden.
79259
<i>Zeichnung des Kapitalsi>
Die fünfzig (50) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Auf alle Aktien wurde eine Barzahlung in Höhe von einhundert Prozent (100%) geleistet, so dass der Gesellschaft
vom heutigen Tage an ein Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar, der
dies bezeugt, nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, für welche die Gesesellschaft aufgrund ihrer Gründung haftet, werden auf eintausendsiebenhundert Euro
(EUR 1.700,-) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, die die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten
und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengekommen
und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-2320 Luxemburg, boulevard de la Pétrusse festgelegt.
2. Wie folgt wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung
2009 bestimmt:
a) die Aktiengesellschaft MARE-LUX S.A. mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im
Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 62.985 vertreten durch Herrn Robert Mehrpahl;
b) Herr Dr. Bernhard Rudolf Heiss, vorgenannt;
c) Herr André Harpes, vorgenannt;
3. Die vorgenannte Gesellschaft MARE-LUX S.A., vertreten durch Herrn Robert Mehrpahl, wird mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt. Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Herrn
Robert Mehrpahl. Diese Zeichnungsgewalt schließt den An- und Verkauf von in der Bilanz enthaltenen Investitionsgütern
aus.
4. Die Aktiengesellschaft COMPTABILUX S.A. mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 1, place du Théâtre, eingetragen
im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 87.204, durch Herrn Yves Schmid handelnd, wird zum Kommissar
ernannt mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung des Geschäftsjahres 2009.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, vol. 154S, fol. 30, case 6. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémoral, Recueil des Sociétés et Associations.
(066978.3/202/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
INTERPORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.902.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société i>
<i>qui s’est tenue le 15 juin 2006 à 12.00 heuresi>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Patrice Crochet, Jean-Marc de Volder
et Maxime Vermesse pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires
en 2007.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises, KPMG AUDIT, Luxembourg, pour un terme d’un an
devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064470.3/3085/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
1. Bernard Heiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
2. André Harpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Senningerberg, den 6. Juli 2006.
P. Bettingen.
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
79260
VS MANAGEMENT CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
H. R. Luxemburg B 117.411.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, am zweiundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Ist erschienen:
CER INTERNATIONAL S.A., Jasmine Court, 35A, Regent Street, Belize City, Belize, hier vertreten durch ihre
Direktorin Frau Berendina ten Brinke.
Der Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den instrumentierenden Notar ersucht nachfolgenden Gesellschaftsver-
trag zu beurkunden.
Titel I. - Zweck, Firmennamen, Dauer, Sitz
Art. 1. Zwischen den Komparent, der Inhaber von Anteilen wird, wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet, die den sich darauf beziehenden Gesetzen sowie den folgenden Statuten unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung im Bereich Personalangelegenheiten, Rechnungswesen, Finanzen, In-
vestitionen, Expansion, wirtschaftliche Beratung, administrative Dienstleistungen und weitere allgemeine Verwaltungs-
angelegenheiten an in- und ausländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Geselschaft kann jedwede
kommerzielle, gewerbliche oder finanzielle Tätigkeit ausüben, die sie zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks für nützlich
hält und sich insbesondere auch an anderen Gesellschaften durch Investition, Erwerb durch Kauf, Tausch oder in ande-
rer Art und Weise beteiligen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Der Gesellschaftsname lautet VS MANAGEMENT CONSULTING, S.à r.l.
Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist in Bridel.
Er kann durch Beschluss des Gesellschafters in irgendeine andere Ortschaft des Landes verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen an anderen Orten des In- und Auslandes errichten.
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) aufgeteilt in 125 (einhundert-
fünfundzwanzig) Anteile von je EUR 100,- (einhundert Euro).
Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie ausserordentlichen Generalversammlungen.
Die Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
CER INTERNATIONAL S.A., vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile (125).
Der Gesellschafter hat seine Einzahlungsverpflichtung in bar erfüllt, so dass das gesamte Kapital der Gesellschaft zur
Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit geändert werden durch Einverständnis des Gesellschafters.
Art. 8. Jeder Anteil gibt im Verhältnis zu der Summe der bestehenden Anteile ein Recht auf einen Bruchteil des
Gesellschaftskapitals sowie der Gewinne.
Art. 9. Die Anteile sind nicht teilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen Inhaber für jeden Anteil anerkennt.
Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so können sie die Rechte aus diesem nur
durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben.
Art. 10. Die Gesellschaftsanteile können frei veräussert werden an Gesellschafter. Die Anteile können aber nicht
veräussert werden unter Lebenden an Dritte, die nicht Gesellschafter sind ohne Einverständnis des Gesellschafters. Der
Uebergang von Gesellschaftsanteilen von Todes wegen regelt sich nach derselben Bestimmung des Einverständnisses
des Gesellschafters. In diesem letzten Fall jedoch ist das Einverständnis nicht erfordert wenn der Uebergang auf die
Erben, Kinder oder Ehepartner erfolgt.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod, durch Entziehung der Rechte, Konkurs oder Zahlungs-
unfähigkeit des Gesellschafters.
Art. 12. Die Gläubiger, Interessenten und Erben haben nicht das Recht mit gleichwelcher Begründung es auch sei
auf die Güter und Dokumente der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen.
Titel III. - Verwaltung und Vertretung
Art. 13. Die Gesellschaft wird durch einen Verwalter verwaltet, der gegenüber von Drittpersonen die ausgedehn-
testen Befugnisse hat, um im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und um sämtliche Akten und Geschäfte
zu genehmigen soweit sie im Rahmen des Zweckes der Gesellschaft sind.
Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Verwalter. Der Verwalter kann Vollmachten ertei-
len, die im Umfang und der Vertretungsberechtigung zu definieren sind.
Art. 14. Der Tod des Geschäftsführers oder seine Austretung aus der Gesellschaft, aus gleich welchem Grund, zieht
nicht die Auflösung der Gesellschaft mit sich.
Art. 15. Der Alleingesellschafter fasst sämtliche Beschlüsse allein.
79261
Art. 16. Der Geschäftsführer haftet nicht persönlich für die Verpflichtungen die er im Namen der Gesellschaft form-
richtig eingegangen ist. Als blosser Bevollmächtigter hat er nur die Verpflichtung, sein Mandat nach Treu und Glauben
auszuüben.
Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am
Gründungstag und endet am 31. Dezember 2006.
Art. 18. Jedes Jahr am 31. Dezember wird ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie eine Bilanz
durch den Geschäftsführer erstellt.
Art. 19. Der Ertrag der Gesellschaft, wie er aus dem jährlichen Inventar hervorgeht, nach Abzug der Unkosten, der
Belastungen und der notwendigen Abschreibungen, ergibt den Reingewinn.
Von dem Reingewinn werden 5% (fünf Prozent) zurückgehalten zur Bildung des gesetzlichen Reservefonds bis
derselbe 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo steht zur Verfügung des Gesellschafters.
Titel IV. Auflösung, Liquidation
Art. 20. Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, der Gesell-
schafter oder Drittpersonen, ernannt von den Gesellschafter, der ihre Befugnisse und Entschädigungen festlegt.
Art. 21. Für alle nicht durch vorliegende Satzung geregelten Punkte gelten die sich in Kraft befindenden gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183. des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen tausend sechs
hundert Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann ist der Gründer zu einer ausserordentlichen Generalversammlung getreten und hat folgende Beschlüsse
gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel.
2. Die Generalversammlung beruft zum alleinigen Geschäftsführer:
Herrn Stefan Justinger, geboren am 26. August 1964 in Trier, Deutschland und wohnhaft in D-54308 Langsur, In der
Acht 30.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Signé: B. ten Brinke, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, vol. 154S, fol. 14, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065191.3/211/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
I & T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 74.250.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre INWESTFINANZIERUNG A.G., dont
le siège social est situé au 20, Löwenstrasse, 8001 Zürich, Suisse, et TULIPA-GESTÃO E SERVIÇOS S.A., Rua dos Mur-
ças 88, P.O. Box 7, 9000 Funchal, Madeira, Portugal, datée du 24 avril 2006, que treize (13) parts sociales de la société
à responsabilité limitée I & T LUX, S.à r.l. dont le siège social est situé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, ont été
acquises le 24 avril 2006 par TULIPA-GESTÃO E SERVIÇOS S.A., préqualifiée.
Le capital social de la I & T LUX, S.à r.l. est détenu comme suit depuis le 24 avril 2006:
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00411. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065403.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
J. Elvinger.
TULIPA-GESTÃO E SERVIÇOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 parts sociales
Pour extrait conforme
Signature
79262
WOLFGANG SCHNEIDER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1110 Luxemburg-Findel, Cargo Center West.
H. R. Luxemburg B 103.402.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Wolfgang Schneider, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-56357 Holzhausen a.d.H., Am Limes 29;
2) Frau Ingrid Schneider, Pharmazeutische Technische Assistentin, wohnhaft in D-56357 Holzhausen a.d.H., Am Limes
29.
Diese Erschienenen, handelnd wie oben erwähnt, haben den amtierenden Notar ersucht ihre Erklärungen folgender-
maßen zu beurkunden:
I. Die Erschienenen sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WOLFGANG
SCHNEIDER, S.à r.l., mit Sitz in Esch-sur-Alzette, Z.I. Lankelz, rue Jos Kieffer, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen
durch den unterzeichneten Notar am 24. September 2004, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C Nummer 1256 vom 8. Dezember 2004.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 103.402.
II. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Fünfzig (50) Anteile gehören dem Gesellschafter Wolfgang Schneider, vorbenannt, und fünfzig (50) Anteile gehören
der Gesellschafterin Ingrid Schneider, vorbenannt.
III. Alsdann halten die vorgenannten Gesellschafter der Gesellschaft, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertre-
ten, diese außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter der Gesellschaft beschließen die Verlegung des Gesellschaftssitzes von Esch-sur-Alzette, Z.I.
Lankelz, rue Jos Kieffer nach L-1110 Luxemburg-Findel, Cargo Center West, Building A, Büro 115.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen den ersten Satz von Artikel 5. der Satzung der Gesellschaft umzuändern, um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Erschienenen zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschieben.
Unterzeichnet: W. Schneider, I. Schneider, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, vol. 28CS, fol. 61, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065316.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
WOLFGANG SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1110 Luxembourg Findel, Cargo Center West.
R. C. Luxembourg B 103.402.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
42784 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 juillet 2006.
(065318.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
ASSAINISSEMENT URBAIN JEAN-PIERRE FEIDERT ET COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 69-71, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 7.323.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00775, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065398.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxemburg, den 13. Juni 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Signature
<i>Un mandatairei>
79263
MASON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 37, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 96.156.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02204, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(065552.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
MASON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 37, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 96.156.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02212, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(065554.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
GM REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 112.148.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 14 juin 2006 que Mon-
sieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Manuel Lentz, démissionnaire.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05212. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064549.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
CHARMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 85.570.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s’est tenue i>
<i>en date du 30 juin 2006 au siège sociali>
L’Assemblée décide de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société GRANT THORNTON RE-
VISION ET CONSEILS S.A.
L’Assemblée décide de nommer la société ALEXANDER J. DAVIES, S.à r.l., 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxem-
bourg aux fonctions de commissaire aux comptes. Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065746.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
MASON S.A.
Signature
MASON S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
79264
FFTW FUNDS SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.079.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-second day of June.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FFTW FUNDS SELECTION (hereafter referred to
as the «Corporation»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 55.079),
incorporated by a deed of the notary Camille Hellinckx, then residing in Luxembourg, on the eleventh day of June, 1996,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 11th July, 1996, number 333. The
Articles were amended for the last time on 27th June 2005, published in the Mémorial of 19th August 2005, number 811.
The meeting was opened at 11.00 a.m. with Denis Gleeson, private employee, residing professionally in Luxembourg,
as chairman of the meeting.
The chairman appointed as secretary Olive Miley, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mike Wickler, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
Extraordinary Resolution to amend the Articles of Incorporation by adding or changing the provisions outlined below:
1) Amendment of the last paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation to provide for an investment limit
of 10% of the net assets of any class in units of undertakings for collective investments as defined in article 41 (1) e) of
the Luxembourg law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment.
2) Amendment of article 21 of the Articles of Incorporation by adding the following wording as seventh paragraph:
«If the requests for redemption and/or conversion received for any class of shares for any specific Valuation Day ex-
ceed a certain amount or percentage of the net asset value of such class, such amount or percentage being fixed by the
board of directors from time to time and disclosed in the offering documents, the board of directors may defer such
redemption and/or conversion requests to be carried forward for realisation on the next following applicable Valuation
Day.»
3) Amendment of article 23 of the Articles of Incorporation by replacing the word «nominal» by «market» in item
A.(5).
II. That the meeting held on 16th May 2006 could not validly deliberate for lack of quorum, and that the present meet-
ing was convened by notices sent to the registered shareholders of the Corporation by registered mail on 24th May
2006, and published in the Mémorial, the D’Wort and Tageblatt on 22nd May 2006 and 7th June 2006.
III. That the shareholders present or represented, and the number of their shares are shown on an attendance list;
this attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineer, the proxy holders and the undersigned notary
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
IV. No quorum is required for this meeting and the Extraordinary Resolution will be passed if voted by two thirds of
the votes cast at the meeting.
V. As a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the item on the
agenda.
Then the meeting, after deliberation takes the following resolution:
<i>Extraordinary resolutioni>
The meeting by 30,201.2136 votes in favour and 0 votes against decides:
1) To amend the last paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The Corporation will not invest more than 10% of the net assets of any class in units of undertakings for collective
investment as defined in article 41 (1) e) of the Law.»
2) To amend article 21 of the Articles of Incorporation by adding the following wording as seventh paragraph:
«If the requests for redemption and/or conversion received for any class of shares for any specific Valuation Day ex-
ceed a certain amount or percentage of the net asset value of such class, such amount or percentage being fixed by the
board of directors from time to time and disclosed in the offering documents, the board of directors may defer such
redemption and/or conversion requests to be carried forward for realisation on the next following applicable Valuation
Day.»
3) To amend article 23 of the Articles of Incorporation by replacing the word «nominal» by «market» in item A.(5).
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed at 11.40 a.m.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version.
On request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French version, the Eng-
lish version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first name, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deuxième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire résidant à Hesperange.
79265
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société FFTW FUNDS SELECTION (ci-après
la «Société»), Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 55.079), constituée suivant
acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 1996, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 11 juillet 1996, numéro 333. Les Statuts ont été modifiés
pour la dernière fois le 27 juin 2005 et publiés au Mémorial le 19 août 2005, numéro 811.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures.
L’assemblée est présidée par Denis Gleeson, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire Olive Miley, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Mike Wickler, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Résolution extraordinairei>
Pour modifier les statuts par ajout ou modification des dispositions énoncées ci-dessous:
1) Modification du dernier paragraphe de l’article 16 des statuts afin de prévoir une limite d’investissement de 10%
des avoirs nets d’une classe dans des parts d’organismes de placement collectif tels que définis à l’article 41 (1) e) de la
loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.
2) Modification de l’article 21 des statuts en ajoutant le texte suivant comme septième paragraphe:
«Si les demandes de rachat et/ou conversion reçues pour une classe d’actions pour un Jour d’Evaluation spécifique
excèdent un certain montant ou pour centage de la valeur nette d’inventaire de cette classe, ce montant ou pour centage
de la valeur nette d’inventaire étant fixé par le conseil d’administration de temps en temps et publié dans les documents
de vente, le conseil d’administration peut différer le traitement de ces demandes de rachat et/ou conversion jusqu’au
prochain Jour d’Evaluation applicable.»
3) Modification de l’article 23 des statuts par le remplacement du mot «nominale» par «de marché» au point A(5).
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur, les mandataires et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. L’assemblée tenue le 16 mai 2006 n’a pas pu valablement délibérer pour manque de quorum et la présente assem-
blée a été convoquée par des avis de convocation envoyés aux actionnaires nominatifs de la Société par lettre recom-
mandée en date du 24 mai 2006 et publiés dans le Mémorial, le D’Wort et Tageblatt les 22 mai 2006 et 7 juin 2006.
IV. Aucun quorum n’est requis pour la présente assemblée, et la résolution extraordinaire sera adoptée par le vote
des deux tiers des votes exprimés lors de la présente assemblée.
V. Qu’à la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
sur l’ordre du jour.
L’assemblée, après en avoir délibéré, prend la résolution suivante:
<i>Résolution extraordinairei>
L’assemblée, par 30,201.2136 votes favorables et 0 votes contre décide:
1) De modifier le dernier paragraphe de l’article 16 des statuts de manière à lire ce qui suit:
«La Société n’investira pas plus de 10% des avoirs nets d’une classe dans des parts d’organismes de placement collectif
tels que définis par l’article 41 (1) e) de la Loi».
2) De modifier l’article 21 des statuts en ajoutant le texte suivant comme septième paragraphe:
«Si les demandes de rachat et/ou conversion reçues pour une classe d’actions pour un Jour d’Evaluation spécifique
excèdent un certain montant ou pour centage de la valeur nette d’inventaire de cette classe, ce montant ou pour centage
de la valeur nette d’inventaire étant fixé par le conseil d’administration de temps en temps et publié dans les documents
de vente, le conseil d’administration peut différer le traitement de ces demandes de rachat et/ou conversion jusqu’au
prochain Jour d’Evaluation applicable.»
3) De modifier l’article 23 des statuts par le remplacement du mot «nominale» par «de marché» au point A(5).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.40 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, et qui en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.
Signé: D. Gleeson, O. Miley, M. Wickler, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, vol. 153S, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(066010.2/241/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Hesperange, le 28 juin 2006.
M. Decker.
79266
FFTW FUNDS SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.079.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 4 juillet 2006.
(066011.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
TRANSOCEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 98.025.
—
Par résolution circulaire datée du 8 juin 2006, les gérants de la société TRANSOCEAN INVESTMENTS, S.à r.l., ont
décidé de transférer le siège social de la société du 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064457.3/5564/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
BALTEIRE, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 295.052.350,-.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 114.350.
—
En date du 19 mai 2006, il a été décidé de transférer le siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 7A,
rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08290. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064459.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
KELTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 90.039.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00685, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065435.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
KELTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 90.039.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00678, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065433.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>M. Decker
<i>Notairei>
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Signature.
79267
CAPITAL HOLDING, Société Anonyme.
Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 117.421.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the nineteenth day of June.
Before Us, M
e
Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1.- The liable company incorporated under the laws of the Panama WOODHENGE, with registered office in Panama;
2.- The liable company incorporated under the laws of the Panama XEN INVESTMENTS CORP., with registered of-
fice in Panama, all two duly represented by Mr Patrick Römer, private employee, with professional address in L-2212
Luxemburg, 6, place de Nancy by virtue of a proxy dated on June 19th, 2006.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock com-
pany to be organized among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-
after, a joint stock company is herewith formed under the name of CAPITAL HOLDING.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 310
(three hundred ten) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-
sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter or telefax confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board
of directors’ meetings.
79268
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances by the joint signatures of two directors or by the
individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with public
administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six
years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation.
The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the second Monday of the month of October, 9.00 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be
convened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on June 1st and ends on May 31st of the next year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-
tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital. The remaining bal-
ance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the subscribed capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
General disposition
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on May 31st, 2007.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.
79269
<i>Subscription and paymenti>
The 310 (three hundred ten) shares have been subscribed to as follows:
All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000.-
(thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on
Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
EUR 2,100.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, rep-
resenting the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general
meeting and unanimously passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to
deliberate on the financial statements of the first business year:
a.- Mr Ronald Weber, director, residing professionally in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
b.- Mr Romain Bontemps, auditor, residing professionally in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
c.- Mr Lic. jur. Christoph Langenauer, lawyer, residing in CH-9042 Speicher, Hinterwies, 42,
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called
to deliberate on the financial statements of the first business year:
The private liable company ABAX AUDIT, with registered office in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy (R.C.S.-L
N
°
B 27.761).
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
<i>Fourth resolutioni>
The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, who is known to the notary
by their surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us, Notary,
the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same person appear-
ing and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten Juni.
Vor uns Notar Paul Decker, mit Amtssitz zu Luxembourg-Eich, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1.- Die Aktiengesellschaft unter dem Recht der Republik Panama WOODHENGE, mit Sitz in Panama,
2.- Die Aktiengesellschaft unter dem Recht der Republik Panama XEN INVESTMENTS CORP., mit Sitz in Panama,
alle beide hier vertreten durch Herrn Patrick Römer, Privatbeamter, berufsansässig in L-2212 Luxemburg, 6, place de
Nancy auf Grund von einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 19. Juni 2006.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten
Notar ne varietur paraphiert wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen
zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CAPITAL HOLDING gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Subscribers
Number Amount subscribed to
of shares
and paid up in EUR
1. WOODHENGE, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
15,500.-
2. XEN INVESTMENTS CORP., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
15,500.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31,000.-
79270
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von
Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.
Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an
alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garan-
tien gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fordern.
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 310
(dreihundertzehn) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 100,- (einhundert Euro).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-
ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des
Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder per Telefax abgeben.
Fernschreiben und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Im Falle von
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen
und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach Außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
79271
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte
Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Sie können von
der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Montag des Monats Oktober jeden Jahres um 9.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört,
hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai des daurauffolgenden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden
zahlen.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den
gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter
durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung
ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmung
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmun-
gen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Mai 2007.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2007 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen
Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche
den ersten Verwaltungsrat ernennt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die 310 (dreihundertzehn) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 31.000,- (einunddreizigtausend Euro) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
Aktionär
Aktienzahl
gezeichnetes
Kapital in EUR
1. WOODHENGE vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
15.500,-
2. XEN INVESTMENTS CORP. vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
15.500,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31.000,-
79272
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, sowie auf die späteren Änderungen erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise 2.100,- EUR.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, sich zu einer
außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen
gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet,
werden ernannt:
a.- Herr Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, berufsansässig in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
b.- Herr Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, berufsansässig in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
c.- Herr Lic. jur. Christoph Langenauer, Rechtsanwalt, wohnhaft in CH-9042 Speicher, Hinterwies, 42,
<i>Zweiter Beschlussi>
Zum Kommissar bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, wird ernannt:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABAX AUDIT, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy (R.C.S.-L
N
°
B 27.761).
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung zu übertra-
gen.
Der amtierende Notar, welcher die englishe Sprache versteht und spricht, bestätigt hiermit dass auf Wunsch der
Komparenten vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung, und dass im Falle
von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar vorlie-
gende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Römer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 90, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(065472.3/206/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
FERRANIA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 69.684.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre INWESTFINANZIERUNG AG, dont
le siège social est situé au 20, Löwenstrasse, 8001 Zürich, Suisse, et TULIPA-GESTÃO E SERVIÇOS S.A., Rua dos Mur-
ças 88, P.O. Box 7, 9000 Funchal, Madeira, Portugal, datée du 24 avril 2006 que deux cent trente-trois (233) parts so-
ciales de la société à responsabilité limitée FERRANIA LUX., S.à r.l., dont le siège social est situé au 18, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg, ont été acquises le 24 avril 2006 par TULIPA-GESTÃO E SERVIÇOS S.A., préqualifiée.
Le capital social de la FERRANIA LUX., S.à r.l. est détenu comme suit depuis le 24 avril 2006:
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00406. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065405.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxemburg-Eich, den 28. Juni 2006.
P. Decker.
TULIPA-GESTÃO E SERVIÇOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 parts sociales
Pour extrait conforme
Signature
79273
LEXICON MARKETING OPERATING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 20,000.-.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 105.521.
—
In the year two thousand and six, on the twentieth day of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of LEXICON MARKETING OPERATING LUXEM-
BOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed enacted on 20, December, 2004, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register, with the number B 105.521, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations on 23 March 2005.
To this end, appears LEXICON LANGUAGES HOLDING S.L., a Spanish company, with registered office at Gran Via
45, 6A, Bilbao (Vizcaya) Spain, 4801, owning all the 400 (four hundred) shares, representing the whole capital of the
Company, here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy
under private seal, which will remain here annexed.
All the shares are represented so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholder states having been duly informed.
After the sole shareholder approved the foregoing, the following resolutions were taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved that the sole shareholder of the Company waives its right to the prior notice of the current meeting;
the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and
therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation
produced to the meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order
to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to approve the transfer of all the 400 (four hundred) shares, representing the whole capital of the Com-
pany by the founder NEW LEXICON INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the Cay-
man Islands with its registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands to CYPRESSA-COMERCIO INTERNACIONAL, LDA,
a company incorporated under the laws of Portugal, having its registered office at Sé, municipality of Funchal, Avenida
do Infante n
°
50, Portugal at the afore mentioned nominal value.
<i>Third resolutioni>
It is resolved to approve the transfer of all the 400 (four hundred) shares, representing the whole capital of the Com-
pany by CYPRESSA-COMERCIO INTERNACIONAL, LDA prenamed to LEXICON LANGUAGES HOLDING S.L., a
Spanish company, with registered office at Gran Via 45, 6A, Bilbao (Vizcaya) Spain, 4801, current sole shareholder.
<i>Notificationi>
According to article 190 of the Luxembourg Companies Act as amended, the management of the Company accepts
this transfer of shares and considers it as duly notified to the company, according to article 1690 of the Luxembourg
«Code Civil» as amended.
Such amendment in the partnership will be deposed and published at the Trade Register in accordance with article
11 bis of the Luxembourg Trading Companies Law of August 10th, 1915, as amended.
<i>Fourth resolutioni>
It is resolved to amend articles 12 and 14 of the Company’s articles of association in order to give them the following
wording:
«Art. 12. The Company will be managed by one manager or more managers (as the case may be). In the case where
more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not
be shareholders of the Company. In the case where there would be only one sole manager, this sole manager has all
the powers of the board of managers.
The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of
shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole share-
holder. The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The
general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove
and replace any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of share-
holders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the
sole manager (as the case may be).
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager; and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two of the managers.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers
for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.»
79274
«Art. 14. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of man-
agers, or the sole manager (as the case may be).
The board of managers shall choose from among its members a chairman. They may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or
for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48h in advance of the time set
for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means
or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any
other suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any meeting of the board of managers, in the case of plurality of managers, shall take place in Luxembourg and shall
require the presence of two managers, either present in person, by proxy or by representative, which shall form a quo-
rum.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or elec-
tronic means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other
suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by a majority of the managers
present or duly represented.
Any decisions relating to the following matters shall not be valid unless it has been adopted by a majority of 75% of
the votes of the managers present or duly represented:
- Decisions to make or permit any substantial alteration to the relevant business(es) of the Company;
- Decisions to acquire any assets, business or undertakings where either (i) the value or (ii) the consideration paid
for the assets, business or undertaking concerned is in excess of USD 20,000.-;
- Decisions to dispose or to sell any assets, business or undertakings of the Company where either (i) the value or
(ii) the consideration paid for the assets, business or undertaking concerned is in excess of USD 20,000.-;
- Decisions to propose to liquidate or otherwise wind up the Company;
- Decisions to propose to approve the annual accounts of the Company;
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by
ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication
means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-
tent.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.»
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de LEXICON MARKETING OPERATING
LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée par acte notarié du 20 décembre, enregistré au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 105.521, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du 23 mars 2005.
79275
A cette fin comparaît LEXICON LANGUAGES HOLDING S.L., société espagnole ayant son siège social à Gran Via
45, 6A, Bilbao (Vizcaya) Espagne, propriétaire de toutes les 400 (quatre cents) parts sociales, représentant l’intégralité
du capital social de la Société, ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxem-
bourg en vertu d’une procuration sous seing privé, qui restera ci-annexée.
Toutes les parts sont représentées, de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour, dont l’associé avait été préalablement informé.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique de la Société renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée
générale; l’associé unique reconnaît qu’il a été suffisamment informé de l’ordre du jour et qu’il se considère avoir été
valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points à l’ordre du jour. Il est en
outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’associé unique
dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’approuver le transfert de toutes les 400 (quatre cents) parts sociales, représentant l’intégralité du ca-
pital social de la Société par l’associé fondateur: NEW LEXICON INTERNATIONAL LIMITED, avec siège à M&C COR-
PORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands à CYPRESSA-COMERCIO INTERNACIONAL, LDA, société portugaise avec siège à Sé, commune de
Funchal, Avenida do Infante n
°
50, Portugal, à leur valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé d’approuver le transfert de toutes les 400 (quatre cents) parts sociales, représentant l’intégralité du ca-
pital social de la Société par CYPRESSA-COMERCIO INTERNACIONAL, LDA, société prédésignée, à LEXICON LAN-
GUAGES HOLDING SL, société espagnole, avec siège à Gran Via 45, 6A, Bilbao (Vizcaya) Spain qui est l’actuel associé
unique de la S.à r.l.
<i>Significationi>
Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, la gérance, accepte ces
cessions de parts sociales et se les considère comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du
code civil luxembourgeois telle que modifié.
Cette modification dans le personnel des associés de la Société sera déposée et publiée au registre de Commerce
conformément à l’article 11 bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de modifier les articles 12 et 14 des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (le cas échéant). Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associés de la Société. Dans l’hypothèse
où il y aurait un gérant unique, celui-ci disposerait de tous les pouvoirs du conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) sont nommés et leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des associés prise
à la majorité simple des voix ou, en cas d’associé unique, par décision de cet associé unique. La rémunération du/des
gérant(s) peut être modifiée par résolution de l’assemblée générale des associés prises dans les mêmes conditions de
majorité. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l’assemblée
générale des associés ou par une décision de l’associé unique (le cas échéant). Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés ou à l’associé unique (le cas échéant), seront de la
compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (le cas échéant).
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique; et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux des gérants.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (le cas échéant), peut de temps en temps subdéléguer une partie de son/
ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui ne sont pas nécessairement associé(s) ou
gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (le cas échéant), détermine les pouvoirs, les obligations et la rémunération
(s’il y a lieu) de son/ses agent(s), la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.»
«Art. 14. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance, ou
par le gérant unique (le cas échéant).
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est
pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du conseil de gé-
rance ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant 48 heures avant
la réunion sauf en cas d’urgence, la nature même de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la
réunion.
Toutes les convocations devront spécifier l’heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les gérants peuvent renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
79276
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l’heure et au lieu précisé
lors d’une résolution du conseil de gérance précédemment prise.
Les réunions du conseil de gérance en cas de pluralité de gérants, se tiendront à Luxembourg et requièrent que deux
gérants soient présents en personne, par procuration ou par représentation, ce qui est constitutif du quorum.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tous gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l’ensemble des personnes participant
à cette réunion de communiquer en même temps.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Sous réserve de ce qui est autrement prévu par les Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la
majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés.
Aucune décision concernant les sujets suivants ne sera valide, à moins qu’elle n’ait été adoptée par une majorité de
75% des votes des gérants présents ou dûment représentés:
- Décisions de faire ou d’autoriser toute modification substantielle de la ou des activité(s) de la Société;
- Décisions d’acquérir tous actifs, activités ou engagements où soit (i) la valeur soit (ii) le paiement réalisé en contre-
partie des actifs, activités ou engagements concernés dépasse les 20.000,- USD;
- Décisions d’aliéner ou de vendre tous actifs, activités ou engagements de la Société où soit (i) la valeur soit (ii) le
paiement réalisé en contrepartie des actifs, activités ou engagements concernés dépasse les 20.000,- USD;
- Décisions de proposer la liquidation ou tout autre cessation d’activités de la Société;
- Décisions de proposer l’approbation des comptes annuels de la Société;
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions ou décisions doivent être prises expressément soit par lettre circulaire transmise par
lettre, courrier électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de communication
approprié.
Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le
même contenu.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux
gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.»
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportées par la Société ou devant
être payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à mille euros.
Aucune autre affaire n’ayant à être traitée, l’assemblée a été ajournée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent docu-
ment.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec Nous, Notaire, l’original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 mars 2006, vol. 436, fol. 9, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065731.3/242/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
LEXICON MARKETING OPERATING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 105.521.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065734.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Mersch, le 3 mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 4 mai 2006.
H. Hellinckx.
79277
ALENA INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08225, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065399.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
SQUARE HOLDINGS (CDE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SQUARE HOLDINGS (CDE) S.A.).
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 116.492.
—
In the year two thousand and six, on the thirtieth day of May.
Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SQUARE HOLDINGS (CDE) S.A., a société
anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger acting in replacement
of Maître Jacques Delvaux of 28 April 2006, not yet published in the Mémorial C, and in the process of registration with
the Registry of Commerce and Companies of Luxembourg. The Articles of Incorporation of the Company have not
been amended since this date.
The meeting is declared open at 3.30 pm with Emanuela Brero, employee, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Guillaume de Villenaut, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To transform the Company from its current form of a «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».
2. To acknowledge that all the shares in issue on the date of the shareholders meeting being shares of a «société
anonyme» with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) be converted into shares of a «société à
responsabilité limitée» having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), with the same rights and privileges, at the
following ratio: twenty (20) shares of the «société anonyme» will be exchanged against one (1) share of the «société à
responsabilité limitée».
3. To create five classes of shares and to reclassify the existing shares.
4. To increase the corporate capital by an amount of forty-four thousand three hundred and seventy-five Euro (EUR
44,375.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to seventy-five thousand
three hundred and seventy-five Euro (EUR 75,375.-).
5. To issue three hundred and fifty-five (355) new Class A Shares, three hundred and fifty-five (355) new Class B
Shares, three hundred and fifty-five (355) new Class C Shares, three hundred and fifty-five (355) new Class D Shares
and three hundred and fifty-five (355) new Class E Shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share,
having the same rights and privileges attached as the existing shares issued by the Company.
6. To accept subscription for these new shares and accept payment in full for such new shares by a contribution in
cash.
7. To fully restate the Articles of Incorporation of the Company to reflect the resolution to be adopted under items
1 to 6.
8. To reconfirm the appointment of the existing directors.
9. To confer powers on the Company’s board of directors to implement the resolutions adopted under the preceding
items.
10. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
Signatures.
79278
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to transform the Company from its current form of a «société anonyme» into a «so-
ciété à responsabilité limitée».
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to acknowledge that all the shares in issue on the date of the shareholders meeting
being shares of a «société anonyme» with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) be converted into
shares of a «société à responsabilité limitée» having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), with the same rights and
privileges, at the following ratio: twenty (20) shares of the «société anonyme» will be exchanged against one (1) share
of the «société à responsabilité limitée».
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to create five classes of shares issued by the Company - the Class A Shares, the Class
B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares and the Class E Shares - and to reclassify the one thousand two hundred
and forty (1,240) existing shares issued by the Company into two hundred and forty-eight (248) new Class A Shares,
two hundred and forty-eight (248) new Class B Shares, two hundred and forty-eight (248) new Class C Shares, two
hundred and forty-eight (248) new Class D Shares and two hundred and forty-eight (248) new Class E Shares held by
the Company’s current shareholder.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of forty-four thousand
three hundred and seventy-five Euro (EUR 44,375.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand
Euro (EUR 31,000.-) to seventy-five thousand three hundred and seventy-five Euro (EUR 75,375.-).
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolved to issue three hundred and fifty-five (355) new Class A Shares, three hundred and fifty-
five (355) new Class B Shares, three hundred and fifty-five (355) new Class C Shares, three hundred and fifty-five (355)
new Class D Shares and three hundred and fifty-five (355) new Class E Shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) per share, having the same rights and privileges attached as the existing shares issued by the Company.
<i>Sixth resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Jean-Michel Schmit, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of:
(i) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 90393, acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) L.P., having
its registered office at Walker House, Mary Street, PO Box 908, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK154931 by virtue of a
proxy given on 26 May 2006;
(ii) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 90393, acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) L.P., having
its registered office at Walker House, Mary Street, PO Box 908, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK154934 by virtue of a
proxy given on 26 May 2006; and
(iii) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a company governed by the laws of Jersey and having its regis-
tered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered with the Jersey Financial Services Commission
under number 90393, acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (E) L.P.,
having its registered office at Walker House, Mary Street, PO Box 908, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK154933 by virtue of
a proxy given on 26 May 2006;
(together the «Subscribers»).
The attorney-in-fact declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscribers to the new Class A Shares,
Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per
share, as follows:
Subscribers
Class A
Class B
Class C
Class D
Class E
Shares
Shares
Shares
Shares
Shares
CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED acting as general
partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY PART-
NERS IV (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
61
61
61
CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED acting as general
partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY PART-
NERS IV (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
261
261
261
261
CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED acting as general
partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY PART-
NERS IV (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
33
33
33
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355
355
355
355
355
79279
The attorney-in-fact declared, in the name and on behalf of the Subscribers, to fully pay up each of such new shares
by a contribution in cash.
The amount of forty-four thousand three hundred and seventy-five Euro (EUR 44,375.-) is as from now at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
Thereupon, the shareholders resolved to waive, to the extent necessary, their preferential subscription right, to ac-
cept the said subscriptions and payments and to allot each such new shares to the Subscribers as set out above.
<i>Seventh resolutioni>
As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to fully restate of the Company’s Articles of Incor-
poration, which shall from now on read as follows:
«Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the
laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10 August 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 7.1, 7.2, 7.6, 9 and 12.2 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. Definitions
In addition to the other terms defined in other clauses of these Articles, the following words and terms shall have
the following meanings if and when written with capital letters:
«Available Profit» means for the purpose of calculating the Repurchase Price, the Distributable Profit which shall be
determined on the basis of the Interim Financial Statements drawn up by the Board of Directors on the date immediately
preceding the Repurchase Date;
«Board of Directors» has the meaning as set forth in Article 8.1.1 of these Articles;
«Class A Shares» means the shares of class A having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class A Share»
means any of them;
«Class B Shares» means the shares of class B having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class B Share»
means any of them;
«Class C Shares» means the shares of class C having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class C Share»
means any of them;
«Class D Shares» means the shares of class D having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class D Share»
means any of them;
«Class E Shares» means the shares of class E having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class E Share»
means any of them;
«Company» has the meaning as set forth in Article 1;
«Distributable Profits» means the Company’s profit available for distribution in accordance with the provisions of the
Law and including the Share Premium Reserve, after allocation of profits to any reserve that may be required by the
Law and/or these Articles (if any);
«First Classes Shares» means, at a given moment, the class(es) of Shares still in issue, other than the Last Class of
Shares;
«General Shareholders’ Meeting» means any general meeting of the Shareholders of the Company;
«Interim Financial Statements» means the interim balance sheet, the interim profit and loss account and the attached
notes of the Company;
«Last Class of Shares» means the last class of Shares based on alphabetical order which is still in issue at a given mo-
ment;
«Law» has the meaning as set forth in Article 1;
«Par Value» means twenty-five Euro (EUR 25.-) per Share;
«Preferential Dividend» has the meaning as set forth in Article 13.3.1 of these Articles;
«Repurchase Date» has the meaning as set forth in Article 7.4.2 of these Articles;
«Repurchase Price» means the sum of the Available Profit of the Company plus the aggregate Par Value of all the Last
Class of Shares to be repurchased;
«Shares» means the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares and the Class E Shares
and «Share» means any of them;
«Shareholders» means the holders of Shares of any class and «Shareholder» means any of them; and
«Statutory Distributable Profits» means the Distributable Profits after deduction of the Preferential Dividend.
Art. 3. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-
panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-
pany law of 31 July 1929.
79280
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. Denomination
The Company will have the denomination SQUARE HOLDINGS (CDE), S.à r.l.
Art. 6. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or
in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 7. Share capital - Shares
7.1 Subscribed share capital
The Company’s corporate capital is fixed at seventy-five thousand three hundred and seventy-five Euro (EUR
75,375.-) divided into three thousand and fifteen (3,015) Shares as follows:
All with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per Share are fully subscribed and entirely paid up.
7.2 Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the general shareholders’ meeting, in accordance with
Article 9 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
7.3 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in
existence.
7.4 Repurchase of Shares
7.4.1 The Company may repurchase its Shares under due observance of the provisions of the Law and the Articles.
7.4.2 Furthermore, subject to compliance with Luxembourg law, the sole Director, or in case of plurality of Directors,
the Board of Directors shall be entitled, and the holders of the Last Class of Shares shall be entitled to require the sole
Director or the Board of Directors, to repurchase the entire Last Class of Shares at any time by serving notice to the
holders of the Last Class of Shares or to the sole Director or the Board of Directors as the case may be, specifying the
number of relevant Last Class of Shares to be repurchased and the date on which the repurchase is to take place (the
«Repurchase Date»).
7.4.3 Each Last Class of Share repurchased in accordance with this Article 7.4 shall entitle its holder to a pro rata
portion of the Repurchase Price.
7.4.4 The repurchase of the Last Class of Shares may not have the effect of reducing the net assets of the Company
below the aggregate of the subscribed share capital and the reserves that may not be distributed under the law and the
Articles. Therefore, the repurchase can only be made by using sums met out of profit, or a fresh issue of shares or from
sums created to available reserves such as the Share Premium Reserve.
7.4.5 Immediately after the payment of the Repurchase Price, the sole Director, or in case of plurality of Directors,
the Board of Directors shall take all appropriate measures, including but not limited to convening a General Meeting in
view of decreasing the share capital by cancelling the repurchased Last Class of Shares.
7.5 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7.6 Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of Article 189 and 190 of the Law.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-
ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.
7.7 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-
cordance with Article 185 of the Law.
Class of Shares
Number
of Shares
Class A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Class B Shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Class C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Class D Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Class E Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
79281
Art. 8. Management
8.1 Appointment and removal
8.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) (the «Director») or more directors (gérants) (the «Direc-
tors»). If several Directors (gérants) have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance).
The Director(s) (gérant(s)) need not to be Shareholder(s).
8.1.2 The Director(s) is/are appointed by the General Meeting of Shareholders.
8.1.3 A Director may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by
the Shareholders.
8.1.4 In the event a Director is removed or replaced or in the event a Director resigns, dies, retires or in the event
of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the General Shareholders’ Meeting.
8.1.5 The members of the Board of Directors shall not be compensated for their services as Directors, unless oth-
erwise resolved by the General Meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable
expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attend-
ing meetings on the board.
8.2 Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.
8.3 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 8.3 shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the
joint signature of any two members of the board of directors.
The director, or in case of plurality of directors, the board of directors, may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
8.4 Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.
The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the
secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any director.
The board of directors can discuss or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at the meeting of the board of directors.
In case of plurality of directors, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
8.5 Liability of directors
The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 9. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,
may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-
ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 10. Annual general shareholders’ meeting
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in
accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the third Tuesday of June, at 3.00 pm. If such day is not a bank business
day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances
so require.
79282
Art. 11. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one
or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 12. Fiscal year - Annual accounts
12.1 Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1 January and ends on the 31 December of each year.
12.2 Annual accounts
Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an
indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,
the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.
Art. 13. Distribution of profits
13.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit.
13.2 Legal Reserve
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
13.3 Dividends
13.3.1 To the extent that the holders of Shares declare a dividend in any financial year any distributable profits shall
be allocated in the following priority:
(i) first and exclusively to the holders of the First Classes of Shares an amount up to zero point five per cent (0.5%)
of the Par Value of the First Classes of Shares for the full accounting year payable pro rata temporis; then
(ii) provided that all the Shareholders hold at least one (1) Share in the Last Class of Shares, any Statutory Distribut-
able Profit shall be allocated to the holders of the Last Class of Shares. In the event that not all the Shareholders hold
at least one (1) in the Last Class of Shares upon a declaration of a dividend, any Statutory Distributable Profit shall be
allocated pro rata to the to the holders of all the Shares without regard to the Class they belong.
13.3.2 Interim dividends or any other distribution decided by the Board of Directors or the Shareholders shall be
made in compliance with any applicable legal provision and allocated between the Shareholders in accordance with Ar-
ticle 13.3.1.
Art. 14. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the single shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 15. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
Art. 16. Modification of articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of share-
holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.»
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolved to reconfirm the appointment of the existing directors.
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting resolved to confer full powers to the board of directors of the Company, for the purpose of
implementing the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at EUR 3,100.-.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The notary has drawn the attention of the appearing parties on the wording of article 182 of the law on commercial
companies, what the appearing parties acknowledges.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with us, notary, this original deed.
79283
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SQUARE HOLDINGS (CDE) S.A.,
une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Maître Joseph Elvinger agissant en
remplacement de Maître Jacques Delvaux empêché en date du 28 avril 2006, non encore publié au Mémorial C et en
cours d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Les statuts de la Société n’ont pas
été modifiés depuis cette date.
L’assemblée est déclarée ouverte à 15:30 heures sous la présidence de Emanuela Brero, employée privée, demeurant
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Guillaume de Villenaut, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transformation de la Société de sa forme présente de «société anonyme» en «société à responsabilité limitée».
2. Reconnaissance que toutes les actions émises à la date de l’assemblée générale des actionnaires étant des actions
d’une société anonyme ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) seront converties en parts so-
ciales d’une société à responsabilité limitée ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) avec les mêmes
droits et privilèges, au ratio suivant: vingt (20) actions de la société anonyme seront échangés contre une (1) part sociale
de la société à responsabilité limitée.
3. Création de cinq catégories d’actions et reclassement des actions existantes.
4. Augmentation du capital social de la société d’un montant de quarante-quatre mille trois cent soixante-quinze
euros (EUR 44.375,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante-quinze
mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 75.375,-).
5. Emission de trois cent cinquante-cinq (355) nouvelles Actions de Catégorie A, trois cent cinquante-cinq (355) nou-
velles Actions de Catégorie B, trois cent cinquante-cinq (355) nouvelles Actions de Catégorie C, trois cent cinquante-
cinq (355) nouvelles Actions de Catégorie D et trois cent cinquante-cinq (355) nouvelles Actions de Catégorie E d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes émises
par la Société.
6. Acceptation de la souscription de ces actions nouvelles et acceptation de la libération intégrale de ces actions nou-
velles par apport en espèces.
7. Reformulation intégrale des statuts de la Société afin de mettre en oeuvre les résolutions prises aux points 1 à 6.
8. Confirmation du mandat des gérants actuels de la Société.
9. Délégation de pouvoirs au Conseil de Gérance de la Société afin de mettre en oeuvre les résolutions prises aux
points précédents.
10. Divers.
(i) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
(ii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants res-
teront pareillement annexées aux présentes.
(iii) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu
être fait abstraction des convocations d’usage.
(iv) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée générale, après délibération, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de transformer la Société de sa forme présente de «société anonyme» en «société à
responsabilité limitée».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de reconnaître que toutes les actions émises à la date de l’assemblée générale des ac-
tionnaires étant des actions d’une société anonyme ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25)
seront converties en actions d’une société à responsabilité limitée ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) avec les mêmes droits et privilèges, au ratio suivant: vingt (20) actions de la société anonyme seront échangés con-
tre une (1) part sociale de la société à responsabilité limitée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de créer cinq catégories de Parts Sociales émises par la Société - les Parts Sociales de
la Catégorie A, les Parts Sociales de la Catégorie B, les Parts Sociales de la Catégorie C, les Parts Sociales de la Catégorie
D et les Parts Sociales de la Catégorie E - et de reclasser les mille deux cent quarante (1.240) Parts Sociales existantes
79284
émises par la Société en deux cent quarante-huit (248) nouvelles Parts Sociales de Catégories A, deux cent quarante-
huit (248) nouvelles Parts Sociales de Catégories B, deux cent quarante-huit (248) nouvelles Parts Sociales de Catégories
C, deux cent quarante-huit (248) nouvelles Parts Sociales de Catégories D et deux cent quarante-huit (248) nouvelles
Parts Sociales de Catégories E détenues par l’actionnaire actuel de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de quarante-quatre mille trois
cent soixante-quinze euros (EUR 44.375,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) à soixante-quinze mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 75.375,-).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’émettre trois cent cinquante-cinq (355) nouvelles Actions de Catégorie A, trois cent
cinquante-cinq (355) nouvelles Actions de Catégorie B, trois cent cinquante-cinq (355) nouvelles Actions de Catégorie
C, trois cent cinquante-cinq (355) nouvelles Actions de Catégorie D et trois cent cinquante-cinq (355) nouvelles Actions
de Catégorie E d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes émises par la Société.
<i>Sixième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite s’est présenté Jean-Michel Schmit, prémentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé des
actionnaires existants de la Société:
(i) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social
au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 90393,
agissant en sa qualité de general partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) L.P.,
ayant son siège social à Walker House, Mary Street, PO Box 908, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrit
au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands sous le numéro WK154931, en vertu d’une procuration
donnée le 26 mai 2006;
(ii) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social
au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 90393,
agissant en sa qualité de general partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) L.P.,
ayant son siège social à Walker House, Mary Street, PO Box 908, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrit
au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands sous le numéro WK154934, en vertu d’une procuration
donnée le 26 mai 2006; et
(iii) CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social
à 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 90393,
agissant en sa qualité de general partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) L.P.,
ayant son siège social à Walker House, Mary Street, PO Box 908, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrit
au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands sous le numéro WK154933, en vertu d’une procuration
donnée le 26 mai 2006;
(ensemble les «Souscripteurs»).
Le mandataire a déclaré souscrire au nom et pour le compte des Souscripteurs aux nouvelles Parts Sociales de Ca-
tégorie A, Parts Sociales de Catégorie B, Parts Sociales de Catégorie C, Parts Sociales de Catégorie D et Parts Sociales
de Catégorie E d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, de la manière suivante:
Le mandataire déclare libérer, au nom et pour le compte des Souscripteurs, intégralement chacune de ces nouvelles
actions par un apport en espèces.
Le montant de quarante-quatre mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 44.375,-) est à partir de maintenant à la
disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.
Ensuite, l’assemblée générale a décidé de renoncer, dans la mesure du nécessaire, à leur droit préférentiel de sous-
cription et d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’attribuer chacune des nouvelles actions aux Souscrip-
teurs tel qu’énoncé ci-dessus.
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale a décidé de refondre intégralement les sta-
tuts de la Société qui seront dorénavant rédigés comme suit:
«Art. 1
er
. Forme sociale
Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en
particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
Souscripteurs
Parts Sociales de Catégorie
A
B
C
D
E
CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED agissant en sa qualité de general partner
au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) L.P.. . . . . . . .
61
61
61
61
61
CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED agissant en sa qualité de general partner
au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) L.P. . . . . . . .
261 261 261 261 261
CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED agissant en sa qualité de general partner
au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (E) L.P. . . . . . . . .
33
33
33
33
33
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355 355 355 355 355
79285
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7.1, 7.2, 7.6, 9 et 12.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Définitions
En plus des autres termes définis dans ces Statuts, les mots et les termes suivants auront les significations suivantes
quand ils seront écrits en majuscules:
«Bénéfices Disponibles» signifie, pour le calcul du Prix de Rachat, les Bénéfices Distribuables qui seront déterminés
à partir des Etats Financiers Intérimaires établis par le Conseil de Gérance à la date qui précède immédiatement la Date
de Rachat;
«Conseil de Gérance» a la signification prévue à l’article 8.1.1 des ces Statuts;
«Parts Sociales de Classe A» signifie les parts sociales de classe A ayant les droits tels que définis dans les Articles 7.4
et 13.3 et «Part Sociale de Classe A» signifie une d’entre elles;
«Parts Sociales de Classe B» signifie les parts sociales de classe B ayant les droits tels que définis dans les Articles 7.4
et 13.3 et «Part Sociale de Classe B» signifie une d’entre elles;
«Parts Sociales de Classe C» signifie les parts sociales de classe C ayant les droits tels que définis dans les Articles 7.4
et 13.3 et «Part Sociale de Classe C» signifie une d’entre elles;
«Parts Sociales de Classe D» signifie les parts sociales de classe D ayant les droits tels que définis dans les Articles
7.4 et 13.3 et «Part Sociale de Classe D» signifie une d’entre elles;
«Parts Sociales de Classe E» signifie les parts sociales de classe E ayant les droits tels que définis dans les Articles 7.4
et 13.3 et «Part Sociale de Classe E» signifie une d’entre elles;
«Société» a la signification prévue dans l’article 1
er
;
«Bénéfices Distribuables» signifie les bénéfices de la Société disponibles pour distribution en conformité avec les dis-
positions de la Loi et des Statuts, y compris la Réserve de Prime d’Emission de Parts Sociales, après allocation des bé-
néfices à toute autre réserve requise par la Loi et/ou ces Statuts (le cas échéant);
«Parts Sociales de Première Classe» signifie, à un moment donné, les classes de parts sociales encore en circulation,
et autres que la Dernière Classe de Parts Sociales;
«Assemblée Générale» signifie toute assemblée des Associés de la Société;
«Etats Financiers Intérimaires» signifie le bilan intérimaire, le rapport de profits et de pertes intérimaire, et les an-
nexes de la Société;
«Dernière Classe de Parts Sociales» signifie la dernière classe de Parts Sociales basée sur l’ordre alphabétique et qui
sont encore en circulation à un moment donné;
«Loi» a la signification prévue dans l’article 1
er
;
«Valeur Nominale» signifie vingt-cinq euros (25,- EUR) par Part Sociale;
«Dividende Préférentiel» a la signification prévue dans l’article 13.3.1 de ces Statuts;
«Date de Rachat» a la signification prévue dans l’article 7.4.2 de ces Statuts;
«Prix de Rachat» signifie le montant des Bénéfices Disponibles de la Société plus la Valeur Nominale de toutes les
parts sociales de la Dernière Catégorie de Parts Sociales à être rachetées;
«Parts Sociales» signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C,
les Parts Sociales de Classe D, et les Parts Sociales de Classe E et «Part Sociale» signifie l’une d’entre elles;
«Associés» signifie les détenteurs de Parts Sociales de toute classe et «Associé» signifie l’un d’entre eux;
«Bénéfices Distribuables Statutaires» signifie les Bénéfices Distribuables après déduction du Dividende Préférentiel.
Art. 3. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-
bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.
D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et
de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-
tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.
La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Dénomination
La Société aura la dénomination: SQUARE HOLDINGS (CDE), S.à r.l.
Art. 6. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
79286
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 7. Capital social - Parts sociales
7.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à soixante-quinze mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 75.375,-) représenté par trois
mille quinze (3.015) Parts Sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, divisé en:
Toutes ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), entièrement souscrites et libérées.
7.2 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’Associé unique ou par une décision
de l’assemblée générale des Associés conformément à l’article 9 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’ar-
ticle 199 de la Loi.
7.3 Participation aux profits
Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des Parts Sociales existantes.
7.4 Rachat de Parts Sociales
7.4.1 La Société pourra racheter ses Parts Sociales sous condition d’observer les dispositions de la Loi et des Statuts.
7.4.2 En outre, sous condition d’observer les dispositions légales luxembourgeoises, le Gérant unique, ou en cas de
plusieurs Gérants, le Conseil de Gérance aura droit, et les titulaires de la Dernière Catégorie de Parts Sociales auront
le droit de forcer le Gérant unique ou le Conseil de Gérance de racheter entièrement la Dernière Catégorie de Parts
Sociales à tout moment par notification des titulaires de la Dernière Catégorie de Parts Sociales ou le Gérant unique
ou le Conseil de Gérance, en précisant le nombre de Parts Sociales de Dernière Catégorie à racheter et la date à laquelle
le rachat aura lieu (la «Date de Rachat»).
7.4.3 Chaque Parts Sociale de Dernière Catégorie de Parts Sociales rachetée selon les dispositions de cet article 7.4
donnera à son titulaire le droit à une part pro rata du Prix de Rachat.
7.4.4 Le rachat de la Dernière Catégorie de Parts Sociales ne pourra avoir pour effet de réduire l’actif net de la Société
en dessous de la valeur du capital social souscrit et des réserves qui ne peuvent être distribuées selon la Loi et les Statuts.
Ainsi, le rachat ne pourra être effectué qu’en utilisant des montants provenant des bénéfices, ou d’une nouvelle émission
de Parts Sociales, ou des montants crées aux réserves disponibles telles que la Réserve de Prime d’Emission de Parts
Sociales.
7.4.5 Immédiatement après le paiement du Prix de Rachat, le Gérant unique, ou en cas de plusieurs Gérants, le Con-
seil de Gérance prendra les mesures nécessaires, y compris, mais non exclusivement, la convocation d’une Assemblée
Générale en vue de réduire le capital social par l’annulation de la Dernière Catégorie de Parts Sociales rachetée.
7.5 Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
7.6 Transfert de Parts Sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect
des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
Les Part Sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-Associés qu’après approbation préalable en
assemblée générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Le transfert de Parts Sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut
être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
7.7 Enregistrement de parts
Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des
Associés conformément à l’article 185 de la Loi.
Art. 8. Management
8.1 Nomination et révocation
8.1.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de Gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement Associé(s).
8.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des Associés.
8.1.3 Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les
Associés.
8.1.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un
gérant, l’assemblée générale des Associés, pourvoiront à son remplacement.
8.1.5 Les gérants ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérants, sauf s’il en est décidé autrement
par l’assemblée générale des Associés. La Société pourra rembourser aux gérants les dépenses raisonnables survenues
Part Sociale de Classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Part Sociale de Classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Part Sociale de Classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Part Sociale de Classe D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Part Sociale de Classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
79287
lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la
participation à des réunions du Conseil de Gérance, en cas de pluralité de gérants.
8.2 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des Associés
relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du Conseil de Gérance.
8.3 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 8.3.
En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants
par la signature conjointe de deux gérants.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer ses compétences pour des opé-
rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du manda-
taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
8.4 Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un
secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et
le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, le secrétaire ou par un gérant.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du Conseil de Gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les
gérants présents ou représentés à ladite réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du Conseil de Gérance par «conference call» via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.
8.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 9. Assemblée générale des associés
L’Associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des Associés.
En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts qu’il détient. Chaque Associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des Associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l’unanimité des Associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’Associés détenant au
moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n’est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des Associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des Associés doit être tenue, confor-
mément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans
la convocation de l’assemblée, le troisième mardi du mois de juin, à 15h00. Si ce jour devait être un jour non ouvrable
à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à
l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent
Art. 11. Vérification des comptes
Si le nombre des Associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs
commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t Associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.
Art. 12. Exercice social - Comptes annuels
12.1 L’exercice social
L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de l’année suivante.
79288
12.2 Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance dresse un inventaire (indiquant tou-
tes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque Associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 13. Distribution des profits
13.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
13.2 Réserve Légale
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-
temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
13.3 Dividendes
13.3.1 Dans la mesure où les détenteurs de Parts Sociales déclarent un dividende pendant l’exercice social, les béné-
fices distribuables doivent être distribués dans l’ordre suivant:
(i) en priorité et exclusivement aux détenteurs des Parts Sociales de Première Classe jusqu’à un montant qui repré-
sente zéro virgule cinq pour cent (0,5%) de la Valeur Nominale des Parts Sociales de Première Classe pour la première
année comptable pro rata temporis;
(ii) pourvu que tous les Associés détiennent au moins Une (1) Part Sociale dans la Dernière Classe de Parts Sociales,
les Bénéfices Légaux Distribuables seront distribués aux détenteurs de la Dernière Classe de Parts Sociales. Au cas où
tous les Associés ne détiennent pas au moins Une (1) Part Sociale dans la Dernière Classe de Parts Sociales sur décla-
ration d’un dividende, les Bénéfices Légaux Distribuables seront distribués pro rata aux détenteurs de toutes les Parts
Sociales sans considération de la Classe à laquelle ils appartiennent.
13.3.2 Les dividendes intérimaires ou toute autre distribution décidée par le Conseil de Gérance ou par les Associés
sera effectuée conformément aux provisions légales applicables et alloués entre les Associés selon l’article 13.3.1.
Art. 14. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite
de l’Associé unique ou d’un des Associés.
Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les As-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 15. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les Associé(s) s’en réfèrent aux dispositions
de la Loi.
Art. 16. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des Associés selon le quorum et conditions de vote re-
quis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de reconfirmer le mandat des gérants actuels de la Société.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de déléguer pouvoirs au Conseil de Gérance de la Société afin de mettre en oeuvre
les résolutions prises aux points précédents.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à EUR 3.100,-.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Le Notaire a attiré l’attention des parties sur la portée de l’article 182 de la loi sur les sociétés commerciales, ce que
ces derniers reconnaissent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Brero, J.M. Schmit, G. de Villenaut, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, vol. 153S, fol. 83, case 12. – Reçu 443,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068468.3/208/745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
J. Delvaux.
79289
BALTA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.666.650,-.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 101.259.
—
En date du 19 mai 2006, il a été décidé de transférer le siège social du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08288. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064462.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
FRANCE-LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 26.621.
—
Nous vous informons par la présente que la société FRANCE-LUXEMBOURG HOLDING S.A. S.A. ayant été
dissoute en date du 28 juin 2006, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 11 décembre 2000 entre la société
FRANCE-LUXEMBOURG HOLDING S.A. et nous-mêmes est devenu sans objet.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09671. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064556.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
SODEMARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.589.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 7 juin 2006i>
- Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09372. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064636.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
CERATIZIT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8201 Mamer, route de Holzem.
H. R. Luxemburg B 4.610.
—
Verwaltungsrat der CERATIZIT S.A.
Ich bestätige in meiner Eigenschaft als corporate secretary der CERATIZIT S.A. folgende Veränderung in der Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrates ab dem 13. Juni 2006.
Mit Wirkung ab dem 13. Juni 2006 ist Frau Anne Lanners De Rycker nicht länger Vorsitzende des Verwaltungsrates.
Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wurde am 13. Juni 2006 Herr Dr. Michael Schwarzkopf auf drei Jahre
bestellt.
Frau Anne Lanners De Rycker wurde am 13. Juni 2006 auf drei Jahre zur Stellvertretenden Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates bestellt.
Ich überreiche diese Erklärung unter Bezugnahme auf anliegenden avis d’agrément zu den Kosten dreifach im Original.
Luxemburg, den 1. Juli 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02264. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064963.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
F. Mesenburg / J.-P. Reiland
<i>Senior Manageri> / <i>Senior Vice-Présidenti>
Certifié sincère et conforme
SODEMARE S.A.
R. Burri / G. Vailati Venturi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
G. Kerckhoff
Unterschrift
79290
HUMANITARIAN WORLD HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 33.003.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur de
Messieurs Jean-Marc Beaujolin, Giulio Severini et Laurent-Olivier Girard, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’As-
semblée générale ordinaire annuelle de 2007.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de la société
ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle
de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00807. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065004.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
HUMANITARIAN WORLD HOLDING, Société Anonyme,
(anc. EQUITABLE BUSINESS WORLD HOLDING).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 33.003.
Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en
date du 12 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
294 du 24 août
1990; statuts modifiés suivant acte du même notaire, en date du 26 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations C N
°
53 du 7 février 1991, en date du 27 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C N
°
328 du 31 juillet 1992, et en date du 14 décembre 1995, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
95 du 23 février 1996. Le capital social a été converti en euros
dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 3 octobre 2001, extrait
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
266 du 16 février 2002. Les statuts ont été modifiés,
et notamment la dénomination sociale, qui a été changée, tout d’abord en EQUITABLE BUSINESS WORLD
HOLDING, suivant acte reçu par le même notaire, en date du 25 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C N
°
795 du 3 août 2004, et ensuite en HUMANITARIAN WORLD HOLDING, suivant
acte reçu par le même notaire, en date du 21 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C N
°
790 du 6 août 2005. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du
29 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
76 du 12 janvier 2006 et en date du
1
er
février 2006, non encore publié.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00814, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(064999.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.606.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04013, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
(065404.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour extrait conforme
HUMANITARIAN WORLD HOLDING
Signature
HUMANITARIAN WORLD HOLDING
Signature
<i>Pouri> <i>UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) S.A.
i>PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
V. Petit-Jean / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Directeuri>
79291
24 SPORT VILLAGE - SOCIETA IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 84.439.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01182, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(065397.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CORAVIT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 28.717.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 2. Mai 2006 von 9.00 bis 9.15 Uhri>
Die Aktionäre fassten hiermit einstimmig den nachstehenden Beschluss:
Zu Verwaltungsratsmitgliedern sind bestellt:
Carl Scharffenorth, wohnhaft in Goetzingen, Präsident des Verwaltungsrats;
Hermann Kuhnel, wohnhaft in Nospelt, Verwaltungsratsmitglied;
Raymond Sinnen, wohnhaft in Limpach, Verwaltungsratsmitglied.
Zum Kommissar ist bestellt:
BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, mit Sitz in Luxemburg.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden, sofern sie nicht verlängert werden, mit
Ablauf der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05694. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065159.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
CORAVIT AG & CO. II KG, Société en commandite simple.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 83.766.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 29. Mai 2006 von 9.30 bis 9.45 Uhri>
Die Aktionäre fassten hiermit einstimmig den Beschluss:
Zur Geschäftsführung sind bestellt:
Carl Scharffenorth, wohnhaft in Goetzingen;
Hermann Kuhnel, wohnhaft in Nospelt;
Raymond Sinnen, wohnhaft in Limpach.
Die Mandate der Geschäftsführung werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentlichen Generalversammlung
über das Geschäftsjahr 2006 verlängert.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05598. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065163.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
EUROPRIUS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 69.683.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08227, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065401.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme
<i>Le Domiciliataire
i>Signatures
Für die Richtigkeit des Auszugs
B. Vaisière
Für die Richtigkeit des Auszugs
B. Vaisière
Signatures.
79292
EMERALD FIRST LAYER «A» S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.472.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2006 a approuvé la résolution suivante:
Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, PricewaterhouseCoopers, est renouvelé pour une période de 6 ans.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09652. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064503.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01231, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2006.
(065406.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
HOLMES PLACE 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 97.488.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01111, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065407.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
MERRILL LYNCH LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.505.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09752, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065430.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
L D R S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 51.524.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00797, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065440.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
P. Callasin.
<i>Pouri> <i>INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
i>PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Fondé de Pouvoir / Directeuri>
HOLMES PLACE 2, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Géranti> / <i>Géranti>
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
79293
UNICAPITAL INVESTMENTS IV (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.108.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04023, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
(065410.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.360.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04019, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
(065411.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
JALFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 51.521.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00794, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065442.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ALFERWEIHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6412 Echternach, rue Alferweiher.
R. C. Luxembourg B 103.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01261, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065445.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.225.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01260, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065447.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Pouri> <i>UNICAPITAL INVESTMENTS IV (MANAGEMENT) S.A.
i>PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
V. Petit-Jean / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Directeuri>
<i>Pouri> <i>UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) S.A.
i>PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
V. Petit-Jean / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Directeuri>
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
79294
PARTICIPATIONS ALPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.288.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 16 mai 2006. i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
- ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064001.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
TRADEHOLD LIMITED.
Siège social: Parrow East 7501 Republic of South Africa.
TRADEHOLD LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.
Siège de la succursale: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 89.549.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 27 avril 2006i>
- M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg a été nommé en tant qu’administrateur
de la personne morale de droit étranger dénommée TRADEHOLD LIMITED, Luxembourg Branch, avec effet au 27 avril
2006.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04306. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064067.3/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
FIVE MOUNTS REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 93.862.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales signé le 24 février 2006 que la société REALEST FINANCE S.A. a
cédé à la société FIVE MOUNTS PROPERTIES HOLDING LIMITED, ayant son siège social au 31 Broad Street JE4 8ZP
St Helier, Jersey, United-Kingdom, la part sociale qu’elle détenait dans la société FIVE MOUNTS REAL ESTATE INVEST-
MENTS, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00665. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065468.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
MM. Nino Granzotti, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse), administrateur;
Francesco Logaldo, expert comptable, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait
<i>La société
i>Signature
79295
ONET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 14.629.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 avril 2006 à Luxembourgi>
L’assemblée générale ordinaire de la société à responsabilité limitée ONET LUXEMBOURG procède aux modifica-
tions suivantes:
1. L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du réviseur, la société ERNST & YOUNG S.A., dont le siège
social se situe à L-5365 Munsbach, Parc d’Activité Syrdall, 7, pour une durée d’un an, ce mandat expirant à l’issue de
l’Assemblée Générale de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065733.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ONET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 14.629.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01835, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(065749.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.073.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions du gérant unique de la Société datée du 20 juin 2006, que les personnes suivantes pourront
à partir du 1
er
juillet 2006, sauf stipulations contraires des statuts, sous leur signature individuelle engager valablement
la Société pour tous les actes et documents professionnels notamment les avis professionnels en conformité avec la loi,
ainsi que les contrats d’engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires employés):
- John Hames,
- Fabien Hautier,
- Paul Leyder,
- Frank Muntendam,
- André Pesch,
- Marc Schmitz,
- Dietmar Klos,
- Katrin Lakebrink,
- Karen Wauters,
- Jean-Marie Gischer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 28 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00280. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065853.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour ONET LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>VO CONSULTING LUX S.A.
<i>Mandataire
i>Signature
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature
79296
EQUEN S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 76.550.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2006, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
<i>1. Mandatsniederlegung des Verwaltungsratsi>
Die Verwaltungsratsmitglieder Dr. Thomas Weimer, Robert Langmantel, Gerhard Greif, und Uwe Waldau haben ihr
Mandat zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 9. Mai 2006 niedergelegt. Das Mandat von Herrn Mahdi
Elmamoun erlischt in Folge Todes.
<i>2. Beschlussfassung über die Reduzierung des Verwaltungsrats von bisher 5 Mitgliedern auf 3 Mitgliederi>
Die Versammlung beschliesst einstimmig, dass der bisherige Verwaltungsrat von bisher 5 Mitgliedern auf 3 Mitglieder
reduziert wird.
<i>3. Neubestellung von 3 Verwaltungsratsmitgliederni>
Folgende Personen werden zum neuen Verwaltungsrat bestellt:
1. Frau Vivian Hong, geb. am 8. April 1976 in Xiamen, China, wohnhaft in Unit 24A, 246 Hubin Road, Xiamen, China;
2. Herr Peter Yin, geb. am 10. Juli 19977 in Shengdu, China, wohnhaft in Appt. 12B, 593 Zong Sheng Road, Xiamen,
China;
3. Herr Yusni bin Rahim, geb. am 27. Januar 1970 in Malaysia, wohnhaft in Kampung Kisap, Mukim Kuah, 07000 Lang-
kawi, Kedah, Malaysia.
Diese nehmen das Amt an und führen es bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.
<i>4. Mandantsverlängerung des Aufsichtskommissarsi>
Das Mandat der FIDES INTER-CONSULT S.A. als Aufsichtskommissar wird verlängert bis zur ordentlichen General-
versammlung des Jahres 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00590. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065804.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ASSURANCES RISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 87, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 79.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08592, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(065450.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Für die Versammlung
i>Unterschrift
<i>Pour la société
i>BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Gummi-Roller, G.m.b.H.
Prisma Energy Turkey, S.à r.l.
Tordell S.A.
Xul S.A.
Celin Holding S.A.
Anterfi S.A.
Golden Square S.A.
Golden Square S.A.
Sarazar S.A.
Charme Management S.A.
Morgan Ré S.A.
Finalam S.A.
Tradenet Europe S.A.
Investrat S.A.
Alstrat S.A.
Compagnie Financière Van Wittenberge & Fils S.A.
Witham Holding S.A.
Lux. Financial Company Holding S.A.
Article S.A.
Delta Inter-Link S.A.
Continental Pac Holding S.A.
Helios Management S.A.
Trading Invest S.A.
Luxpictures, S.à r.l.
Calimar Property AG
Interportfolio
VS Management Consulting, S.à r.l.
I & T Lux, S.à r.l.
Wolfgang Schneider, S.à r.l.
Wolfgang Schneider, S.à r.l.
Assainissement Urbain Jean-Pierre Feidert et Compagnie S.A.
Mason S.A.
Mason S.A.
GM Real Estates S.A.
Charmont Holding S.A.
FFTW Funds Selection
FFTW Funds Selection
Transocean Investments, S.à r.l.
Balteire
Kelti S.A.
Kelti S.A.
Capital Holding
Ferrania Lux, S.à r.l.
Lexicon Marketing Operating Luxembourg, S.à r.l.
Lexicon Marketing Operating Luxembourg, S.à r.l.
Alena Invest
Square Holdings (CDE), S.à r.l.
Balta Luxembourg, S.à r.l.
France-Luxembourg Holding S.A.
Sodemare S.A.
Ceratizit S.A.
Humanitarian World Holding
Humanitarian World Holding
Unicapital Investments II (Management) S.A.
24 Sport Village - Società Immobiliare S.A.
Coravit AG
Coravit AG & Co. II KG
Europrius Asset Management S.A.
Emerald First Layer «A» S.A.
International Global Fund Management (Luxembourg) S.A.
Holmes Place 2, S.à r.l.
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A.
L D R S.A.
Unicapital Investments IV (Management) S.A.
Unicapital Investments III (Management) S.A.
Jalfin S.A.
Alferweiher, S.à r.l.
Climmolux S.A.
Participations Alpa S.A.
Tradehold Limited, Luxembourg Branch
Five Mounts Real Estate Investments, S.à r.l.
Onet Luxembourg, S.à r.l.
Onet Luxembourg, S.à r.l.
Ernst & Young Tax Advisory Services
Equen S.A.
Assurances Risch, S.à r.l.