logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

79105

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1649

31 août 2006

S O M M A I R E

Achmea Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

79143

M.C.I.  Marketing  Communication  International, 

Alias Investment, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

79133

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79149

Ampus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79107

Majentel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79151

Amtel Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg . .

79123

Maveja, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . 

79133

Andante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79144

Mavica Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

79148

Arten Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79132

Mavica Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

79148

Bank of China Ltd, Bank of China Limited, Succur-  

Messina Paolo, S.à r.l., Ehlange . . . . . . . . . . . . . . . . 

79151

sale de Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

79124

Multi Investment  Management  Central  Europe, 

Beca, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79106

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79141

Biscarosse S.A., Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79149

Newgate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

79132

Biscarosse S.A., Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79150

Novara Aquilone Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . 

79116

C&S Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79107

Oasis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79108

Cedar Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

79146

Pemik S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79133

(Le) Comitium International S.A., Luxembourg  . .

79140

Personal Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79109

Credit  Suisse  Euro  Bond  Express  Management 

Qstar Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79108

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

79106

Renascence MC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

79125

Crowntek Systems Luxembourg, Beaufort . . . . . . .

79116

Renascence MC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

79125

Crowntek Systems Luxembourg, Beaufort . . . . . . .

79117

Renascence MC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

79132

DIT Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

79109

Rono S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79107

Edge Core Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

79141

Rono S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79107

Estalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79148

Sandalfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79116

Experta Management A.G., Luxembourg . . . . . . . .

79152

Scip-Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

79148

F. Ackermann Optique (Optique Centre Bourse) 

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero VI Zeta, S.à r.l., 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79135

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79125

FA.PI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79106

Siv-Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

79147

FAM Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

79124

Son Group S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79131

Financial Fleurus Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

79149

Surrey Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

79135

Food and Bulk Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . .

79144

Thermic Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

79109

Food and Bulk Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . .

79146

Timaru S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79147

Forum Film Corp. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

79132

Tis-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

79147

Global Energy Invest Company S.A., Luxembourg

79131

Tit-Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

79148

HQ Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

79109

TMS S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79133

International Society Marken Consultance (ISOM) 

TR Marketing & Consulting S.A., Bertrange . . . . . 

79143

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79108

TR Marketing & Consulting S.A., Bertrange . . . . . 

79143

International Society Marken Consultance (ISOM) 

UBP Multifunds II, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . 

79124

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79108

UBP Multifunds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

79124

Iskander Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

79150

United Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

79116

Iskander Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

79151

Victoria Management Services S.A., Luxembourg 

79140

Jack Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79152

Victoria Management Services S.A., Luxembourg 

79140

LMC Group S.A., Luxembourg Management Com-  

Wintersport Investments  Holding  S.A., Luxem-  

pany Group, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79106

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79147

79106

CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.001. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00048, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065533.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

LMC GROUP S.A., LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.897. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06117, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

(063028.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

FA.PI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 103.577. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

(063063.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

BECA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2174 Luxembourg, 19A, rue du Mur.

R. C. Luxembourg B 111.960. 

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2006

Les associés de la société à responsabilité limitée BECA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1321 Luxembourg 170, rue

de Cessange se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 juin 2006. L’assemblée a pris les résolutions sui-
vantes:

L’adresse du siège social est transféré de L-1321 Luxembourg, 170, rue de Cessange à L-2174 Luxembourg, 19A, rue

du Mur. 

Monsieur Serge Calteux, ingénieur diplômé, né à Luxembourg, le 15 avril 1971 et Madame Patricia Kips, née à Esch-

sur-Alzette, le 20 septembre 1971 ont démissioné comme gérants de la société BECA, S.à r.l. avec effet immédiat.

La société CALTEUX, S.à r.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B nu-

méro 106.605, est nommée nouveau gérant technique de la société BECA, S.à r.l.

Monsieur Daniel Beck, agent immobilier, né à Luxembourg, le 3 août 1970, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, 10,

op de Maessen, est également nommé gérant technique.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des deux gérants tech-

niques.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065512.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger

<i>Pour LMC GROUP S.A.
Signature

<i>Pour FA.PI S.A.
Signature

CALTEUX, S.à r.l. / D. Beck
Signatures / -

79107

C&amp;S HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.753. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 24 juillet 1997 entre:
Société domiciliée: C&amp;S HOLDING S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg: B 61.753,

et
Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 28.967,

a pris fin avec effet au 10 mai 2006.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063287.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

AMPUS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.486. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 14 décembre 2000 entre:
Société domiciliée: AMPUS S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg:

B 79.486,

et
Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 28.967, 

a pris fin avec effet au 5 mai 2006.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06728. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063289.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

RONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.490. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07981, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

(063311.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

RONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.490. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07948, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

(063310.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour <i>RONO S.A., <i>Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour <i>RONO S.A., <i>Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

79108

OASIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.971. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 24 septembre 2001 entre:
Société domiciliée: OASIS HOLDING S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg: B 83.971,

et
Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 28.967, 

a pris fin avec effet au 6 avril 2006.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063298.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

QSTAR TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 90.239. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 3 décembre 2002 entre:
Société domiciliée: QSTAR TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 90.239,

et
Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 28.967, 

a pris fin avec effet au 5 mai 2006.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06759. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063299.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

INTERNATIONAL SOCIETY MARKEN CONSULTANCE (ISOM) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.956. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07991, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

(063332.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

INTERNATIONAL SOCIETY MARKEN CONSULTANCE (ISOM) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.956. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07988, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

(063334.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour <i>INTERNATIONAL SOCIETY MARKEN CONSULTANCE (ISOM) S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour <i>INTERNATIONAL SOCIETY MARKEN CONSULTANCE (ISOM) S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

79109

PERSONAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 111.290. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 4 octobre 2005 entre:
Société domiciliée: PERSONAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 111.290,

et
Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 28.967,

a pris fin avec effet au 6 avril 2006.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06760. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063300.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

HQ PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 33.101. 

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09606, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063392.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

THERMIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 37.083. 

Le bilan au 31 décembre 2004 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08648, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2006.

(063429.3/317/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

DIT LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 117.489. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the ninth day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DIT LUXEMBOURG 1, S.à r.l., a company incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with registered

office at 2 Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg and in process to be registered in the Registre de Commerce of Lux-
embourg,

here represented by Mr Olivier Jarny, banker, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 9th, in Lux-

embourg.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

79110

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name DIT LUXEM-

BOURG 2, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies. It may also give
guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries,
affiliated companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over
some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

hundred twenty-five (125) shares in registered form with a par value of hundred Euro (EUR 100) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

79111

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by a manager acting jointly with any manager of the Com-
pany.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of any manager or by the single or joint

signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these
Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of July of each year and end on the thirty of June

of the following year.

79112

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 30 June 2007.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, DIT LUXEMBOURG 1, S.à r.l. prequalified and represented as stated here-above, declares to have sub-

scribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all two hundred shares by contribution in
cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has
been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred (EUR 1,500).

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Tom Verheyden, banker, born on August 14th, 1974 in Diest, Belgium, having his professional address at 2, boul-

evard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,

- Mr Vincent de Rycke, banker, born on March 22nd, 1973 in Ghent, Belgium, having his professional address at 2,

boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,

- Mr Victor Patrick Hoog Antink, CEO, born on September 19th, 1953 in Melbourne, Victoria, Australia, whose busi-

ness address is at Level 9, 343 George Street, Sydney NSW 2000 PO Box R1822 Royal Exchange NSW 1225, Australia.

2. The registered office of the Company is set at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DIT LUXEMBOURG 1, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg, et en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg.

79113

ici représentée par Monsieur Olivier Jarny, banquier, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le

9 juin 2006 à Luxembourg.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination DIT LUXEMBOURG 2, S.à r.l. (la Société), qui

sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tier-
ces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées. La Société pourra en
outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés por-
tant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

79114

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant agissant conjointement avec tout autre gérant.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de tout gérant, ou par la

signature unique ou les signatures conjointes de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément à l’article 8.2 des présents statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

79115

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 30 juin 2007.

<i>Souscription - Libération

DIT LUXEMBOURG 1, S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social

de la Société et d’avoir entièrement libéré les cent vingt-cinq parts sociales par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500).

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Tom Verheyden, banquier, né le 14 août 1974 à Diest, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2,

boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,

- Monsieur Vincent de Rycke, banquier, né le 22 mars 1973 à Gand, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2,

boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,

- Monsieur Victor Patrick Hoog Antink, CEO, né le 19 septembre 1953 à Melbourne, Victoria, Australia, ayant son

adresse professionnelle à Level 9, 343 George Street, Sydney NSW 2000 PO Box R1822 Royal Exchange NSW 1225,
Australia.

2. Le siège social de la Société est établi au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: O. Jarny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 84, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067250.3/220/392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

G. Lecuit.

79116

NOVARA AQUILONE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.851. 

Le bilan au 28 février 2006, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08705, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2006.

(063580.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

UNITED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 15.273. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07663, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.

(063622.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

SANDALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.704. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09350, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.

(063652.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

CROWNTEK SYSTEMS LLC

Siège social: DE 19806 Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, USA, 1308, Delaware Avenue.

CROWNTEK SYSTEMS LUXEMBOURG

Siège de la succursale: L-6312 Beaufort, 104, route d’Eppeldorf.

R. C. Luxembourg B 117.306. 

<i>Ouverture de succursale

Par décision de l’Assemblée Extraordinaire prise en date du 16 mai 2006:
- Immatriculation d’une succursale de la société à responsabilité limitée de droit américain CROWNTEK SYSTEMS

LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY), ayant son siège social à 1308 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19806, County
of New Castle, State of Delaware, USA, immatriculée sous Nr. 4147317 à Chambers of Commerce Delaware, USA;

- dénomination de la succursale sera Crowntek Systems Luxembourg;
- l’adresse de la succursale sera au 104, route d’Eppeldorf, L-6312 Beaufort;
- la succursale a pour objet: le commerce, l’import et l’export des produits informatiques, électriques, électroniques

et des équipements, cadeaux et souvenirs, produits pour la construction, meubles et de tous produits à l’exclusion de
toute vente de matériel militaire;

- a été nommé représentant permanent pour l’activité de la succursale: Monsieur Vitor Manuel da Silva Filipe, con-

seiller, demeurant à Rua Latino Coelho, 87, 1050 Lisboa, Portugal. Il peut engager la société avec sa seule signature;

- a été nommé président de la société: Monsieur Joaquim Magro de Almeida, conseiller, demeurant à Rua Ana e

Castro Osotio, Lote 3, Damaia, 2700 Amadora, Portugal, ayant le pouvoir d’engager la société.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR5604. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062477.4//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

<i>Pour <i>NOVARA AQUILONE SICAV, <i>Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

SANDALFIN S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour la société
J.M. De Almeida
<i>Président

79117

CROWNTEK SYSTEMS LLC

Siège social: DE 19806 Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, USA, 1308, Delaware Avenue.

CROWNTEK SYSTEMS LUXEMBOURG

Siège de la succursale: L-6312 Beaufort, 104, route d’Eppeldorf.

R. C. Luxembourg B 117.306.

<i>Certificate of formation of CROWNTEK SYSTEMS LLC

First: The name of the limited liability company is CROWNTEK SYSTEMS LLC.
Second: The address of its registered agent in the State of Delaware is 1305 Delaware Avenue, Wilmington, DE,

19806, County of New Castle. The none of its registered agent at such address is ATRIUM OFFSHORE LLC.

Third: The purpose of the limited liability company shall be to engage in any lawful act or activity for which a limited

liability company may be formed. under the Limited Liability Company Law of the State of Delaware.

Fourth: The limited liability company shall have perpetual existence unless dissolved by law.
Fifth: Management of the limited liability company is vested in its members in accordance with their ownership inter-

ests, unless this is varied by the operating agreement. A limited liability company member may not assign, wholly or
partially, the right to participate in management without the written consent of all of the limited liability company mem-
bers. The initial member(s) to form the limited liability company shall be:

SC OVERSEAS MANAGEMENT LIMITED
95 Wilton Road, Suite 717
Victoria, SW1V 1BZ
London, England
Sixth: The name and address of the person forming this limited liability company at the instruction of its members is

as follows: 

Jennifer Toscano-Goetz
1308 Delaware Avenue
Wilmington, DE 19806
Seventh: The power to adopt, alter, amend or repeal the Operating Agreement shall be vested in the members of

this limited liability company.

Eighth: To the fullest extent permitted by law, no member of this limited liability company shall be personally liable

to the limited liability company or its members for monetary damages for breach of fiduciary duty of such member.
Without b.mitation of the above, in the event that Delaware law is arn.ended to authorize further elimination of liability
of members, then the liability of such members shall be eliminated to the fullest extent permitted under such amended
law.

In witness whereof, the undersigned has executed this Certificate of Formation, of CROWNTEK SYSTEMS LLC, this

24th day of April, 2006. 

<i>Operating agreement of CROWNTEK SYSTEMS LLC

Upon valuable consideration, the persons named below as «Members» hereby covenant and agree to be bound to

the following as their limited liability company operating agreement dated this 25th day of April, 2006 (this «Agreement»
or this «Operating Agreement») for CROWNTEK SYSTEMS LLC, a limited liability company organized under the laws
of the State of Delaware (hereinafter known as «the LLC»):

Art. I. Definitions
As used in this Operating Agreement, the following terms are to have the meaning as stated below:
«LLC» means «Limited Liability Company» and «the LLC» means CROWNTEK SYSTEMS LLC.
«LLC Units» or «Units» means measures of ownership in the LLC. The capital structure of the LLC shall consist of

Units all of the same class with equal rights for all purposes under this Operating Agreement.

«LLC Unit Percentage» means, with respect to an LLC member, the percentage derived from the following fraction:

number of LLC Units held by such Member divided by the total number of LLC Units held by all Members (and, there-
after, multiplying said fraction by 100 to arrive at a percentage).

«State Law» means the laws of the State of Delaware.
«Vote in interest of LLC members», means a vote of the LLC members in which each LLC member shall have one

vote per LLC Unit possessed; for example, a member possessing 150 LLC Units would have 150 votes in interest.

«Supermajority vote in interest of LLC members» means a vote of the LLC members in which each LLC member

shall have one vote per LLC Unit possessed and the number of affirmative votes for any resolution before the members
shall be more than 66% of the outstanding LLC Units. For example, if there are 1,000 outstanding LLC Units, 667 af-
firmative votes are required to achieve a Supermajority vote in interest upon a resolution before the members.

Art. II. General provisions
Section 2.1. Formation
Articles of Organization either already have been filed with the appropriate State office or shall shortly be done so.

The Members shall execute or cause to be executed all other instruments, certificates, notices and documents as may
now or hereafter be required for the formation, valid existence and, when appropriate, termination of the LLC as a
limited liability company under the laws of the State of Delaware.

J. Toscano-Goetz
<i>Authorized Person

79118

Section 2.2. Company Name
The name of the LLC is CROWNTE SYSTEMS LLC or such other name or names as may be selected by the Members

from time to time, and its business shall be carried on in such name with such variations and changes, as the Members
deem prudent.

Section 2.3. Purpose of the LLC
The purpose of the LLC is to engage in any lawful act or activity for which a limited liability company may be organized

under the laws of the State of Delaware including, but not limited to general trading, import and export, agency for
informatics, products and equipments, promotional gifts, sea oils, building materials, textiles, shoes and accessories, food
products, auto parts and vehicles, decoration articles, office furniture, wooden products and furniture, hygiene, cleaning
and esthetic products.

Section 2.4. Place of Business
The business address of the LLC shall be determined by the Members. The LLC may from time to time have such

other place or places of business, within or without the State of Delaware, as the Members may decide.

Section 2.5. Registered Agent
The initial registered agent shall be as follows:
ATRIUM OFFSHORE LLC
1308 Delaware Avenue
Wilmington (New Castle County)
DE 19806

and Registered office of the LLC shall be as follows:
1308 Delaware Avenue
Wilmington (New Castle County)
DE 19806

The Members may remove or replace the LLC registered agent at any time.

Section 2.6. Business Transactions of a Member with the Company
A Member may lend money to, borrow money from, act as surety, guarantor or endorser for, guarantee or assume

one or more obligations of, provide collateral for, and transact other business with, the LLC and, subject to applicable
law, shall have the same rights and obligations with respect to &amp;bsol;any such matter as a Person who is not a Member.

Section 2.7 Company Property
No real or other property of the LLC shall be deemed to be owned by any Member individually, but shall be owned

by and title shall be vested solely in the LLC.

Section 2.8. No Term To Existence
The LLC’s existence shall commence on the date of the filing of the Article of Organization with the appropriate state

office and, thereafter, the LLC’s existence shall be perpetual without term.

Section 2.9. Accounting Period
The close of the LLC’s year for financial statement and federal income tax purposes shall be as determined by the

Members.

Art. III. Members
Section 3.1. Members
The name, initial capital contribution, LLC Units and LLC Unit Percentage of the Members are set forth in the below

table, which shall be amended from time to time to reflect the admission of new Members. 

Section 3.2. Admission of New Members
New members may be admitted to the LLC by an affirmative Supermajority vote in interest of LLC members.

Section 3.3. No Liability of Members
All debts, obligations and liabilities of the LLC, whether arising in contract, tort or otherwise, shall be solely the debts,

obligations and liabilities of the LLC, and no member shall be obligated personally for any such debt, obligation or liability
of the LLC solely by reason of being a member. This section does not prevent an LLC member, should he or she so
choose, from separately agreeing to guaranty or otherwise become liable for a debt, which is also one of the LLC.

Section 3.4. Access to Books and Records of LLC
Each LLC member shall have the right to inspect the books and records of the LLC during normal business hours

after the giving of reasonable notice of this intent to the LLC custodian of said documents and information; however,
each member gaining access to the books and records of the LLC shall hold this information confidential and only use
LLC information for the furtherance of LLC business and interests or for making investment decisions regarding the
member’s LLC interest. Upon withdrawal or departure as a member of an LLC, a member shall deliver all LLC books
and records in his or her possession to the remaining LLC members or managers.

Member Name

Initial Capital Contribution

LLC Units

LLC Unit

SC OVERSEAS MANAGE-

MENT LIMITED  . . . . . . . . . . . . .

USD 3,000,000

1,000

100%

79119

Section 3.5. Actions by the Members; Meetings, Quorum
a. The LLC members may take any action at a meeting in person, by proxy, or without a meeting by written resolution

in accordance with Section 3.5(d). Meetings of LLC members may be conducted in person or by telephone conference.
A voting proxy given by an LLC Member to another person must be in writing.

b. Voting. Each LLC member shall be entitled to vote upon all matters for which LLC members have the right to vote.

All LLC member votes shall be tallied by interest under which each member shall be entitled to one vote for each LLC
Unit possessed (for example, a member possessing 150 LLC Units

shall be entitled to 150 votes upon any matter submitted to the LLC Members for a vote). Each vote per LLC Unit

shall carry the same weight and have the same value, for voting purposes, as every other LLC Unit. Should state law
create statutory situations where LLC member votes are to be taken on a one vote per member basis, votes per mem-
ber (as opposed to per LLC Unit interest) shall be limited to those specific circumstances under which state law requires
such a vote.

c. Unless another percentage is given elsewhere in this operating agreement or by state law, all LLC member votes

on any matter shall require an affirmative vote in interest by LLC members of LLC Unit in excess of 50% of the out-
standing total to pass or approve the motion, resolution, or otherwise take action by the LLC members. For example,
if there are 1,000 LLC Units outstanding, a vote of 501 LLC Units in favour of a resolution is required for its passage
unless the resolution involves a matter for which this operating agreement or state law requires a higher percentage.

d. Any action required or permitted to be taken at any meeting of the Members may be taken without a meeting if

Members with the percentage of votes (per LLC units) sufficient to approve the action pursuant to the terms of this
Agreement resolve thereto in writing and the writing or writings are filed with the LLC records of actions taken by
Members. In no instance where action is authorized by written resolution shall it be required that a meeting of Members
be called or notice be given; however, upon passage, a copy of the action taken by written resolution of the members
shall be sent promptly to all LLC members. e. Meetings of Members may be called by any LLC member, or members,
collectively holding 25% or more of the outstanding LLC Units upon seven (7) days written notice to the other LLC
members. Notice of a meeting called for hereunder may be made by standard U.S. mail, electronic mail, or facsimile
transmission and shall contain the time, place, and purpose of such meeting. A quorum for any action to be taken at a
meeting of LLC members shall be LLC members present (in person, via telephone, or by proxy) holding more than 50%
of the LLC Units. Any Member may through a written instrument waive the right to receive prior notice of a meeting
of the Members as described herein.

f. Notwithstanding any other provision of this Agreement, the following actions shall require a Supermajority vote in

interest of the LLC Members:

f.1 - any merger, consolidation or other business combination;
f.2 - sale or other disposition of substantially all the assets of the LLC;
f.3 - filing of a petition or commencing other proceedings seeking reorganization; liquidation, arrangement or other

similar relief under any federal or state law relating to bankruptcy or insolvency;

f.4 - the amendment or modification of any provision of this Agreement;
f.5 - the issuance of additional LLC Units (other than those issued pursuant to the founding of the LLC as set forth

in Section 3.1 of this operating agreement) to any Member or other party including any other individual, trust, estate,
corporation, partnership, limited liability company or any other incorporated or unincorporated entity («Person») per-
mitted to be a member of a limited liability company under the Act;

f.6 - the removal of any Member;
f.7 - the decision to appoint managers for the LLC under Article IV hereof.

Section 3.6. Power to Bind the LLC
No LLC member or group of members acting in their individual capacity - separate and apart from action as LLC

members pursuant to this operating agreement - shall have any authority to bind the LLC to any third party with respect
to any matter.

Section 3.7. Members who are not individuals
Each Member who is an artificial entity or otherwise not an individual hereby represents and warrants to the LLC

and each Member that such Member is: (a) duly incorporated or formed (as the case may be), (b) validly existing and in
good standing under the laws of the jurisdiction of its incorporation or formation, and (c) has full power and authority
to execute and deliver this Agreement and to perform its obligations hereunder.

Section 3.8. Tax Matters Partner
José Ribeiro is hereby designated as the LLC’s «Tax Matters Partner» under Section 6231(a)(7) of the Internal Rev-

enue Code of 1986, as amended (the «Code»), and shall have all the powers and responsibilities of such position as
provided in the Code and the Treasury Regulations there under. The LLC members may remove or replace the Tax
Matters Partner by a vote of the majority in interest.

Art. IV. Management
Section 4.1. Management of the LLC
This LLC shall be managed by SC OVERSEAS MANAGEMENT LIMITED with address at 95 Wilton Road, Suite 717,

Victoria, SW1 V 1 BZ London, England; however, the LLC members reserve the right to appoint managers, who may
also be members, at a later date.

79120

Art. V. Capital, Structure
Section 5.1. Capital Structure
The capital structure of the LLC shall consist of one class of LLC Units each having equal rights under all provisions

of this operating agreement.

Section 5.2 LLC Units
1,000 LLC Units shall be issued to the Members, as set forth in Section 3.1 hereof, as part of the initial funding of the

LLC; however, additional LLC units may be issued pursuant to a Supermajority Vote in interest of LLC Members.

Section 5.3. Capital Contributions
a. Each Member shall contribute or shall have contributed, as an initial capital contribution («Initial Capital Contribu-

tion») to the LLC the amounts set forth below. The breakdown between cash and non-cash contributions by the Mem-
bers is as set forth in Table 2 of Attachment 1 hereto. 

b. The Members shall complete their initial capital contributions to the capital contributions to the LLC within 20

days of the date of this agreement

unless another date is agreed upon in writing by all the LLC Members. An Member who fails to make the required

initial capital contribution, as set forth in this paragraph shall indemnify all other Members of the LLC for any losses or
expenses (including reasonable attorneys fees) that are caused by the failure to make the initial capital contribution as
set forth herein.

Section 5.4. Additional Capital Contributions
Members may make additional capital contributions but shall not be required to do so.

Section 5.5. Raising Additional Capital
Additional capital may be raised by the LLC through sales of new LLC Units pursuant to an affirmative Supermajority

Vote of LLC Members, see Section 5.2 above. Any Member resolution authorizing the raising of additional capital
through the sale of LLC Units shall state, in reasonable detail, the purposes and uses of such additional capital and the
amounts of additional capital required.

Section 5.6. No Withdrawal Of Capital Contributions
Except upon the dissolution and liquidation of the LLC as set forth herein, no Member shall have the right to withdraw

its capital contributions. Furthermore, no interest shall be paid upon any member’s capital account.

Section 5.7. Maintenance of Capital Accounts
An individual capital account shall be maintained for each LLC Member consisting of the member’s capital contribu-

tions and (1) increased by that member’s share of LLC profits, (2) decreased by that member’s share of LLC losses, and
(3) further adjusted as required or allowed by the Internal Revenue Code (Title 26 of the United States Code) and / or
all published Treasury Regulations (Title 26 of the Code of Federal Regulations). In all cases, the capital accounts of the
members shall be accounted for in accordance with the Internal Revenue Code (Title 26 of the United States Code)
and or all published Treasury Regulations (Title 26 of the Code of Federal Regulations).

Art. VI. Allocations and distributions
Section 6.1. Allocations to Capital Accounts
Except as may be required by the Internal Revenue Code (Title 26 of the United States Code) or the Treasury Reg-

ulations (Title 26 of the Code of Federal Regulations) or this Operating Agreement, net profits, net losses, and other
items of income, gain, loss, deduction and credit of the LLC shall be allocated among the Members ratably in proportion
to each Member’s LLC Unit Percentage. For example, if a Member has an LLC Unit Percentage of 45%, he or she shall
be allocated 45% of all profits or losses (and other allocation items) for any given tax year.

a. Notwithstanding the foregoing, no item of loss or deduction of the LLC shall be allocated to a Member to the

extent such allocation would result in a negative balance in such Member’s capital account if other Members then have
positive balances in their capital accounts. Such loss or deduction shall be allocated first among the Members with pos-
itive balances in their capital accounts in proportion to (and to the extent of) such positive balances and thereafter to
Members in accordance with their Unit Percentages.

Section 6.2. Tax Allocations
In the case of any special tax allocations allowed under the Internal Revenue Code or Treasury Regulations, the meth-

od of allocation and formula determined by the Tax Matters Partner shall be followed so long as it complies with state
law, the Internal Revenue Code, the Treasury Regulations, and fairly treats each Member. The method of tax allocation
selected by the Tax Matters Partner shall be presumed to be «fair to all the members» and any Member or party chal-
lenging said allocation on these grounds shall bear the burden of proof.

Section 6.3. Distributions
The LLC Members, by resolution issued pursuant to this agreement, may make distributions to the Members from

time to time in amounts it deems appropriate; however, no distribution shall be declared or made if, after giving it effect,
the LLC would not be able to pay its debts as they become due in the usual course of business or the LLC’s total assets
would be less than the sum of its total liabilities.

Section 6.4. Family Partnership Savings Provision
Notwithstanding anything in this Operating Agreement to the contrary, should any provision of this Operating Agree-

ment, or any act of the parties, result in violation of the family partnership provisions of Internal Revenue Code Sec.

Member Name

Initial Capital Contribution

SC OVERSEAS MANAGEMENT LIMITED . . . . . . . . . . . 

USD 3,000,000

79121

704(e) (as amended) or the regulations and cases hereunder, the Members may amend this Agreement, or take any
other actions reasonably necessary to prevent or correct such violation.

Art. VII. Transfers of units; Withdrawal, Death, Removal of member
Section 7.1. Transfer of LLC Units
Members may freely sell, convey or otherwise transfer their LLC Units to other parties without restriction; however,

any transferee of a Members’ interest shall be required to agree to the terms of, and sign, this LLC operating agreement
before said transferee assumes the rights of a Member under this agreement.

Section 7.2. Withdrawal Of Member
a. Members shall have the unilateral right to resign or withdraw at any time from the LLC.
b. A Member is required to give thirty (30) days written notice to each of the other LLC Members to initiate a with-

drawal. In this notice, the withdrawing Member shall state an effective date for his or her withdraw and said date must
be at least thirty (30) days after delivery of notice to all other LLC members and be the last day of a month (i.e., the
30th or the 31st). Upon receipt of said notice, the remaining LLC members shall cause a reasonably prompt preparation
of financial statements for the LLC as of the effective date of withdrawal for said Member.

c. Upon withdrawal, the withdrawing Member shall receive, in exchange for his or her LLC Units, the Withdrawal

Compensation Amount to be paid within 1 Year of the effective date of the Member’s withdrawal.

d. The «Withdrawal Compensation Amount» is defined herein as 100% of the withdrawing member’s capital account.
Should the LLC fail to perform upon its obligations under this section to make payments to a withdrawing Member

when due, the LLC shall, in addition to any other remedies the withdrawing Member may possess, be liable to the with-
drawing Member for interest upon the amount of any deficiency at the rate of 10% per annum (compounded annually)
computed from the date that said deficient payment was due to the withdrawing Member under this agreement.

f. Upon withdrawal, the withdrawing Member shall have no continuing obligations to the LLC other than pursuant to

state law, this Agreement or other applicable laws or such obligations as expressly assumed by such Members.

g. A withdrawing Member shall retain the right to vote as an LLC member up until the effective date of his or her

withdrawal, at which time, the withdrawing Member’s LLC Units shall be considered transferred back to the LLC and
the person who has withdrawn shall no longer be considered a member of the LLC. If a withdrawing Member was also
a «manager» of the LLC, the withdrawing Member shall resign as a manager immediately upon giving notice of to the
other LLC members of his or her intent to withdraw.

Section 7.3. Death Of Member
a. Upon the death of a Member, the remaining LLC members shall cause a prompt preparation of financial statements

for the LLC as of the end of the month in which the Member died which shall be the effective date of death for the
deceased Member for accounting purposes under this agreement. For purposes of this section, if LLC Units are titled
in the name of a revocable trust, the trustee of said revocable trust shall be treated as the Member.

b. The estate of the deceased Member (or his revocable trust if the LLC Units were so titled) shall receive, in ex-

change for his or her LLC Units, the Death Compensation Amount to be paid within 2 years of the effective date of the
Member’s death. The payments shall be made in two equal instalments payable at the annual anniversary of the effective
date of death with no interest being neither due nor owing upon the outstanding amount.

c. The «Death Compensation Amount» is defined herein as an amount agreed upon between a majority in interest

of the remaining LLC members and the estate of the deceased Member (or his or her revocable trust should the LLC
Units been titled in its name) as the fair market value of the deceased Member’s LLC Units. Should the parties be unable
to agree upon a value for the deceased Member’s LLC Units, they shall file a declaratory judgment petition with a court
having jurisdiction where the LLC’s principal place of business is located and ask the court determine the fair market
value of the deceased Member’s LLC Units should the enterprise be sold on the open market, between a willing buyer
and a willing seller, in a commercially reasonable manner upon the effective date of death.

d. Should the LLC fail to perform upon its obligations under this section to make payments to a deceased Member’s

estate or revocable trust (as the case may be) when due, the LLC shall, in addition to any other remedies may possess,
be liable to the estate of the deceased Member (or his or her revocable trust, as the case may be) for interest upon the
amount of any deficiency at the rate of 10% per annum (compounded annually) computed from the date that said defi-
cient payment was due under this agreement.

e. Upon death, the estate of the deceased Member (or his or her revocable trust, as the case may be) shall have no

continuing obligations to the LLC other than pursuant to state law, this Agreement or other applicable laws or such
obligations as expressly assumed by said Member.

Section 7.4. Removal Of Member
a. A Member may be involuntarily removed from the LLC only under either of the following circumstances: (1) the

Member is required to provide services to the LLC (as reflected in Attachments to this agreement), said Member is not
substantially performing the promised services, and a Supermajority vote in interest of LLC Members for removal or
(2) the Member has defaulted upon its obligations under this agreement to make capital contributions (or loans) to the
LLC.

b. In the case of a removal for failure to perform required services, 60 days prior to any vote to remove, the other

LLC Members shall cause a notice to be issued to the Member in question stating that they shall bring to a vote of the
LLC Members a motion to remove said Member within 60 days for unsatisfactory performance of required services and
detail specific instances or tasks that were allegedly not satisfactorily performed. The other LLC Members shall then
give the Member in question a good faith opportunity to cure the deficiencies in performance of services prior to the
vote of removal. The period of this good faith opportunity to cure need not extend beyond 60 days. If the Member in

79122

question completes a cure within 60 days of receiving the aforementioned notice, then the motion pending before the
LLC Members for removal shall be withdrawn.

c. In the case of a removal for failure to make required capital contributions, 30 days prior to any vote to remove,

the other LLC Members shall cause a notice to be issued to the Member in question stating that they shall bring to a
vote of the LLC Members a motion to remove said Member within 30 days for non-payment of required capital contri-
butions. The Member in question shall then have 30 days within which to cure the default which shall consist of making
all required capital contributions plus 10% per annum interest (compounded annually) upon the amount of any deficiency
computed from the date said contribution was due to be made to the LLC. If the Member in question completes this
cure within 30,days of receiving the aforementioned notice, then the motion pending before the LLC Members for re-
moval shall be withdrawn and the Member in question shall, henceforth, be consider in good standing.

d. If, after complying with the above notice and cure provisions, an affirmative Supermajority vote in interest of LLC

Members is made to remove the Member in question, then, as of that moment, this person shall no longer be entitled
to exercise any rights, powers or privileges of a Member and his or her LLC Units shall be considered redeemed by the
LLC.

e. Upon the affirmative Supermajority vote in interest of LLC Members to remove a Member, the remaining LLC

members shall cause a prompt preparation of financial statements for the LLC as of the end of the month in which the
resolution was passed by the LLC Members removing said Member and this shall be the effective date of removal for
the Member for accounting purposes only under this agreement.

f. The removed Member shall receive in exchange for his or her LLC Units the Removal Compensation Amount to

be paid within 1 year of the effective date of the Member’s removal.

g. The «Removal Compensation Amount» is defined herein as 100% of the removed member’s capital account.
h. Should the LLC fail to perform upon its obligations under this section to make payments to a removed Member

when due, the LLC shall, in addition to any other remedies may possess, be liable to the removed Member for interest
upon the amount of any deficiency at the rate of 10% per annum (compounded annually) computed from the date that
said deficient payment was due under this agreement.

Art. VIII. Dissolution of the company
Section 8.1. Dissolution
The LLC shall be dissolved upon the occurrence of the following event (hereinafter, a «Liquidation Event»): a Super-

majority vote in interest by the LLC Members to dissolve the LLC. Despite any provision of state law to the contrary,
no other event - including (but not limited to) the withdrawal, removal, death, insolvency, liquidation, dissolution, ex-
pulsion, bankruptcy, or physical or mental incapacity of a Member - shall cause the existence of the LLC to terminate
or dissolve.

Section 8.2 Liquidation
a. Should a Liquidation Event occur, the LLC shall then be liquidated and its affairs shall be wound up - including prep-

aration of final financial statements and an accounting - by (or at the direction of) the LLC Members. All proceeds from
the liquidation shall be distributed in accordance with state law, and all LLC Units shall, thereafter, be cancelled. Distri-
butions to the Members shall be made in accordance, and proportion, with the Members’ relative Capital Account bal-
ances.

b. Final distributions to Members shall not be made until all liabilities have been satisfied and any contingent claims

against the LLC have been resolved.

c. Upon the completion of the liquidation and distribution of the LLC’s assets, the LLC shall be terminated and the

Managers shall cause the Company to execute and file d certificate of cancellation in accordance with state law.

Art. IX. Exculpation Of Liability: Indemnification
Section 9.1. Exculpation of Liability
Unless otherwise provide by law or expressly assumed, a person who is a Member or Manager, or both, shall not be

liable for the acts, debts or liabilities of the LLC to third-parties - i.e., persons other than the LLC or LLC Members.

Section 9.2.Indemnification
Except as otherwise provided in this Article, the LLC shall indemnify any Member or Manager (and may indemnify

any employee or agent) of the LLC who was or is a party or is threatened to be made a party to a potential, pending or
completed action, suit or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative, and whether formal or in-
formal, other than an action by or in the right of the LLC, by reason of the fact that such person is or was a Member,
Manager, employee or agent of the LLC. Indemnification shall be limited to expenses, including attorney’s fees, judg-
ments, penalties, fines, and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by such person in connection
with the action, suit or proceeding, if, and only if, the person acted in good faith, with the care an ordinary prudent
person in a like position would exercise under similar circumstances. For persons other than Members or Managers of
the LLC, indemnification shall only be made after an affirmative vote of a majority in interest of LLC Members.

Art. X. Miscellaneous
Section 10.1. Amendment of Operating Agreement
This Agreement may be amended by, and only by, a written resolution setting forth in detail the amendment and

signed by sufficient Members to reflect a Supermajority vote interest of LLC Members in favour of said amendment.

Section 10.2. Successors
This Agreement shall be binding as upon all successors in interest of the Members, which includes, but is not limited

to, executors, personal representatives, estates, trustees, heirs, beneficiaries, assignees, nominees, and creditors of the
Members.

79123

Section 10.3. Counterparts
This Agreement may be executed in several counterparts with the same effect as if the parties executing the several

counterparts had all executed one counterpart.

Section 10.4. Governing Law
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware. Each Mem-

ber, by signing this agreement, hereby submits to personal and subject matter jurisdiction in the State of Delaware of
any dispute between or among the Members, the LLC, and the LLC Managers connected to or regarding the business
of, or investment in, the LLC.

Section 10.5. Severability, Standard for Interpretation
If it shall be determined by a court or other competent body that any provision or wording of this Agreement shall

be invalid or unenforceable under state or other applicable law, such invalidity or unenforceability shall not invalidate
the entire Agreement. Whenever two or more interpretations of the provisions or wording of this Agreement shall be
possible, the interpretation or construction which leads to the enforcement and validity of any provision of this Agree-
ment shall be favored and deemed to be the intended interpretation of the parties to this Agreement.

ATTACHMENT

<i>Member Capital Contributions and required serivces

Table 1 - Required Capital Contributions 

Table 2 - Required services of members 

Witness whereof, the undersigned have duly executed this Operating Agreement as of the date first above written

as Members: 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR10035. – Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062477.5//406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

AMTEL HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.698. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 avril 2006

1. Le mandat des administrateurs:
a) Monsieur Sudhir Gupta, né le 11 avril 1958 en Inde, administrateur de sociétés, demeurant à Singapore, 38, Bel-

mont Road, ayant pouvoir de signature A;

b) Monsieur Pierre Metzler, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avocat à la Cour,

demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, ayant pouvoir de signature B;

c) Monsieur François Brouxel, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), avocat à la Cour, demeurant à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, ayant pouvoir de signature B;

d) Monsieur Daniel Gupta, né le 13 mai 1982 à Moscou (Russie), administrateur de sociétés, demeurant à Singapour,

38, Belmont Road, ayant pouvoir de signature A;

est renouvelé jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos

au 31 décembre 2006.

2. L’assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer la société AACO, S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 88.833,
commissaire aux comptes en remplacement de la société OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous
le numéro B 97.326 et ce jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comp-
tes clos au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR10039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065168.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Member Name

Contribution

 Cash Capital Contribution

 Contribution

SC OVERSEAS MANAGEMENT

LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

USD 3,000,000

USD 1,000,000

USD 2,000,000

Member Name

 Required Service 

Time

 Description of Services

SC OVERSEAS MANAGEMENT

LIMITED

 NO

General Supervision of the Company’s Business and Develop-
ment

SC OVERSEAS MANAGEMENT LIMITED
Signatures
<i>Member / Manager 

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Signature.

79124

FAM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.491. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09258, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(063682.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

UBP MULTIFUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.602. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration prise par voie circulaire avec effet au 20 juin 2006

- Monsieur André Gigon est désigné Président du Conseil d’Administration avec effet au 20 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063687.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

UBP MULTIFUNDS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.691. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration prise par voie circulaire avec effet au 20 juin 2006

- Monsieur André Gigon est désigné Président du Conseil d’Administration avec effet au 20 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063689.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

BANK OF CHINA LTD, BANK OF CHINA LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG,

Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.755. 

Madame Zhou Lihong devient au même titre que M. Tang Maoheng et Monsieur Zhang Wei, le troisième membre

de la Direction ayant le pouvoir de signer tout seul tous les documents de BANK OF CHINA LIMITED, SUCCURSALE
DE LUXEMBOURG, conformément à l’accord de la CSSF du 3 novembre 2006.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01935. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064585.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FAM FUND
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Le Conseil d’Administration
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

<i>Pour BANK OF CHINA LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
M. Tang 
<i>Directeur Général Exécutif

79125

RENASCENCE MC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 81.596. 

Le bilan au 31 décembre 2003 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

29 juin 2006, réf. LSO-BR09267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

(063887.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

RENASCENCE MC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 81.596. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

29 juin 2006, réf. LSO-BR09271, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

(063891.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO VI ZETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 117.443. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

SIREO IMMOBILIENFONDS No. 5 LIBERO VI, S.à r.l., a company incorporated and organised under the laws of

Luxembourg with its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, represented by Mr Jean-Claude
Michels, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on June 27, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of SIREO IMMOBILIENFONDS No. 5

LIBERO VI ZETA, S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter
the «Articles»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The

board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory regis-
tered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of
managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 3. Corporate Objectives. The Company’s object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in

other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

79126

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease

of real estate as well as of rights equivalent to real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well
as for any other operations relating to real estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings
in companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg
or abroad, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of
real estate, including real estate located abroad.

The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a
«Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any
of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of
Luxembourg Law; it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to
be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies, as amended from time to time.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), repre-

sented by hundred twenty-five (125) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where

there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets

and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is

admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely

transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of

the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company’s unit capital.

Chapter III.- Management

Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The man-

agers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

email or letter another manager as his proxy.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating man-

ager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each
participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members

of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail,
telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers’ meetings,
physically held.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is con-

firmed in writing.

Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

79127

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agree-
ments and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any member of

the board of managers.

Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate

his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any),

the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at

a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Liabilities of the Manager. The members of the board of managers assume, by reason of their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Chapter IV.- General Meeting of Unitholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred

to the general unitholders’ meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal

representative(s) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the

unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning
at least three-quarters of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business year, Balance sheet

Art. 17. Business Year. The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of

each year.

At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and bal-

ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual ac-

counts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to
five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten
per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders. 

Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31st De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

All the hundred twenty-five (125) units representing the entire capital have been entirely subscribed by SIREO

IMMOBILIENFONDS No. 5 LIBERO VI, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given
to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about euro.

79128

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined period:
a. Mr Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Luxembourg;
b. Mr Detlef Niezgodka, Senior Consultant, SIREO, D-50259 Pulheim, Germany; 
c. Dr. Bernd Wieberneit, Executive Director, SIREO REAL ESTATE, GmbH, D-63150 Heusenstamm, Germany;
d. Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Senior Consultant, SIREO, D-61476 Kronberg, Germany;
e. Mr Jost-Albrecht Nies, Head of Institutional Clients, SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l., 4, rue

Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Luxembourg,

f. Dr. Rolf Sutter, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, The Netherlands.
In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of any member of the

board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg is appointed as auditor

of the Company for an undetermined period of time.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SIREO IMMOBILIENFONDS No. 5 LIBERO VI, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au

4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

représentée par Monsieur Jean-Claude Michels, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé le 27 juin 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomi-

nation de SIREO IMMOBILIENFONDS No. 5 LIBERO VI ZETA, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle
entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil de gérance est

autorisé à transférer le siège de la Société à l’intérieur de la Ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant de la même manière que pour une modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce

soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie entre autres de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société peut également utiliser ses fonds en vue de l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la ges-

tion et/ou la location de biens immobiliers ainsi que de droits assimilés aux biens immobiliers au Grand-Duché du
Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toutes autres opérations ayant trait à l’immobilier. En particulier, la Société peut
détenir directement ou indirectement des actions dans des sociétés et des participations dans des sociétés à responsa-
bilité limitée (limited partnership) ou toutes autres entités juridiques quelle que soit leur forme et basés soit
Luxembourg ou à l’étranger ayant pour objet principal l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion
et/ou la location de biens immobiliers, y compris de biens immobiliers situés à l’étranger.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la So-

79129

ciété, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et
chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme
contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d’apporter tou-
te assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’effectuera aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières telle que modifiée de temps à
autre.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq

cent vingt (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Modification du Capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique

(quand il y a un seul associé) ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 16
des présents Statuts.

Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs

et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 9. Transfert des parts. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Chaque associé s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu’il détient sans le consen-

tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Chapitre III.- Gérance

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois membres. Les gérants

ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par
une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une lettre.

L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et ap-

prouvées par écrit par tous les membres du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plu-
sieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même
validité que des décisions votées lors d’une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.

Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail, télé-

gramme ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom

de la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l’objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, en particulier, conclure des contrats de conseil en
investissement et des contrats d’administration, par exemple des real estate agent’s agreements et des property mana-
gement agreements.

Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature d’un des mem-

bres du conseil de gérance.

79130

Art. 13. Sub-délégation et Agent du Gérant. Tout membre du conseil de gérance, peut subdéléguer une partie

de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout membre du conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces

agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés posté-

rieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 15. Responsabilités du Gérant. Les membres du conseil de gérance ne contractent en raison de leur fonc-

tion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés 

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale de l’Associé (des Associés). L’associé unique exerce tous pou-

voirs qui sont conférés à l’assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas né-

cessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite,
par fax, câble, télégramme ou par e-mail.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être
adoptés que par une majorité d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pres-
criptions de la Loi.

Chapitre V.- Exercice social, Comptes annuels

Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un

inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes

annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net,
il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%)
du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits

civils, d’insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l’un des associés.

Art. 20. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en prenant personnellement

en charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par SIREO

IMMOBILIENFONDS No. 5 LIBERO VI, S.à r.l., prénommée, et intégralement libérées par des versements en numérai-
re, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de
la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Monsieur Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Luxembourg;
- Monsieur Detlef Niezgodka, Senior Consultant, SIREO, D-50259 Pulheim, Allemagne;
- Dr. Bernd Wieberneit, Executive Director, SIREO REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT, GmbH, D-63150

Heusenstamm, Allemagne;

- Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Senior Consultant, SIREO, D-61476 Kronberg, Allemagne;

79131

- Monsieur Jost-Albrecht Nies, Head of Institutional Clients, SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l., 4,

rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Luxembourg,

- Dr. Rolf Sutter, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, Pays-Bas.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d’un des membres du

conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg est désignée comme

étant réviseur d’entreprises de la Société pour une période illimitée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J.C. Michels, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2006, vol. 905, fol. 28, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065868.3/239/363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SON GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers.

R. C. Luxembourg B 82.124. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063899.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

GLOBAL ENERGY INVEST COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.468. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1

er

 juin 2006 que:

<i>Délibérations

L’assemblée transfère le siège social de la société au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
L’assemblée prend acte de la démission de la société EUROFID, S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg de ses fonctions de commissaire aux comptes et nomme la société ELITIUS &amp; ASSOCIES S.A. avec
siège social au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme
allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2007.

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Waldemar Kluch, directeur de société, demeurant à D-22946

Brunsbeck (Allemange), Im Dorfe 11, de son mandat d’administrateur et nomme Monsieur Dominique Verhaegen, di-
recteur de société, demeurant à B-6900 Humain, château de Humain, ainsi que Monsieur Yuriy Tekhnikov, directeur de
société, demeurant au 28/2 Zoologicheskaya St. RU-123056 Moscou (Russie) aux fonctions d’administrateurs pour un
terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2011.

L’Assemblée renouvelle les mandats de Monsieur Andrew Shmakov, directeur de société, demeurant professionnel-

lement au 28/2 Zoologicheskaya St. RU-123056 Moscou (Russie), ainsi que de Madame Kira Loukianova, directrice de
société, demeurant professionnellement au 28/2 Zoologicheskaya St. RU-123056 Moscou (Russie), aux fonctions d’ad-
ministrateurs pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2011.

Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00738. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064988.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Belvaux, le 3 juillet 2006.

J.-J. Wagner.

SON GROUP S.A.
Signature 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

79132

RENASCENCE MC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 81.596. 

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

29 juin 2006, réf. LSO-BR09263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

(063915.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ARTEN SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 90.288. 

Les états financiers au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08082, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063953.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

FORUM FILM CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 70.606. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09147, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

(064109.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

NEWGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 93.808. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 mai 2006 tenue au siège de la société

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Olivier Thonnard de son poste d’administrateur

et décide de nommer en son remplacement par cooptation, Madame Handan Yilmaz, administratrice de sociétés, née à
Inegol (Turquie), le 7 juin 1960, demeurant à Kaptanpasa Sokak, n

°

 32/A, TR-06700 Ankara, Turquie, en tant que nou-

velle administratrice de la société.

Cette nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

<i>Seconde résolution

Le Conseil d’administration décide de nommer Madame Handan Yilmaz, prénommée, à la fonction d’administratrice-

déléguée, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Le mandat de l’administratrice et de l’administatrice-déléguée nouvellement nommées expire à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065253.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Signatures.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

79133

TMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.

R. C. Luxembourg B 58.578. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09320, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064472.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ALIAS INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.732. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01200, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064506.6//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

PEMIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 111.931. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00646, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064521.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

MAVEJA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 11, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 117.470. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trente et un mai.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Marcel Feiereisen, programmeur, demeurant à L-4140 Esch-sur-Alzette, 11, rue Victor Hugo.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet la vente et la maintenance de software avec l’achat et la vente des articles de la bran-

che.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires,

entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le dé-
veloppement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de MAVEJA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

<i>Pour ALIAS INVESTMENT
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and Domiciliary agent
Signatures

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

79134

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent parts sociales (100)

de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. L’associé reconnaît que le capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré

par un apport en nature de même montant ainsi que le constate l’état du matériel dont l’estimation a été faite par le
futur associé sous son unique responsabilité, lequel état après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé, de sorte que le montant de douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2006.

<i>Frais

L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ huit cent soixante-dix euros
(EUR 870,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Marcel Feiereisen, prédit.
2.- La société est gérée par l’associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-4140 Esch-sur-Alzette, 11, rue Victor Hugo.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Feiereisen, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2006, vol. 918, fol. 29, case 3. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(066649.3/203/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2006.

A. Biel.

79135

F. ACKERMANN OPTIQUE (OPTIQUE CENTRE BOURSE) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.044. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08273, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

(064592.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

SURREY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 117.488. 

STATUTES

In the year two thousand six on the ninth day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-

istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,

here represented by Mr Gautier Rochez, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 8, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name SURREY EUROPE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

<i>Pour F. ACKERMANN OPTIQUE (OPTIQUE CENTRE BOURSE) S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

79136

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

79137

3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2006.

<i>Subscription - Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, QUEBEC NOMI-

NEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contri-
bution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Gautier Rochez, lawyer, born at Haine-Saint-Paul (Belgium) on April 1, 1976, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg;

- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

2) The adress of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est

établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,

ici représentée par Monsieur Gautier Rochez, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 8 juin 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

79138

Art. 4. La Société aura la dénomination: SURREY EUROPE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, Le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-

tés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

79139

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme

dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Gautier Rochez, juriste, né à Haine-Saint-Paul (Belgique) le 1

er

 avril 1976, avec adresse au 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 septembre 1969, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg. 

2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, et après lecture faite et interprétation donnée

au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Rochez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 85, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067249.3/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

G. Lecuit.

79140

LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.527. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2006

Il résulte de l’Assemblée Générale tenue le 28 juin 2006 que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la situation du siège social de la prédite société en le fixant à L-1371 Luxem-

bourg, 31, Val Sainte Croix.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide d’accepter la démission de ses fonctions d’administrateur-délégué

de:

- Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte

Croix.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de révoquer:
- la société FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
de sa fonction de Commissaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouveau commissaire

aux comptes:

- La société de droit luxembourgeois dénommée FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l., avec siège

social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

Le 28 juin 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065129.3/1091/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.765. 

<i>Conseil d’Administration: 

Claude Beffort, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
Christian Tailleur, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
Danielle Buche, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
Frédérique Duculot, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Claude Beffort, Christian Tailleur, Danielle Buche et Frédérique Duculot (les Administrateurs) sont renommés pour

une période se terminant lors de l’Assemblée Générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2006. 

<i>Commissaire aux comptes: 

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., domiciliée au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (le Commissaire aux comptes) est renommée pour une période se termi-

nant lors de l’Assemblée Générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065161.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.765. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09332, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065170.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 juin 2006.

Signature.

79141

EDGE CORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 94.331. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 mai 2006 tenue au siège de la société

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Olivier Thonnard de son poste d’administrateur

et décide de nommer en son remplacement par cooptation, Madame Handan Yilmaz, administratrice de sociétés, née à
Inegol (Turquie), le 7 juin 1960, demeurant à Kaptanpasa Sokak, n

°

 32/A, TR-06700 Ankara, Turquie, en tant que nou-

velle administratrice de la société.

Cette nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

<i>Seconde résolution

Le Conseil d’administration décide de nommer Madame Handan Yilmaz, prénommée, à la fonction d’administratrice-

déléguée, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Le mandat de l’administratrice et de l’administatrice-déléguée nouvellement nommées expire à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065266.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

MULTI INVESTMENT MANAGEMENT CENTRAL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AM INVESTMENTS MANAGEMENT CENTRAL EUROPE, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.065. 

In the year two thousand and six, on the ninth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

for an extraordinary general meeting of the shareholders of AM INVESTMENTS MANAGEMENT CENTRAL EU-

ROPE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered of-
fice at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul
Frieders, notary public residing in Luxembourg, on March 11, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number C 775 dated August 3, 2005 (the Company).

AM INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg
trade and companies register, under the number B 106.996, here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 8, 2006.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. AM INVESTMENTS, S.à r.l. is the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder);
II. The Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into one

hundred (100) shares of one hundred twenty-five Euro (EUR 125) each;

III. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Change of the Company’s name;
2. Amendment of article 1 of the articles of association of the Company to reflect the above change; and
3. Miscellaneous.
IV. The Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name into MULTI INVESTMENT MANAGEMENT CEN-

TRAL EUROPE, S.à r.l.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the articles of association of the Company, which shall hence-

forth read as follows:

«There exists private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MULTI INVEST-

MENT MANAGEMENT CENTRAL EUROPE, S.à r.l. (hereafter the Company), which is governed by the laws of Lux-

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

79142

embourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as
well as by the present articles of association (hereafter the Articles).».

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, Luxembourg on the day named at the beginning of the

deed.

The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, the proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

pour une assemblée générale extraordinaire des associés de AM INVESTMENTS MANAGEMENT CENTRAL EU-

ROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 11 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C 775 daté
du 3 août 2005 (la Société).

AM INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.996.

Ici représentée par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 8 juin 2006.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. AM INVESTMENTS, S.à r.l. est le seul associé de la Société (l’Associé Unique);
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé en cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune;

III. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société;
2. Modification de l’article 1

er

 des statuts de la Société pour refléter le changement susmentionné; et

3. Divers.
IV. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en MULTI INVESTMENT MANAGEMENT

CENTRAL EUROPE, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société qui se lira désormais de la manière suivante:

«Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination MULTI INVESTMENT MANAGEMENT CEN-

TRAL EUROPE, S.à r.l. (la Société), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juin 2006, vol. 437, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065699.3/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Mersch, le 26 juin 2006.

H. Hellinckx.

79143

TR MARKETING &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 112.042. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 juin 2006

<i>Résolutions

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité, de donner un pouvoir de signature individuel, à durée indéterminée,

à Monsieur Tekin Seydi, domicilié à B-3582 Beringen, 13 Stationsstraat, afin d’engager la société à l’égard des tiers.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09608. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065279.5//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

TR MARKETING &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 112.042. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 juin 2006

<i>Résolution

L’assemblée décide de nommer comme directeur, à partir du 27 juin 2006, Monsieur Tekin Seydi, domicilié à B-3582

Beringen, 13 Stationsstraat, à qui elle va déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion, pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09584. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065279.4//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ACHMEA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 37.290. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 11 avril 2006

Le conseil d’administration a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 12 avril 2006 à l’adresse

suivante: 1A, rue du Nord, L-2229 Luxembourg.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 25 avril 2006

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de renouveler le mandat des personnes suivantes en tant

qu’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2007:

- Monsieur A. Walravens, demeurant au 130, Oude Delft, 2611 CG Delft, Pays-Bas;
- Monsieur W. Van Duin, demeurant au 112, Amsteldijk Zuid, 1188 VJ Amstelveen, Pays-Bas;
- Monsieur R. Burgerhout, demeurant au 926, Prins Willem Alexanderlaan, 7300 HC Apeldoorn, Pays-Bas;
- Monsieur P. Mousel, demeurant à rue de Dippacn, L-8055 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur A. Lugtigheid, demeurant au 1, Marinaweg, NL-1361 AE Almere, Pays-Bas; 
et de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur:
- Monsieur Hubertus Anna Johannes Hannen, demeurant au 651, Prins Willem-Alexanderlaan, 7300 Apeldoorn, Pays-

Bas.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de renouveler le mandat de réviseur d’entreprises de

KPMG, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065412.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

MAYA INVEST LIMITED / ALPHA ACCOUNTING AG / PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED
Signature / Signature / Signature

L. Voet / M. Cady / M. Keersmaekers
Président / Secrétaire / Scrutatrice

<i>Pour ACHMEA REINSURANCE S.A.
Signature

79144

ANDANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.948. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 15 mai 2006 à 14 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Gabriel Jean, juriste, demeurant professionnellement

au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange, et des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. établies
au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL

LTD, avec siège social au 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 15 mai 2006 à 15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la so-

ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065416.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

FOOD AND BULK LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 82.398. 

L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son confrère

empêché Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FOOD AND BULK LOGISTICS S.A.,

une société anonyme avec siège social à L-2550 Luxembourg, 52, avenue du X Septembre constituée suivant acte reçu
par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, le 23 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1160 du 13 décembre 2001 et modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois
suivant acte reçu par le même notaire en date du 7 octobre 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1732 du 4 décembre 2002.

L’assemblée est ouverte à 16.05 heures sous la présidence de Madame Zamyra Cammans, manager, demeurant

professionnellement à L-2550 Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Preeti Khitri, employée privée,
demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Petra Dunselman, administratrice de sociétés, demeurant profession-

nellement à L-2250 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée à pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Avancement de l’assemblée générale annuelle du deuxième lundi du mois de juillet au premier mardi du mois de

juin à 11.00 heures.

2.- Modification de l’article 12 des statuts.
3.- Suppression du deuxième paragraphe de l’article 13 des statuts concernant les mesures transitoires.
4- Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur à été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

<i>Pour ANDANTE S.A.
Signature

79145

L’assemblée générale après délibération, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’avancer l’assemblée générale annuelle du deuxième lundi du mois de juillet au premier

mardi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2007.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de l’avancement de l’assemblée générale annuelle le premier alinéa de l’article 12 des statuts est

modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tient au siège social de la société, ou à tout autre endroit

au Luxembourg qui est fixé dans l’avis de convocation, le lier mardi du mois de juin à 11.00 heures.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer le deuxième paragraphe de l’article 13 concernant les mesures transitoi-

res.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.10 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des compa-

rants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure; ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the twenty second day of June.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Paul Decker,

notary, residing in Luxembourg-Eich, who shall remain depositary of the present deed. 

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of FOOD AND BULK LOGISTICS S.A., a société

anonyme, having its registered office at L-2550 Luxembourg, 52, avenue du X Septembre incorporated by a deed of
Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange on May 23rd, 2001 published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1160 on December 13th, 2001, modified several occasions and for the last time by a
deed received by the same notary on October 7th, 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1732 on December 4th, 2002.

The meeting is called to order at 4.05 p.m. by Mrs Zamyra Cammans, manager, residing professionally in L-2250

Luxembourg, who acts as the Chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary to the meeting Mrs Preeti Khitri, private employee, residing professionally in

L-2550 Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Petra Dunselman, director of companies, residing professionally in L-2550

Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Advance the date of the annual general meeting from the second Monday in July on the first Tuesday in June on

11.00 a.m.

2.- Amendment of Article 12 of the articles of incorporation.
3.- Delete the second paragraph of article 13 of the articles of incorporation regarding the transitory disposition.
4.- Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

III. That it appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital are represented at

the meeting. All the shareholders represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior
to this meeting, so that no convening notices were necessary. 

IV. That the present meeting representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the Items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions.

<i>First resolution

The general meeting resolves to advance the date of the annual extraordinary meeting from the second Monday in

July to the first Tuesday in June on 11.00 a.m. and for the first time in 2007.

79146

<i>Second resolution

Consequently, article 13 of the articles of incorporation will from now on read as follows:

«Art. 13. The annual general meeting of the shareholders will be held at least once a year on the first Tuesday of

the month of June at 11.00 a.m.»

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to delete the second paragraph of article 13 of the articles of incorporation regarding

the transitory dispositions.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was adjourned at 4.10 p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded In French followed by a English version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English and the French text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Signé: Z. Cammans, P. Khitri, P. Dunselman, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, vol. 28CS, fol. 93, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(065034.2/206/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FOOD AND BULK LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 82.398. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg-Eich, le 3 juillet 2006.

(065035.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

CEDAR LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 105.320. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire

<i> en date du 27 avril 2006

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires accepte la démission de la société MEESPIERSON INTERTRUST LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg de sa fonction de commissaire avec
effet au 1

er

 avril 2006.

L’Assemblée Générale des actionnaires décide de nommer, avec effet au 1

er

 avril 2006, la société HRT REVISION,

S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg à la fonction de commissaire. Le commissaire nommé
poursuivra le mandat du commissaire sortant.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires décide de procéder au renouvellement du mandat de commissaire de la so-

ciété HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de la tenue de l’Assemblée Générale des Actionnaires ayant pour ordre du jour l’approbation des comptes
clôturés au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02300. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065343.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Luxembourg-Eich, le 30 juin 2006.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

<i>Pour CEDAR LOGISTICS S.A.
B. Verhaeghe
<i>Administateur

79147

WINTERSPORT INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 51.942. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

(065378.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

TIS-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.484. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00945, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

(065379.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SIV-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.483. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00953, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

(065380.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

TIMARU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.983. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2006

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Martine Philippe, avec adresse privée au 17, rue Raoul

Follereau, L-8027 Strassen, Monsieur Bernard Ewen, avec adresse privée au 17, rue Raoul Follereau, L-8027 Strassen,
et la société LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., ayant son siège social au 824, Market Street, Suite 720,
DE-19801 Wilmington - Etat du Delaware (U.S.A.), ainsi que celui du commissaire aux comptes, Madame Joëlle Lietz,
avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2008. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 26 juin 2006

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Madame Martine Philippe, avec adresse privée au

17, rue Raoul Follereau, L-8027 Strassen, et Monsieur Bernard Ewen, avec adresse privée au 17, rue Raoul Follereau,
L-8027 Strassen, administrateurs-délégués, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire sta-
tuant sur les comptes de l’exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09333. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065305.3/506/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

79148

MAVICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.476. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00968, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

(065383.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

MAVICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.476. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00970, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

(065384.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SCIP-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place d’Argent.

R. C. Luxembourg B 43.481. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00957, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

(065381.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

TIT-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.485. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00964, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

(065382.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 38.117. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09659, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

(065387.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

79149

M.C.I. MARKETING COMMUNICATION INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 39.426. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00326, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065391.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 42.729. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00339, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065392.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

BISCAROSSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5680 Dalheim, 6, Wénkelhiel.

R. C. Luxembourg B 98.972. 

L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BISCAROSSE S.A., avec siège

social à L-5680 Dalheim, 6, Wénkelhiel, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à
Luxembourg, en date du 29 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 327
du 23 mars 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
98.972.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Ries, employé privé, demeurant à Dalheim,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jeannine Ries-Fonck, sans état particulier, demeurant à Dalheim.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Modification de l’article treize des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-

lution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article treize des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Ries, B. Bartolovic, J. Fonck, E. Schlesser.

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

Signature.

79150

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, vol. 28CS, fol. 95, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(065703.2/227/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

BISCAROSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5680 Dalheim, 6, Wénkelhiel.

R. C. Luxembourg B 98.972. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7

juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065704.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

ISKANDER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 85.109. 

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de ISKANDER LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 85.109, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2001, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 561 du 11 avril 2002.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences écono-

miques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent (100) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Constatation de la libération intégrale du capital souscrit de la Société suite à la réception par la Société d’un mon-

tant de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (EUR 23.250,-) en règlement des soixante-quinze pour cent (75%)
du montant jusqu’à présent non libéré de son capital souscrit.

2) Réduction de la valeur nominale des actions de EUR 100,- à EUR 1,25 et augmentation correspondante du nombre

des actions de 310 à 24.800.

3) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
4) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La Société ayant reçu un montant de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (EUR 23.250,-) en paiement de

soixante-quinze pour cent (75%) de son capital souscrit, le capital souscrit de la Société d’un montant total de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve intégralement libéré.

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est réduite de EUR 100,- à EUR 1,25 et le nombre des actions est augmenté en con-

séquence de 310 à 24.800.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par vingt-quatre

mille huit cents (24.800) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.»

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

E. Schlesser.

79151

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Schill, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, vol. 28CS, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066272.2/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

ISKANDER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 85.109. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 836 du 13 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 10 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066274.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

MESSINA PAOLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange, route de Mondercange.

R. C. Luxembourg B 32.328. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00661, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

MAJENTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.599. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 18 mai 2006 à 14 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Gabriel Jean, juriste, demeurant professionnellement

au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange, Monsieur Peter Vansant, demeurant professionnellement au 28,
Côte d’Eich, L-1450 Howald et de la société KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2012.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL

LTD, avec siège social au 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange et Monsieur Peter Vansant de-
meurant professionnellement au 28, Côte d’Eich, L-1450 Howald.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 18 mai 2006 à 15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Messieurs Gabriel Jean et Peter Vansant ont été élus aux fonctions d’Administra-

teur-délégué de la société; ils auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065400.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Signature.

<i>Pour MAJENTEL S.A.
Signature

79152

EXPERTA MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.063. 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 27 avril 2006 a renouvelé à la fonction

d’administrateur pour une période d’un an, Messieurs:

- Hanspeter Oes, DEXIA PRIVATBANK (Schweiz), 48, Beethovenstrasse, CH-8039 Zürich;
- Rolf Tresch, DEXIA PRIVATBANK (Schweiz), 48, Beethovenstrasse, CH-8039 Zürich;
- Christian Assel, DEXIA PRIVATBANK (Schweiz), 48, Beethovenstrasse, CH-8039 Zürich;
a pris note du non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur: 
- Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch L-1470 Luxembourg;
a nommé à la fonction d’administrateur Madame:
- Annemarie Arens, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison L-1445 Strassen;
a nommé à la fonction de Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, 400, route d’Esch L-1014

Luxembourg pour une période d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065328.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

JACK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 80.197. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 15 mai 2006 à 18 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Guy Hardy, administrateur de sociétés,

demeurant 91, rue de la Carrière, B-4600 Visé, Monsieur Marc Libert, mécanicien, demeurant 49, rue du Roi Albert I

er

,

B-4680 Oupeye et Monsieur Antoine Louwart, comptable, demeurant 59/7, quai du Roi Albert, B-4020 Liège, a été re-
nouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société LUXOR AUDIT,

S.à r.l., ayant son siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Guy Hardy, administrateur
de sociétés, demeurant 91, rue de la Carrière, B-4600 Visé et Monsieur Marc Libert, mécanicien, demeurant 49, rue du
Roi Albert I

er

, B-4680 Oupeye.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 15 mai 2006 à 19 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Messieurs Guy Hardy et Marc Libert ont été élus aux fonctions d’Administrateur-

délégué de la société; ils auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature.

Luxembourg, le 15 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065396.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

<i>Pour EXPERTA MANAGEMENT A.G., Société Anonyme
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour JACK INVEST S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Credit Suisse Euro Bond Express Management Company S.A.

LMC Group S.A., Luxembourg Management Company Group

FA.PI S.A.

Beca, S.à r.l.

C&amp;S Holding S.A.

Ampus S.A.

Rono S.A.

Rono S.A.

Oasis Holding S.A.

Qstar Technologies S.A.

International Society Marken Consultance (ISOM) S.A.

International Society Marken Consultance (ISOM) S.A.

Personal Properties S.A.

HQ Portfolio

Thermic Investments S.A.

DIT Luxembourg 2, S.à r.l.

Novara Aquilone Sicav

United Holding S.A.

Sandalfin S.A.

Crowntek Systems Luxembourg

Crowntek Systems Luxembourg

Amtel Holdings Luxembourg S.A.

FAM Fund

UBP Multifunds

UBP Multifunds II

Bank of China Ltd, Bank of China Limited, Succursale de Luxembourg

Renascence MC S.A.

Renascence MC S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero VI Zeta, S.à r.l.

Son Group S.A.

Global Energy Invest Company

Renascence MC S.A.

Arten Sicav

Forum Film Corp. S.A.

Newgate Holding S.A.

TMS S.A.

Alias Investment

Pemik S.A.

Maveja, S.à r.l.

F. Ackermann Optique (Optique Centre Bourse) S.A.

Surrey Europe, S.à r.l.

Le Comitium International S.A.

Victoria Management Services S.A.

Victoria Management Services S.A.

Edge Core Holding S.A.

Multi Investment Management Central Europe, S.à r.l.

TR Marketing &amp; Consulting S.A.

TR Marketing &amp; Consulting S.A.

Achmea Reinsurance S.A.

Andante S.A.

Food and Bulk Logistics S.A.

Food and Bulk Logistics S.A.

Cedar Logistics S.A.

Wintersport Investments Holding S.A.

Tis-Holding

Siv-Holding

Timaru S.A.

Mavica Investments S.A.

Mavica Investments S.A.

Scip-Holding S.A.

Tit-Holding

Estalux S.A.

M.C.I. Marketing Communication International, S.à r.l.

Financial Fleurus Holding S.A.

Biscarosse S.A.

Biscarosse S.A.

Iskander Luxembourg S.A.

Iskander Luxembourg S.A.

Messina Paolo, S.à r.l.

Majentel S.A.

Experta Management A.G.

Jack Invest S.A.