logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

78673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1640

30 août 2006

S O M M A I R E

SHERPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8398 Roodt-Eisch.

R. C. Luxembourg B 22.276. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf. LSO-BP00790, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064665.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Abowijs International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

78688

Hultet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78701

Aesha S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78688

Hurtigruta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78690

API Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

78674

Koch  Chemical  Technology  Group  SCS,  Dude-

Auchan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

78685

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78720

Auchan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

78685

Koch  Chemical  Technology  Group  SCS,  Dude-

Azur International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

78696

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78720

Balspeed Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78689

Matrix  German  Portfolio  No.  1  Frankfurt  S.A., 

Benchley Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .

78687

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78674

Caza Immo S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78684

MC Holding Participation S.A., Luxembourg  . . . . 

78684

Codemalux S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78689

Orlan Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

78690

Conventum   Asset   Management   S.A.,   Luxem-

Particom Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

78686

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78683

Philippe   Location   et   Services,   S.à r.l.,   Luxem-

Dashabo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78686

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78683

Doranda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78683

Pusan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78687

Emerald Advisory Services and Equity Investments 

Romada.Fi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78688

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78702

Sherpa S.A., Roodt-Eisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78673

Emerald Advisory Services and Equity Investments 

Sicris Immobilier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

78684

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78704

Sicris Immobilier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

78684

Euroinvest (Czech 1), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

78686

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero I Alpha, S.à r.l.,

Euroinvest (Hungary 1), S.à r.l., Luxembourg. . . . .

78687

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78704

Euroinvest (Czech 3), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

78687

Sireo  Immobilienfonds  No.  5  Libero  VI,  S.à r.l., 

European   Advisors   of   Transport   S.A.,   Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78710

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78685

Société pour le Transport International de Conte-

Hams Hall Birmingham DC2, S.à r.l., Munsbach  . .

78689

neurs, S.à r.l., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78687

Hams   Hall   Birmingham   Nominee,   S.à r.l., Muns-

Soludec Development, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

78682

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78688

West Avenue Coventry DC7, S.à r.l., Munsbach. . 

78690

HMTF CPD Canada Luxco, S.à r.l., Luxembourg . .

78716

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

78674

API IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 113.239. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00212, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 117.358. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the nineteenth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1) MATRIX GERMAN PORTOFOLIO NO. 1 HOLDCO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited

liability company), incorporated and governed under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boul-
evard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registrar of Companies under number B
112.074; and

2) Mr Robert J. H. Randall, professionally residing at One Jermyn Street, London, SW1Y 4UH, United Kingdom.
Each of them here represented by Mr Hille-Paul Schut, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies un-

der private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a public limited liability company (société anonyme), which they form between themselves:

Art. 1. Form - Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Company in the form of a société anonyme, under the name of MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1
FRANKFURT S.A., which will be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(hereafter the «Law») as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind
(including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of
its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

3.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type

of equity or debt instruments (convertible or not).

3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies

under a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting
of any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any oper-
ation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.4. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance,

whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of
the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company
and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest, or any director, manager
or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provi-
sion.

3.5. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

relating directly or indirectly to real estate or movable property.

3.6. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office of the Company

may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors. Branches or other offices may
be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

Luxembourg, le 30 juin 2006.

Signature.

78675

4.2. If the Board of Directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which

are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with
abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely
returned to normal. Such measures will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such provisional
transfer of the registered office, if any, remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital - Authorised capital - Shares and share certificates
5.1. Capital
The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 24,800 (twenty-

four thousand eight hundred) shares, all with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) per share.

5.2. Share premium
Each share can be issued subject to the payment of a share premium (hereinafter the «Share Premium»). The Share

Premium shall be allocated to a reserve (hereinafter the «Share Premium Reserve») which is available for any type of
distribution or for the payment of costs. 

5.3. Authorised Capital
5.3.1. Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at EUR 120,000.-

(one hundred and twenty thousand Euro) to be divided into 96,000 (ninety-six thousand) shares all with a par value of
EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) per share.

5.3.2. The Board of Directors is authorised, during a period of five years, ending on 19 May 2011, to issue convertible

debt instruments and/or to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the authorised cap-
ital, following the conversion of the debt or equity instruments as applicable, up to a total amount of EUR 120,000 (one
hundred and twenty thousand Euro). Such increased amount of capital may be subscribed to and issued by with or with-
out an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine.

5.3.3. The Board of Directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving for the existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares so issued.

5.3.4. Further, the Board of Directors is authorised and empowered to carry out any increase of the capital within

the limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind, by
conversion of claims, integration of reserved profits or any other manner and to determine the place and date of the
issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new
shares.

5.3.5. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any

other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part
or all of such increased amount of capital.

Upon cash increase of the share capital of the Company by the Board of Directors within the limits of the authorised

share capital, the amount of the authorised share capital specified in Article 5.3.1 of the Articles shall be deemed to be
decreased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in Articles 5.1 and
5.3.1 of the Articles will be amended accordingly pursuant to each notarial deed recording the relevant increase of the
share capital under Article 5.3 of the Articles.

5.4. Shares
5.4.1. The Shares shall be in registered form.
5.4.2. The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such Shares. 

5.4.3. Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfers of registered Shares shall

be effected by declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and
the transferee or by persons granted suitable powers of attorney to that effect.

Art. 6. Increase of capital
6.1. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 7 hereof.

6.2. The Company may proceed to the repurchase of its own shares within the limits set out by the Law.

Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meeting of shareholders shall have competence in all matters where the Board of Direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. Any general meeting shall be convened by means of a convening notice sent, to each shareholder, by any two

Directors in compliance with the Law.

7.3. Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by Law, resolutions at an annual or ordinary meeting of shareholders duly convened

will be passed by a simple majority of those present and voting, regardless of the proportion of the capital represented.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital of the Company is represented and the agenda indicates the proposed amendments to
the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed
by the Articles or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results
of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital repre-

78676

sented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the share-
holders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders increased only

with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

7.5. The Board of Directors may determine any other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to

take part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

received prior infirmation of the agenda of the meeting, the shareholders may validly waive any convening formalities.

Art. 8. Board of directors
8.1. The Company shall be managed by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three

(3) members (each, a «Director»), who need not be shareholders of the Company.

8.2. The Directors shall be appointed at the annual general shareholders’ meeting for a period of maximum six (6)

years and shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible. They may be removed at any time by
a resolution of the general meeting of shareholders. In case a Director is appointed without indication as to the term
of his mandate, he is deemed to be appointed for six years from the date of his appointment.

8.3. In the event of one or more vacancies on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancy until the next
meeting of shareholders.

8.4. The Directors shall not be compensated for their services as Director, unless otherwise resolved upon by the

general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses incurred through
their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings of the Board.

Art. 9. Procedures of meeting of the board of directors
9.1. The Board of Directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
Board of Directors and of the shareholders.

9.2. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or two Directors at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, fax, electronic mail to each Director at least three (3) Business Days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set forth for such meeting by telefax
and/or telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or electronic
mail of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. All reasonable efforts will be provided so that,
sufficiently in advance of any meeting of the Board of Directors, so that each Director is provided with a copy of the
documents and/or material to be discussed or resolved upon by the Board of Directors at such meeting.

9.3. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, or telegram

or electronic mail another Director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be
allowed and the Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video
or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
that in such latter case such vote is confirmed in writing.

9.4. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least any two Directors are present at the meeting

of the Board of Directors.

9.5. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
9.6. Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a meeting.

9.7. For the purposes of the Articles, «Business Day» means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday) on

which banks are open for business in Luxembourg.

Art. 10. Minutes of meetings of the board
10.1. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by all the Directors

present at the meeting and recorded in the corporate books of the Company.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by any two Directors.

Art. 11. Powers of the board
11.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles for the general meeting of
shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

11.2. The Board of Directors may delegate, with the prior consent of the general meeting of shareholders, its powers

to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such manage-
ment and affairs, to one of the members of the Board of Directors who shall be called the managing director. It may
also confer all powers and special mandates to any person who need not be a Director, appoint and dismiss all officers
and employees and determine their emoluments.

Art. 12. Binding signature
The Company will be bound by the single signature of any Director of the Company.

78677

Art. 13. Statutory auditor
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not be (a) shareholder(s). The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders,
which determine their number and the term of their mandate.

Art. 14. Appropriation of profits
14.1. Legal Reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

14.2. Dividends
14.2.1. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how

the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends with-
out ever exceeding the amounts proposed by the Board of Directors.

14.2.2. Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by Law, upon decision of the Board

of Directors and report by the statutory auditors.

Art. 15. Dissolution and liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required

for amendment of these Articles as prescribed in Article 7 hereof.

15.2. In the event of dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators

named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and compen-
sation.

Art. 16. Governing law
All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law.

Art. 17. Annual general meeting of shareholders
17.1. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second
of June at 3.00 p.m.

17.2. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the following Business Day. The

annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional
circumstances so require.

17.3. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be spec-

ified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 18. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of

December of each year.

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 31st

December 2006.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in June 2007.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the whole capital as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of hundred percent (100%) by payment in cash of the amount of EUR

31,000.- (thirty-one thousand Euro), together with a share premium of EUR 4,000.- (four thousand Euro), so that the
amount of EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro) is now available to the Company, evidence thereof having been given
to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the Law have been satis-

fied.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately two thousand two hundred Euro. 

Subscribers

Number

Subscribed

% of share

of Shares amount (in EUR)

capital

Mr Robert J.H. Randall,
prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1.25

00.01%

MATRIX GERMAN PORTOFOLIO NO.1 HOLDCO, S.à r.l.,
prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,799

30,998.75

99.99%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,800

31,000.00

100.00%

78678

<i>Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened, have

immediately proceeded with an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have adopted the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of Directors is fixed at 3 (Three).
2. The following are appointed Directors:
- Mr Ian Blake, born on 29 January 1963 in Stafford (United Kingdom), with professional address at One Jermyn

Street, London, SW1Y 4UH, United Kingdom; 

- Mr Hille-Paul Schut, born on 29 September 1977 in The Hague (Netherlands), with professional address at 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Robert Kimmels, born on 4 March 1969 in Breukelen (Netherlands), with professional address at 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Unless renewed, their term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.

3. Has been appointed statutory auditor:
C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, and registered with the Lux-

embourg Register of Commerce and Companies under number B 68.168.

Unless renewed, its term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.

4. The registered office of the Company is established at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Fassung der Satzungen:

Im Jahre zweitausendsechs, am neunzehnten Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Sind erschienen:

(1) MATRIX GERMAN PORTOFOLIO NO. 1 HOLDCO, S.à r.l., ein société à responsabilité limitée (Gesellschaft

mit beschränkter Haftung) gegründet in Luxembourg, mit Gesellschaftsitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 112.074; und 

(2) Herr Robert J. H. Randall, berufsmäßig wohnhaft in One Jermyn Street, London, SW1Y 4UH, Vereinigtes König-

reich,

hier vertreten aufgrund von zwei Vollmachten durch Herrn Hille-Paul Schut, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in Luxem-

bourg.

Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

vorliegender Urkunde beigefügt, um die derselben registriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den Notar, die Satzung einer société anonyme, die sie hiermit gründen, zu beurkunden:

Art. 1. Form, Name
Hiermit wird zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten Aktien

eine Gellschaft in Form einer société anonyme errichtet mit dem Namen MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO.1
FRANKFURT S.A., die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in der aktuell geänderten Fas-
sung (das «Gesellschaftsgesetz»), sowie der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Art. 2. Dauer
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 3. Zweck
3.1. Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxembur-

gischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die
Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuld-
verschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art
(darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Port-
folios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

3.2. Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligatio-

nen, mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar
oder nicht) aufnehmen und gewähren.

3.3. Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaf-

ten bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (ein-
schliesslich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmassnahmen
treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

3.4. Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede anderere Form von Sicherheiten

oder Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder an-
derweitige Belastung aller oder eines Teils der Sachanlagen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch
alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr

78679

verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an der die Gesellschaft beteiligt ist
oder eines Verwaltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbun-
denen Unternehmen oder Konzerngesellschaften innerhalb der Beschränkungen der geltenden rechtlichen Vorschriften.

3.5. Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Transaktionen sowie alle Übertragungen,

die sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen. 

3.6. Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die

Holdinggesellschaft.

Art. 4. Geschäftssitz
4.1. Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Der Geschäftssitz

kann durch Beschluss des Verwaltungstrates innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Durch Verwaltungsratsbe-
schluss können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros, sowohl innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg, als auch
im Ausland eröffnet werden.

4.2. Falls der Verwaltungsrat feststellt, ausserordentliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art der

gewöhnlichen Geschäftsabwicklung entgegenstehen oder eine normale Verbindung mit dem Geschäftssitz oder des Ge-
schäftssitzes mit dem Ausland verhindert oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis
zur Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorläufigen Massnahmen ha-
ben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, trotz dieses vorläufigen Beschlusses, eine luxemburgi-
scher Gesellschaft bleibt.

Art. 5. Kapital - Genehmigte Kapital - Aktien und Aktienzertifikate
5.1. Kapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreizigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist eingeteilt in vier-

undzwanzigtausendachthundert (24.800,-) Aktien mit einem Nennwert von jeweils ein Euro und fünfundzwanzig Cents
(EUR 1,25).

5.2. Emissionsagio
Jede Aktie kann vorbehaltlich der Bezahlung eines Emissionsagio («Emissionsagio») ausgegeben werden. Das Emissi-

onsagio wird einer Rücklage zugewiesen («Emissionsagiorücklage»), die für jede Art von Ausschüttung oder zur Bestrei-
tung von Kosten zur Verfügung steht.

5.3. Genehmigtes Gesellschaftkapital
5.3.1. Neben und zusätzlich zum gezeichneten Kapital, wird das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf einhundert-

undzwanzigtausend Euro (EUR 120.000,-) festgesetzt, eingeteilt in sechsundneunzigtausend (96.000) Aktien mit einem
Nennwert von jeweils EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig Cents).

5.3.2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt während einer Zeitspanne von fünf Jahren, die am 19. Mai 2011 endet, wan-

delbare Schuldtitel auszugeben und/oder das gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals einmal oder
mehrfach nach der Umwandlung der Schuldtitel oder Aktieninstrumente, je nach Sachlage, bis zu einem Gesamtbetrag
in Höhe von EUR 120.000,- (einhundertzwanzigtausend Euro) zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können gezeichnet
und ausgegeben werden mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Entscheidung des Verwaltungsrates.

5.3.3. Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Emissionen vorzunehmen, ohne den jetzigen Aktionären

ein Vorzugszeichnungsrecht auf die auszugebenden Aktien einzuräumen.

5.3.4. Des weiteren ist der Verwaltungsrat dazu berechtigt und ermächtigt, jedwede Kapitalerhöhung im Rahmen des

genehmigten Kapitals in einer oder mehreren aufeinander folgenden Teilen durchzuführen. Dies kann durch Bezahlung,
durch Einbringung von Sachwerten, durch Anspruchsumwandlung, Einbringung zurückgestellter Gewinne oder ander-
weitig erfolgen. Ferner kann der Verwaltungsrat den Ort und das Datum der Anteilsausgabe bzw. Folgeausgabe, den
Ausgabepreis, die Zeichnungsbedingungen und die Einzahlung der neuen Aktien festlegen.

5.3.5. Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsratsmitglied oder Prokuristen oder jeder anderen ermächtigten

Person Vollmacht erteilen, um die Pflichten der Annahme von Aktienzeichnungen und die Zahlung des Aktienpreises,
welche die gesamte oder Teile der Kapitalerhöhung darstellen, wahrzunehmen.

Jedesmal, wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals durchgeführt

hat, wird der Wortlaut von Artikel 5.3.1. abzüglich des Betrages dieser Kapitalerhöhung als angepasst betrachtet. Folg-
lich werden die in Artikel 5.1 und 5.3.1. der Satzung festgelegten Beträge durch die entsprechenden Urkunden zur Ka-
pitalerhöhung gemäss Artikel 5.3 abgeändert.

5.4. Aktien
5.4.1. Die Aktien sind Namensaktien.
5.4.2. Die Gesellschaft betrachtet Personen, auf deren Namen die Aktien im Aktienregister eingetragen sind, als voll-

ständige Eigentümer dieser Aktien.

5.4.3. Den Aktionären werden Namenszertifikate ausgehändigt, aus denen diese Eintragung hervorgeht. Die Übertra-

gung von Namensaktien erfolgt mittels einer Übertragungserklärung, die in das Aktienregister eingetragen wird und vom
Übertragenden und dem Übertragungsempfänger bzw. von Personen, die über eine geeignete Vollmacht hierfür verfü-
gen, mit dem jeweiligen Datum und Unterschrift zu versehen ist.

Art. 6. Erhöhung des Gesellschaftkapitals 
6.1. Das Gesellschaftkapital kann ebenfalls erhöht oder herabgesetzt werden mittels eines Beschlusses der Aktionäre,

der in der für Satzungsänderungen erforderlichen Weise angenommen wird, gemäss Artikel 7 der Satzung.

6.2. Die Gesellschaft kann ihrer eigenen Aktien gemäss den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes zurückkaufen.

Art. 7. Hauptversammlung - Allgemeines
7.1. Jede rechtsgültig einberufene Hauptversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft.

78680

Dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheis-

sen. Insbesondere verfügen die ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre über die Entscheidungsbefugnis in al-
len Angelegenheiten, in denen der Verwaltungsrat in alleinigem Ermessen die formelle Genehmigung der ordentlichen
Hauptversammlung der Aktionäre wünscht.

7.2. Jede Hauptversammlung wird durch die Versendung einer Einberufungsmitteilung an jeden Aktionäre von zwei

Verwaltungsratsmitgliedern im Einklang mit dem geltenden Recht einberufen.

7.3. Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann sich auf jeder Hauptversammlung der Aktionäre

schriftlich oder per Fax, Telegramm oder Telex erteilter Vollmacht durch eine andere Person vertreten lassen.

7.4. Soweit rechtlich nichts anderes verlangt wird, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Jahres-

oder ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden ge-
fasst, wobei der Anteil am repräsentierten Kapital unberücksichtigt bleibt.

Eine einberufene außerordentliche Hauptversammlung zur Änderung von Bestimmungen in der Satzung kann recht-

mäßig keine Beschlüsse fassen, wenn nicht mindestens die Hälfte des Kapitals anwesend ist und der Tagesordnung die
vorgeschlagenen Satzungsänderungen zu entnehmen sind. Wird die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt, kann eine
zweite Hauptversammlung in der in der Satzung oder im geltenden Recht beschriebenen Weise einberufen werden. In
einer solchen Einberufungsmitteilung müssen die Tagesordnung, sowie das Datum und die Ergebnisse der ersten Ver-
sammlung enthalten sein. Die zweite Versammlung gilt unabhängig vom Anteil des anwesenden Kapitals als beschlussfä-
hig. Auf beiden Versammlungen müssen die Beschlüsse, um Rechtswirksamkeit zu erlangen, von einer
Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre angenommen werden.

Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft sowie die Erhöhung der Pflichten ihrer Aktionäre ist allerdings nur

durch einen einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und im Einklang mit allen weiteren rechtlichen Vorschriften möglich.

7.5. Der Verwaltungsrat legt alle anderen Bedingungen zu den Hauptversammlungen fest.
7.6. Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen vorlie-

genden Tagesordnung genommen haben, können Hauptversammlungen auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig
stattfinden.

Art. 8. Verwaltung, Aufsicht
8.1. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet (der «Verwaltungsrat»), der sich aus mindestens drei

Mitgliedern zusammensetzt, (jeder einzeln als «Mitglied» oder zusammen als «Mitglieder»), die keine Aktionäre der Ge-
sellschaft sein müssen.

8.2. Die Mitglieder werden durch die Hauptversammlung gewählt für eine maximale Amtszeit von sechs Jahren und

bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig von der
Hauptversammlung abgewählt werden. Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied unbefristet bestellt wird, wird da-
von ausgegangen, dass er für einen Zeitraum von sechs Jahren vom Datum seiner Wahl an bestellt wurde.

8.3. Im Falle einer Vakanz von einem oder mehreren Mitgliedern im Todesfalle oder aus anderen Gründen, müssen

die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder innerhalb von 30 Tagen die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im
Verwaltungsrat bis zur nächtsfolgenden Hauptversammlung ausfüllen.

8.4. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder, solange

von der Hauptversammlung der Aktionäre nichts anderes beschlossen wird. Die Gesellschaft erstattet den Verwaltungs-
ratsmitgliedern ihre Auslagen im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Amts in angemessenem Rahmen, darunter an-
gemessene Reise- und Unterhaltskosten für die Teilnahme an den Verwaltungsratssitzungen. 

Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates
9.1. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Es kann ferner ein Schriftführer gewählt werden,

der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und für das Führen des Protokolls der Verwaltungsratssitzung und der
Hauptversammlung der Aktionäre zuständig ist.

9.2. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder zwei Mitglieder am in der Einberufungsmitteilung genann-

ten Ort einberufen. Die Einberufungsmitteilung beinhaltet eine Tagesordnung und ist per Post (per Expresspost oder
Sonderkurier), Telegramm, Fax oder E-Mail an jedes Verwaltungsratsmitglied zu versenden. Der Versand muss minde-
stens 3 (drei) Geschäftstage vor dem für die Sitzung angesetzten Termin erfolgen, es sei denn, es liegt ein Notfall vor.
In diesem Fall ist die Art dieses Notfalls in der Einrufungsmitteilung auszuführen und die Mitteilung muss mindestens 24
Stunden vor der für die Versammlung festgelegten Uhrzeit per Telefax und/oder Telegramm versandt werden. Auf diese
Einberufungsmitteilung kann per schriftlicher Genehmigung oder per Genehmigung mittels Fax, Telegramm oder E-Mail
von jedem Verwaltungsratsmitglied verzichtet werden. Für Sitzungen, die zu einem Zeitpunkt und einem Ort abgehalten
werden, die in einem vorab per Beschluss des Verwaltungsrats genehmigten Terminplan anberaumt wurden, ist keine
separate Mitteilung erforderlich. Es werden alle angemessenen Bemühungen unternommen, um zu gewährleisten, dass
vor jeder Verwaltungsratssitzung jedes Verwaltungsratsmitglied eine Kopie der Dokumente und/oder Unterlagen erhält,
über die vom Verwaltungsrat im Rahmen der Sitzung gesprochen werden oder im Zusammenhang mit denen ein Be-
schluss gefasst werden soll.

9.3. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied

vertreten werden, sofern er dieses schriftlich oder per Fax, Telegramm oder E-Mail hierfür bevollmächtigt hat. Der Ein-
satz einer Videokonferenzausrüstung und von Konferenzgesprächen ist erlaubt und die Verwaltungsratsmitglieder, die
diese Technologie nutzen, gelten als anwesend und sind dazu berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen. Nach
der Erörterung können Stimmen ebenfalls schriftlich oder per Fax, Telegramm, Telex oder Telefon abgegeben werden,
vorausgesetzt, dass bei Letzterem die Stimmabgabe schriftlich bestätigt wird.

9.4. Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit von zwei der Mitglieder

gegeben.

9.5. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

78681

9.6. Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden, haben dieselbe Wirkung, als wären

die Beschlüsse im Rahmen einer Sitzung gefasst worden.

9.7. Für die Zwecke dieser Satzung bezieht sich «Geschäftstag» auf jeden Kalendertag (ohne Samstage oder Sonnta-

ge), an dem die Banken in Luxemburg geöffnet sind.

Art. 10. Sitzungsprotokolle
10.1. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet und im

Protokollbuch der Gesellschaft verzeichnet.

10.2. Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen,

werden von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 11. Befugnisse der Verwaltungsrat
11.1. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehendsten Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung

des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des Gesell-
schaftszwecks. Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Hauptversammlung gemäss Gesellschaftsgesetz
oder laut der gegenwärtigen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.

11.2. Der Verwaltungsrat ist befugt die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu

übertragen, welche nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt,
durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für Sondergeschäfte zu bestellen.

Art. 12. Unterschrift
Die Gesellschaft wird unter jeden Umständen durch die individuelle Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglie-

der verpflichtet.

Art. 13.Wirtschaftsprüfer
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre

sein können. Die Kommissären werden durch die Hauptversammlung, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate fest-
legt, ernannt.

Art. 14. Gewinn
14.1. Reservefonds
Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals

erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig wenn und solange der Reservefonds zehn Prozent
des Nominalwertes des Kapitals beträgt.

14.2. Dividende
14.2.1. Darüberhinaus verfügt die Hauptversammlung über den Saldo nach Gutdünken. Die auszuschüttende Dividen-

de gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung. Die Hauptversamm-
lung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung als derjenigen, in der die Bilanz
ergeht zu zahlen und dabei selbstständig den Umrechnungskurs zu bestimmen.

14.2.2. Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden ge-

setzlichen Bestimmungen und auf Beschluss des Verwaltungsrats und Bericht der Abschlussprüfer.

Art. 15. Auflösung, Liquidation
15.1. Die Hauptversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft in der für Satzungsänderungen vor-

geschriebenen Weise, gemäss Artikel 7 der Satzung, zu beschließen.

15.2. Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; deren Bestel-

lung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Hauptversammlung.

Art. 16. Gesellschaftsgesetz
Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft den gesetz-

lichen Bestimmungen.

Art. 17. Ordentliche Hauptversammlung
17.1. Die ordentliche Hauptversammlung findet alljährlich am 2. des Monates Juni um 15.00 Uhr an einem in den Ein-

berufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg oder an einem anderen Ort in Luxemburg, wie dies in der je-
weiligen Einberufungsmitteilung angegeben ist statt.

17.2. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die

Hauptversammlungen - auch die ordentliche jährliche Hauptversammlung - im Auslande stattfinden; die Festlegung die-
ser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat.

17.3. Weitere Versammlungen der Aktionäre, ordentlicher oder außerordentlicher Natur, können an dem Ort und

zu dem Zeitpunkt abgehalten werden, wie dies in der jeweiligen Einberufungsmitteilung angegeben ist. Sie können am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem beliebigen anderen Ort abgehalten werden.

Art. 18. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endigt am 31. Dezember.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2007.

78682

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Aktien wurden durch die Erschienenen gezeichnet wie folgt: 

Die Aktionäre haben den Betrag ihrer Zeichnung sofort und in bar eingezahlt; zusammen mit einer Ausgabe Prämie

von EUR 4.000,- (viertausend Euro), somit verfügt die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag von EUR 35.000 (fünf-
unddressigtausend Euro), worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Kostenabschätzung

Der Gesellschaft obliegen Gründungskosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welcher ihr wegen ihrer Grün-

dung anerfallen, für zirka zweitausendzweihundert Euro.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Nach Festlegung der Satzung der Gesellschaft haben die Erschienenen, welche das gesamte Aktienkapital vertreten

und sich als rechtsgültig zusammengerufen betrachten, in ausserordentlicher Hauptversammlung einstimmig folgende
Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 (drei) festgesetzt.

2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bestellt:
- Herr Ian Blake, geboren am 29. Januar 1963 in Stafford (United Kingdom), berufsmäßig wohnhaft in One Jermyn

Street, London, SW1Y 4UH, Vereinigtes Königreich;

- Herr Hille-Paul Schut, geboren am 29. September 1977 in Den Haag (Niederlanden), berufsmäßig wohnhaft in 9,

rue Schiller, L-2519 Luxemburg;

- Herr Robert Kimmels, geboren am 4. März 1969 in Breukelen (Niederlanden), berufsmäßig wohnhaft in 9, rue Schil-

ler, L-2519 Luxemburg.

Solange keine Verlängerung vorliegt, enden die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sofort nach der jährlichen

Hauptversammlung im Jahre 2011.

3) Zum Kommissar wurde bestellt:
C.A.S. SERVICES S.A., mit Gesellschaftsitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Han-

dels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 68.168.

Solange keine Verlängerung vorliegt, endet der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sofort nach der jährlichen

Hauptversammlung von 2011.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, welcher die deutsche Sprache kennt, erklärt dass auf Antrag der erschienenen Parteien

gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlangen der Parteien ist
im Falle einer Abweichung der beiden Fassungen die Englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben alle mit Uns, Notar, die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.-P. Schut, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 mai 2006, vol. 436, fol. 94, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(064453.3/242/538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

SOLUDEC DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.372. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR06006, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062163.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

Aktionäre

Aktien

Gezeichneter % Gesellschaft-

Nummer Betrag (in EUR)

kapital

Herr Robert J.H. Randall,
vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1,25

00,01%

MATRIX GERMAN PORTOFOLIO NO.1 HOLDCO, S.à r.l.,
vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.799

30.998,75

99,99%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.800

31.000,00

100,00%

Mersch, den 15. Juni 2006.

H. Hellinckx.

Bascharage, le 30 juin 2006.

Signature.

78683

PHILIPPE LOCATION ET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 45, boulevard J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.022. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062229.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

CONVENTUM ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme,

(anc. BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT S.A.).

Capital social: EUR 500.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.959. 

Société Anonyme constituée le 7 février 1986 suivant publication au Mémorial C n

°

 67 du 15 mars 1986, derniers statuts 

modifiés en date du 15 décembre 2005 suivant publication au Mémorial C n

°

 1474 du 29 décembre 2005.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises sous forme circulaire par le Conseil d’Administration du 26 avril 2006

Le Conseil d’Administration décide, avec effet au 1

er

 mai 2006, de transférer le siège social de CONVENTUM ASSET

MANAGEMENT du 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2006

L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs.

<i>Composition du Conseil d’Administration

M. Antoine Calvisi, Président,
M. Pierre Ahlborn, Administrateur,
M. Mario Keller, Administrateur,
M. Pit Reckinger, Administrateur,
M. Fernand Reiners, Administrateur.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08237. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062323.3/007/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

DORANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.625. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 mai 2006

- Les démissions de Mademoiselle Corinne Bitterlich et de Messieurs Jean-Paul Reiland et Carlo Schlesser de leur

mandat d’Administrateur sont acceptées.

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 9 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09369. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064647.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

<i>Pour la société
P. Lacour

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
R. Herrmann

Certifié sincère et conforme
<i>DORANDA S.A.
MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

78684

CAZA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 98.482. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09093, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

(064584.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

MC HOLDING PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 76.425. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 28 juin 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en date

du 28 juin 2006 que:

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance, l’Assemblée a décidé d’appeler

aux fonctions d’Administrateurs les personnes suivantes:

Sont réélus:
- Maître Bernard Felten, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,
- Monsieur Frédéric Collot, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
- La société CD-GEST, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2012.
L’Assemblée a décidé d’appeler au poste de Commissaire aux comptes la société suivante:
Est réélue:
- La société CD-SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00902. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064606.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

SICRIS IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 85.967. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00608, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064652.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

SICRIS IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 85.967. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00616, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064653.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

<i>Pour CAZA IMMO S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Signature.

78685

AUCHAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 73.616. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 2006

1. Les mandats d’Administrateurs de:
- Monsieur Christophe Dubrulle, Directeur Général, résidant professionnellement au 40, avenue de Flandre, F-59964

Croix, 

- AUCHAN LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,
- Monsieur Henri Mathias, Administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 40, avenue de Flandre,

F-59964 Croix, 

sont reconduits pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée ayant son siège social

au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09374. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064634.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

AUCHAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 73.616. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 26 mai 2006

- Le mandat de Monsieur Henri Mathias, Administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 40, avenue de

Flandre, F-59964 Croix, en tant que Président du Conseil d’Administration, est reconduit pour une nouvelle période
d’un an. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064631.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

EUROPEAN ADVISORS OF TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 45.703. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’Administration tenu en date du 29 juin 2006 que:
- Monsieur Turcarelli Angelo, médecin, demeurant à L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté, a été élu à la

fonction d’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Steve Lang démissionnaire.

- Monsieur Turcarelli Angelo a été élu à la fonction d’Administrateur-délégué de la société.
Monsieur Turcarelli disposera d’un pouvoir de signature individuel dans les limites de l’article 60 de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Son mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02063. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064662.3/1285/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Certifié sincère et conforme
AUCHAN INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
AUCHAN INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

78686

PARTICOM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 77.730. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 28 juin 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en date

du 28 juin 2006 que:

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance, l’Assemblée a décidé d’appeler

aux fonctions d’Administrateurs les personnes suivantes:

Sont réélus:
- Maître Bernard Felten, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,
- Monsieur Frédéric Collot, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
- La société CD-GEST, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2012.
L’Assemblée a décidé d’appeler au poste de Commissaire aux comptes la société suivante:
Est réélue:
- La société CD-SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 29 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064608.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

EUROINVEST (CZECH 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 70.881. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00567, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2006.

(064620.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

DASHABO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.505. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant au 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg, aux fonctions

d’administrateur;

- Madame Efthalia Daskalides, avec adresse professionnelle au Bruxelles, aux fonctions d’administrateur;
- Madame Georgette Daskalides, avec adresse professionnelle au Bruxelles, aux fonctions d’administrateur et

d’administrateur-délégué.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31

décembre 2006.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064684.3/657/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

X. Kotoula / J. W. van Koeverden Brouwer
<i>Manager / <i>Manager

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

78687

EUROINVEST (HUNGARY 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 70.927. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00551, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2006.

(064621.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

EUROINVEST (CZECH 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 70.883. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00550, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2006.

(064622.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 27.617. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00379, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064623.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

PUSAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 54.027. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00383, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064624.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

SOCIETE POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE CONTENEURS, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 21.314. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00387, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064625.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

X. Kotoula / J.W. van Koeverden Brouwer
<i>Manager / <i>Manager

X. Kotoula / J.W. van Koeverden Brouwer
<i>Manager / <i>Manager

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

78688

AESHA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 21.828. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00391, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064626.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.922. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00402, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064628.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

HAMS HALL BIRMINGHAM NOMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR GBP 360.000.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 70.941. 

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 3 juin 2006, réf. LSO-BS00256, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064643.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ROMADA.FI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.758. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 mars 2006

- Les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnel-
lement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leur mandat d’Administrateur de Catégorie A sont acceptées.

- Le nombre des Administrateurs est réduit de 6 à 5.
- La société DMC, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société EFFIGI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs de
Catégorie A. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

- La société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg continue son mandat d’Administrateur de Catégorie A, mandat qui viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 22 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064639.3/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

 

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ROMADA.FI S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

78689

CODEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3660 Kayl, 25, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 47.450. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social, le 10 mai 2006 à 10.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. Réélection du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.
Sont réélus Administrateurs:
- Monsieur Pierre Malay, Ingénieur, né le 6 février 1948 à Sart-les-Spa, demeurant 7, rue Joseph Wauters, B-4570

Marchin. 

- Monsieur Guy Malay, Directeur technique, né le 22 octobre 1953 à Sart-les-Spa, demeurant 16, Chemin de la

Xhavée, B-4130 Esneux.

- Monsieur Jean-Claude Defourny, Ingénieur, né le 19 avril 1949 à Battice, demeurant 70, rue de la Clé, B-4650 Herve.
Est réélu Commissaire aux Comptes:
- Monsieur André Thunus, Expert-Comptable, né le 26 mars 1959 à Malmedy, demeurant 8B, Pré Messire, B-4970

Stavelot.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée Générale

Ordinaire de 2011.

2. Le Conseil d’Administration décide de réélire en son seing pour une nouvelle période de six ans Monsieur Pierre

Malay aux fonctions d’Administrateur-Délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Le mandat de l’Administrateur-Délégué prendra fin à l’issue de l’assemblée Générale Ordinaire de 2011.
3. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire, le Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064642.3/642/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

HAMS HALL BIRMINGHAM DC2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.222. 

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 3 juin 2006, réf. LSO-BS00251, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064646.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

BALSPEED RE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.186. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 22 juin 2006

«Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Arthur Ed. Ziegler,
- Monsieur Robert Ziegler,
- Monsieur Alain Ziegler,
- Monsieur Lambert Schroeder.
Est nommée réviseur indépendant la société ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg (à la place de COMPAGNIE DE

RÉVISION).

Le mandat des administrateurs et du réviseur prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle devant statuer sur

les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08474. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064687.3/682/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature / Signature / Signature 
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

 

Signature.

<i>Pour la société BALSPEED RE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

78690

WEST AVENUE COVENTRY DC7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.436. 

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00246, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064648.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ORLAN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.490. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 mars 2006

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur François Mesenburg, employé privé avec adresse professionnelle au 23,

avenue Monterey à L-2086 Luxembourg et de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé avec adresse professionnelle
au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de cinq ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

- Monsieur Jean-Robert Bartolini et Monsieur Serge Krancenblum ne se représentent pas aux suffrages.
- Les sociétés LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, et MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs pour une période statu-
taire de cinq ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de cinq ans, jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 2 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064649.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

HURTIGRUTA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 117.478. 

STATUTES

In the year two thousand six, the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1. The Company LWM HOLDINGS I CORP., with registered office in Panama, East 54th Street, Arango - Orillac

Building, 2nd Floor, Republic of Panama,

duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la

Foire Internationale, 

by virtue of a proxy delivered the 28th of June 2006.
2. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg, on the 4th of April 1967, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

3. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg, on the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit

de la Foire Internationale,

by virtue of a proxy delivered the 28th of June 2006.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

 

Signature.

Certifié sincère et conforme
ORLAN INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur 

78691

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of HURTIGRUTA S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into one

thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by

letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current

78692

relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Monday of the month of June, at 2 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing at least twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed and paid-up as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

Subscriber

Number of

shares

Amount subscribed to

 subscribed

and paid-up in EUR

1) LWM HOLDINGS I CORP., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998

30,938.-

2) Mr Eric Leclerc, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

31.-

2) Mr Jos Hemmer, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

31.-

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

31,000.-

78693

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the

year 2012:

- Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg, on the 4th of April 1967, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

- Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg, on the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

- Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg, on the 10th of December 1960, residing professionally

in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held

in the year 2012:

Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in Arlon (B), the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary, who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société LWM HOLDINGS I CORP., ayant son siège social à Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building,

2nd Floor, Republique de Panama,

ici représentée par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A,

Circuit de la Foire Internationale,

en vertu d’une procuration donnée le 28 juin 2006.
2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

ici représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg,

6A, Circuit de la Foire Internationale,

en vertu d’une procuration donnée le 28 juin 2006.
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de HURTIGRUTA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

78694

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou, indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommée par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

78695

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième lundi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatations

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Souscripteurs

 Nombre d’actions

Montant souscrit et

 souscrites

 libéré en EUR

1) LWM HOLDINGS I CORP., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998

30.938,-

2) M. Eric Leclerc, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

31,-

2) M. Jos Hemmer, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

31,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

31.000,-

78696

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros

(2.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012:
1. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, demeurant professionnelle-

ment à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en

2012:

Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à Arlon (B), le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement à

L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 juin 2006, vol. 533, fol. 82, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(066817.3/213/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

AZUR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 117.479. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-second day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) Mr Tomas Pettersson, company director, born in A Täby (Sweden), on 5 February 1971, residing at Radmansgatan

104 tr. SE-114 25 Stockholm (Sweden); 

2) Mr Lars Olov Pettersson, company director, born in X Söderhamn (Sweden), on 3 November 1945, residing at

Nybrogatan 54, SE-114 40 Stockholm (Sweden);

3) Ms Lotten Pettersson, student, born in A Boo (Sweden), on 13 March 1980, residing at Brahegatan 35 4 tr. SE-114

37 Stockholm (Sweden);

4) Mr Pär Pettersson, student, born in A Gustaf Vasa (Sweden), on 4 November 1977, residing at Skeppargatan 53 3

tr. SE-114 58 Stockholm (Sweden); 

5) Ms Anna-Klara Pettersson, student, born in A Boo (Sweden), on 29 January 1990, residing at Nybrogatan 54,

SE-114 40 Stockholm (Sweden);

all here represented by:
Mr Marc Lacombe, employee, with professional address at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of five (5) proxies, which proxies, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing persons

and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacities as proxy holder, has requested the above notary to draw

up the articles of incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which the prenamed
parties hereby form among themselves as follows:

Grevenmacher, le 7 juillet 2006.

J. Gloden.

78697

Art. 1. Form. There is established by the appearing parties a «société à responsabilité limitée» (the «Company»),

governed by the law of 10th August 1915, on commercial companies, as amended, and by the present articles of incor-
poration.

The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of a

single partner, notably as a result of transfer(s) of shares, without this resulting into the liquidation of the Company.

Art. 2. Object. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase
or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st,
1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. Name. The name of the Company is AZUR INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management.
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad.

Art. 6. Capital. The corporate capital is set at twenty-five thousand Euro (25,000.- EUR), divided into one thousand

(1,000) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single partner

or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners. 

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst

them or not.

Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer

freely its shares.

If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisa-

tion of the general meeting of partners representing at least three-quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any

other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners

or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

Art. 14. Powers of the managers. The manager has the broadest powers to carry out any act of administration,

management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls
within the object of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court
either as plaintiff or defendant.

78698

Art. 15. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 16. Liability of the managers. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 17. Representation of the Company. The Company is in all circumstances bound by the single signature of

the sole manager or in case of plurality of managers by the joint signatures of two managers or by the joint signatures
or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager, within the limit of
such power.

Art. 18. General meetings of partners. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-

ners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the
associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 19. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be,

are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.
The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 20. Financial year. The financial year begins on the first day of July of each year and ends on the thirtieth of

June of the next year.

Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the thirtieth of June, a general inventory of the assets and liabilities of the

Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying
a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 22. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction

of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 23. Dissolution, liquidation. In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one

or several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of
partners, who shall determine their powers and their compensation.

Art. 24. Matters not provided. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be

determined in accordance with the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared Mr Marc Lacombe, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of

the prenamed associates, by virtue of the above-mentioned proxy and declared to subscribe and pay up the issued
shares in such capacity as follows: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand six hundred Euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 30th June 2006.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, through their both proxy-holder, have immediately proceeded to hold an extraordinary

general meeting and have adopted the following resolutions by unanimous vote:

Associates

Subscribed

Number

Paid in

capital (EUR)

of shares

capital (EUR)

1) Mr Tomas Pettersson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,675.-

227

5,675.-

2) Mr Lars Olov Pettersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,300.-

92

2,300.-

3) Mrs Lotten Pettersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,675.-

227

5,675.-

4) Mr Pär Pettersson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,675.-

227

5,675.-

5) Ms Anna-Klara Pettersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,675.-

227

5,675.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000.-

1,000

25,000.-

78699

1.- The number of the managers is set at one (1), and the following manager is elected for an unlimited duration, with

the powers set forth in article fourteen (14) of the articles of incorporation of the Company.

Mr Peter Vansant, jurist, born in Turnhout (Belgium), on 20 January 1965, residing professionally at 28, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg.

2.- The address of the registered office of the Company is set at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Tomas Pettersson, directeur de société, né à A Täby (Suède), le 5 février 1971, demeurant à Radmans-

gatan 104 tr. SE-114 25 Stockholm (Suède);

2) Monsieur Lars Olov Pettersson, directeur de société, né à X Söderhamn (Suède), le 3 novembre 1945, demeurant

à Nybrogatan 54, SE-114 40 Stockholm (Suède);

3) Mademoiselle Lotten Pettersson, étudiante, née à A Boo (Suède), le 13 mars 1980, demeurant à Brahegatan 35 4

tr. SE-114 37 Stockholm (Suède);

4) Monsieur Pär Pettersson, étudiant, né à Gustaf Vasa (Suède), le 4 novembre 1977, demeurant à Skeppargatan 53

3 tr. SE-114 58 Stockholm (Suède);

5) Mademoiselle Anna-Klara Pettersson, étudiante, née à A Boo (Suède), le 29 janvier 1990, demeurant àt Nybrogatan

54, SE-114 40 Stockholm (Suède);

tous ici représentés par:
Monsieur Marc Lacombe, employé, demeurant professionnellement au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
en vertu de cinq (5) procurations, lesquelles après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentaire, resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités de mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit

les statuts d’une société à responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Forme. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement,

il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), qui est régie par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter un seul associé,

par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n’entraîne la dissolution de la Société.

Art. 2. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres so-

ciétés, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de
brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous con-
cours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de AZUR INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

78700

La propriété d’une part emporte de plain droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d’un associé unique, ledit associé unique peut librement cé-

der ses parts.

Si la Société est composée d’une pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration,

de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition
qu’elles rentrent dans l’objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit
en demandant soit en défendant.

Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de
l’exécution de son mandat.

Art. 17. Représentation de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du

gérant unique ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants ou par les signatures conjointes
ou la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués par les Gérants dans
la limite de ces pouvoirs.

Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce

les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de
la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas, seront

établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des
associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites. 

Art. 20. Année sociale. L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de

l’année suivante.

Art. 21. Bilan. Chaque année, le trente juin, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de la société

et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.

Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite

des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

78701

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 23. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents statuts seraient ré-

gies conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Ensuite a comparu Monsieur Marc Lacombe, prénommé, agissant dans sa qualité de mandataire dûment autorisé des

associés prénommés, en vertu de la procuration ci-dessus décrite et a déclaré souscrire et libérer les parts sociales émi-
ses en cette qualité comme suit: 

Preuve de cette libération a été donnée au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 30 juin 2006.

<i>Coût, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés prénommés, par leur mandataire susnommé, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraor-

dinaire et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1), et le gérant suivant est nommé pour une durée illimitée, avec les pouvoirs

prévus à l’article quatorze (14) des statuts de la Société.

Monsieur Peter Vansant, juriste, né à Turnhout (Belgique), le 20 janvier 1965, avec adresse professionnelle au 28,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

2.- L’adresse du siège social est fixée au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les mêmes comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lacombe, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2006, vol. 905, fol. 25, case 2. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066841.3/239/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

HULTET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 88.374. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00962, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065130.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Associés

Capital

Nombre de

Libération

 souscrit (EUR)

parts sociales

(EUR)

1) M. Tomas Pettersson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.675,-

227

5.675,-

2) M. Lars Olov Pettersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.300,-

92

2.300,-

3) Mme Lotten Pettersson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.675,-

227

5.675,-

4) M. Pär Pettersson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.675,-

227

5.675,-

5) Mlle Anna-Klara Pettersson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.675,-

227

5.675,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000,-

1,000

25.000,-

Belvaux, le 29 juin 2006.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

78702

EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 78.471. 

In the year two thousand six, on the second day of June.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY IN-

VESTMENTS S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted under the name of CHA-
MANIN S.A., by a notarial deed on October 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 301, of April 25, 2001, the articles of which having been amended pursuant to a notarial deed on December 28,
2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 664 of August 22, 2001 and for the last
time pursuant to a notarial deed on August 5, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1372 of December 13, 2005.

The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (B), being in the chair,
who appointed as secretary Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing in Russange (F).
The meeting elected as scrutineer Mr Gautier Rochez, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of thirty thousand Euro (30,000.- EUR) to bring it from its present

amount of two hundred and fifty thousand Euro (250,000.- EUR) to two hundred and eighty thousand Euro (280,000.-
EUR) by the issuing of three thousand (3,000) new Class I shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each, having
the same rights and obligations as the existing Class I shares.

2. Waiver by the existing shareholders EMERALD FIRST LAYER «A», EMERALD FIRST LAYER «B», EMERALD FIRST

LAYER «C», EMERALD FIRST LAYER «D», EMERALD FIRST LAYER «E», EMERALD FIRST LAYER «F», EMERALD
FIRST LAYER «G» and EMERALD FIRST LAYER «H» of their preferential subscription right.

3. Subscriptions and full payment of the 3,000 Class «I» shares by EMERALD FIRST LAYER «I» S.A.
4. Subsequent modification of the articles of association.
5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of thirty thousand Euro (30,000.- EUR)

to bring it from its present amount of two hundred and fifty thousand Euro (250,000.- EUR) to two hundred and eighty
thousand Euro (280,000.- EUR) by the issuing of three thousand (3,000) new Class «I» shares with a par value of ten
Euro (10.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing Class «I» shares.

<i>Second resolution

The general meeting, having acknowledged that the existing shareholders waived, totally or partially, their preferential

subscription rights, decides to admit to the subscription of the three thousand (3,000) new Class I shares, the company
EMERALD FIRST LAYER «I» S.A. having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the company EMERALD FIRST LAYER «I» S.A., prenamed,
here represented by Mr Gautier Rochez, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on May 31, 2006,
the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities,

declared to subscribe to the three thousand (3,000) new Class «I» shares and to have them fully paid up by contri-

bution in cash of an amount of thirty thousand Euro (30,000.- EUR).

The amount of thirty thousand Euro (30,000.- EUR) is at the disposal of the company, proof of the payment has been

given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend article 4 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-

lowing wording:

«Art. 4. The share capital of the Company is set at two hundred and eighty thousand Euro (280,000.- EUR), divided

into twenty-eight thousand (28,000) shares with a par value of ten (10) Euro each. The shares are all entirely paid-up,
and are divided into ten (10) different classes indicated, respectively, by the letters «A», «B», «C», «D» until «J». Of all
classes of shares a hundred shares are issued, with the exception of the «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H» and

78703

«I» classes, of which 3,100 shares per class are issued. The rights and obligations attached to the different classes of
shares are governed by Article 5 below.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand six hundred
Euro (1,600.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le deux juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EMERALD ADVISORY SER-

VICES AND EQUITY INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de CHA-
MANIN S.A., suivant acte notarié du 20 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
301 du 25 avril 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes notariés du 28 décembre 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 664 du 22 août 2001, suivant acte notarié du 26 janvier 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 724 du 5 septembre 2001 et pour la dernière fois suivant acte
notarié du 5 août 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1372 du 13 décembre 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant à Russange (F).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gautier Rochez, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social du montant de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le porter de son montant

actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) au montant de deux cent quatre-vingt mille euros (280.000,-
EUR) par l’émission de trois mille (3.000) nouvelles actions de Classe I, d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
chacune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions de Classe I existantes. 

2. Renonciation par les actionnaires actuels EMERALD FIRST LAYER «A», EMERALD FIRST LAYER «B», EMERALD

FIRST LAYER «C», EMERALD FIRST LAYER «D», EMERALD FIRST LAYER «E», EMERALD FIRST LAYER «F», EME-
RALD FIRST LAYER «G» et EMERALD FIRST LAYER «H», à leur droit de souscription préférentiel.

3. Souscription aux 3.000 actions de Classe I par EMERALD FIRST LAYER «I».
4. Modification subséquente des articles des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) au montant de deux cent quatre-vingt
mille euros (280.000,- EUR) par l’émission de trois mille (3.000) nouvelles actions de Classe I, d’une valeur nominale de
dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions de Classe I existantes.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires actuels ayant renoncé partiellement ou totalement à leur droit de souscription préférentiel, l’assem-

blée décide d’accepter la souscription des trois mille (3.000) actions de Classe I nouvelles par la société EMERALD FIRST
LAYER «I» S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Souscription et libération

Est alors intervenue aux présentes:
la société EMERALD FIRST LAYER «I» S.A., précitée,
ici représentée par Monsieur Gautier Rochez, prénommé,

78704

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 mai 2006,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles,

laquelle société déclare souscrire les trois mille (3.000) actions nouvelles de Classe I et les libérer entièrement par

un apport en espèce d’un montant de trente mille euros (30.000,- EUR).

Le montant de trente mille euros (30.000,- EUR), se trouve à présent à la disposition de la société. Preuve du verse-

ment en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt mille (280.000,-) euros, divisé en vingt-huit mille

(28.000) actions d’une valeur nominale de dix (10) euros chacune. Les actions sont entièrement libérées et sont divisées
en dix (10) classes différentes identifiées par les lettres «A», «B», «C», «D», «E» jusqu’à «J». Cent actions de toutes les
classes d’actions sont émises, à l’exception de celles des classes «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H» et «I» pour
lesquelles 3.100 actions par classe sont émises. Les droits et obligations se rapportant aux différentes classes d’actions
sont régis par l’article 5 ci-dessous.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille six cents euros (1.600,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Tassigny, M. Nezar, G. Rochez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 28CS, fol. 71, case 5. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065844.3/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.471. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065846.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO I ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1246 Luxembourg, 44, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 117.441. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO I, S.à r.l., a company incorporated and organised under the laws of Lux-

embourg with its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, represented by Mr Jean-Claude
Michels, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on June 27, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBE-

RO I ALPHA, S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the
laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the
«Articles»).

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

G. Lecuit.

78705

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The

board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory regis-
tered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of
managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 3. Corporate Objectives. The Company’s object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in

other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease

of real estate as well as of rights equivalent to real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well
as for any other operations relating to real estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings
in companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg
or abroad, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of
real estate, including real estate located abroad.

The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a
«Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any
of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxem-
bourg Law; it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be en-
gaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies, as amended from time to time.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), repre-

sented by hundred twenty-five (125) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where

there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets

and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is

admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely

transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of

the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company’s unit capital.

78706

Chapter III.- Management

Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The man-

agers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

email or letter another manager as his proxy.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating man-

ager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each
participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members

of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail,
telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers’ meetings,
physically held.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is con-

firmed in writing.

Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agree-
ments and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any member of

the board of managers.

Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate

his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any),

the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at

a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Liabilities of the manager. The members of the board of managers assume, by reason of their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Chapter IV.- General meeting of unitholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred

to the general unitholders’ meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal

representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the

unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning
at least three-quarters of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business year - Balance sheet

Art. 17. Business Year. The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of

each year.

At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and bal-

ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual ac-

counts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to
five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten
per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

78707

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31st De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

All the hundred twenty-five (125) units representing the entire capital have been entirely subscribed by SIREO IM-

MOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO I, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thou-
sand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to
the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined period:
a. Mr Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Luxembourg;
b. Mr Detlef Niezgodka, Senior Consultant Sireo, D-50259 Pulheim, Germany; 
c. Dr. Bernd Wieberneit, Executive Director, SIREO REAL ESTATE, GmbH, D-63150 Heusenstamm, Germany;
d. Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Senior Consultant SIREO, D-61476 Kronberg, Germany;
e. Mr Jost-Albrecht Nies, Head of Institutional Clients, SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l., L-1246

Luxembourg, Luxembourg;

F. Dr. Rolf Sutter, Laan Van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, The Netherlands.
In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of any member of the

board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg is appointed as auditor

of the Company for an undetermined period of time.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO I, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au

4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemourg, représentée par Monsieur Jean-Claude Michels, avocat, résidant au
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 27 juin 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée, sous la déno-

mination de SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO I ALPHA, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle
entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil de gérance est

autorisé à transférer le siège de la Société à l’intérieur de la Ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant de la même manière que pour une modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure

78708

provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce

soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie entre autres de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société peut également utiliser ses fonds en vue de l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la ges-

tion et/ou la location de biens immobiliers ainsi que de droits assimilés aux biens immobiliers au Grand-Duché du
Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toutes autres opérations ayant trait à l’immobilier. En particulier, la Société peut
détenir directement ou indirectement des actions dans des sociétés et des participations dans des sociétés à responsa-
bilité limitée (limited partnership) ou toutes autres entités juridiques quelle que soit leur forme et basés soit Luxem-
bourg ou à l’étranger ayant pour objet principal l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou
la location de biens immobiliers, y compris de biens immobiliers situés à l’étranger.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la So-
ciété, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et
chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme
contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d’apporter tou-
te assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’effectuera aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières telle que modifiée de temps à
autre.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq

cent vingt (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Modification du Capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique

(quand il y a un seul associé) ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 16
des présents Statuts.

Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs

et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 9. Transfert des Parts. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Chaque associé s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu’il détient sans le consen-

tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Chapitre III.- Gérance

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois membres. Les gérants

ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par
une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une lettre.

78709

L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et ap-

prouvées par écrit par tous les membres du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plu-
sieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même
validité que des décisions votées lors d’une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.

Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail, télé-

gramme ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom

de la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l’objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, en particulier, conclure des contrats de conseil en
investissement et des contrats d’administration, par exemple des real estate agent’s agreements et des property mana-
gement agreements.

Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature d’un des mem-

bres du conseil de gérance.

Art. 13. Sub-délégation et Agent du Gérant. Tout membre du conseil de gérance, peut subdéléguer une partie

de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout membre du conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces

agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés posté-

rieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 15. Responsabilités du Gérant. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction,

aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés 

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale de l’Associé (des Associés). L’associé unique exerce tous pou-

voirs qui sont conférés à l’assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas né-

cessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite,
par fax, câble, télégramme ou par e-mail.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être
adoptés que par une majorité d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pres-
criptions de la Loi.

Chapitre V.- Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un

inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes

annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net,
il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%)
du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits

civils, d’insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l’un des associés.

Art. 20. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en prenant personnellement

en charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

78710

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par SIREO

IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO I, S.à r.l., prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Monsieur Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Luxembourg;
- Monsieur Detlef Niezgodka, Senior Consultant SIREO, D-50259 Pulheim, Allemagne;
- Dr Bernd Wieberneit, Executive Director, SIREO REAL ESTATE, GmbH, D-63150 Heusenstamm, Allemagne;
- Dr Hilmar Friedrich-Rust, Senior Consultant SIREO, D-61476 Kronberg, Allemagne;
- Monsieur Jost-Albrecht Nies Head of Institutional Clients, SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l.,

L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Dr Rolf Sutter, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, Pays-Bas.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d’un des membres du

conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg est désignée comme

étant réviseur d’entreprises de la Société pour une période illimitée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J.-C. Michels, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2006, vol. 905, fol. 27, case 10. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065831.3/239/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 44, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 117.442. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5, SICAV, a company incorporated and organised under the laws of Luxembourg

with its registered office is at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

represented by Mr Jean-Claude Michels, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal

on June 26, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBE-

RO VI, S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws
pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Arti-
cles»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The

board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory regis-
tered office.

Belvaux, le 3 juillet 2006.

J.-J. Wagner.

78711

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of
managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 3. Corporate Objectives. The Company’s object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in

other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease

of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real
estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited
partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg or abroad, the principal object of which
is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate, including real estate located
abroad. 

The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a
«Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any
of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxem-
bourg Law; it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be en-
gaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies, as amended from time to time.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at thirty-five thousand Euro (EUR 35,000.-), represented by

three hundred fifty (350) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where

there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets

and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is

admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely

transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of

the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company’s unit capital.

Chapter III.- Management

Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The man-

agers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

78712

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

email or letter another manager as his proxy.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating man-

ager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each
participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members

of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail,
telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers’ meetings,
physically held.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is con-

firmed in writing.

Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agree-
ments and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any member of

the board of managers.

Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate

his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any),

the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at

a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Liabilities of the Manager. The members of the board of managers assume, by reason of their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Chapter IV.- General meeting of unitholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred

to the general unitholders’ meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal

representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the

unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning
at least three-quarters of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business year - Balance sheet

Art. 17. Business Year. The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of

each year.

At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and bal-

ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual ac-

counts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to
five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten
per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

78713

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31st De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

All the three hundred fifty (350) units representing the entire capital have been entirely subscribed by SIREO IMMO-

BILIENFONDS NO. 5, SICAV, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of thirty-five thousand Euro
(EUR 35,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined period:
a. Mr Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Luxembourg;
b. Mr Detlef Niezgodka, Senior Consultant SIREO, D-50259 Pulheim, Germany; 
c. Dr Bernd Wieberneit, Executive Director, SIREO REAL ESTATE, GmbH, D-63150 Heusenstamm, Germany;
d. Dr Hilmar Friedrich-Rust, Senior Consultant SIREO, D-61476 Kronberg, Germany;
e. Mr Jost-Albrecht Nies, Head of Institutional Clients, SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l., L-1246

Luxembourg;

f. Dr Rolf Sutter, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, The Netherlands.
In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of any member of the

board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg is appointed as auditor

of the Company for an undetermined period of time.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5, SICAV, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 4, rue

Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

représentée par Monsieur Jean-Claude Michels, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé le 26 juin 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomi-

nation de SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO VI, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil de gérance est

autorisé à transférer le siège de la Société à l’intérieur de la Ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant de la même manière que pour une modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce

soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie entre autres de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

78714

La Société peut également utiliser ses fonds en vue de l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la ges-

tion et/ou la location de biens immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toutes autres opé-
rations ayant trait à l’immobilier. En particulier, la Société peut détenir directement ou indirectement des actions dans
des sociétés et des participations dans des sociétés à responsabilité limitée (limited partnership) ou toutes autres entités
juridiques quelle que soit leur forme et basés soit Luxembourg ou à l’étranger ayant pour objet principal l’acquisition,
le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers, y compris de biens immobi-
liers situés à l’étranger.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la So-
ciété, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et
chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme
contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d’apporter tou-
te assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’effectuera aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières telle que modifiée de temps à
autre.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros
(EUR 35.000,-), représenté par trois cents cinquante (350) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR

100,-) chacune.

Art. 6. Modification du Capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique

(quand il y a un seul associé) ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 16
des présents Statuts.

Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs

et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 9. Transfert des parts. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Chaque associé s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu’il détient sans le consen-

tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Chapitre III.- Gérance

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois membres. Les gérants

ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par
une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une lettre.

L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et ap-

prouvées par écrit par tous les membres du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plu-
sieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même
validité que des décisions votées lors d’une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.

78715

Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail, télé-

gramme ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom

de la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l’objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, en particulier, conclure des contrats de conseil en
investissement et des contrats d’administration, par exemple des real estate agent’s agreements et des property mana-
gement agreements.

Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature d’un des mem-

bres du conseil de gérance.

Art. 13. Sub-délégation et Agent du Gérant. Tout membre du conseil de gérance, peut subdéléguer une partie

de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout membre du conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces

agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés posté-

rieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 15. Responsabilités du Gérant. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction,

aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés 

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale de l’Associé (des Associés). L’associé unique exerce tous pou-

voirs qui sont conférés à l’assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas né-

cessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite,
par fax, câble, télégramme ou par e-mail.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être
adoptés que par une majorité d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pres-
criptions de la Loi.

Chapitre V.- Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un

inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes

annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net,
il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%)
du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits

civils, d’insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l’un des associés.

Art. 20. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en prenant personnellement

en charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les trois cents cinquante (350) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5, SICAV, prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire,
de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

78716

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Monsieur Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Luxembourg;
- Monsieur Detlef Niezgodka, Senior Consultant SIREO, D-50259 Pulheim, Allemagne;
- Dr Bernd Wieberneit, Executive Director, SIREO REAL ESTATE, GmbH, D-63150 Heusenstamm, Allemagne;
- Dr Hilmar Friedrich-Rust, Senior Consultant SIREO, D-61476 Kronberg, Allemagne;
- Monsieur Jost-Albrecht Nies, Head of Institutional Clients, SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l.,

L-1246 Luxembourg;

- Dr Rolf Sutter, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, Pays-Bas.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d’un des membres du

conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg est désignée comme étant

réviseur d’entreprises de la Société pour une période illimitée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J.-C. Michels, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2006, vol. 905, fol. 27, case 9. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065833.3/239/363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

HMTF CPD CANADA LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 142,500.-.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 113.271. 

In the year two thousand and six, on the ninth day of June.
Before Us, Maître Anja Holtz, notary residing in Wiltz (Luxembourg), acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,

notary residing in Mersch (Luxembourg), who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

HMTF FUND V CAYMAN, L.P., a limited partnership established under the laws of Cayman Islands, having its regis-

tered office at 36A Dr. Roy’s Drive, P.O. Box 1043GT, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar
of Exempted Limited Partnerships under number CR-12476,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

May 26, 2006,

HM5-P COINVESTORS CAYMAN, L.P., a limited partnership established under the laws of Cayman Islands, having

its registered office at 36A Dr. Roy’s Drive, P.O. Box 1043GT, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships under number CR-12473,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

May 29, 2006,

HM5-E COINVESTORS CAYMAN, L.P., a limited partnership established under the laws of Cayman Islands, having

its registered office at 36A Dr. Roy’s Drive, P.O. Box 1043GT, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships under number CR-12692,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

May 26, 2006,

Daniel J. Hopkin, associate, born on November 10, 1977 in the State of Illinois, USA, residing at 1052 Village Parkway,

Coppell, TX 75019, USA,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

May 24, 2006,

Shi Zheng, associate, born February 3, 1978 in Jilin (China), residing at 2808 McKinney Avenue, Apt. 849, Dallas, TX

75204-8613, USA,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

May 26, 2006,

Belvaux, le 3 juillet 2006.

 J.-J. Wagner.

78717

John Junghun Park, associate, born on March 20, 1981 in the State of Maryland, USA, residing at 3010 State Street,

Apt. 106, Dallas, TX 75204-3925, USA,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

May 25, 2006,

Olivier P. Vincent, sales man, born on April 10, 1964 in Antony (France), residing at 903 Turnberry LN, Southlake,

TX 76092-4230, USA,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

June 1, 2006,

WHISKEY TRAIL INVESTMENTS, LLC, a company established under the laws of the State of Oklahoma, with regis-

tered office at 16528 State Highway 53, Springer, OK 73458, USA, registered with the State of Oklahoma under tax
identification number 20-3895969,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

June 1, 2006,

- RICHARD M. AND CHERYL A. DAILEY TRUST, with registered office at 10353 Burned Oak Lane, Escondido, CA

92026, USA,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

June 2, 2006,

- THE MacDonald FAMILY TRUST, with registered office at 11116-33rd Avenue NW, Edmonton, AB T6J 3Y3, Can-

ada,

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of a power of attorney given on

May 26, 2006,

(collectively referred to as the Partners).
Said proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Partners, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. 100% of the share capital of HMTF CPD CANADA LUXCO, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 113.271, incorporated by a deed of the
replaced notary on December 15, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No. 672 of
April 1, 2006 (the Company), is represented at the present meeting. The articles of association of the Company (the
Articles) were amended pursuant to a deed of the replaced notary dated December 21, 2005, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, C number 1045 of May 30, 2006;

II. The Partners have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Partners resolve to waive the convening notices, the Partners having been duly convened and having perfect

knowledge of the agenda, which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Partners resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 650.- (six hundred fifty Euro)

to bring it from its present amount of EUR 142,500.- (one hundred forty-two thousand five hundred Euro) to EUR
143,150.- (one hundred forty-three thousand one hundred fifty Euro) and thus to issue 26 (twenty-six) new shares in
registered form of the Company with a par value of EUR 25.- each, having the same rights and obligations as the existing
shares of the Company.

<i>Declaration - Subscription - Payment

Thereupon, the Partners resolve to waive the preferential subscription rights they may have in respect of the issue

of the new shares.

There appeared:

- Ms Jennifer Anne Rikely, born on May 7, 1966 in Halifax (Canada), residing at A-4 1870 W 6th Avenue, Vancouver,

BC V6J 1R6, Canada, declares to subscribe for 1 (one) share and to fully pay it up by way of a contribution in cash in an
amount of EUR 25.- (twenty-five Euro) to be allocated to the nominal share capital account of the Company;

- Ms Raysa Evelyn Hidalgo Tejada, born on April 19, 1967 in V Altagracia (the Dominican Republic), residing at 808

909 Burrard Street, Vancouver, BC V6Z 2N2, Canada, declares to subscribe for two (2) shares and to fully pay them
up by way of a contribution in cash in an amount of EUR 50.- (fifty Euro) to be allocated to the nominal share capital
account of the Company;

- BVT ASSOCIATES, INC., with registered office at 56 Maple Avenue, Toronto, Ontario M4W 2T7, Canada, declares

to subscribe for 4 (four) shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash in an amount of EUR 100.-
(one hundred Euro) to be allocated to the nominal share capital account of the Company;

- Mr Cameron Mehlenbacher, born on March 8, 1961 in Hamilton (Canada), residing at 200 Panorama Rd., Lions Bay,

BC V0N 2E0, Canada, declares to subscribe for 1 (one) share and to fully pay it up by way of a contribution in cash in
an amount of EUR 25.- (twenty-five Euro) to be allocated to the nominal share capital account of the Company;

- Mr Peter Scott, born on December 31, 1958 in Winnipeg, Canada, residing at P.O. Box 896, Ft. Langley, BC V1M

253, Canada, declares to subscribe for 3 (three) shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash in an
amount of EUR 75.- (seventy-five Euro) to be allocated to the share capital account of the Company; and

78718

- LaVELLE INVESTMENTS, LLC, with registered office at 89697 Scheffler Rd, Elmira, OR 97437, USA, declares to

subscribe for 15 (fifteen) shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash in an amount of EUR 375.-
(three hundred seventy-five Euro) to be allocated to the nominal share capital account of the Company;

each being represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, by virtue of powers of attorney

which will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The amount of EUR 650.- (six hundred fifty Euro) is at the disposal of the Company, as has been proved to the un-

dersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Third resolution

As a result of the above share capital increase, the Partners resolve to amend the first paragraph of Article 5 of the

Articles which will henceforth read as follows:

«The Company’s corporate capital is set at EUR 143,150.- (one hundred forty-three thousand one hundred fifty Euro)

represented by 5,726 (five thousand seven hundred twenty-six) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all sub-
scribed and fully paid-up.»

<i>Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand eight

hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant nous, Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz (Luxembourg), agissant en remplacement de Maître

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

HMTF FUND V CAYMAN, L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au 36A

DR. Roy’s Drive, P.O. Box 1043GT, Grand Cayman, Iles Cayman, immatriculé au Registrar of Exempted Limited Par-
tnerships, sous le numéro CR-12476,

représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 26 mai 2006,

HM5-P COINVESTORS CAYMAN, L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social

au 36A DR. Roy’s Drive, P.O. Box 1043GT, Grand Cayman, Iles Cayman, immatriculé au Registrar of Exempted Limited
Partnerships sous le numéro CR-12473,

représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, agissant en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée le 29 mai 2006,

HM5-E COINVESTORS CAYMAN, L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social

au 36A DR. Roy’s Drive, P.O. Box 1043GT, Grand Cayman, Iles Cayman, immatriculé au Registrar of Exempted Limited
Partnerships sous le numéro CR-12692,

représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 26 mai 2006,

Monsieur Daniel J. Hopkin, Associé, né le 10 novembre 1977 dans l’Etat de l’Illinois, demeurant au 1052 Village

Parkway, Coppell, TX 75019, USA,

représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 24 mai 2006,

Monsieur Shi Zheng, Associé, né le 3 février 1978 à Jilin (Chine), demeurant au 2808 McKinney Avenue, Apt. 849,

Dallas, TX 75204-8613, USA,

représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 26 mai 2006,

Monsieur John Junghun Park, Associé, né le 20 mars 1981 dans l’Etat du Maryland, demeurant au 3010 State Street,

Appt. 106, Dallas, TX 75204-3925, USA,

représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 25 mai 2006,

Monsieur Olivier P. Vincent, vendeur, né le 10 avril 1964 à Antony (France), demeurant au 903 Turnberry LN, South-

lake, TX 76092-4230, USA, 

représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 1

er

 juin 2006,

WHISKEY TRAIL INVESTMENTS LLC, une société organisée selon les lois de l’Etat d’Oklahoma, avec siège social au

16528 State Highway 53, Springer, OK 73458, USA, immatriculée auprès de l’Etat d’Oklahoma sous le numéro d’iden-
tification fiscale 20-3895969, 

représentée par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 1

er

 juin 2006,

78719

- RICHARD M. AND CHERYL A. DAILEY TRUST, avec siège social au 10353 Burned Oak Lane, Escondido, CA

92026, USA

représentée par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 2 juin 2006,

- THE MacDonald FAMILY TRUST, avec siège social au 11116-33rd Avenue NW, Edmonton, AB T6J 3Y3, Canada,
représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 26 mai 2006,

(collectivement déginés les Associés).
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, ont demandé au notaire d’acter ce qui suit:
I. 100% du capital social de HMTF CPD CANADA LUXCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembour-

geoise, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.271, constituée suivant acte reçu par le notaire rem-
placé le 15 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N

°

 672 du 1

er

 avril 2006 (la

Société), est représenté à la présente assemblée. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire remplacé en date du 21 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C nu-
méro 1045 du 30 mai 2006;

II. les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, les Associés ayant été dûment convoqués et ayant

une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 650,- (six cent cinquante

euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 142.500,- (cent quarante-deux mille cinq cents euros) à EUR
143.150,- (cent quarante-trois mille cent cinquante euros) et par conséquent d’émettre 26 (vingt-six) nouvelles parts
sociales de la Société sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales de la Société déjà existantes.

<i>Déclaration - Souscription - Paiement

Les Associés décident de renoncer aux droits de souscription préférentielle qu’ils peuvent avoir concernant l’émis-

sion des nouvelles parts sociales.

Ont comparu:

- Madame Jennifer Anne Rikely, née le 7 mai 1966 à Halifax (Canada), demeurant au A4-1870 W 6th Avenue, Van-

couver, BC V6J 1R6, Canada, déclare souscrire à 1 (une) part sociale de la Société et de la libérer entièrement par un
apport en espèce s’élevant à EUR 25,- (vingt-cinq euros) à affecter au compte capital nominal de la Société;

- Madame Raysa Evelyn Hidalgo Tejada, née le 19 avril 1967 à V Altagracia (République Dominicaine), demeurant au

808 909 Burrard Street, Vancouver, BC V6Z 2N2, Canada, déclare souscrire à 2 (deux) parts sociales de la Société et
de les libérer entièrement par un apport en espèce s’élevant à EUR 50,- (cinquante euros), à affecter au compte capital
nominal de la Société;

- BVT ASSOCIATES, Inc., une société avec siège social au 56 Maple Avenue, Toronto, Ontario M4W 2T7, Canada,

déclare souscrire à 4 (quatre) parts sociales de la Société et de les libérer entièrement par un apport en espèce s’élevant
à EUR 100,- (cent euros), à affecter au compte capital nominal de la Société;

- Monsieur Cameron Mehlenbacher, né le 8 mars 1961 à Hamilton (Canada), demeurant au 200 Panorama Rd., Lions

Bay, BC V0N 2E0, Canada, déclare souscrire à 1 (une) part sociale de la Société et de la libérer entièrement par un
apport en espèce s’élevant à EUR 25,- (vingt-cinq euros) à affecter au compte capital nominal de la Société;

- Monsieur Peter Scott, né le 31 décembre 1958 à Winnipeg (Canada), demeurant à P.O. Box 896, Ft. Langley, BC

V1M 253, Canada, déclare souscrire à 3 (trois) parts sociales de la Société et de les libérer entièrement par un apport
en espèce s’élevant à EUR 75,- (soixante-quinze euros) à affecter au compte capital nominal de la Société; et

- LaVELLE INVESTMENTS, LLC, une société avec siège social au 89697 Scheffler Rd, Elmira, OR 97437, USA, déclare

souscrire à 15 (quinze) parts sociales de la Société et de les libérer entièrement par un apport en espèce s’élevant à
EUR 375,- (trois cent soixante-quinze euros) à affecter au compte capital nominal de la Société;

chacun étant représenté par Madame Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu de procura-

tions qui resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement. 

Le montant de EUR 650,- (six cent cinquante euros) est à la disposition de la Société, preuve en a été donnée au

notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Troisième résolution

En conséquence de l’augmentation du capital social ci-dessus, les Associés décident de modifier le premier paragraphe

de l’Article 5 des Statuts de sorte qu’il aura la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à EUR 143.150,- (cent quarante-trois mille cent cinquante euros) représenté

par 5.726 (cinq mille sept cent vingt-six) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.»

<i>Déclaration - Estimation des coûts

Le montant des dépenses relatives au présent acte est estimé à environ mille huit cents euros.

78720

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des parties

comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; et qu’à la demande des mêmes
comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite au représentant des parties comparantes, ledit représentant a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: S. Wolter, A. Holtz.
Enregistré à Mersch, le 16 juin 2006, vol. 437, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065962.3/242/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP SCS, Société en commandite simple.

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R. C. Luxembourg B 83.170. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés du 22 mars 2006

L’assemblée générale décide d’élire M. Dennis Roy Peterson, M. James William Lambert et Mme Jeanne Renée

Hernandez en tant que membres du Conseil de Surveillance dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02044. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064658.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP SCS, Société en commandite simple.

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R. C. Luxembourg B 83.170. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01971, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064607.7//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Mersch, le 28 juin 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP SCS
M. Martinez
<i>Gérant

J. Hernandez
<i>Director

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Sherpa S.A.

API Immobilière S.A.

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt S.A.

Soludec Development, S.à r.l.

Philippe Location et Services, S.à r.l.

Conventum Asset Management

Doranda S.A.

Caza Immo S.A.

MC Holding Participation S.A.

Sicris Immobilier S.A.

Sicris Immobilier S.A.

Auchan International S.A.

Auchan International S.A.

European Advisors of Transport S.A.

Particom Invest S.A.

Euroinvest (Czech 1), S.à r.l.

Dashabo

Euroinvest (Hungary 1), S.à r.l.

Euroinvest (Czech 3), S.à r.l.

Benchley Investments S.A.

Pusan S.A.

Société pour le Transport International de Conteneurs, S.à r.l.

Aesha S.A.

Abowijs International S.A.

Hams Hall Birmingham Nominee, S.à r.l.

Romada.Fi S.A.

Codemalux S.A.

Hams Hall Birmingham DC2, S.à r.l.

Balspeed Re S.A.

West Avenue Coventry DC7, S.à r.l.

Orlan Invest S.A.

Hurtigruta S.A.

Azur International, S.à r.l.

Hultet S.A.

Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A.

Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero I Alpha, S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero VI, S.à r.l.

HMTF CPD Canada Luxco, S.à r.l.

Koch Chemical Technology Group SCS

Koch Chemical Technology Group SCS