This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
76705
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1599
23 août 2006
S O M M A I R E
18 rue Godot de Mauroy «Paris 75009», S.à r.l.,
EM Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
76715
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76710
EM Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
76715
43 rue Descamps «Paris 75016», S.à r.l., Luxem-
Eurobeton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
76711
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76710
Europaring 5, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76708
ACP Venture A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
76708
Fridge Finance Company, S.à r.l., Luxembourg . .
76714
Aero International Finance S.A., Luxembourg . . . .
76706
G.T.V. S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76749
Aviation Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
76737
Goldford Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
76711
Aviation Finance S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . .
76736
Goldford Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
76711
Benetton Holding International N.V. S.A., Luxem-
Granilo Holding B.V., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . .
76724
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76741
Guillain Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
76707
Benetton International Property N.V. S.A., Lu-
Imagine Partners Invest S.A., Luxembourg . . . . . .
76707
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76709
Immo Belouzes S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76737
Benetton International Property N.V. S.A., Lu-
Industrie Nähmaschinen Holding S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76723
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76707
Benetton International S.A., Luxembourg . . . . . . .
76713
Ing Office Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Benetton Real Estate International S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76742
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76713
Intec Maritime Offshore Services Holding S.A.,
Benetton Real Estate International S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76721
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76719
Intec Maritime Offshore Services Holding S.A.,
Bienlux S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76724
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76721
Brideshead Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
76749
International Gas Distribution S.A., Luxembourg
76750
CAVEM - Centre Audio-visuel de l’Enseignement
International Gas Distribution S.A., Luxembourg
76750
Musical, S.à r.l. Pop-Music School Jean Roderes,
International Gas Distribution S.A., Luxembourg
76750
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76714
Internationale Participations Financières S.A., Lu-
California Lines Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
76722
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76724
CB Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76739
John Deere Cash Management S.A., Luxembourg
76715
Cencan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76752
Karlbo Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
76722
Central Africa Growth Sicar, S.A., Luxembourg . .
76719
Kent Inter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
76709
Circles Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
76739
Kent Inter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
76709
Compass Rose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
76716
Kent Investment Holding S.A., Luxembourg. . . . .
76708
Compass Rose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
76716
Key Largo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
76713
DB Platinum II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76720
Key West, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76723
DB Platinum III, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
76717
Looping International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
76751
DB Platinum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
76716
Looping International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
76751
Definlux DFL S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
76752
Lusofin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76751
Definlux DFL S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
76752
Lusofin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76751
Duscholux S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76719
Lux Code S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
76736
Duscholux S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76719
M’en Fous S.A. Immobilien Verwaltungsgesell-
Easy Hole Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76720
schaft, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76736
Eliade Invest S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
76741
Marbristone Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
76723
76706
NEW EXERCISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7651 Heffingen, 16A, am Duerf.
R. C. Luxembourg B 48.724.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01237, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
(052665.03/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
NEW EXERCISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7651 Heffingen, 16A, am Duerf.
R. C. Luxembourg B 48.724.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01254, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
(052661.03/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
AERO INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 32.378.
—
<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 13 mars 2006i>
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, la société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l.,
R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nom-
mée commissaire aux comptes (en remplacement de la société INTERAUDIT, S.à r.l.).
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00221. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052809.03/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
MB Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76739
Schrader Investments Luxembourg, S.à r.l., Sen-
MHP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76740
ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76738
MP Times, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76740
Spanish Property Investment S.A., Luxembourg. .
76718
N&W Finance Company (Luxembourg), S.à r.l.,
Spanish Property Investment S.A., Luxembourg. .
76718
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76714
Synteco Group S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
76723
Netview Real Estate S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
76718
Techpoint, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
76722
Netview Real Estate S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
76718
Tharros S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76717
New Exercise, S.à r.l., Heffingen . . . . . . . . . . . . . . .
76706
Tomkins American Investments, S.à r.l., Sennin-
New Exercise, S.à r.l., Heffingen . . . . . . . . . . . . . . .
76706
gerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76712
Parfid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76740
Tomkins Holdings Luxembourg, S.à r.l., Senninger-
PB Distributions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
76739
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76750
Periflex International Consulting S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76721
Tomkins Luxembourg, S.à r.l., Senningerberg . . . .
76738
Periflex International Consulting S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76721
Tomkins Overseas Financing, S.à r.l., Senninger-
Piranha, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
76722
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76710
Regency Resources S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
76741
Tomkins Overseas Holdings, S.à r.l., Senninger-
Regency Resources S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
76741
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76712
Safilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76714
Torpet International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
76723
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AERO INTERNATIONAL FINANCE S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
76707
INDUSTRIE NÄHMASCHINEN HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 5.621.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2006, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Charles Lambert Beauduin, 44D, Lennilsesteenweg, B-1500 Halle,
- Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
- Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
- COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
- COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Charles Lambert Beauduin, Administrateur,
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00156. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052260.03/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
GUILLAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 82.223.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08869, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052310.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
IMAGINE PARTNERS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 104.101.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 19 mai 2006i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs et de commissaire aux comptes de:
- Monsieur Francis Lagarde, administrateur-délégué;
- Monsieur Jean-François Guillaume, administrateur-délégué;
- Monsieur Maurice Houssa;
- MAZARS, commissaire aux comptes.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’assemblée générale à tenir en 2009.
Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05618. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059956.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.
<i>Pour INDUSTRIE NÄHMASCHINEN HOLDING
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Signature.
M. Houssa
<i>Administrateuri>
76708
ACP VENTURE A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
H. R. Luxemburg B 34.661.
—
Die ordentliche Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 1998 hat folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Gesellschaftsversammlung verlängert die Mandate von Herrn Peter Meiser, Herrn Dieter de Lazzer und Herrn
Gianfranco Apicella.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 16. Juni 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR06000. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059959.3/1682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.
EUROPARING 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.600,-.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 95.741.
—
Il résulte du Conseil de Gérance tenu au siège social en date du 28 avril 2006 de la société EUROPARING 5, S.à r.l.,
que les actionnaires ont pris la décision suivante:
- Démission du Commissaire aux Comptes suivant:
KPMG ACCOUNTANTS N.V., avec siège social 10-20, Burgemeester Rijnderslaan, 1185 MC Amstelveen, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05667. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060054.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.
KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 20.505.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 27 avril 2006, les mandats des
administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Monique Juncker, Administrateur;
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
Monsieur Gérard Birchen, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06200. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060213.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Für die Richtigkeit der Angaben
MAZARS (LUXEMBOURG)
Unterschrift
EUROPARING 5, S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Géranti>
<i>Pour KENT INVESTMENT HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
76709
KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.570.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 27 avril 2006, les mandats des
administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Monique Juncker, Administrateur;
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
Monsieur Gérard Birchen, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06204. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060283.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.570.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-
BR06206, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
(060340.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 89.123.
—
Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 4 mai 2006 que les personnes suivantes ont été renom-
mées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateur de la société:
- Monsieur Mauro Fava, Administrateur de sociétés, demeurant à Vicolo S. Antonino n.5/b, Tréviso, Italie;
- Monsieur Giuseppe Mazzocato, Administrateur de sociétés, demeurant au 12, rue J. Engling, L-1466 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg;
- Monsieur Pier Francesco Facchini, Administrateur de sociétés, demeurant à Viale Monfenera n.16/C, Tréviso, Italie.
Il résulte également de ladite assemblée que PricewaterhouseCoopers N.V., ayant son adresse à Amstelstation, Prins
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Pays-Bas, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comp-
tes de la société.
L’assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07006. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060421.3/4170/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
<i>Pour KENT INTER HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Senningerberg, le 20 juin 2006.
Signature.
76710
43 RUE DESCAMPS «PARIS 75016», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 89.573.
—
Suite à une augmentation de capital de la société PARIS PREMIER PROPERTIES, S.à r.l. en date du 24 janvier 2006,
Monsieur Adrien Labi a souscrit à cette augmentation par apport en nature et a apporté les 500 parts sociales qu’il
détenait dans la société 43 RUE DESCAMPS «PARIS 75016», S.à r.l.
La société PARIS PREMIER PROPERTIES, S.à r.l., ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-
bourg, est donc devenu l’Associé unique de la société 43 RUE DESCAMPS «PARIS 75016», S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07163. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060365.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
18 RUE GODOT DE MAUROY «PARIS 75009», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 104.848.
—
Suite à une augmentation de capital de la société PARIS PREMIER PROPERTIES, S.à r.l. en date du 24 janvier 2006,
Monsieur Adrien Labi a souscrit à cette augmentation par apport en nature et a apporté les 500 parts sociales qu’il
détenait dans la société 18 RUE GODOT DE MAUROY «PARIS 75009», S.à r.l.
La société PARIS PREMIER PROPERTIES, S.à r.l., ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-
bourg, est donc devenue l’Associée unique de la société 18 RUE GODOT DE MAUROY «PARIS 75009», S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07179. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060367.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
TOMKINS OVERSEAS FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 86.642.
—
EXTRAIT
En date du 21 février 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la démission de Monsieur Douglas Fran-
cis Sutherland, né le 7 juin 1956 dans l’Oregon (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 39, am Bounert, L-6975 Grand-
Duché du Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet au 31 mars 2006, et a décidé de nommer Mademoiselle
Géraldine Cassells, née le 23 octobre 1967 à Dublin (Irlande), résidant au 20, Domaine du Beauregard, L-8357 Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.
Par conséquent, du 21 février 2006 au 31 mars 2006, le conseil de gérance était composé comme suit:
- Mademoiselle Géraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, ayant son adresse à P.O. Box 297, 1180 AG Amstelveen, Pays-Bas,
- Monsieur Theodore Schartz, résidant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Douglas Francis Sutherland, prénommé.
Depuis le 1
er
avril 2006, les gérants de la société nommés pour une durée indéterminée sont:
- Mademoiselle Géraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, prénommé,
- Monsieur Theodore Schartz, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07027. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060402.3/4170/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
76711
EUROBETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.
R. C. Luxembourg B 53.950.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée des actionnaires de la Société en date du 6 avril 2006 que les actionnaires de la Société ont
pris acte de la démission de Monsieur Gaston Reinesch de sa fonction d’administrateur de la Société, avec effet immé-
diat.
Dès lors, les administrateurs de la Société sont:
- Norbert Becker, cadre dirigeant, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg et demeurant au 40, rue des Genêts, L-8131
Bridel,
- Marc Assa, cadre dirigeant, né le 31 janvier 1941 à Luxembourg, demeurant au 9, rue des Noyers, L-7303 Steinsel,
- Christian Weiler, cadre dirigeant, né le 21 mars 1960 à Bettembourg, demeurant au 35, rue Bocksberg, L-6614 Was-
serbillig, et
- Jean Pierre Vallée, cadre dirigeant, né le 12 février 1952 à Laval, France, demeurant au 3, allée Cassard, 44000 Nan-
tes, France.
Le mandat de ces administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice social se
clôturant le 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06998. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060381.3/4170/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
GOLDFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 104.362.
—
<i>Extrait du livre des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2006i>
L’Assemblée Générale a pris les décisions suivantes:
1) Renouvelle, à l’unanimité, le mandat des administrateurs suivants:
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique;
- Ekaterini Mouzaki, avocat, demeurant à Athènes, Grèce;
- Pagona Loutridou, employée privée, demeurant à Athènes, Grèce.
Leur mandat étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2007.
2) Renouvelle le mandat du Commissaire:
Georgios Georgiou-Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire 2007.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07544. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060826.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
GOLDFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 104.362.
—
Le bilan du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08737, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060819.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administrationi>
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
76712
TOMKINS OVERSEAS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 51.028.
—
EXTRAIT
En date du 21 février 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la démission de Monsieur Douglas Fran-
cis Sutherland, né le 7 juin 1956 dans l’Oregon (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 39, am Bounert, L-6975 Grand-
Duché du Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 mars 2006, et a décidé de nommer Mademoiselle
Geraldine Cassells, née le 23 octobre 1967 à Dublin (Irlande), résidant au 20, Domaine du Beauregard, L-8357 Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.
Par conséquent, du 21 février 2006 au 31 mars 2006, le conseil de gérance était composé comme suit:
- Mademoiselle Geraldine Cassells, prénommée;
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, ayant son adresse à P.O. Box 297, 1180 AG Amstelveen, Pays-Bas;
- Monsieur Theodore Schartz, résidant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, résidant à Swagermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, Pays-Bas;
- Monsieur Malcom Terence Swain, résidant au 19, Meadow Way, Rowledge Surrey, GU10 4DY, United Kingdom;
- Monsieur Douglas Francis Sutherland, prénommé.
Depuis le 1
er
avril 2006, les gérants de la société nommés pour une durée indéterminée sont:
- Mademoiselle Géraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, prénommé,
- Monsieur Theodore Schartz, prénommé,
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, prénommé,
- Monsieur Malcom Terence Swain, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07018. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060392.3/4170/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 86.645.
—
EXTRAIT
En date du 21 février 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la démission de Monsieur Douglas Fran-
cis Sutherland, né le 7 juin 1956 dans l’Oregon (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 39, am Bounert, L-6975 Grand-
Duché du Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 mars 2006, et a décidé de nommer Mademoiselle
Geraldine Cassells, née le 23 octobre 1967 à Dublin (Irlande), résidant au 20, Domaine du Beauregard, L-8357 Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.
Par conséquent, du 21 février 2006 au 31 mars 2006, le conseil de gérance était composé comme suit:
- Mademoiselle Geraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, ayant son adresse à P.O. Box 297, 1180 AG Amstelveen, Pays-Bas,
- Monsieur Theodore Schartz, résidant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, résidant à Swagermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, Pays-Bas,
- Monsieur Malcom Terence Swain, résidant à 19 Meadow Way, Rowledge Surrey, GU10 4DY, United Kingdom,
- Monsieur Douglas Francis Sutherland, prénommé.
Depuis le 1
er
avril 2006, les gérants de la société nommés pour une durée indéterminée sont:
- Mademoiselle Géraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, prénommé,
- Monsieur Theodore Schartz, prénommé,
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, prénommé,
- Monsieur Malcom Terence Swain, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07030. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060408.3/4170/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
76713
BENETTON REAL ESTATE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 79.876.
—
Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 4 mai 2006 que les personnes suivantes ont été renom-
mées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateur de la société:
- Monsieur Mauro Fava, Administrateur de sociétés, né le 14 janvier 1957 à Tréviso (Italie), demeurant à Vicolo S.
Antonino n.5/b, Tréviso, Italie;
- Monsieur Giuseppe Mazzocato, Administrateur de sociétés, né le 11 août 1958 à Montebelluna (Italie), demeurant
au 12, rue J. Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
- Monsieur Silvano Cassano, Administrateur de sociétés, né le 18 décembre 1956 à Argenta (FE-ltalie), demeurant au
146/6, via Schiavonia, Preganziol, Italie;
- Monsieur Pier Francesco Facchini, Administrateur de sociétés, né le 4 août 1967 à Lugo Di Romagna (Italie), de-
meurant à Viale Monfenera n.16/C, Tréviso, Italie.
Il résulte également de ladite assemblée que PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route
d’Esch, L-1014 Luxembourg a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société.
L’assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060412.3/4170/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
BENETTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 78.734.
—
Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 4 mai 2006 que les personnes suivantes ont été renom-
mées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateur de la société:
- Monsieur Massimo Branda, Administrateur de sociétés, né le 17 avril 1960 à Canelli (AT-ltalie), demeurant à Via
Manzoni n.25, Torino, Italie;
- Monsieur Mauro Fava, Administrateur de sociétés, né le 14 janvier 1957 à Tréviso (Italie), demeurant à Vicolo S.
Antonino n.5/b, Treviso, Italie;
- Monsieur Giuseppe Mazzocato, Administrateur de sociétés, né le 11 août 1958 à Montebelluna (Italie), demeurant
au 12, rue J. Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
- Monsieur Giancarlo Olgiati, Administrateur de sociétés, né le 1
er
juin 1938 à Cadenazzo (Suisse), demeurant à Via
Nassa 21, Lugano, Suisse;
- Monsieur Pier Francesco Facchini, Administrateur de sociétés, né le 4 août 1967 à Lugo Di Romagna (Italie), de-
meurant à Viale Monfenera n.16/C, Treviso, Italie.
Il résulte également de ladite assemblée que PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route
d’Esch, L-1014 Luxembourg a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la société.
L’assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07009. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060424.3/4170/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
KEY LARGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 103.837.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09428, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
(051840.03/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
Senningerberg, le 20 juin 2006.
Signature.
Senningerberg, le 20 mai 2006.
Signature.
<i>Pour KEY LARGO S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
76714
SAFILUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 24.581.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 juin 2006i>
L’assemblée nomme au poste de Commissaire aux Comptes la société IMMOLYS S.A., Société Anonyme, 4, rue Tony
Neuman, L-2241 Luxembourg en remplacement de Nathalie Jastrow démissionnaire.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02991. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060552.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
N&W FINANCE COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 102.111.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil de gérance du 14 juin 2006 i>
Le conseil de gérance de la Société décide à l’unanimité:
- d’approuver le transfert du siège social de la Société de L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll à L-1371
Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06932. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060589.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
FRIDGE FINANCE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FRIDGE FINANCE COMPANY S.A.).
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 70.970.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil de gérance du 14 juin 2006i>
Le conseil de gérance de la Société décide à l’unanimité:
- d’approuver le transfert du siège social de la Société de L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll à L-1371
Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06939. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060590.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
CAVEM - CENTRE AUDIO-VISUEL DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL, S.à r.l. POP-MUSIC SCHOOL
JEAN RODERES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2628 Luxembourg, 10, rue des Trévires.
R. C. Luxembourg B 20.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01129, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
(052027.03/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour copie conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
76715
EM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 81.492.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 16 juin 2006i>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des Administrateurs en fonction, à savoir:
- Monsieur René Küppers, demeurant au 31, Chemin Moise-Duboule, CH-1209 Genève, Suisse,
- Monsieur Helmut Stoefler, demeurant au 96, rue de Vigny, F-01220 Divonne-les-Bains, France,
- La société PROMIBEL FINANCIAL SERVICES CORP, ayant son siège social à Road Town, Tortola, PO Box 3161,
British Virgin Islands,
pour un nouveau terme d’un an, leur mandat viendra donc à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue
en 2007.
L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes actuellement en
fonction, HRT REVISION, S.à r.l., pour un nouveau terme d’un an. Son mandat viendra donc à échéance lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire tenue en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060602.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 101.957.
—
EXTRAIT
Par résolution en date du 23 mai 2006, le Conseil d’Administration de la Société:
(1) a noté la démission de Monsieur Steve Warren de son poste d’administrateur de la Société avec effet au 1
er
juin
2006 et
(2) a décidé de coopter avec effet au 16 mai 2006 Thomas Spitzfaden, né le 9 juillet 1956 à Cincinnati, Ohio (Etats-
Unis), résidant au 2726, 16th Avenue, Moline, Illinois, Etats-Unis, en vue d’exercer le mandat de l’administrateur démis-
sionnaire jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060689.3/1092/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
EM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 81.492.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06513, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(060391.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
<i>Pour EM FINANCE HOLDING S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pouri> <i>EM FINANCE HOLDING S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>D. Ransquin
76716
DB PLATINUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 104.413.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 26 mai 2006 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Yassine Bouhara,
DEUTSCHE BANK AG LONDON,
1, Great Winchester Street,
GB-London EC2N 2DB,
Monsieur Freddy Brausch,
ETUDE LINKLATERS LOESCH,
35, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Monsieur Werner Burg,
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.,
2, boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg,
Monsieur Frank Langer,
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT,
Grosse Gallusstrasse 10-14,
D-60311 Frankfurt am Main,
Monsieur Klaus-Michael Vogel,
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.,
2, boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg,
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007;
- de renouveler le mandat de:
ERNST & YOUNG,
Parc d’Activité Syrdall 7,
L-5365 Munsbach,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05151. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060932.3/1126/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
COMPASS ROSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.925.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07040, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060672.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
COMPASS ROSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.925.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07186, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060671.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
<i>Pour DB PLATINUM, Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
76717
DB PLATINUM III, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 107.709.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 26 mai 2006 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Yassine Bouhara,
DEUTSCHE BANK AG LONDON,
1, Great Winchester Street,
GB-London EC2N 2DB,
Monsieur Freddy Brausch,
ETUDE LINKLATERS LOESCH,
35, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Monsieur Werner Burg,
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.,
2, boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg,
Monsieur Frank Langer,
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT,
Grosse Gallusstrasse 10-14,
D-60311 Frankfurt am Main,
Monsieur Klaus-Michael Vogel,
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.,
2, boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg,
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007;
- de renouveler le mandat de:
ERNST & YOUNG,
Parc d’Activité Syrdall 7,
L-5365 Munsbach,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060934.3/1126/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
THARROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 110.507.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 juin 2006,
que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2011:
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à
Luxembourg;
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Michele Clerici, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6900
Lugano.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant au 26, Carabella, CH-6582 Piaezzo.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06623. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060777.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
<i>Pour DB PLATINUM III, Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
76718
SPANISH PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.594.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 19 juin 2006i>
Les mandats des administrateurs suivants: A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., et
A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., sont renouvelés pour
un nouveau terme statutaire de six années se terminant à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en l’an 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060836.3/813/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
SPANISH PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.594.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06948, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060817.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
NETVIEW REAL ESTATE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 64.878.
—
Gemäß Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft NETVIEW REAL ESTATE
S.A. vom 9. November 2005 wird das Mandat des Rechnungskommissars ABAX AUDIT sowie die Mandate der Verwal-
tungsratsmitglieder Hasim Bayram, Hakan Eroglu und Tahsin Yilmaz um ein Jahr verlängert.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06802. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060852.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
NETVIEW REAL ESTATE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 64.878.
—
Gemäß Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft NETVIEW REAL ESTATE
S.A. vom 7. Juni 2006 wird das Mandat des Rechnungskommissars ABAX AUDIT sowie die Mandate der Verwaltungs-
ratsmitglieder Hasim Bayram, Hakan Eroglu und Tahsin Yilmaz um ein Jahr verlängert.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06808. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(060862.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>A.T.T.C S.A. / A.T.T.C S.A.
<i>Géranti> / <i>Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-déléguéi> / <i>Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>A.T.T.C S.A. / A.T.T.C S.A.
<i>Géranti> / <i>Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-déléguéi> / <i>Administrateur-déléguéi>
H. Eroglu
<i>Direktori>
H. Eroglu
<i>Direktori>
76719
DUSCHOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 18.516.
Société constituée le 30 juin 1981 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n
°
222 du 16 octobre 1981.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises lors de l’assemblée générale du 13 juin 2006 que:
Le mandat de chacun des trois administrateurs, Messieurs Jean Wagener, Nico Scholtes et Jean-Pierre Weiler ainsi
que le mandat du réviseur d’entreprises, BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, sont reconduits pour une période d’une
année, soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2007.
Le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Nico Scholtes est également reconduit pour une année, soit jusqu’à
l’assemblée générale à tenir en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06949. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060842.3/279/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
DUSCHOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 18.516.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06937, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060783.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
BENETTON REAL ESTATE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 79.876.
—
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07047, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060163.3/4170/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
CENTRAL AFRICA GROWTH SICAR, S.A., Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.247.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2006i>
L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires reconduit jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
en mars 2007, les mandats d’administrateurs de Messieurs Bahadurali R. Jetha, Mohamadou Diop, Etienne Viard et
Edward Van Kleeck Jaycox.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061009.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Les statuts furent modifiés par Maître Reginald Neuman, le 28 avril 1982 (Mémorial C 181 du 28 juillet 1982), le
12 janvier 1983 (Mémorial C n
°
57 du 5 mars 1983), le 18 décembre 1991 (Mémorial C n
°
265 du 18 juin 1992),
le 19 avril 1994 (Mémorial C n
°
324 du 6 septembre 1994) et Ie 17 mai 2001 (Mémorial C n
°
1083 du 29 novembre
2001).
Pour extrait
J. Wagener
<i>Le mandatairei>
J. Wagener
<i>Le mandatairei>
Senningerberg, le 20 juin 2006.
Signature.
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and domiciliary agent
i>Signatures
76720
DB PLATINUM II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 99.199.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 28 avril 2006 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Yassine Bouhara,
DEUTSCHE BANK AG LONDON,
1, Great Winchester Street,
GB-London EC2N 2DB,
Monsieur Freddy Brausch,
ETUDE LINKLATERS LOESCH,
35, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Monsieur Werner Burg,
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.,
2, boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg,
Monsieur Frank Langer,
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT,
Grosse Gallusstrasse 10-14,
D-60311 Frankfurt am Main,
Monsieur Klaus-Michael Vogel,
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.,
2, boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg,
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007;
- de renouveler le mandat de:
ERNST & YOUNG,
Parc d’Activité Syrdall 7,
L-5365 Munsbach,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05152. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060944.3/1126/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
EASY HOLE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.709.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 mai 2006 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat d’Administrateur de:
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, 11, rue de Fischbach, Blaschette,
Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de sociétés, 92, rue de l’Horizon, Plateau St Hubert, Itzig,
COSAFIN S.A., Société Anonyme,
ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de:
Monsieur Pierre Schill, Licencié en Sciences Economiques, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale
qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02973. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061073.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
<i>Pour DB PLATINUM II, Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
76721
PERIFLEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.842.
—
Les actionnaires de PERIFLEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale an-
nuelle le 16 mai 2006 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et a l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ont accepté la démission de Madame Jacqueline Broere, demeurant à Patrijzenlaan 46, B-2010 Essen, Belgique,
comme administratrice de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Ont nommé Madame Marit Ahlvik, demeurant à Verbrandendijk 50, B-2070 Zwijndrecht, Belgique, comme adminis-
tratrice de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06535. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061066.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
PERIFLEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.842.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06537, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
INTEC MARITIME OFFSHORE SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.786.
—
Les actionnaires de INTEC MARITIME OFFSHORE SERVICES HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée gé-
nérale annuelle le 1
er
juin 2006 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et a l’unanimité ont pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ont accepté la démission de Madame Antoinette Faucheux de Bergerac, demeurant à Luxembourg, comme adminis-
tratrice de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant au 18, rue Gritt, L-6185 Gonderange,
comme administratrice de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06547. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061088.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
INTEC MARITIME OFFSHORE SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.786.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06548, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061089.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
PERIFLEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signatures.
INTEC MARITIME OFFSHORE SERVICES HOLDING S.A.
Signatures
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signatures.
76722
CALIFORNIA LINES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 81.122.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenuei>
<i>le 2 juin 2006 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005i>
<i>Conseil d’Administration:i>
Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67,
rue Michel Welter, Monsieur Angel Caschera, comptable, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter et
celui de la société @CONSEILS, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, arrivant
à leur terme, l’assemblée générale a décidé de les renouveler pour une période de 6 ans soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire annuelle de 2012.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Le mandant de commissaire aux comptes de la société READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxem-
bourg, 67, rue Michel Welter arrivant à son terme, l’assemblée générale a décidé de le renouveler pour une période de
6 ans soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06687. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060942.3/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
PIRANHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.650,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 89.513.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00902, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060968.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
TECHPOINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 93.637.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07494, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061002.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
KARLBO ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 67.935.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2006i>
L’assemblée générale extraordinaire a procédé à la nomination de Monsieur Pascal Fabeck, demeurant professionnel-
lement au 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, comme commissaire aux comptes. Son mandat
prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061154.3/050/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Luxembourg, le 2 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
R.P. Pels.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
B. Zech.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
76723
TORPET INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 93.279.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06882 et LSO-
BR06879, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061129.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
SYNTECO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 92.096.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06875 et LSO-
BR06874, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061131.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
KEY WEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 60.589.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06149, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060166.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 89.123.
—
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07044, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060167.3/4170/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
MARBRISTONE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.250.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05814, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2006.
(060172.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Signature.
Senningerberg, le 20 juin 2006.
Signature.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
76724
BIENLUX, Société Civile.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg E 1.061.
—
EXTRAIT
Suite à la dissolution en date du 25 mai 2004 de L.I.V. LUXEMBURGISCHE IMMOBILIEN-VERWALTUNG S.A., so-
ciété anonyme de droit luxembourgeois, R.C.S. Luxembourg B 56.877, sa participation détenue dans BIENLUX, a été
reprise par THEVIS COMMERCIAL LIMITED, IBC n
°
465486, avec siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street,
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01677. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053690.03/507/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
INTERNATIONALE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 107.585.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06737, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060119.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
GRANILO HOLDING B.V., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Amsterdam.
Effective management seat: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 116.802.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
SANDYCOVE N.V., a company incorporated and existing under the laws of Netherlands Antilles, having its statutory
seat and registered office at Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Curacao, the Netherlands Antilles and registered in the trade
register kept by the Chamber of Commerce and Industries at Curacao under number 52067, being the sole shareholder
of GRANILO B.V. with registered office in Amsterdam,
here represented by Mr Thomas Heyman, employee, residing professionally in Münsbach,
by virtue of a proxy established on November 24, 2005.
The appearing person, represented as stated here-above, requested the notary to act the ratification of the resolu-
tions taken by the extraordinary meeting of shareholders of the Company held before a Dutch civil Law Notary on
November 25, 2005, which resolved, among others:
(i) to transfer the principal establishment and effective place of business of the Company from The Netherlands to
Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and
(ii) to set the date of effectiveness of the said transfer from The Netherlands to Luxembourg at November 25, 2005.
The minutes of said resolutions of the sole shareholder, after signature ne varietur by the proxy holder of the ap-
pearing person and the notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxy, to be filed at the
same time with the registration authorities.
Thereupon, the appearing person, represented as stated here above, further requested the notary to state that:
I. The administrative and actual effective management seat of the Company is transferred from Amsterdam (The
Netherlands) to Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with effect on November 25, 2005; its registered office re-
maining in the Netherlands.
II. The Company will be submitted to Luxembourg laws as a legal entity situated in the Grand Duchy of Luxembourg
and adopt the Luxembourg nationality.
III. The Company adopts the form of a «société à responsabilité limitée».
IV. The address of the administrative and effective management seat is fixed at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
V. The balance sheet of the Company dated November 24, 2005 shall remain annexed to the present deed, as well
as a valuation certificate of the director of GRANILO HOLDING B.V. stating that the net worth of the Company is
estimated as per
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Signature.
76725
at one hundred and ten million seven hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-two United States
Dollars (USD 110,775,832.-) convert at ninety-three million eight hundred and seventy-eight thousand eighty-six Euro
and fifty-nine cents (EUR 93,878,086.59) at the exchange rate of 1.- USD = EUR 0.84746.
VI. The sole shareholder resolves to accept the resignation of MeesPierson INTERTRUST (AMSTERDAM) B.V. as
director of the Company as from the aforementioned date and to grant it discharge for the exercise of its mandate.
VII. The sole shareholder resolves to appoint as new members of the management board of the Company for an
unlimited duration as of November 25, 2005 the following persons:
- Mr Mohanan Aniyath, born on April 15th, 1969 in Kerala, India, residing at 218, Bin Humaidan Bldg., Al-Ghusais,
P.O. Box 61078, Dubai, United Arab Emirates, as category A managing director;
- Mr Romain Thillens, born on October 30th, 1952 in Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg residing at 46, route de
Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg, as category B managing director.
VIII. The Company proceeds with a restatement of its Articles of Association in order to bring them in conformity
with Luxembourg laws, which shall henceforth be worded as follows:
Name, duration, seat and objective
Art. 1.
1. The Company bears the name of GRANILO HOLDING B.V. (the «Company»).
2. The Company is formed for an unlimited period of time.
3. Its administrative and actual effective management seat is situated in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and its registered office is situated in Amsterdam, The Netherlands. The Company may set-up branches and sub-offices
elsewhere.
Art. 2.
The object of the Company is:
1. To acquire, run and alienate interests in, to finance, control and run, be joint-founder of; conduct the management
of, to give security in behalf of, to participate in and enter into communities of interest in combination with, and to pro-
vide service to other enterprises and non-profit organisations in whatever manner, irrespective of objective or legal
form.
2. To acquire and to alienate securities, real estate and other items of property and also to administer and invest
property in the widest sense.
3. To perform any activity within its objective, related to that objective in the widest sense of the word, both on its
own account as on account of third parties.
Capital and shares
Art. 3a.
1. a. The subscribed capital of the Company amounts to forty-five thousand Euro (EUR 45,000.-) divided into one
thousand (1,000) shares, each of forty-five Euro (EUR 45.-), all subscribed and entirely paid-up.
b. The authorized capital of the Company amounts to ninety thousand Euro (EUR 90,000.-) divided into two thousand
(2,000) shares of forty-five Euro (EUR 45.-) each.
c. Further issue of shares not subscribed for at the incorporation shall take place pursuant to a resolution adopted
by the general meeting of shareholders resolving in the manner provided for the amendment of the articles.
d. The general meeting of shareholders shall also state the price and the conditions of the issue in compliance with
the articles of association and arrange everything which has a bearing upon such a decision.
e. All shares issued by the Company need to be fully paid-up. The price of issue may not be below par value.
2. Upon the issue of shares every shareholder has a claimright in proportion to the number of shares already held by
him, subject to provisions in the law. The claim right is not transferable.
3. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 3b.
1. With due observance of the restriction laid down in article 4, the board of management is entitled to purchase
shares in the capital of the Company.
2. Such a purchase will not reduce the issued capital; the Company itself is the holder of these shares. However, the
voting and patrimonial rights are suspended for any share held by the Company, as long as it is held by the Company.
Art. 4.
1. The Company is only allowed to acquire shares in its own stock for free or when each and any of the following
requirements are fulfilled:
a. The Company’s equity reduced with the price to be paid is not less than the amount of its share capital paid in plus
the reserve funds required by the law or the articles.
b. The par value both of the shares to be acquired and/or the shares already held by the Company and its affiliated
companies together does not exceed ten per cent of the Company’s own stock.
c. The general shareholder’s meeting authorized the acquisition and agreed upon the price to be paid.
2. The validity of the acquisition is dependent from the amount of the Company’s own equity according to the last
approved balance sheet reduced with the consideration to be paid for the shares in its own stock and with the payments
out of profit or reserve funds to third parties which become due for the Company and its affiliated companies after the
date of the balance. Should a financial year be passed for over six months without the balance sheet being confirmed,
transfer as mentioned in paragraph 2 is not allowed.
76726
3. The former paragraphs do not apply to shares which acquired by the Company as general successor, except for
the above paragraph 1a.
Art. 5.
1. All shares will be registered shares. The shares will be numbered in the way determined by the board of manage-
ment.
2. Share certificates will not be issued.
Register of shareholders
Art. 6.
1. The management of the Company shall prepare a register containing completed and conformed copies of the con-
stitutive instrument of the Company and of the instruments amending said instruments and in which a list of the names,
professions and addresses of all shareholders shall be recorded.
All notices and convocations to shareholders pursuant to these articles of association shall be sent in writing to the
addresses listed in the register.
2. Said register must at all time be available for inspection by the persons entitled thereto at the office of the Com-
pany. Extracts from the said register shall be supplied free of charge.
3. Every shareholder shall be required to ensure that his address is known at the office of the Company. He himself
shall be responsible for the consequences resulting for him from non-compliance with this provision.
4. Each and any transfer and devolution of shares shall be noted in the register with mention of the date of transfer
or devolution. Such annotations shall be signed by a managing director.
Transfer and Devolution of shares
Art. 7.
The transfer of shares shall require a transfer deed executed by a civil law notary in The Netherlands and the service
of such deed upon the Company, or the written acknowledgement of the transfer by the Company upon production of
such a deed to the Company.
Art. 8.
1. Without prejudice of article 7 of the present articles, every transfer of shares otherwise than to a co-shareholder
or the Company, can only be made after the shares have been tendered for sale to the other shareholders in the manner
laid down hereinafter.
2. The shareholder hereinafter to be called the tenderer will notify the board of management of the number of shares
he wishes to transfer.
3. This notification will be regarded as a tender to the co-shareholders for sale of the shares. These co-shareholders
will only include the Company if the Company is the holder of shares in its own capital and if the tenderer has declared
in his tender to agree to this. Unless unanimously agreed upon otherwise by the shareholders the price will be fixed by
one or more independent experts to be appointed by the shareholders by mutual consultation.
If shareholders do not come to terms in this respect within fourteen days after receipt of the notification of the ten-
der referred to in paragraph 5 of this article, the willing party will request the Cantonal Court of the canton within which
the Company has its registered office in virtue of the articles of association to appoint three independent experts.
4. The experts referred to in the preceding paragraph will be entitled to inspect all the accounting records and vouch-
ers of the Company and to acquire any information, perusal of which may be useful for their appraisal.
5. The board of management will notify the co-shareholders of the tenderer of the tender within fourteen days after
receipt of the notification referred to in paragraph 2 and will subsequently notify all the shareholders of the price within
fourteen days after the board has been notified of the price fixed by the experts or of the price agreed upon by the
shareholders.
6. Contrary to the provisions of paragraph 8, the board of management will immediately notify the tenderer if, prior
to the period referred to there, all the co-shareholders have notified that the tender will not or will not fully be made
use of.
7. The shareholders wishing to buy the shares tendered will notify the board of management thereof within thirty
days after they have been notified of the price in accordance with paragraph 5.
8. The board of management will then reserve the shares tendered to the interested parties and will notify the ten-
derer and all the shareholders thereof within forty days after it has notified the shareholders of the price in accordance
with paragraph 5. If and as far as no shares have been allotted, the board of management will likewise notify the tenderer
and all the shareholders thereof within the said period.
9. In case two or more shareholders are interested in a number of shares exceeding the number of shares tendered,
the shares will be reserved by the board of management proportionate to the holdings of shares of the interested par-
ties. If a shareholder is interested in a lower number of shares than the number to which he would be entitled on the
basis of the proportion referred to, the shares hence becoming available will be reserved to the other interested parties
on the basis of the proportion referred to. Shares can only be reserved to the Company as far as the other co-share-
holders have not applied for them. As far as allotment on the basis of the standard referred to is not possible, lots will
be drawn to decide.
10. Once it is determined to whom the shares shall be transferred, the board of management will notify to all share-
holders the identity of the persons to whom the shares will be transferred and shall obtain, in the form of a circular
resolution as mentioned in article 18.6, or by holding a shareholder’s meeting, confirmation of approval to such transfer
from the shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company. No transfer of shares
will occur before this approval is obtained.
76727
11. The tenderer continues being entitled to withdraw his tender provided this is done within one month after he
has been notified of the name of the interested party to whom he can sell all the shares to which the tender relates and
at what price.
12. The shares bought shall be delivered against simultaneous payment of the purchase amount within eight days after
expiry of the period during which the tender can be withdrawn.
13. The tenderer may freely transfer the shares tendered within three months after he has been notified in accord-
ance with paragraph 6 or paragraph 8 that the tender has not or has not fully been made use of. Transfer to a third party
at a lower price than the value after it has been fixed in the manner laid down in paragraph 3, can only be made after
the shareholders have been granted an opportunity to exercise their pre-emptive right at such price as described here-
inbefore.
14. All communications and notifications mentioned in this article shall be sent by registered letter or against receipt.
15. The experts referred to in paragraph 3 will decide in fairness who will pay for the costs of the appraisal. They
may decide that they will be fully or partially for account of the Company.
16. The provisions of this article will be correspondingly applicable as much as possible to the alienation by the Com-
pany of Company shares bought by it or acquired in any other way.
Art. 9.
1. In the event of either one of the following instances of change of ownership:
a. devolution of shares, either in full or for an undivided part, other than as a result of transfer;
b. allocation of shares upon division and partition of any community of property,
the acquirer shall be deemed to have offered such shares for sale in the manner set forth in article 8, except, however,
that if the offer is accepted in full it cannot be withdrawn and that if shares are allocated to one or several persons who
together with the registered holder are joint owners of the same joint community of property, the holder concerned
shall have preference over the co-shareholders to take over the shares if he is still a shareholder on some other account.
2. Within two weeks after having received notice thereof the management must notify the other shareholders of any
devolution or allocation of shares as contemplated by paragraph 1 hereof.
3. The provisions of article 8 shall to the extent possible be of corresponding application.
Art. 10.
1. Articles 8 and 9 shall not apply to any transfer and any devolution of shares in respect of which all shareholders
have declared in writing that they do not wish the said articles to apply, and if such transfer and devolution has taken
place within three months following such declaration.
2. Article 8 shall not apply to transfers to the Company, except the provisions relating to the Company as expressly
stated in these
3. Article 9 shall not apply in the event of:
a. partial devolution by marriage with any community of property or by the death of the spouse of the holder;
b. division and partition of any community of property, insofar as an allocation is made to the registered holder.
4. In any situation of transfer of shares, the new shareholder shall address a notification letter to the Company stating
his name, profession, address, date of final acquisition of the shares and the number of shares he/she holds. Should the
new shareholder be a legal person, the necessary document(s) proving that the signatories of the letter can validly com-
mit the new shareholder will be joined to the notification letter.
Management
Art. 11.
1. The management of the Company is entrusted to the board of management consisting of one or more managing
directors. If several managing directors have been appointed, they will be appointed as managing director(s) of category
A or as managing director(s) of category B.
The managing directors will be appointed by the general meeting of shareholders and they may at any time be sus-
pended and dismissed by this meeting. The meeting of shareholders may appoint one or more managing directors to be
authorized managing director.
2. In the event of a managing director being absent or unable to attend, the other managing director(s) will tempo-
rarily be charged with the management and in the event of all the managing directors being absent or unable to attend,
the person annually to be designated for this purpose by the general meeting of shareholders will temporarily be charged
with the management. This person shall call a general meeting of shareholders as soon as possible in order to definitively
provide for the management. In the event of one or more managing directors but not all the managing directors being
absent or unable to attend, the general meeting of shareholders will be entitled to designate a person as referred to in
the preceding sentence who will in such case temporarily be charged with the co-management.
3. The remuneration of the managing directors will be determined by the general meeting of shareholders.
Representation
Art. 12.
1. The Company is managed by one or more managing directors. If the board of management consists of one person,
he alone will represent the Company. If the board of management consists of more than one person, the Company will
be validly committed towards third parties by the joint signature of two managing directors, with necessarily the signa-
ture of one category A managing director and one category B managing director, subject to the provision that, if one
or more managing directors has/have been appointed authorized managing director, every authorized managing director
will additionally be entitled independently to represent the Company in and out of court.
76728
2. In case of plurality of managing directors, the board of management can validly deliberate in the presence of at least
a majority of category A managing director and one category 6 managing director. The resolutions of the board of man-
agement shall be adopted by the majority of the managing directors present or represented at the meeting, with nec-
essarily a simple majority in each category of managing directors.
3. The meetings of the board of management will be held at the effective management seat of the Company, and if
not possible, exclusively on the territory of the Grand Duchy of Luxembourg.
4. In the event of all the managing directors being absent or unable to attend, the aforementioned person annually to
be designated for this purpose by the general meeting will alone represent the Company.
5. In all cases when the Company has a contradictory interest with that of one or more managing directors, the Com-
pany will nevertheless be represented in the manner described above. The managing director having a contradictory
interest shall however restrain himself from representing the Company for the concerned transaction.
6. The general meeting of shareholders is entitled to subject resolutions of the board of management to its approval,
such resolutions to be clearly described in a relative resolution of the meeting. However, the subject of a resolution to
the approval of the Shareholder’s meeting shall not cause nullity or suspension of the resolution of the directors if such
resolution is already validly adopted.
Annual account
Art. 13.
1. The financial year of the Company coincides with the calendar year unless decided otherwise by the general meet-
ing of shareholders held in front of a notary, upon a majority of shareholders representing three-quarters of the corpo-
rate capital, and which decision can only take effect after it has been filed as appropriate.
2. Annually, within five months after the end of the financial year of the Company, apart from extension of this period
to a maximum of six months by the general meeting on the ground of special circumstances, the board of management
will compile a balance sheet and a profit and loss account with explanatory memorandum, which documents will be sub-
mitted to the general meeting of shareholders.
Within the said period the board of management will also submit the annual report. The balance sheet, the profit and
loss account and the explanatory memorandum will be signed by all the managing directors. If any signature should be
lacking, the reason thereof will be stated.
3. The Company will see to it that the annual account compiled, the annual report will be present at its office from
the date of the convening notice for the general meeting destined to consider these documents. The shareholders and
other parties entitled may peruse the documents there and may obtain a copy thereof free of charge.
Art. 14.
Discharge from liability to the board of management for the management conducted by it during the past year will
be approved by a resolution of the shareholders meeting and will expressly stated in the minutes of that shareholders’
meeting.
Art. 15.
1. The profit will be available to the general meeting of shareholders, which meeting may destine the profit in part or
in full for the formation of or payment into one or more general or special reserve funds.
2. a. The Company may only pay benefits to shareholders and other claimants to the profit insofar as the Company’s
own equity exceeds the part of the share capital paid in plus the reserve funds to be kept in compliance with the law
and the articles.
b. Payment out of the profit shall be made after adopting the financial account showing that payment is permitted.
c. No profit on shares may be distributed to the Company itself.
3. The Company may only distribute interim dividend if the requirements in the paragraph 2. a. are met and the gen-
eral shareholders meeting has approved the distribution.
Art. 16. One month after fixation of the dividend, it will be available to the shareholders unless the general meeting
of shareholders determines a different period. Dividends not collected within five years after they were made available
will revert to the Company.
General meeting of shareholders
Art. 17.
1. The meetings of shareholders will be held in the place where the Company has its registered office or alternatively
administrative and actual effective management seat.
2. Annually, at a point of time to be fixed by the board of management, not later than within six months after the end
of the financial year, a general meeting of shareholders will be held.
The following items will be brought up for consideration in this meeting:
a. the balance sheet and the profit and loss account with explanatory memorandum;
b. the annual report;
c. vacancies will be filled;
d. the person referred to in article 11, paragraph 2, will be designated;
e. proposals placed on the agenda by the board of management or by shareholders representing at least one/tenth
part of the issued capital. Proposals of shareholders shall be submitted to the board of management before the conven-
ing of the meeting, with explanatory notes;
f. any other subjects brought up for consideration subject to the provision that no legally valid resolutions can be
passed as regards subjects not laid down in the convening notice or in a supplementary convening notice with due ob-
76729
servance of the period fixed for convening unless the resolution is passed unanimously in a meeting in which all the
shareholders will be present or represented.
Art. 18.
1. The resolutions of the general meeting of shareholders shall be taken by an absolute majority of votes, except when
these articles of association provide that a larger majority is required.
2. Votes concerning business matters shall be taken orally and votes concerning persons by means of a secret ballot.
If at the election of persons the absolute majority of votes are not obtained at the first ballot, a second vote shall be
taken between the two persons who have polled the largest number of votes.
3. In case of a draw at a vote concerning business matters, the proposal shall be rejected. In case of a draw at the
election of persons, a drawing of lots shall decide.
4. Blank votes (abstentions) shall be regarded as not having been cast.
5. Voting by acclamation shall be permitted, provided none of those present entitled to vote shall object.
6. If the number of shareholders is not superior to twenty-five, all resolutions to be passed in a general meeting of
shareholders can also be passed without a meeting being held, unless persons other than shareholders will have to be
called as well, provided all the shareholders have declared in writing to be in favor of the proposal.
Art. 19.
1. Shareholders will be called to attend a general meeting by the board of management by means of convening letters
to be sent at least fourteen days, exclusive of the day of convening and that of the meeting, prior to the day when the
general meeting will be held, to the addresses of the shareholders laid down in the register of shareholders.
2. The convening letters shall contain the subjects to be considered.
3. If the period of convening has not been observed or if no convening has taken place, no legally valid resolutions
can be passed unless this is done unanimously in a meeting in which all the shareholders and, if any, other persons who
should have been called to the meeting are present or represented.
4. In case one or more shares form part of an undivided community of property, the persons jointly entitled can only
have themselves represented towards the Company by one person to be designated in writing.
Art. 20. A managing director has the right to attend the general meeting of shareholders, he will have an advisory
vote as such.
Art. 21. Each share carries the right to cast one vote.
Art. 22. Extraordinary general meetings of shareholders shall be held as often as the management shall call such
meetings.
Art. 23.
1. The general meeting of shareholders will designate a chairman.
2. If no notarial record will be made out, the minutes of the proceedings of the general meeting of shareholders will
be signed by the chairman and a secretary appointed by the chairman and keeping the minutes.
Amendment of the articles of association and dissolution
1. Shareholders of the Company may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous vote.
2. Any other changes to the articles of association of the Company shall be resolved upon a majority of members
representing three-quarters of the corporate capital. However, in no case the majority may oblige any of the sharehold-
ers to increase its participation in the Company.
3. Simultaneously with the convening notice for a meeting to amend the articles of association, a copy of the proposal,
containing the verbatim text of the proposed amendment, shall be deposited at the office of the Company for inspection
by every shareholder till the end of the meeting.
Art. 25.
1. In case of dissolution of the Company, it will be liquidated by the board of management unless decided otherwise
by the general meeting of shareholders.
2. During the liquidation, the provisions of these articles of association will continue to be effective as much as pos-
sible. The relative provisions as regards managing directors will then be applicable to the liquidators.
3. A possible positive balance of the liquidation account will be paid out to the holders of shares proportionate to
their holdings of shares.
Cases not provided for
Art. 26. Within the limits laid down by law and these articles of association, the general meeting of shareholders
holds all powers not granted to other parties.
Art. 27. Reference is made to the provisions of the applicable law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at
The present transfer of the effective and actual management seat («principal établissement») of the Company out of
The Netherlands and the setting up of the effective and actual management seat in Luxembourg is not subject to the
pro-rata contribution duty in accordance with article 3-2 of the law of December 21, 1971.
76730
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zweitausendfünf, am fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
SANDYCOVE N.V., eine Gesellschaft gegründet nach und unterstellt dem Recht der Niederländischen Antillen, mit
Gesellschaftssitz in Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Curacao, The Netherlands Antilles und angemeldet beim Handelsre-
gister in Curacao unter der Nummer 52067, einziger Gesellschafter der Gesellschaft GRANILO HOLDING B.V. mit
Sitz in Amsterdam,
hier vertreten durch Herrn Thomas Heyman, Angestellter, berufsmäßig wohnhaft in Münsbach,
mittels einer am 24. November 2005 erteilten Vollmacht.
Die Erschienene, vertreten wie oben beschrieben, bittet den Notar, die Beschlüsse, die von der Generalversammlung
der Gesellschafter, die am 25. November 2005 in den Niederlanden vor einem Niederländischen Notar abgehalten wur-
de, gefasst wurden, zu beurkunden. Die Versammlung hat unter anderem beschlossen:
(i) den Verwaltungssitz und den aktuellen Sitz der effektiven Geschäftsleitung von den Niederlanden nach Münsbach,
Großherzogtum Luxemburg, zu verlegen, und
(ii) die genannte Verlegung von den Niederlanden nach Luxemburg für den 25. November 2005 für wirksam zu er-
klären.
Das Protokoll der genannten Beschlüsse des einzigen Gesellschafters soll nach ne varietur Unterzeichnung durch die
Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde beigefügt bleiben, um zusammen mit der
Vollmacht bei den Registrierungsbehören einregistriert zu werden.
Daraufhin bittet die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, den Notar festzuhalten, dass:
I. Der Verwaltungssitz und der aktuelle Sitz der Geschäftsleitung der Gesellschaft werden von Amsterdam (Die Nie-
derlande) nach Münsbach, Großherzogtum Luxemburg, mit Wirksamkeit zum 25. November 2005 übertragen. Der Ge-
sellschaftssitz der Gesellschaft bleibt in den Niederlanden.
II. Die Gesellschaft wird als juristische Person in Luxemburg Luxemburgischem Recht unterstellt und nimmt die Lu-
xemburgische Nationalität an.
III. Die Gesellschaft nimmt die Form einer «société à responsabilité limitée» an.
IV. Die Adresse des Verwaltungssitzes und des Sitzes der Geschäftsleitung werden festgelegt auf 22, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Münsbach.
V. Die Bilanz der Gesellschaft vom 24. November 2005 bleibt beiliegender Urkunde beigebogen sowie die Wertbe-
stimmungsbescheinigung des Verwaltungsratsmitgliedes der GRANILO HOLDING B.V., welcher bescheinigt dass der
Wert der Aktiva der Gesellschaft mindestens einhundertundzehn Millionen siebenhundertfünfundsiebzigtausendacht-
hundertzweiunddreißg US Dollar (USD 110.775.832,-) umgewandelt mittels Kurs von 1,- USD = EUR 0,84746 in drei-
undneunzig Millionen achthundertachtundsiebzigtausendsechsundachtzig Euro und neunundfünfzig Cent (EUR
93.878.086,59).
VI. Der einzige Gesellschafter, beschließt, den Rücktritt von MeesPierson INTERTRUST (AMSTERDAM) B.V. als Di-
rektor der Gesellschaft mit Wirkung zu dem oben genannten Datum anzunehmen und ihm für die Ausübung seines Man-
dates Entlastung zu erteilen.
VII. Der einzige Gesellschafter beschließt, die folgenden Personen als neue Mitglieder der Geschäftsführung für eine
unbestimmte Zeit mit Wirkung vom 25. November 2005 zu ernennen:
- Herr Mohanan Aniyath, geboren am 15. April 1969 in Kerala, India, wohnhaft in 218, Bin Humaidan Bldg., Al-Ghusais,
P.O. Box 61078, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, als Geschäftsführer der Kategorie A;
- Herr Romain Thillens, geboren am 30. Oktober 1952 in Wiltz, Großherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 46, route
de Luxemburg, L-7240 Bereldange, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Kategorie B.
II. Die Gesellschaft nimmt eine völlige Änderung ihrer Satzung vor, um sie in Übereinstimmung mit Luxemburgischen
Recht zu bringen. Die Satzung soll fortan folgenden Wortlaut haben:
Name, Dauer, Sitz und Gesellschaftzweck
Art. 1.
1. Die Gesellschaft trägt den Namen GRANILO HOLDING B.V. (die «Gesellschaft»).
2. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3. Ihr Verwaltungssitz und der aktuelle Sitz der Geschäftsleitung befinden sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg und ihr Gesellschaftssitz befindet sich in Amsterdam, den Niederlanden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassun-
gen und Büros an allen anderen Orten gründen.
Art. 2. Der Gesellschaftszweck der Gesellschaft ist:
1. Beteiligungen zu erwerben, zu betreiben und zu unterhalten, zu finanzieren, kontrollieren und zu betreiben, Mit-
gründer zu sein von, die Geschäftsführung zu übernehmen von, Sicherheiten zu übernehmen im Namen von, sich zu
beteiligen an und in gemeinsame Beteiligungen einzutreten in Kombination mit, und Dienstleistungen zu erbringen ge-
76731
genüber anderen Firmen und nonprofit Organisationen in welcher Art auch immer, unabhängig von dem Gesellschafts-
zweck oder der Rechtsform.
2. Sicherheiten zu erwerben oder zu halten, Grundbesitz und anderes Eigentum zu erwerben und Eigentum zu ver-
walten und darin zu investieren, im weitesten Sinne.
3. Jede Aktivität, die unter ihren Gesellschaftszweck fällt, in Verbindung mit diesem Gesellschaftszweck, im weiteten
Sinne des Wortes, steht, für sich und für andere auszuüben.
Kapital und Anteile
Art. 3a.
1. a) Das unterzeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundvierzigtausend Euro (EUR 45.000,-) aufgeteilt in ein-
tausend (1.000) Anteile, mit einem Wert von je fünfundvierzig Euro (EUR 45,-), alle gezeichnet und voll einbezahlt.
b) Das autorisierte Kapital der Gesellschaft beträgt neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-), aufgeteilt in zweitausend
(2.000) Anteile von je fünfundvierzig Euro (EUR 45,-).
c) Die Ausgabe von Anteilen die nicht bei Gründung der Gesellschaft ausgegeben werden, findet in Folge von Be-
schlüssen, die von der Generalversammlung der Gesellschafter gefasst werden, zu den Bedingungen, wie sie für die Ab-
änderung der Satzung vorgesehen sind, statt.
d) Die Generalversammlung der Gesellschafter legt auch den Preis und die Bedingungen der Ausgabe von Anteile in
Übereinstimmung mit der Satzung fest und arrangiert alles, was Einfluss auf eine solche Entscheidung hat.
e) Alle Anteile, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, müssen voll eingezahlt werden. Der Ausgabepreis darf
nicht unterhalb des Nominalwertes liegen.
2. Bei Ausgabe von Anteilen hat jeder Anteilinhaber ein Zeichnungsvorzugsrecht im Verhältnis zu den von ihm bereits
gehaltenen Anteilen; die geltenden Rechtsbestimmungen finden hierauf Anwendung.
3. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen
ist. Gemeinsame Eigentümer müssen eine Person als Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.
Art. 3b.
1. Unter genauer Einhaltung der Einschränkungen, die Artikel 4. vorsieht, ist die Geschäftsführung berechtigt, Anteile
der Gesellschaft zu kaufen.
2. Dieser Kauf führt nicht zu einer Verminderung des ausgegebenen Stammkapitals. Jedoch werden die Stimm- und
Vermögensrechte für jeden von der Gesellschaft gehaltenen Anteil so lange ausgesetzt, wie der Anteil von der Gesell-
schaft gehalten wird.
Art. 4.
1. Die Gesellschaft ist nur berechtigt, Anteile für ihr eigenes Vermögen zu erwerben, wenn diese kostenlos sind oder
wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Die Eigenmittel der Gesellschaft, die um den Verkaufspreis reduziert werden, dürfen nicht geringer als der Betrag
des eingezahlten Kapitals, der um die gesetzliche Rücklage erhöht wird, sein.
b) Der Nennwert der zu erwerbenden Anteile und/oder der schon von der Gesellschaft und verbundenen Unter-
nehmen gehaltenen Anteile überschreitet nicht zehn Prozent der Eigenmittel der Gesellschaft.
c) Die Generalversammlung der Gesellschafter hat den Erwerb genehmigt und dem Kaufpreis zugestimmt.
2. Die Wirksamkeit dieses Erwerbs hängt ab von dem Wert der Eigenmittel, wie er durch die letzte Bilanz ausgewie-
sen wird, vermindert um die Gegenleistung, die für ihre eigenen Anteile geleistet wird und um die Zahlungen aus den
Gewinnen oder der Reserve an Dritte, welche die Gesellschaft und mit ihr verbundene Unternehmen nach dem Datum
der Bilanz schulden. Wenn ein Geschäftsjahr seit mehr als sechs Monaten abgeschlossen worden ist, ohne dass die Bilanz
bestätigt wurde, ist die in Absatz 2. genannte Übertragung nicht gestattet.
3. Der vorstehende Absatz findet keine Anwendung auf Anteile, die von der Gesellschaft in Generalrechtsnachfolge
erworben werden, mit Ausnahme von Absatz 1a.
Art. 5.
1. Alle Anteile sind Namensanteile. Die Anteile werden in einer Reihenfolge, die von der Geschäftsführung festgelegt
wird, numeriert.
2. Anteilszertifikate werden nicht erteilt.
Gesellschafterregister
Art. 6.
1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft soll ein Register führen, das vollständige und bestätigte Kopien der Grün-
dungssatzung der Gesellschaft und aller die Satzung ändernden Urkunden enthält und in dem eine Liste von den Namen,
Berufen und Adressen aller Anteilsinhaber geführt werden soll.
Alle Mitteilungen und Einberufungen, die den Anteilsinhabern entsprechend dieser Satzung zugestellt werden, müssen
schriftlich an die in dem Register aufgeführten Adressen gesandt werden.
2. Das genannte Register muss jederzeit zur Einsichtnahme von den hierzu berechtigten Personen am Gesellschafts-
sitz zur Verfügung stehen. Auszüge aus dem genannten Register müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
3. Jeder Anteilsinhaber muss sicherstellen, dass seine Adresse an dem Gesellschaftssitz der Gesellschaft bekannt ist.
Er selbst ist für die Konsequenzen, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Vorschrift ergeben, verantwortlich.
4. Jede Übertragung von Anteilen muss in dem Register unter Angabe des Datums der Übertragung vermerkt werden.
Solche Vermerke müssen von einem geschäftsführenden Geschäftsführer unterzeichnet werden.
76732
Übertragung und Übergang von Anteilen
Art. 7.
Die Übertragung von Anteilen benötigt eine Übertragungsurkunde, die von einem bürgerlich-rechtlichen Notar in
den Niederlanden beurkundet werden muss und die Zurverfügungstellung einer solchen Urkunde gegenüber der Ge-
sellschaft oder ein durch die Gesellschaft bei Vorlage einer solchen Urkunde gegenüber der Gesellschaft schriftlich er-
teiltes Einverständnis mit der Übertragung.
Art. 8.
1. Unter Vorbehalt von Artikel 7. der vorliegenden Satzung kann die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschaf-
ter nur erfolgen, nachdem die Anteile zum Verkauf durch die anderen Gesellschafter in der nachfolgend festgelegten
Weise freigegeben worden sind.
2. Der Gesellschafter, der nachfolgend Anbieter genannt wird, teilt der Geschäftsführung die Anzahl der Anteile, die
er zu übertragen wünscht, mit.
3. Diese Mitteilung wird als Angebot zum Verkauf der Anteile an die Mitgesellschafter betrachtet. Die Mitgesellschaf-
ter werden die Gesellschaft nur miteinbeziehen, wenn die Gesellschaft eigene Anteile am Stammkapital hält und wenn
der Anbieter in seinem Angebot dem zustimmt. Wenn nicht einstimmig oder anders von den Gesellschaftern zuge-
stimmt, wird der Preis durch einen oder mehrere unabhängige Sachverständige, die von den Gesellschaftern gemeinsam
ernannt werden, festgelegt.
Wenn die Gesellschafter sich in dieser Hinsicht nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt der in Absatz 5. dieses
Artikels genannten Mitteilung einig werden, beantragt die gewillte Partei beim Kantonalen Gericht des Bezirks, in dem
die Gesellschaft ihren Gesellschaftssitz hat, gemäß der Satzung drei unabhängigen Sachverständigen zu beauftragen.
4. Die Sachverständige, die in dem vorstehenden Abschnitt genannt werden, sind berechtigt, in alle Buchführungsun-
terlagen und Belege der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und alle Informationen zu erwerben, deren Durchsicht für ihre
Bewertung nützlich sein könnte.
5. Die Geschäftsführung wird die Mitgesellschafter von dem Angebot des Anbieters innerhalb von vierzehn Tagen
nach Erhalt der in Abschnitt zwei genannten Mitteilung benachrichtigen und wird im Anschluss daran alle Gesellschafter
von dem Preis benachrichtigen und zwar innerhalb von vierzehn Tagen, nachdem der Geschäftsführung der von dem
Sachverständigen festgelegte Preis oder der Preis auf den sich die Gesellschafter geeinigt haben mitgeteilt worden ist.
6. Im Gegensatz zu den Vorschriften von Absatz 8., benachrichtigt die Geschäftsführung dem Anbietenden sofort,
wenn vor dem dort angegebenen Datum alle Mitgesellschafter mitgeteilt haben, dass von dem Angebot nicht oder nicht
vollständig Gebrauch gemacht werden wird.
7. Die Gesellschafter, welche die angebotenen Anteile erwerben möchten, werden dies der Geschäftsführung inner-
halb von dreißig Tagen, nachdem ihnen der Preis in Übereinstimmung mit Absatz 5. mitgeteilt worden ist, mitteilen.
8. Die Geschäftsführung wird dann die angebotenen Anteile für die interessierten Parteien reservieren und den An-
bietenden und alle Gesellschafter innerhalb von vierzig Tagen, nachdem sie den Gesellschaftern den Preis in Überein-
stimmung mit Absatz fünf mitgeteilt hat, informieren. Wenn und insofern nicht alle Anteile zugewiesen worden sind,
informiert die Geschäftsführung den Anbieter und alle Gesellschafter hierüber innerhalb des genannten Zeitraumes.
9. Wenn zwei oder mehr Gesellschafter an einer Anzahl an Anteilen interessiert sind, welche die Anzahl der ange-
botenen Anteile überschreitet, werden die Anteile von der Geschäftsführung im Verhältnis zu den von den von den in-
teressierten Parteien gehaltenen Anteilen reserviert. Wenn ein Gesellschafter an einer geringeren Anzahl von Anteilen
interessiert ist als die Anzahl, zu der er aufgrund des genannten Verhältnisses berechtigt wäre, werden die verfügbar
gewordenen Anteile für die anderen interessierten Parteien auf der Grundlage des genannten Verhältnisses reserviert.
Anteile können für die Gesellschaft nur reserviert werden, soweit die anderen Mitgesellschafter sich nicht um sie be-
worben haben. Soweit eine Zuweisung auf der genannten Grundlage nicht möglich ist, entscheidet das Los.
10. Wenn einmal bestimmt ist, an wen die Anteile übertragen werden, teilt die Geschäftsführung allen Gesellschaftern
die Identität der Personen, denen die Anteile übertragen werden, mit und erhält in Form eines Umlaufbeschlusses gemäß
Artikel 18.6 oder durch Abhaltung eines Aktionärstreffens Genehmigung einer solchen Übertragung durch die Gesell-
schafter, die mindestens drei viertel des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Es erfolgt keine Übertragung
von Anteilen bevor diese Genehmigung nicht erteilt ist.
11. Der Anbieter ist weiterhin berechtigt, sein Angebot zurückzuziehen, vorausgesetzt dies erfolgt innerhalb eines
Monats nachdem ihm der Name der interessierten Partei an die er die Anteile veräußern kann und der Preis mitgeteilt
worden ist.
12. Die erworbenen Anteile werden gegen gleichzeitige Zahlung der Kaufpreissumme innerhalb von acht Tagen nach
Ablauf des Zeitraums während dessen das Angebot zurückgezogen werden kann, geliefert.
13. Der Anbieter kann angebotene Anteile innerhalb von drei Monaten nachdem ihm in Übereinstimmung mit Absatz
6. oder Absatz 8. mitgeteilt wurde, dass von dem Angebot ganz oder teilweise kein Gebrauch gemacht worden ist, frei
übertragen. Die Übertragung an einen Dritten zu einem geringeren Preis als der Wert, der in der in Absatz 3. festge-
legten Weise bestimmt wurde, kann nur erfolgen, nachdem die Gesellschafter die Möglichkeit hatten, ihr Vorzugsrecht
zu einem wie oben beschriebenen Preis, auszuüben.
14. Alle Informationen und Mitteilungen, die in diesem Artikel erwähnt werden, müssen durch eingeschriebenen Brief
oder gegen Empfangsbestätigung erfolgen.
15. Die in Absatz 3. genannten Sachverständigen entscheiden von Rechts wegen, wer für die Kosten des Gutachtens
aufkommen muss. Sie können entscheiden, dass sie vollständig oder teilweise der Gesellschaft auferlegt werden.
16. Die Vorschriften dieses Artikels sind soweit wie möglich auf die Veräußerung von Anteilen der Gesellschaft, die
von ihr gekauft oder auf andere Weise erworben wurden, durch die Gesellschaft entsprechend anwendbar.
76733
Art. 9.
1. Wenn einer der folgenden Fälle des Eigentümerwechsels vorliegt:
a) völliger oder teilweise Übergang von Anteilen auf andere Art als durch Übertragung;
b) Vergabe von Anteilen aufgrund von Teilung und Teilung einer Eigentümergemeinschaft;
wird der Erwerber so behandelt als habe er solche Anteile zum Verkauf in der Art und Weise wie sie Artikel 8. vor-
sieht angeboten, außer, jedoch, wenn das Angebot vollständig angenommen worden ist und es nicht mehr zurückgezo-
gen werden kann und wenn Anteile an einen oder mehrere Personen, die zusammen mit dem Inhaber des Namensanteils
gemeinsame Eigentümer der gleichen Eigentümergemeinschaft sind; der betroffene Halter soll den Vorzug vor den ge-
meinsamen Anteilsinhaber haben um die Anteile zu übernehmen wenn er noch Gesellschafter eines anderen Kontos ist.
2. Innerhalb von zwei Wochen nach dem Erhalt der Mitteilung teilt die Geschäftsführung den anderen Gesellschaftern
jede Übertragung oder Veräußerung von Anteilen wie in Absatz 1. dargelegt, mit.
Art. 10.
1. Artikel 8. und 9. sind nicht anwendbar auf alle Übertragungen und Veräußerung von Anteilen wenn alle Gesellschaf-
ter schriftlich erklärt haben, dass sie nicht wünschen, dass die genannten Artikel Anwendung finden und wenn eine sol-
che Übertragung und Veräußerung innerhalb von drei Monaten, die einer solchen Mitteilung folgen, stattgefunden hat.
2. Artikel 8. findet keine Anwendung auf die Übertragung an die Gesellschaft, mit Ausnahme der Vorschriften, die
sich auf die Gesellschaft beziehen, wie ausdrücklich in diesen festgestellt wird.
3. Artikel 9. findet keine Anwendung, im Falle von:
a) teilweiser Übertragung durch Heirat mit einer anderen Eigentümergemeinschaft oder durch Tod des Ehegatten/
der Ehegattin des Anteilsinhabers;
b) Aufteilung und Teilung einer Eigentümergemeinschaft, soweit die Zuteilung an den Inhaber des Namensanteils er-
folgt.
4. In jedem Fall der Übertragung von Anteilen, muss der neue Gesellschafter eine Mitteilung an die Gesellschaft mit
seinem Namen, Beruf, Anschrift, Datum des letztendlichen Erwerbs der Anteile und der Anzahl der Anteile die er/sie
hält, adressieren. Wenn der neue Gesellschafter eine Gesellschaft ist, müssen die notwendigen Dokumente, die bewei-
sen, dass die Unterzeichner der Mitteilung den neuen Gesellschafter wirksam verpflichten können, der Mitteilung bei-
gefügt werden.
Management
Art. 11.
1. Das Management der Gesellschaft wird der Geschäftsführung anvertraut, die aus einem oder mehreren Geschäfts-
führern besteht. Wenn mehrere Gesellschafter ernannt worden sind, werden sie als Geschäftsführer der Kategorie A
oder als Geschäftsführer der Kategorie B ernannt. Die Geschäftsführer werden von der Generalversammlung der Ge-
sellschafter ernannt und können jederzeit von dieser Versammlung suspendiert und entlassen werden. Die Versammlung
der Gesellschafter kann einen oder mehrere Geschäftsführer als autorisierte Geschäftsführer ernennen.
2. Wenn ein Geschäftsführer abwesend oder in der Teilnahme verhindert ist, wird der/die andere(n) Geschäftsführer
zeitweise mit der Geschäftsführung betraut und wenn alle Geschäftsführer abwesend oder in der Teilnahme verhindert
sind, wird die Person, die jährlich zu diesem Zweck von der Generalversammlung ernannt wird, mit der Geschäftsfüh-
rung betraut. Diese Person soll so bald wie möglich eine Generalversammlung der Gesellschafter einberufen um definitiv
für die Geschäftsführung zu sorgen. Wenn einer oder mehrere Geschäftsführer abwesend oder in der Teilnahme ver-
hindert sind, ist die Generalversammlung der Aktionäre berechtigt, eine Person, auf die in dem vorhergehenden Satz
Bezug genommen wird, vorübergehend mit der Mitgeschäftsführung zu betrauen.
3. Die Bezahlung der Geschäftsführer wird durch die Generalversammlung der Gesellschafter festgelegt.
Vertretung
Art. 12.
1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Wenn die Geschäftsführung aus mehr
als einer Person besteht, wird die Gesellschaft wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch die gemeinsame Unter-
schrift von zwei Geschäftsführern mit notwendig der Unterschrift eines Geschäftsführers, unter der Voraussetzung dass
wenn einer oder mehrere Geschäftsführer als ermächtigter Geschäftsführer ernannt wurde/n, jeder ermächtige Ge-
schäftsführer zusätzlich berechtigt ist, die Gesellschaft allein vor und außerhalb von einem Gericht zu vertreten.
2. Im Fall der Mehrheit von Geschäftsführern kann die Geschäftsführung wirksam beraten in der Anwesenheit von
einer Mehrheit eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B. Die Beschlüsse der
Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der anwesenden oder bei der Versammlung vertretenen Geschäftsführer
gefasst, mit notwendig einer einfachen Mehrheit in jeder Kategorie von Geschäftsführern.
3. Die Versammlungen der Geschäftsführung werden am Sitz der Geschäftsleitung der Gesellschaft abgehalten, und
wenn dies nicht möglich ist, ausschließlich auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg.
4. Wenn alle Geschäftsführerabwesend oder in der Teilnahme verhindert sind, kann die oben genannte, jährlich zu
diesem Zweck durch die Generalversammlung ermächtigte Person allein die Gesellschaft vertreten.
5. Immer wenn die Gesellschaft ein widerstreitendes Interesse mit dem Interesse eines oder mehrerer Gesellschaf-
ter(s) hat, wird die Gesellschaft dennoch in der oben beschriebenen Weise vertreten. Der Geschäftsführer, der ein wi-
derstreitendes Interesse hat, muss selbst davon absehen, die Gesellschaft bei der betroffenen Transaktion zu vertreten.
6. Die Generalversammlung der Gesellschafter ist berechtigt, Beschlüsse der Geschäftsführung seiner Genehmigung
zu unterwerfen. Solche Beschlüsse müssen in dem jeweiligen Beschluss der Versammlung deutlich beschrieben werden.
Jedoch bewirkt die fehlende Zustimmung durch die Generalversammlung der Gesellschafter nicht die Nichtigkeit oder
schwebende Unwirksamkeit der Beschlüsse der Geschäftsführer, wenn solch ein Beschluss bereits wirksam gefasst wor-
den ist.
76734
Jährliche Konten
Art. 13.
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft fällt mit dem Kalenderjahr zusammen wenn nichts anderes von einer vor einem
Notar abgehaltenen Versammlung der Gesellschafter durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die drei viertel des
Stammkapitals repräsentieren, beschlossen wurde; diese Entscheidung kann nur Wirksamkeit entfalten, nachdem sie wie
angemessen beantragt wurde.
2. Jährlich, innerhalb von fünf Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres, unabhängig von der Ausdehnung dieses
Zeitraumes auf ein Maximum von sechs Monaten durch die Generalversammlung auf der Grundlage besonderer Um-
stände, stellt die Geschäftsführung eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung mit erläuterndem Bericht auf. Die-
se Dokumente werden der Generalversammlung der Gesellschafter vorgelegt. Innerhalb des genannten Zeitraumes
wird die Geschäftsführung auch den Jahresbericht vorlegen. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der er-
läuternde Bericht werden von allen Geschäftsführern unterzeichnet. Wenn eine Unterschrift fehlt, muss hierfür der
Grund festgehalten werden.
3. Die Gesellschaft wird dafür sorgen dass die Jahreskonten erstellt und der Jahresbericht in ihrem Büro ab dem Zeit-
punkt der Einberufungsmitteilung für die Generalversammlung die dazu bestimmt ist, diese Dokumente zu betrachten,
ausgelegt wird. Die Gesellschafter und andere berechtige Dritte können dort in die Dokumente Einsicht nehmen und
eine kostenlose Kopie hiervon erhalten.
Art. 14.
Entlastung von der Haftung der Geschäftsführung für die Leitung der während des letzten Jahres durchgeführten Ge-
schäfte wird erteilt durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter und wird ausdrücklich festgehalten im
Protokoll der Generalversammlung der Gesellschafter.
Art. 15.
1. Der Gewinn wird der Generalversammlung der Gesellschafter verfügbar sein, welche den Gewinn teilweise oder
ganz für die Bildung oder Einzahlung in eine oder mehrere allgemeine oder spezielle Kapitalrücklagen bestimmen wird.
2. a) Die Gesellschaft kann Gewinne an Gesellschafter oder an andere Anspruchsberechtigte auszahlen, insoweit das
Vermögen der Gesellschaft den Anteil des eingezahlten Stammkapitals plus die Rücklagen, die in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften und der Satzung gebildet werden müssen, überschreitet.
b) Zahlungen aus dem Gewinn erfolgen nach Annahme der Jahresabschlusskonten die zeigen, dass die Zahlung gestat-
tet ist.
c) Kein Gewinn auf Anteile kann an die Gesellschaft selbst ausgeschüttet werden.
3. Die Gesellschaft kann Zwischendividenden ausschütten, wenn die Anforderungen des Absatzes 2a erfüllt sind und
die Generalversammlung der Gesellschafter zugestimmt hat.
Art. 16. Einen Monat nach Festlegung der Dividende, wird diese den Gesellschaftern zur Verfügung stehen, wenn
nicht die Generalversammlung der Gesellschafter einen bestimmten Zeitraum festlegt. Dividenden, die innerhalb von
fünf Jahren nachdem sie zur Verfügung standen, nicht eingezogen worden sind, werden der Gesellschaft zurückerstattet.
Generalversammlung der Gesellschafter
Art. 17.
1. Die Versammlungen der Gesellschafter wird an dem Ort abgehalten werden, wo die Gesellschaft ihren Gesell-
schaftssitz hat oder alternativ Ihren Verwaltungssitz oder ihren aktuellen Sitz der Geschäftsleitung hat.
2. Jährlich, zu einem Zeitpunkt, der von der Geschäftsführung festgelegt wird, und nicht später als sechs Monate nach
dem Ende des Geschäftsjahres, wird eine Generalversammlung der Gesellschafter abgehalten.
Die folgenden Punkte werden bei dieser Versammlung zur Diskussion gestellt:
a. die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit erläuterndem Bericht;
b. der Jahresbericht;
c. offene Stellen werden besetzt;
d. die Personen, auf die in Artikel 11., Absatz 2. Bezug genommen wird, werden ernannt;
e. Vorschläge die von der Geschäftsführung oder von Gesellschaftern die mindestens ein zehntel des ausgegebenen
Kapitals repräsentieren auf die Tagesordnung gesetzt werden. Vorschläge von Gesellschaftern werden der Geschäfts-
führung mit erklärenden Notizen vor Einberufung der Versammlung vorgelegt;
f. alle anderen zur Diskussion gestellten Themen unterliegen der Vorschrift dass keine rechtlich wirksamen Beschlüs-
se in Bezug auf Themen, die nicht in der Einberufungsmitteilung aufgeführt sind oder in einer zusätzlichen Einberufungs-
mitteilung mit pflichtgemäßer Beachtung der Frist die für Einberufungen festgelegt ist, gefasst werden können, außer
wenn der Beschluss einstimmig in der Versammlung, bei der alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, gefasst
wird.
Art. 18.
1. Die Beschlüsse der Generalversammlung der Gesellschafter werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst, außer
wenn diese Satzung eine qualifizierte Mehrheit verlangt.
2. Stimmen betreffend geschäftlicher Belange werden mündlich und Stimmen betreffend Personen werden in gehei-
mer Wahl mit abgegeben. Wenn bei der Wahl einer Person die absolute Stimmenmehrheit beim ersten Wahlgang nicht
erreicht wird, wird eine zweite Wahl abgehalten zwischen den zwei Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben.
3. Im Falle von Stimmengleichheit in Bezug auf eine Abstimmung über Geschäftsangelegenheiten, soll die Abstimmung
zurückgewiesen werden. Im Fall von Stimmengleichheit in Bezug auf eine Abstimmung über die Wahl einer Person ent-
scheidet das Los.
4. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben.
76735
5. Wahl durch Beifall ist zulässig, vorausgesetzt dass keiner der Wahlberechtigten widerspricht.
6. Wenn die Anzahl der Gesellschafter nicht größer ist als fünfundzwanzig, können alle Beschlüsse, die in einer Ge-
neralversammlung der Gesellschafter gefasst werden müssen, auch ohne eine solche Versammlung gefasst werden, wenn
nicht andere Personen als Gesellschafter ebenfalls angerufen werden müssen, vorausgesetzt dass alle Gesellschafter
schriftlich erklärt haben, dem Vorschlag zuzustimmen.
Art. 19.
1. Gesellschafter werden durch die Geschäftsführung durch Einberufungsmitteilungen aufgefordert, an einer General-
versammlung teilzunehmen, die mindestens vierzehn Tage ohne den Tag der Einberufung und den Tag der Generalver-
sammlung. Die Einberufungsmitteilung muss an die im Gesellschafterregister eingetragenen Adressen zugestellt werden.
2. Die Einberufungsmitteilungen sollen die Tagesordnungspunkte, die behandelt werden, enthalten.
3. Wenn die Frist für die Einberufung nicht beachtet oder wenn keine Einberufung stattgefunden hat, können keine
rechtlich wirksamen Beschlüsse gefasst werden, wenn dies nicht im Rahmen einer Versammlung geschieht in der alle
Gesellschafter, und alle Personen, die zu der Versammlung geladen werden mussten, anwesend oder vertreten sind.
4. Wenn eine oder mehrere Anteile Teil einer unteilbaren Gemeinschaft von Eigentum sind, können die gemeinsam
berechtigten Personen nur sich selbst durch eine Person, die schriftlich bestimmt werden muss, gegenüber der Gesell-
schaft vertreten.
Art. 20. Ein Geschäftsführer hat das Recht an der Generalversammlung der Gesellschafter teilzunehmen; er hat als
solcher eine beratende Stimme.
Art. 21. Jeder Anteil verleiht eine Stimme.
Art. 22. Außerordentliche Generalversammlungen der Gesellschafter werden so oft abgehalten wie die Geschäfts-
führung eine solche Versammlung einberuft.
Art. 23.
1. Die Generalversammlung der Gesellschafter wird einen Vorsitzenden bestimmen.
2. Wenn keine notarielle Urkunde erstellt wird, werden die Protokolle der Versammlungen der Generalversammlung
der Gesellschafter durch den Vorsitzenden und einen Sekretär, der durch den Vorsitzenden ernannt wird und die Pro-
tokolle führt, unterzeichnet.
Abänderung der Satzung und Auflösung
1. Gesellschafter der Gesellschaft können die Nationalität der Gesellschaft nur durch einstimmige Wahl ändern.
2. Alle anderen Änderungen der Satzung der Gesellschaft werden durch Mehrheit der Mitglieder, die drei-viertel des
Stammkapitals repräsentieren, abgegeben. Jedoch kann in keinem Fall die Mehrheit einen Gesellschafter dazu verpflich-
ten, seine Beteiligung an der Gesellschaft zu erhöhen.
3. Gleichzeitig mit den Einberufungsmitteilungen für eine Versammlung zur Abänderung der Satzung muss eine Kopie
des Vorschlags, die den Wortlaut der vorgeschlagenen Änderung wiedergibt, beim Büro der Gesellschaft zur Einsicht-
nahme durch jeden Gesellschafter bis zum Ende der Versammlung hinterlegt werden.
Art. 25.
1. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird diese durch die Geschäftsführung liquidiert, wenn nichts anderes durch
die Versammlung der Gesellschafter beschlossen wird.
2. Während der Liquidation bleiben die Vorschriften dieser Satzung weiterhin so weit wie möglich in Kraft. Die je-
weiligen Vorschriften in Bezug auf Geschäftsführer gelten dann für die Liquidatoren.
3. Eine mögliche positive Bilanz des Liquidationskontos wird ausgezahlt an die Inhaber von Anteilen im Verhältnis zu
den von ihnen gehaltenen Anteilen.
Nicht vorgesehene Fälle
Art. 26. Innerhalb der Grenzen, die von dieser Satzung festgelegt werden, hat die Generalversammlung der Gesell-
schafter alle Rechte, die nicht Dritten gewährt sind.
Art. 27. Es wird Bezug genommen auf die Vorschriften des anwendbaren Rechts für alle Fälle, für die in dieser Sat-
zung keine besondere Regelung getroffen worden ist.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Die eintausend (1.000) Anteile sind durch SANDYCOVE CORPORATION N.V. vorgenannt, gezeichnet und wurden
in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfundvierzigtausend Euro (EUR 45.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung
steht.
Vorliegende Übertragung des Verwaltungssitzes und des aktuellen Sitzes der Geschäftsleitung («principal établisse-
ment») der Gesellschaft aus den Niederlanden und die Festlegung des Verwaltungssitzes und des aktuellen Sitzes der
Geschäftsleitung in Luxemburg ist nicht Gegenstand des «droit proportionnel d’apport» und zwar in Übereinstimmung
mit Artikel 3.-2. des Gesetzes vom 21. Dezember 1971.
<i>Erklärungi>
Der Unterzeichnete Notar der die deutsche und englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass, auf Antrag des
Komparenten, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung,
ist der englische Text maßgebend.
76736
Worüber Urkunde, aufgenommen in Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar
die gegenwärtige Urkunde.
Gezeichnet: T. Heyman, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 décembre 2005, vol. 434, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(053706.03/242/736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
M’EN FOUS S.A. IMMOBILIEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 86.243.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06745, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060158.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
LUX CODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3258 Bettembourg, 4, rue Fernand Mertens.
R. C. Luxembourg B 89.072.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06145, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060168.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
AVIATION FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.
H. R. Luxemburg B 110.850.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den vierundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtsitz in Mersch (Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Marcus Peter, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft AVIATION FI-
NANCE S.A., mit Sitz in 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxemburg, auf Grund eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom
20. März 2006.
Eine Kopie dieses Beschlusses bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigeheftet, um mit derselben formalisiert zu werden.
Der Komparent, namens wie er handelt, ersucht den amtierenden Notar folgende Erklärungen zu beurkunden:
1) Die Aktiengesellschaft AVIATION FINANCE S.A. wurde laut Urkunde des Notars Paul Bettingen vom 28. Sep-
tember 2005 gegründet und im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C unter der Nummer B 110.850 regi-
striert;
2) Artikel 5 der Satzung sieht ein genehmigtes Kapital vor wie folgt:
«Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital von bis zu achtzig Millionen schweizer Franken (CHF 80.000.000,-), ein-
geteilt in fünfhunderttausend (500.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundertsechzig schweizer Franken (CHF
160,-) pro Aktie.»
3) In seiner Versammlung vom 20. März 2006 hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Gesellschaftskapital durch Aus-
gabe von achthundertachtundsiebzig (878) neuen Aktien zum Nominalwert von je einhundertsechzig schweizer Franken
(CHF 160,-), also insgesamt einhundertvierzigtausendvierhundertachtzig schweizer Franken (CHF 140.480,-), zu erhö-
hen. Das gezeichnete Kapital steigt somit von seinem bisherigen Wert in Höhe von vierhundertfünfundsechzigtausend-
sechshundert schweizer Franken (CHF 465.600,-) auf sechshundertsechstausendachtzig schweizer Franken (CHF
606.080,-).
Sämtliche achthundertachtundsiebzig (878) Aktien im Wert von einhundertsechzig schweizer Franken (CHF 160,-) je
Aktie wurden von der Gesellschaft TAFTER HOLDING S.A., eine Gesellschaft nach dem Recht der Republik Panama,
mit Sitz in 53rd Street, Swiss Bank Building, Second Floor, Panama-City, Republik Panama, vorbenannt gezeichnet, nach-
dem alle anderen Aktionäre auf Ihr Zahlungsvorzugsrecht verzichtet haben.
Mersch, den 27. Dezember 2005.
H. Hellinckx.
Signature.
Signature.
76737
Sämtliche neuen Aktien wurden vollständig mittels Zahlungen in bar in Höhe von einhundertvierzigtausendvierhun-
dertachtzig schweizer Franken (CHF 140.480,-) durch vorbenannte Gesellschaft eingezahlt, worüber dem amtierenden
Notar Nachweis im Wege der Vorlage (i) eines Kontoauszugsbriefes der UBS über die Kontobewegungen auf dem Kon-
to der Gesellschaft am und um den 20. März 2006 sowie (ii) des Protokolls der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft
vom 20. März 2006 erbracht wurde und was von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
4) Infolge der Durchführung dieser Kapitalerhöhung wurde der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesell-
schaft abgeändert und erhält nunmehr folgenden Wortlaut:
«Art. 5. erster Absatz. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt sechshundertsechstausendachtzig schweizer
Franken (CHF 606.080,-) eingeteilt in dreitausendsiebenhundertachtundachtzig (3.788) Aktien mit einem Nennwert von
einhundertsechzig schweizer Franken (CHF 160,-) je Aktie.»
<i>Kosten und Gebühreni>
Die Kosten und Gebühren welcher Art auch immer die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde anerfallen,
belaufen sich auf ungefähr dreitausend Euro.
Zwecks Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung geschätzt auf EUR 91.232,63 nach dem Währungsumrechnungs-
kurs von 1:1,5398.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Erschienene mit dem beurkundenden Notar ge-
genwärtigen Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Peter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 56, case 3. – Reçu 912,33 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(053764.03/242/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
AVIATION FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 110.850.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053765.03/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
IMMO BELOUZES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 83.963.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société, le 15 mai 2005, que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet immédiat,
le siège de la Société Anonyme IMMO BELOUZES S.A. à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Il résulte d’une lettre adressée à la société, le 15 mai 2005, que la Société COMPANY GUARD LIMITED démissionne,
avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la Société Anonyme IMMO BELOUZES S.A.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 15 mai 2005, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet im-
médiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société Anonyme IMMO BELOUZES S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06475. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060418.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Mersch, den 12. Mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 15 mai 2006.
H. Hellinckx.
FIDUCIAIRE ITP
Signature
<i>Pour la Société COMPANY GUARD LIMITED
i>Signature
Luxembourg, le 12 juin 2006.
P. Bonnet.
76738
SCHRADER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 111.624.
—
EXTRAIT
En date du 21 février 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la démission de Monsieur Douglas
Francis Sutherland, né le 7 juin 1956 dans l’Oregon (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 39, am Bounert, L-6975
Grand-Duché du Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 mars 2006, et a décidé de nommer
Mademoiselle Géraldine Cassells, née le 23 octobre 1967 à Dublin (Irlande), résidant au 20, Domaine du Beauregard,
L-8357 Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet immédiat, pour une durée
indéterminée.
Par conséquent, du 21 février 2006 au 31 mars 2006, le conseil de gérance était composé comme suit:
- Mademoiselle Géraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, ayant son adresse à P.O. Box 297, 1180 AG Amstelveen, Pays-Bas,
- Monsieur Theodore Schartz, résidant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, résidant à Swagermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, Pays-Bas,
- Monsieur Malcom Terence Swain, résidant au 19, Meadow Way, Rowledge Surrey, GU10 4DY, United Kingdom,
- Monsieur Douglas Francis Sutherland, prénommé.
Depuis le 1
er
avril 2006, les gérants de la société nommés pour une durée indéterminée sont:
- Mademoiselle Géraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, prénommé,
- Monsieur Theodore Schartz, prénommé,
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, prénommé,
- Monsieur Malcom Terence Swain, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07021. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060395.3/4170/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 86.644.
—
EXTRAIT
En date du 21 février 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la démission de Monsieur Douglas Fran-
cis Sutherland, né le 7 juin 1956 dans l’Oregon (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 39, am Bounert, L-6975 Grand-
Duché du Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 mars 2006, et a décidé de nommer Mademoiselle
Géraldine Cassells, née le 23 octobre 1967 à Dublin (Irlande), résidant au 20, Domaine du Beauregard, L-8357 Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.
Par conséquent, du 21 février 2006 au 31 mars 2006, le conseil de gérance était composé comme suit:
- Mademoiselle Géraldine Casselis, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, ayant son adresse à P.O. Box 297, 1180 AG Amstelveen, Pays-Bas,
- Monsieur Theodore Schartz, résidant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, résidant à Swagermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, Pays-Bas,
- Monsieur Malcom Terence Swain, résidant au 19 Meadow Way, Rowledge Surrey, GU10 4DY, United Kingdom,
- Monsieur Douglas Francis Sutherland, prénommé.
Depuis le 1
er
avril 2006, les gérants de la société nommés pour une durée indéterminée sont:
- Mademoiselle Géraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, prénommé,
- Monsieur Theodore Schartz, prénommé
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, prénommé,
- Monsieur Malcom Terence Swain, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07025. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060397.3/4170/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
76739
PB DISTRIBUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 89.412.
—
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Par un extrait en date du 22 mars 2006, déposé le 27 mars 2006 au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et enregistré sous le numéro L060027805 R, la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. a dénoncé le siège social de la So-
ciété Anonyme PB DISTRIBUTIONS S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Cet extrait remplace le précédent extrait, de sorte que la Société Anonyme PB DISTRIBUTIONS S.A. est toujours
domiciliée à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06166. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060415.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
CB INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.311.
—
Les comptes annuels établis au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04456, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
(060416.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
MB INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.329.
—
Les comptes annuels établis au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04457, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
(060419.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
CIRCLES GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.183.
—
<i>Extrait des Délibérations et Décisions prises par le conseil d’Administration en date du 22 septembre 2005i>
Sur proposition des actionnaires Monsieur Benoît della Faille de Leverghem, demeurant 2 Hoogvorstweg, B-3080
Tervuren, est coopté comme Administrateur de la société en remplacement du Baron Guibert Fallon suite au décès de
celui-ci. Il est précisé ensuite que la prochaine Assemblée Générale de la société aura à son ordre du jour la ratification
de la présente cooptation.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03319. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060537.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
<i>La FIDUCIAIRE I.T.P S.A.
i>Signature
<i>Pour la sociétéi> <i>CB INVEST S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
<i>Pour la sociétéi> <i>MB INVEST S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Pour extrait conforme
B. della Faille de Leverghem
<i>Administrateuri>
76740
MP TIMES, S.à r.l., Société à responsabiité limitée.
Siège social: L-4750 Pétange, 19, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 116.742.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange, le 13 juin 2006i>
L’assemblée a décidé de nommer Madame Ferreira Cristina, 64, rue du Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette en tant que
gérante technique de la société MP TIMES, S.à r.l.
La société se trouve engagée par la signature conjointe du gérant et de la gérante technique ou de la signature
individuelle du gérant, en toutes circonstances la signature du gérant est requise.
Gérant:
Monsieur Vieira Da Silva Patrick Michel. demeurant 54, rue des Jardins à L-4741 Pétange.
Pétange, le 13 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06678. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061127.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
PARFID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 97.941.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05415. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061166.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
MHP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 116.838.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 13 juin 2006i>
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale de la Société que les mandats des administrateurs suivants ont été
prolongés pour une période expirant à l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice so-
cial de l’année 2008:
- Yuriy A. Kosyuk, administrateur-délégué, né le 27 mai 1968 à Gaivoron, Kirovohrad, demeurant à Bereznyakivska
str., 16A, ap. 221, Kiev, Ukraine;
- Victoriya B. Kapelushna, administrateur, née le 3 janvier 1970 à Iziaslav, Khmelnytsky, demeurant à Chornobilska
str., 4/56 ap. 198, Kiev, Ukraine;
- Serhiy Malashenko, administrateur, né le 9 octobre 1969 à Mala Wyska, Kirovohrad, demeurant à Mala Viska, Kir-
vogradskyu Reg., L. Tolstogo st., Ukraine;
- Yevhen H. Shatokhin, administrateur, né le 18 février 1976 à Dnepropetrovsk, Ukraine, demeurant à Gomelska str.,
55, ap.31. Dnepropetrovsk, Ukraine;
- John Clifford Rich, administrateur, né le 10 mai 1952 à Sydney, Australie, demeurant à Macka Bayildim Cad 8 Macka,
Istanbul 34357, Turquie;
- Charles Adriaenssen, administrateur, né le 9 novembre 1956 à Belgrade, Yougoslavie, demeurant à Ter Eiken Voor-
destraat 50, 1851 Humbeek, Belgique; et
- John Grant, administrateur, né le 13 octobre 1945 à Belfast, Irlande du Nord, demeurant à the Malthouse, Manor
Lane, Claverdon, Warwickshire CV35 8NH, Royaume-Uni.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
76741
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
<i>Extrait d’une résolution du conseil d’administration de la société tenu à Luxembourg, le 7 juin 2006i>
Il résulte d’une décision du conseil d’administration de la Société que Monsieur Yuriy A. Kosyuk, Chief Executive Of-
ficer - CEO, né le 27 mai 1968 à Gaivoron, région de Kirovohrad, demeurant à Bereznyakivska str., 16A, ap. 221, Kiev,
Ukraine, a été nommé délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et pour la durée de son mandat
en tant qu’administrateur de la Société.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05996. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060433.3/250/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
ELIADE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 78.641.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06138, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060169.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
BENETTON HOLDING INTERNATIONAL N.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 89.124.
—
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07042, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060170.3/4170/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
REGENCY RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.155.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04403, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060614.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
REGENCY RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.155.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04406, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060612.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
<i>Pour MHP S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour MHP S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Senningerberg, le 20 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
76742
ING OFFICE REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 117.314.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-first of June.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ING OFFICE MALTA 2 LIMITED, a limited liability company incorporated and organized under the laws of Malta,
having its registered office at 171, Old Bakery Street, Valletta, Malta, registered at the Malta Registry of Companies un-
der number C38451, duly represented by Mrs Catherine Pogorzelski, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Malta, on June 21, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities.
The appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association (the Articles
of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of ING OFFICE REAL ESTATE LUX-
EMBOURG, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10th August 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association
(the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by
the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad in any companies, part-
nerships or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. It may participate in the
creation, development, management and control of any company, partnership or enterprise, be it as a general partner,
manager, director or otherwise.
3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4 The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object, which includes the acquisition of
and investment in real estate in Luxembourg or abroad.
Art. 4. Duration
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
76743
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1 The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of
the general meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the
case may be, by the sole signature of any manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
76744
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. The inven-
tory and balance sheet are submitted to the partners for approval within the first six months after the end of the ac-
counting year.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisa-
tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2 The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
Art. 17. General provision
17.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, ING OFFICE MALTA 2 LIMITED, prenamed and represented as stated here above, declares to subscribe
to five hundred (500) shares representing the whole share capital of the Company and to pay them up by a contribution
in kind consisting of all its assets and liabilities, which, for the avoidance of doubt, shall include any assets and/or liabilities
which may be discovered later. The assets and liabilities so contributed represent a net contribution in kind in an aggre-
gate amount of nine million forty-four thousand seven hundred sixteen Euro and sixty-four cents (EUR 9,044,716.64) of
76745
which twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) are allocated to the share capital of the Company; the surplus
amounting to nine million thirty-two thousand two hundred sixteen Euro and sixty-four cents (EUR 9,032,216.64) be-
tween the value of the contribution in kind and the nominal value of the subscribed shares is transferred to a share
premium account of the Company.
It results from a certificate issued on June 21, 2006 by ING OFFICE MALTA 2 LIMITED that, as of the date of such
certificate:
«- all assets and liabilities of ING OFFICE MALTA 2 LIMITED are shown on the attached certified balance sheet as
of June 21, 2006;
- based on generally accepted accounting principles the net worth of ING OFFICE MALTA 2 LIMITED per the at-
tached balance sheet as of June 21, 2006 is estimated to be nine million forty-four thousand seven hundred sixteen Euro
and sixty-four cents (EUR 9,044,716.64);
- no impediments, nor legal or contractual, to the transfer of such assets and liabilities to the Company exist; and
- all formalities to transfer all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by ING OFFICE MALTA
2 LIMITED.
Said valuation certificate and certified balance sheet referred to above, after having been signed ne varietur by the
appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of
its incorporation are estimated at approximately nine hundred Euro (900.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The number of managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Steve Van Den Broek, Manager, born on July 26, 1970, in Antwerp, Belgium, with professional address at 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; and
- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a public limited liability company, with registered office at 5, rue Eugène Rup-
pert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 28.967.
3. The registered office of the Company is set at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
4. From the share premium account an amount corresponding to ten per cent (10%) of the share capital of the Com-
pany, being one thousand two hundred fifty Euro (EUR 1,250.-) shall be allocated to the legal reserve which thereafter
shall have reached the minimum required by the Law.
<i>Capital dutyi>
Article 4-1 of the Luxembourg law dated December 29, 1971 on capital duty provides that the contribution by a com-
pany of all its assets and liabilities to another company exclusively against the issuance of shares by the latter company
is exempt of capital duty provided that the companies have their effective place of management or their registered office
within the European Union which proviso is fulfilled in the case at hand.
Therefore, as ING OFFICE MALTA 2 LIMITED contributes all its assets and liabilities as consideration for the issu-
ance of shares by the Company, such exemption from capital duty is applicable to the contribution made under this
deed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ING OFFICE MALTA 2 LIMITED, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois de Malte, ayant
son siège social au 171, Old Bakery Street, Valletta, Malta, immatriculée au Registre des Sociétés de Malte, sous le nu-
méro C38451, dûment représentée par M
e
Catherine Pogorzelski, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Malte, le 21 juin 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l’enregistrement.
La partie comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les statuts (les Statuts) d’une société à responsabilité
limitée qui est constituée comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires de parts sociales, une société sous la forme
d’une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de ING OFFICE REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l. (la
76746
Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société. Le
siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique
ou de l’assemblée générale des associés adoptée dans les formes prescrites pour les modifications des Statuts.
2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société, des suc-
cursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à
compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires ne peuvent toutefois avoir d’effet sur
la nationalité de la Société qui demeurera, en dépis du transfert provisoire de son siège social, une société luxembour-
geoise.
Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés, so-
ciétés de personnes ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. Elle peut participer
à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société, société de personne ou entreprise, en tant
qu’associé commandité, gérant, administrateur ou autre.
3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’obligations, titres de créances et autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émis-
sions de titres de créances à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également consentir des
garanties et des sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre hypothéquer, gager, nantir ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs.
3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
les risques de change, les risques liés aux taux d’intérêts et tous autres risques.
3.4 La Société peut accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que toutes transactions en relation
avec des biens mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social
ou s’y rapportent, ce qui comprend l’investissement dans le secteur immobilier et ainsi que toutes transactions en rela-
tion avec des biens immobiliers au Luxembourg ainsi qu’`à l’étranger.
Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, suspension des droits civiques, d’incapacité, d’insolvabilité,
faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs de ses associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) de parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l’as-
socié unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés, adoptée dans les formes prescrites pour la modi-
fication des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne pour les représenter auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ou, en cas d’associé unique, à des tiers.
6.4 En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés est soumise à l’agrément préalable
de l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société,
ou acceptée par elle, en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toute autre question, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.5 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et il pour-
ra être consulté par chaque associé qui le souhaite.
6.6 La Société peut racheter ses propres parts dans les limites prévues par la Loi.
76747
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou par l’assemblée
générale des associés qui fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne doit/doivent pas être nécessairement associé(s).
7.2 Les gérants peuvent être révoqués ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts sont de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plusieurs gérants, par le conseil de gérance,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par tout gérant de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1 Le conseil de gérance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation de tout gérant
au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2 Des convocations écrites aux réunions du conseil de gérance sont données à tous les gérants au moins vingt-
quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence,
sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 Une convocation préalable n’est pas requise si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et si ils déclarent avoir été dûment informés, et avoir eu connaissance de l’ordre du
jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, fax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises à la majorité des voix exprimées. Les résolu-
tions du conseil de géreance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre et se
parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont considérées comme valablement adoptées et oppo-
sables comme si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du conseil de gérance dûment convoquée. Les signa-
tures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs exemplaires d’une même résolution et peuvent
être envoyées par lettre ou fax.
Art. 10. Représentation
La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature de son gérant unique ou, le cas
échéant, par la seule signature de tout gérant de la Société ou par la signature conjointe ou unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2 de ces Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants n’assument, à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1 L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé peut désigner toute personne ou entité comme son mandataire en vertu d’une procuration écrite
donnée par lettre, télégramme, télex, fax ou e-mail, pour le représenter aux assemblées générales des associés.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1 Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être prises par réso-
lution circulaire, dont le texte sera envoyé à tous les associés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, fax ou
e-mail. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront
sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une même résolution et pourront être envoyées par lettre ou fax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés dé-
tenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour modifier les Statuts ou pour dissoudre ou liquider la Société ne peuvent
être adoptées qu’à la majorité des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1 L’exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication de l’actif et du passif de la Société.
76748
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société. L’inventaire et
le bilan sont soumis à l’approbation des associés dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1 Les résultats bruts de la Société apparaissant dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux,
amortissements et charges constituent le bénéfice net. Un montant correspondant à cinq pour cent (5%) du bénéfice
net annuel de la Société est affecté à la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.
15.2 L’assemblée générale des associés décide discrétionnairement de l’affectation du solde du bénéfice net annuel.
Elle peut en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende ou l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3 Les dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un bilan ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) cet état des comptes, bilan ou rapport montre qu’il y a suffisamment de fonds disponibles pour une distribution;
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées
et les sommes à allouées à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par l’associé unique ou l’assemblée générale des as-
sociés; et
(iv) on s’est assuré que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixe leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera distribué
à l’associé, ou s’íl y a plusieurs associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par
chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Disposition générale
17.1 Pour tous les points non expressément abordés aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prendra fin le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, ING OFFICE MALTA 2 LIMITED, préqualifiée et représentée comme ci-dessus mentionné, déclare
avoir souscrit les cinq cents (500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société et les avoir en-
tièrement libérées par un apport en nature consistant en l’ensemble de ses actifs et passifs, y compris afin d’éviter tout
doute tous avoirs et/ou passifs qui pourront être découverts ultérieurement. Les actifs et passifs ainsi apporté repré-
sentent un apport en nature d’une valeur totale nette de neuf millions quarante-quatre mille sept cent seize euros et
soixante-quatre cents (EUR 9.044.716,64) dont douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sont affectés au capital so-
cial de la Société; la différence, évaluée à neuf millions trente-deux mille deux cent seize euros et soixante-quatre cents
(EUR 9.032.216,64), entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera transférée
au compte de prime d’émission de la Société.
Il résulte d’un certificat délivré le 21 juin 2006 par ING OFFICE MALTA 2 LIMITED qu’a la date de ce certificat:
«- tous les actifs et passifs de ING OFFICE MALTA 2 LIMITED sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté du 21
juin 2006;
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de ING OFFICE MALTA 2 LIMITED selon
le bilan intérimaire daté du 21 juin 2006 est évaluée à neuf millions quarante-quatre mille sept cent seize euros et soixan-
te-quatre cents (EUR 9.044.716,64);
- il n’existe aucune empêchement, ni légal, ni contractuel, au transfert de propriété de ces actifs et passifs à la Société;
et
- toutes les formalités pour le transfert juridique de ces actifs et passifs à la Société ont été accomplies par ING OF-
FICE MALTA 2 LIMITED.
Ledit cetificat et bilan intérimaire dont référence est faite ci-dessus, après signature ne varietur par la partie compa-
rante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’en-
registrement.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison
de sa constitution sont estimés à environ neuf cents euros (900,- EUR).
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social souscrit a
pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants de la société est fixé à deux (2).
76749
2. Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Steve Van Den Broek, gérant, né le 26 juillet 1970 à Anvers, Belgique, avec adresse professionnelle au 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; et
- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 28.967.
3. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
4. Un montant correspondant à dix pour cent (10%) du capital social de la Société, c’est-à-dire mille deux cent cin-
quante euros (EUR 1.250,-) sera alloué à la réserve légale qui aura par la suite atteint le niveau requis par la Loi. Ce
montant est débité du compte prime d`’émission de la Société.
<i>Droit d’apporti>
L’article 4-1 de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971 sur le droit d’apport prévoit que l’apport par une société
de tout son actif et passif à une autre société en contrepartie exclusivement de l’émission de parts sociales par cette
dernière est exonérée de droit d’apport à condition que les sociétés aient leur siège de direction effective ou leur siège
social au sein de l’Union européenne laquelle condition est remplie dans le cas présent.
En conséquence et dans la mesure où ING OFFICE MALTA 2 LIMITED apporte tout son actif et passif en contrepartie
de l’émission par la Société de parts sociales, cette exonération de droit d’apport est applicable à l’apport effectué dans
le cadre de cet acte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que, sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Pogorzelski, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 27 juin 2006, vol. 470, fol. 57, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062803.3/5770/466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
G.T.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3843 Schifflange, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 78.862.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07830, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052012.03/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
BRIDESHEAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 77.651.
—
Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social
à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06023. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052524.03/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Remich, le 30 juin 2006.
M. Schaeffer.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Signature.
<i>Pour BRIDESHEAD HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
76750
TOMKINS HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 102.555.
—
EXTRAIT
En date du 21 février 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la démission de Monsieur Douglas Fran-
cis Sutherland, né le 7 juin 1956 dans l’Oregon (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 39, am Bounert, L-6975 Grand-
Duché du Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 mars 2006, et a décidé de nommer Mademoiselle
Geraldine Cassells, née le 23 octobre 1967 à Dublin (Irlande), résidant au 20, Domaine du Beauregard, L-8357 Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.
Par conséquent, du 21 février 2006 au 31 mars 2006, le conseil de gérance était composé comme suit:
- Mademoiselle Geraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, ayant son adresse à P.O. Box 297, 1180 AG Amstelveen, Pays-Bas,
- Monsieur Theodore Schartz, résidant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, résidant à Swagermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, Pays-Bas,
- Monsieur Malcom Terence Swain, résidant au 19, Meadow Way, Rowledge Surrey, GU10 4DY, United Kingdom,
- Monsieur Douglas Francis Sutherland, prénommé.
Depuis le 1
er
avril 2006, les gérants de la société nommés pour une durée indéterminée sont:
- Mademoiselle Géraldine Cassells, prénommée,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, prénommé,
- Monsieur Theodore Schartz, résidant au 9, rue du Château, prénommé,
- Monsieur Robert Jacques Verdonk, prénommé,
- Monsieur Malcom Terence Swain, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060409.3/4170/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
INTERNATIONAL GAS DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 78.455.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06550, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060982.3/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
INTERNATIONAL GAS DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 78.455.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06562, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060976.3/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
INTERNATIONAL GAS DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 78.455.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06559, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060980.3/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Signature.
76751
LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.018.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 mai 2006, les mandats des admi-
nistrateurs:
- Monsieur Hans Josef Henseler, 29, avenue E.V.A., 7
°
D, 1700-164 Lisboa, Portugal,
- Monsieur Joao Pedro Monteiro Bastos Henseler, 29, avenue E.V.A., 7
°
D, 1700-164 Lisboa, Portugal,
- Madame Maria José Monteiro Bastos Henseler, 29, avenue E.V.A., 7
°
D, 1700-164 Lisboa, Portugal,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
- Madame Joana Maria Monteiro Bastos Henseler, 29, avenue E.V.A., 7
°
D, 1700-164 Lisboa,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Hans Josef Henseler, Administrateur,
- Monsieur Joao Pedro Monteiro Bastos Henseler, Administrateur,
- Madame Maria José Monteiro Bastos Henseler, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06212. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060295.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.018.
—
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-
BR06210, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
(060342.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
LOOPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04422, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060620.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
LOOPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04423, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060618.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour extrait sincère et conforme
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Signature.
76752
DEFINLUX DFL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 32.308.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2006, les mandats des administrateurs:
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- Madame Monique Juncker, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06209. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060286.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
DEFINLUX DFL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 32.308.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-
BR06208, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
(060339.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
CENCAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 23.451.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01826, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052888.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
<i>Pour DEFINLUX DFL S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour DEFINLUX DFL S.A., Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
New Exercise, S.à r.l.
New Exercise, S.à r.l.
Aero International Finance S.A.
Industrie Nähmaschinen Holding
Guillain Holding S.A.
Imagine Partners Invest S.A.
ACP Venture A.G.
Europaring 5, S.à r.l.
Kent Investment Holding S.A.
Kent Inter Holding S.A.
Kent Inter Holding S.A.
Benetton International Property N.V. S.A.
43 rue Descamps «Paris 75016», S.à r.l.
18 rue Godot de Mauroy «Paris 75009», S.à r.l.
Tomkins Overseas Financing, S.à r.l.
Eurobeton S.A.
Goldford Holding S.A.
Goldford Holding S.A.
Tomkins Overseas Holdings, S.à r.l.
Tomkins American Investments, S.à r.l.
Benetton Real Estate International S.A.
Benetton International S.A.
Key Largo S.A.
Safilux
N&W Finance Company (Luxembourg), S.à r.l.
Fridge Finance Company, S.à r.l.
CAVEM - Centre Audio-visuel de l’Enseignement Musical, S.à r.l. Pop-Music School Jean Roderes
EM Finance Holding S.A.
John Deere Cash Management S.A.
EM Finance Holding S.A.
DB Platinum
Compass Rose S.A.
Compass Rose S.A.
DB Platinum III
Tharros S.A.
Spanish Property Investment S.A.
Spanish Property Investment S.A.
Netview Real Estate S.A.
Netview Real Estate S.A.
Duscholux S.A.
Duscholux S.A.
Benetton Real Estate International S.A.
Central Africa Growth Sicar, S.A.
DB Platinum II
Easy Hole Invest S.A.
Periflex International Consulting S.A.
Periflex International Consulting S.A.
Intec Maritime Offshore Services Holding S.A.
Intec Maritime Offshore Services Holding S.A.
California Lines Holding S.A.
Piranha, S.à r.l.
Techpoint, S.à r.l.
Karlbo Associates S.A.
Torpet International, S.à r.l.
Synteco Group S.A.
Key West, S.à r.l.
Benetton International Property N.V. S.A.
Marbristone Invest S.A.
Bienlux
Internationale Participations Financières S.A.
Granilo Holding B.V.
M’en Fous S.A. Immobilien Verwaltungsgesellschaft
Lux Code S.A.
Aviation Finance S.A.
Aviation Finance S.A.
Immo Belouzes S.A.
Schrader Investments Luxembourg, S.à r.l.
Tomkins Luxembourg, S.à r.l.
PB Distributions S.A.
CB Invest S.A.
MB Invest S.A.
Circles Group
MP Times, S.à r.l.
Parfid S.A.
MHP S.A.
Eliade Invest S.A.
Benetton Holding International N.V. S.A.
Regency Resources S.A.
Regency Resources S.A.
Ing Office Real Estate Luxembourg, S.à r.l.
G.T.V. S.A.
Brideshead Holding S.A.
Tomkins Holdings Luxembourg, S.à r.l.
International Gas Distribution S.A.
International Gas Distribution S.A.
International Gas Distribution S.A.
Lusofin S.A. Holding
Lusofin S.A. Holding
Looping International S.A.
Looping International S.A.
Definlux DFL S.A.
Definlux DFL S.A.
Cencan S.A.