This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
58945
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1229
26 juin 2006
S O M M A I R E
MOBILESTOP.COM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.264.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 27 mars 2006i>
Le siège social de la société MOBILESTOP.COM EUROPE, S.à r.l., est transféré, avec effet immédiat, au L-2311
Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP01928. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035953/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
Aerium Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58957
Hofin, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58985
Argelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58961
I.M. & M., S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . .
58962
Armadillo Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
58964
Imolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58956
Armadillo Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
58966
Imolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58957
Associated Consulting Engineers (Holdings) S.A.,
Industrial Development Company S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58973
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58946
Auto Media Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
58986
Iona S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58957
Azure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58985
Johnen-Maraite, GmbH, Troisvierges. . . . . . . . . . .
58954
Bakker Van Vorst B.V., S.à r.l., Luxemburg . . . . . .
58953
Léon Weiwers, les Héritiers, Luxembourg, S.à r.l.,
BC International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
58973
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58947
Belleville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58962
Léon Weiwers, les Héritiers, Luxembourg, S.à r.l.,
BH Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58979
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58948
C-Tec S.A., Hosingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58958
MeesPierson Intertrust Financial Engineering S.A.,
Cerfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58961
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58967
Club Med Asie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58973
Metec Finance S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .
58950
Dimpex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58967
Mobilestop.com Europe, S.à r.l., Luxembourg . . .
58945
Elite Model Management Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Norman International S.A., Luxembourg . . . . . . .
58949
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58967
Patron Dieter Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
58968
European Credit (Luxembourg) S.A., Luxembourg
58946
Patron Dieter, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58974
Fibelfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58979
Patron Elke Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58980
FirstCo Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
58958
Scarlet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58955
Foncière Kons S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
58953
SGL Carbon Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
58955
Foralim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58957
Skyguards S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58953
Heirens Romain, S.à r.l., Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . .
58949
Stardon Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58985
Luxembourg, le 31 mars 2006.
Signature.
58946
INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 12.899.200.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 92.795.
—
EXTRAIT
1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires en date du 23 mars 2006 que:
Remplacement d’administrateurs:
En remplacement de:
- M. Stef Oostvogels,
- M. Mohamed Amersi,
- Mme Delphine Tempé,
ont été nommés en qualité d’administrateur:
- Monsieur Felix Poulsen ayant pour adresse H.C. Andersens Boulevard 51, Copenhage V, Danemark a été nommé
au poste d’administrateur A avec effet au 1
er
février 2006. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle
de 2007,
- Monsieur Mads Braemer-Jensen ayant pour adresse 20/7 ulitsa Chaplygina, 4th floor, 103062 Moscou a été nommé
au poste d’administrateur B avec effet au 1
er
février 2006. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle
de 2007,
- Monsieur E. Clive Anderson ayant pour adresse 203 East 72nd Street, New York, NY 10021-4567, U.S.A. a été
nommé au poste d’administrateur B avec effet au 1
er
février 2006. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale
annuelle de 2007.
Le conseil d’administration est donc composé ainsi:
- Monsieur Felix Poulsen,
- Monsieur Mads Braemer-Jensen,
- Monsieur E. Clive Anderson.
Transfert du siège social:
- Le siège social de la société a été transféré du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg à compter du 1
er
mars 2006.
Remplacement de commissaire:
- La société FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE, S.à r.l., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, a été nommée
en qualité de commissaire à compter du 1
er
février 2006 en remplacement de CORPORATE ADVISORY BUSINESS
S.A. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2007.
2. Il résulte d’une résolution circulaire du conseil d’administration du 23 mars 2006 que:
En remplacement de Monsieur Mohamed Amersi a été nommé au poste d’administrateur-délégué à compter du 23
mars 2006 pour prendre fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2007:
- Monsieur Felix Poulsen, ayant pour adresse H.C. Andersens boulevard 51, Copenhagen V, Danemark.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03211. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034856/260/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.
EUROPEAN CREDIT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 72.192.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2006i>
En date du 15 mars 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Harald Schüssler, Clive Mace Gilchrist, Scott Edel, Steven
Andrew Blakey, Alfonso De Maqua et James Pope, pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 2007.
Luxembourg, le 16 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04444. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032027/1024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
58947
LEON WEIWERS, LES HERITIERS, LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1858 Luxembourg, 22, rue du Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 9.565.
—
L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Madame Irène Léonard, femme au foyer, demeurant à L-2542 Dommeldange, 166, rue des Sources,
2.- Monsieur Frank Weiwers, ingénieur, demeurant à L-1858 Luxembourg, 22, rue de Kirchberg, et
3.- Monsieur Raymond Bellion, directeur de banque en retraite, demeurant à L-2167 Luxembourg, 50, rue des Mu-
guets.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à res-
ponsabilité limitée LEON WEIWERS, LES HERITIERS, LUXEMBOURG avec siège social à L-1858 Luxembourg, 22, rue
de Kirchberg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 9.565,
constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 mai
1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
136 du 24 septembre 1971,
modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 5 janvier 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 45 du 8 mars 1978,
modifiée suivant acte reçu par Maître Marc Fischbach, alors notaire de résidence à Mersch en date du 14 février 1984,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 80 du 22 mars 1984,
modifiée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Bonnevoie en date du 22 décembre 1988,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 94 du 11 avril 1989, et
modifiée pour la dernière fois suivant acte sous seing privé des associés en date du 14 juin 2002, en application de
l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
1282 du 4 septembre 2002.
Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier l’objet social afin de lui donner suivante:
La société a pour objets:
- l’étude, la fourniture, le montage, la mise en service d’installations électriques et l’achat et la vente de produits in-
dustriels,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. La société pourra se
porter garante des engagements des associés.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède les associés représentant l’intégralité du capital social, décident d’actualiser les statuts
de la société et de procéder à une réforme totale des statuts, pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LEON WEIWERS,
LES HERITIERS.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transférer temporairement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées
à toute partie intéressée par un ou plusieurs des organes ou personnes chargés de la gestion journalière de la Société.
Les associés ou les gérants peuvent établir des succursales ou bureaux aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.
Art. 3. La société a pour objets:
- l’étude, la fourniture, le montage, la mise en service d’installations électriques et l’achat et la vente de produits in-
dustriels,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
58948
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. La société pourra se
porter garante des engagements des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) divisé en mille deux
cent cinquante (1.250) parts sociales de ving-cinq (25,- EUR) chacune, réparties comme suit:
Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou
des associés représentant l’intégralité des parts sociales.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés
réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.
Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-
cipation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-
nime des associés.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 1.200,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: I. Léonard, F. Weiwers, R. Bellion, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, vol. 28CS, fol. 8, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(035936/206/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
LEON WEIWERS, LES HERITIERS, LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1858 Luxembourg, 22, rue du Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 9.565.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 10 avril 2006.
(035946/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
a.- Madame Irène Leonard, cent quarante-sept parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
b.- Monsieur Frank Weiwers, mille quatre-vingt-dix-sept parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.097
c.- Monsieur Raymond Bellion, six parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Total: mille deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Luxembourg-Eich, le 10 avril 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
58949
HEIRENS ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. R-ENTREPRISE, S.à r.l.).
Siège social: L-9371 Gilsdorf, 10, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 93.368.
—
L’an deux mille six, le dix-sept février.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée R-ENTREPRISE, S.à r.l. avec
siège social à L-9371 Gilsdorf, 10, rue des Prés, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Cravatte, alors de
résidence à Ettelbruck en date du 2 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 302 du 21 juin 1996.
L’assemblée est composée de l’associé unique Monsieur Romain Heirens, entrepreneur, né à Luxembourg le 24 juillet
1962, demeurant à L-9371 Gilsdorf, 10, rue des Prés.
Lequel comparant déclare agir en tant que seul et unique associé de la société prédésignée et requiert le notaire
instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit ses résolutions prises sur ordre du jour conforme.
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en HEIRENS ROMAIN, S.à r.l. et par
conséquence de modifier le premier article des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société prend la dénomination de HEIRENS ROMAIN, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’objet social de la société et par conséquence de modifier l’article 3 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une carrière de pierres, le commerce de matérieux de construction,
l’exécution de tous travaux d’excavation, de construction, de voirie et de génie civil, le transport de marchandises, l’ex-
ploitation d’une agence immobilière, l’acquisition d’immeubles, la gestion, la mise en valeur et la vente de son propre
patrimoine immobilier, ainsi que toutes les opérations mobilières, immobilières ou financières se rapportant directe-
ment ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation.
La société a en outre pour objet la prise d’intérêts ou la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et
toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de
toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ses intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à des entreprises ayant un objet similaire au moyen des prêts, de garanties ou autre-
ment.
Elle pourra prendre prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances
de dettes.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
Dont acte, fait et passé à Diekirch, en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Heirens, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 20 février 2006, vol. 618, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial
C, Recueil spécial des sociétés et associations.
(919883/234/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
mars 2006.
NORMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 72.947.
—
En date du 10 mars 2006, Messieurs Gérard Becquer et Dominique Robyns ont démissionné de leur mandat d’admi-
nistrateur dans la société NORMAN INTERNATIONAL S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032093/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
Diekirch, le 23 février 2006.
F. Unsen.
Luxembourg, le 31 mars 2006.
Signature.
58950
METEC FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
H. R. Luxemburg B 114.585.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den neunten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Hesperange.
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft CNC FINANCE HOLDING S.A., mit Sitz in L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais, hier vertreten
durch seinen mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwalter und allein Unterschriftsbefugten, Herr Harald
Bormann, Maschinenführer, wohnhaft in D-54689 Dahnen, 2, Murbachstrasse,
2.- Die Gesellschaft der British Virgin Islands PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, mit Sitz in Tortola (B.V.I.), Be-
aufort House P.O. Box 438, Road Town, registriert unter Nummer 221438, hier vertreten durch Dame Nancy Que-
rinjean, Privatangestellte, wohnhaft in B-4960 Malmédy (Belgien), 23, Chemin du Lefa, handelnd in ihrer Eigenschaft als
alleinunterschriftsbefugter Verwalter der Gesellschaft aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats vom 17. Juli 2005,
der Gesellschaft PENDLE HOLDINGS LTD,
Welche Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen
zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine
luxemburgische Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung METEC FINANCE S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Diekirch.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit
am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden
oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser un-
gewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Maßnahme eine Wirkung auf die Staatszu-
gehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben
wird.
Eine solche Sitzverlegungserklärung wird gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch den mit der täglichen
Geschäftsführung Beauftragten der Gesellschaft.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist Beratung- und Geschäftsverbindungsleistungen, sowie die Beteiligung in jedmög-
licher Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften nehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Option,
Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwerten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede
Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.
Sie kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhän-
gen oder ihn fördern, alles im Rahmen von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in tausend (1.000)
Aktien ohne Nennwert.
Art. 6. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Es können je nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann in dem Maße und zu den Bedingungen die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, Aktionäre
oder Nichtaktionäre, welche von der Gesellschafterversammlung für eine Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt
werden. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. Die
nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bezeichnen; in dessen Abwesenheit wird der
Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, welches zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt
wird.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder zugegen oder vertreten sind; ein Man-
dat zwischen Verwaltungsräte ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kollegen
vertreten kann.
58951
Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Kabeltelegramm, Te-
legramm, Fernschreiben oder Telekopie, erteilt werden.
In Dringlichkeitsfällen hat ein schriftlicher von sämtlichen
Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschriebener Beschluss die gleiche gültige und rechtsverbindliche
Wirkung, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung gefasst worden.
Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Art. 10. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten
bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigefügt.
Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegen-
wärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-
ten, die Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder Spe-
zialvollmachten für Einzelgeschäfte einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen, wobei die
Übertragung dieser Vollmachten an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates der vorherigen Genehmigung der Gene-
ralversammlung bedarf.
Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte zu denen er selbst befugt ist.
Art. 13. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unter-
schrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon die obligatorische Mitunterzeichnung des mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung.
Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.
Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre,
welche für die Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalversammlung bestellt werden; sie sind wiederwählbar
und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.
Gesellschafterversammlung
Art. 15. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit
der Gesellschafter.
Sie hat die weitgehendsten Befugnisse um über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu entscheiden.
Art. 16. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am dritten Freitag des Monats mai um 15.00 Uhr.
Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 17. Eine aussergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die
Kommissare einberufen werden.
Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, welche mindestens ein Fünftel des Gesellschafts-
kapitals vertreten, gefordert werden.
Art. 18. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt gemäss der im Gesetz vorgeschriebenen Formen
und Fristen. Sie beinhaltet die Tagesordnung.
Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen
werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und erklären den Inhalt
der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Jeder Aktionär kann selbst oder vermittels Bevollmächtigtem an den Generalversammlungen teilnehmen und abstim-
men.
Soweit dies nicht anders durch das Gesetz bestimmt ist, werden die Bestimmungen einer regelmässig zusammenge-
rufenen Gesellschafterversammlung durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden/vertretenen und stimm-
berechtigten Aktionäre genommen.
Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls
eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche
dieser Aktie anhaften, zu suspendieren solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.
Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterla-
gen nebst einem Tätigkeitsbericht.
Art. 21. Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn
dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obliga-
torische Vorwegnahme entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.
58952
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und mit Zustimmung des oder der Kommissare der Gesell-
schaft wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividenden auszuzahlen.
Auflösung - Liquidation
Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche gemäss den für die Satzungsände-
rung vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, von der Gesellschaf-
terversammlung ernannt, welche ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.
Gesetzgebung
Art. 23. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahr 2007.
<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien sind vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreissigtausend
Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrück-
lich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr 1.500,- EUR geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben, nach Festeilung der ordnungsgemässen Einberufung und
Zusammensetzung dieser Versammlung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen, festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
a) Herr Ralph Heckel, Speditionsfahrer, wohnhaft zu D-54689 Dahnen (Deutschland), 35, Hauptstrasse, geboren zu
Neuerburg (Deutschland), am 8. März 1971,
b) Herr Bertram Lenz, Bankkaufmann, wohnhaft zu D-54619 Lichtenborn (Deutschland), 3, In den Rosen, geboren
zu Binscheid (Deutschland), am 2. August 1968,
c) Herr Hermann Bormann, Fräser, wohnhaft zu D-54619 Eschfeld (Deutschland), 5, Im Schlomm, geboren zu Prum
(Deutschland), am 1. März 1956,
3) Zum Kommissar wird ernannt: Herr Jean-Louis Posson, Handelsagent, wohnhaft in L-9709 Clerf, 7, route de
Marnach, geboren zu Etterbeek (Belgien), am 13. März 1949.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2011.
5) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
6) Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungs-
rat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäfts-
führung individuell an ein oder mehrere Verwaltungsratmitglieder zu übertragen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Clerf, 7, route de Marnach, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung stehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie
Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: N. Querinjean, H. Bormann, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, vol. 27CS, fol. 49, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
<i>Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 9. Februar 2006i>
Verwaltungsratsmitglieder, zugegen:
- Herr Ralph Heckel, Speditionsfahrer, wohnhaft zu D-54689 Dahnen (Deutschland), 35, Hauptstrasse,
1) Die Gesellschaft CNC FINANCE HOLDING S.A., vorbenannt, neunhundertneunundneunzig Aktien . . . . .
999
2) Die Gesellschaft PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: eintausend Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Hesperange, le 2 mars 2006.
M. Decker.
58953
- Herr Bertram Lenz, Bankkaufmann, wohnhaft zu D-54619 Lichtenborn (Deutschland), 3, In den Rosen,
- Herr Hermann Bormann, Fräser, wohnhaft zu D-54619 Eschfeld (Deutschland), 5, Im Schlomm.
Die Verwaltungsratsmitglieder, nachdem sie sich als gültig zusammenberufen betrachtet haben, haben einstimmig
folgenden Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
Gemäss der Ermächtigung durch die ausserordentliche Gesellschafterversammlung, überträgt der Verwaltungsrat die
gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäfts-
führung an Herrn Ralph Heckel, vorbenannt, mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine alleinige und obligatorische
Unterschrift für alle Geschäfte in diesem Zusammenhang zu binden.
Enregistré à Diekirch, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00014. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(921981/241/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2006.
SKYGUARDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.360.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes
ont été adoptées:
- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06224. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032029/6102/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
BAKKER VAN VORST B.V., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
H. R. Luxemburg B 94.477.
—
Aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter vom 13. Februar 2006 ergibt sich, dass
die Gesellschafter den Rücktritt von Herrn Gerd Gebhard zum 15. September 2005 annehmen. An seiner Stelle wird
Frau Myriam Francq, geboren am 25. Dezember 1953 in B-Eupen, beruflich ansässig in L-1220 Luxemburg, 196, rue de
Beggen, auf unbegrenzte Dauer zur Geschäftsführerin der Gesellschaft ernannt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06651. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032032/607/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
FONCIERE KONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.015.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 10 mars 2006i>
Le siège social a été fixé au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 30 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00432. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032062/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
R. Heckel, B. Lenz, H. Bormann.
Pour extrait sincère et conforme
SKYGUARDS S.A.
P. Meunier
<i>Administrateuri>
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FONCIERE KONS S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
58954
JOHNEN-MARAITE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9911 Troisvierges, 11, rue de Drinklange.
H. R. Luxemburg B 114.586.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den zweiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.
Ist erschienen:
Dame Maria Johnen-Maraite, Geschäftsführerin, geboren am 30. April 1957 in Sankt Vith, (Belgien) Matrikel N
°
1957
04 30 729, wohnhaft in B-4784 Sankt Vith (Belgien), 53, Hünningen.
Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihr zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:
Art. 1. Die Unterzeichnete gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der
sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Art. 2. Zweck des Betriebes ist die Bereitstellung von Informationen, die Beratung und Ausbildungskurse in
Bereichen der Lehre und des Allgemeinwissens.
Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter
vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder welche die Entwicklung der
Gesellschaft erleichtern können. Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringung, Anteilszeichnung, Verschmel-
zung oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder
ähnlichen Zweck verfolgen, oder die die Ausdehnung und Entwicklung der gegründeten Gesellschaft begünstigen
können, sowie jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn
fördern kann.
Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen JOHNEN-MARAITE, GmbH.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Troisvierges.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an
jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert (12,400) Euro und ist eingeteilt in
einhundert (100) Anteile von einhundertvierundzwanzig (124) Euro pro Anteil, alle der alleinigen Gesellschafterin Dame
Maria Johnen-Maraite, vorgenannt, gehören.
Die Gesellschafterin erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in
der Gesellschaftskasse befinden.
Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-
schaft.
Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustim-
mung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter
übertragen werden.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die
Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und
welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.
Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die
Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen
abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund
einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise
beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31 Dezember dieses Jahres.
Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am 1. Juni im Gesellschaftssitz statt.
Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Veriustrechnung.
58955
Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-
winn dar.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-
schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
- Dame Maria Johnen-Maraite, vorgenannt, wird zur Geschäftsführerin ernannt.
- Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift der Geschäftsführerin.
- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9911 Troisvierges, 11, rue de Drinklange.
<i>Schätzung der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend
(1.000) Euro geschätzt.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe, mit dem Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: M. Maraite, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 23 février 2006, vol. 618, fol. 18, case 11. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der
Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(921997/234/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2006.
SGL CARBON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 98.290.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée extraordinaire des actionnaires datée du 15 décembre 2004 de la Société que le commissaire
aux comptes ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est remplacé par M.
Joachim Kenneth Becker, ayant comme adresse professionnelle 184, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden, Allemagne
et ce avec effet immédiat et pour une période renouvelable de deux ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01300. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032033/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
SCARLET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000.000.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.306.
—
Lors de la résolution signée en date du 16 mars 2006, l’associé unique de la société ROSE, S.à r.l. a décidé de nommer
Monsieur John Anthony Jackson, résidant au 2, Skivo Wynd, Murieston, Livingston, West Lothian EH54 9GY, Royau-
me-Uni en tant que gérant suppléant de Monsieur Alan Dick pour une période indéterminée et avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00713. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032109/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
Diekirch, den 6. März 2006.
F. Unsen.
Pour extrait sincère et conforme
SGL CARBON LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Le mandatairei>
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
58956
IMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.190.
—
L’an deux mille six, le dix février.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMOLUX S.A., avec siège
social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen,
de résidence à Niederanven, en date du 27 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 784 du 25 juillet 2003,
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 94.190.
L’assemblée est ouverte à 10.45 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Benoît de Bien, consultant,
demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Le transfert du siège de la société de Wiltz à L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal et la modification subsé-
quente de l’article 2 (alinéa premier) des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg»,
2. la démission de la société DELMA & CIE, S.à r.l. de sa fonction d’administrateur avec décharge.
3. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Wiltz à L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal et de
modifier en conséquence l’article 2 (alinéa premier) des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa premier). Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de la société DELMA & CIE, S.à r.l. de sa fonction d’administrateur et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée constate que les deux administrateurs restant assureront l’intérim en attendant la nomination d’un
troisième administrateur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.00 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 800,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.
Signé: B. de Bien, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 15 février 2006, vol. 319, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(922507/2724/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2006.
Wiltz, le 3 mars 2006.
A. Holtz.
58957
IMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.190.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(922510/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2006.
FORALIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.626.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2006i>
- Les démissions de Messieurs Jean-Robert Bartolini et Serge Krancenblum de leur mandat d’Administrateur sont ac-
ceptées.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Les mandats des sociétés
MADAS, S.à r.l. et FINDI, S.à r.l. viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.
Fait à Luxembourg, le 16 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf. LSO-BP00826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032035/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
AERIUM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.764.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 10 mars 2006i>
Le siège social a été fixé au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 30 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00433. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032064/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
IONA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.041.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02339, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034162/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
Wiltz, le 3 mars 2006.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
Certifié sincère et conforme
<i>FORALIM S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AERIUM HOLDINGS S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
58958
FirstCo INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.464.
—
<i>Extrait de la décision des associés datée du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2006i>
Les associés:
- THE ATHOL TRUST, 35-39 La Colomberie Street, St Helier, Jersey JE2 4QB, Channel Islands;
- THE SPRINGBOK TRUST, 35-39 La Colomberie Street, St Helier, Jersey JE2 4QB, Channel Islands;
ont nommé aux fonctions de Gérant, pour une durée illimitée, avec effet au 1
er
mars 2006:
Monsieur David Jonathan Francis, né le 4 août 1969 à Swansea, Channel Islands, domicilié Maxwell Chambers, 35-39
La Colomberie Street, St Helier, Jersey JE2 4QB, Channel Islands.
Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- Mr David Jonathan Francis, Gérant.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.
Luxembourg, le 14 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032071/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
C-TEC S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9809 Hosingen, Op der Hei.
H. R. Luxemburg B 114.664.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den neunten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Hesperange.
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft METEC FINANCE S.A., mit Sitz in L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais, hier vertreten durch seinen
mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwalter und allein Unterschriftsbefugten, Herr Ralph Heckel,
Speditionsfahrer, wohnhaft in D-54689 Dahnen (Deutschland), 35, Hauptstrasse,
2.- Die Gesellschaft der British Virgin Islands PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, mit Sitz in Tortola (B.V.I.),
Beaufort House P.O. Box 438, Road Town, registriert unter Nummer 221438, hier vertreten durch Dame Nancy Que-
rinjean, Privatangestellte, wohnhaft in B-4960 Malmédy (Belgien), 23, Chemin du Lefa, handelnd in ihrer Eigenschaft als
alleinunterschriftsbefugter Verwalter der Gesellschaft aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats vom 17. Juli 2005,
der Gesellschaft PENDLE HOLDINGS LTD.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine
luxemburgische Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung C-TEC S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Hosingen. Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher
oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz
oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vor-
übergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass
jedoch diese Maßnahme eine Wirkung auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provi-
sorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben wird.
Eine solche Sitzverlegungserklärung wird gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch den mit der täglichen
Geschäftsführung Beauftragten der Gesellschaft.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Maschinenbauschlosserei.
Sie kann generell jede Handlungen geschäftlicher, mobiliarer und immobiliarer, industrieller oder finanzieller Art
tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn fördern.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in tausend (1.000)
Aktien ohne Nennwert.
Art. 6. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
<i>Pour FirstCo INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / G. Birchen
58959
Es können je nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann in dem Maße und zu den Bedingungen die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, Aktionäre
oder Nichtaktionäre, welche von der Gesellschafterversammlung für eine Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt
werden. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. Die
nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bezeichnen; in dessen Abwesenheit wird der
Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, welches zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt
wird.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder zugegen oder vertreten sind; ein Man-
dat zwischen Verwaltungsräte ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kollegen
vertreten kann.
Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Kabeltelegramm,
Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie, erteilt werden.
In Dringlichkeitsfällen hat ein schriftlicher von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschrie-
bener Beschluss die gleiche gültige und rechtsverbindliche Wirkung, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung
gefasst worden.
Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Art. 10. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten
bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigefügt.
Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegen-
wärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-
ten, die Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder
Spezialvollmachten für Einzelgeschäfte einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen, wobei die
Übertragung dieser Vollmachten an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates der vorherigen Genehmigung der Gene-
ralversammlung bedarf.
Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte zu denen er selbst befugt ist.
Art. 13. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unter-
schrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon die obligatorische Mitunterzeichnung des mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung.
Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.
Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre,
welche für die Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalversammlung bestellt werden; sie sind wiederwählbar
und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.
Gesellschafterversammlung
Art. 15. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit
der Gesellschafter.
Sie hat die weitgehendsten Befugnisse um über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu entscheiden.
Art. 16. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am dritten Freitag des Monats Mai um 16.00 Uhr.
Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 17. Eine aussergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die
Kommissare einberufen werden.
Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, welche mindestens ein Fünftel des Gesellschafts-
kapitals vertreten, gefordert werden.
Art. 18. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt gemäss der im Gesetz vorgeschriebenen Formen
und Fristen. Sie beinhaltet die Tagesordnung.
Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen
werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und erklären den Inhalt
der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Jeder Aktionär kann selbst oder vermittels Bevollmächtigtem an den Generalversammlungen teilnehmen und abstim-
men.
58960
Soweit dies nicht anders durch das Gesetz bestimmt ist, werden die Bestimmungen einer regelmässig zusammenge-
rufenen Gesellschafterversammlung durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden/vertretenen und stimm-
berechtigten Aktionäre genommen.
Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls
eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche
dieser Aktie anhaften, zu suspendieren solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust-und Gewinnrechnung.
Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterla-
gen nebst einem Tätigkeitsbericht.
Art. 21. Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn
dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obliga-
torische Vorwegnahme entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und mit Zustimmung des oder der Kommissare der Gesell-
schaft wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividenden auszuzahlen.
Auflösung - Liquidation
Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche gemäss den für die Satzungsände-
rung vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, von der Gesellschaf-
terversammlung ernannt, welche ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.
Gesetzgebung
Art. 23. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahr 2007.
<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien sind vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreissigtausend
Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrück-
lich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr 1.500,- EUR geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben, nach Festellung der ordnungsgemässen Einberufung und
Zusammensetzung dieser Versammlung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen, festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
a) Herr Frank Leifgen, Werkzeugmacher, wohnhaft in D-54689 Dahnen (Deutschland), 3, Am Friedhof, geboren zu
Prum (Deutschland), am 31. Januar 1970,
b) Dame Gisela Ludes geborene Breuer, Arzthelferin, wohnhaft in D-54689 Dahnen (Deutschland), 9, Birkenweg,
geboren zu Dahnen (Deutschland), am 20. März 1951,
c) Dame Sonja Meyers, Krankenschwester, wohnhaft in D-54666 Irrel (Deutschland), Talstraße, geboren zu Prum
(Deutschland), am 9. Januar 1971.
3) Zum Kommissar wird ernannt: Herr Jean-Louis Posson, Handelsagent, wohnhaft in L-9709 Clerf, 7, route de
Marnach, geboren zu Etterbeek (Belgien), am 13. März 1949.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2011.
5) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9809 Hosingen, Op der Hei.
1) Die Gesellschaft METEC FINANCE S.A., vorbenannt, neunhundertneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . .
999
2) Die Gesellschaft PENDLE HOLDINGS LIMITED LTD, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: eintausend Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
58961
6) Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungs-
rat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäfts-
führung individuell an ein oder mehrere Verwaltungsratmitglieder zu übertragen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Clerf, 7, route de Marnach, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung stehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie
Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Heckel, N. Querinjean, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, vol. 27CS, fol. 49, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations.
<i>Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 9. Februar 2006i>
Verwaltungsratsmitglieder, zugegen:
- Herr Frank Leifgen, Werkzeugmacher, wohnhaft in D-54689 Dahnen (Deutschland), 3, Am Friedhof;
- Dame Gisela Ludes geborene Breuer, Artzhelferin, wohnhaft in D-54689 Dahnen (Deutschland), 9, Birkenweg;
- Dame Sonja Meyers, Krankenschwester, wohnhaft in D-54666 Irrel (Deutschland), Talstrasse.
Die Verwaltungsratsmitglieder, nachdem sie sich als gültig zusammenberufen betrachtet haben, haben einstimmig
folgenden Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
Gemäss der Ermächtigung durch die ausserordentliche Gesellschafterversammlung, überträgt der Verwaltungsrat die
gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäfts-
führung an Herrn Frank Leifgen, vorbenannt, mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine alleinige und obligatorische
Unterschrift für alle Geschäfte in diesem Zusammenhang zu binden.
Enregistré à Diekirch, le 3 mars 2006, réf. DSO-BO00012. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(923191/241/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 mars 2006.
CERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.027.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02334, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034163/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
ARGELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 54.017.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’administrateur le 28 mars 2006 i>
Le 28 mars 2006, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY et Hans van de Sanden, en tant qu’administrateurs
de la société ARGELUX S.A., ont pris la résolution suivante:
- de confirmer que la société est valablement engagée par la signature individuelle de chacun des administrateurs, en
accord avec l’article 9 des Statuts de la société.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06268. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032081/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
Hesperange, le jeudi 2 mars 2006.
M. Decker.
F. Leifgen / S. Meyers / G. Ludes geborene Breuer.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
58962
BELLEVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.542.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2006i>
- L’Assemblée révoque KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, ayant son siège social 31, allée Scheffer à L-2520
Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes.
- L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes Monsieur Sandro Pedrotti, avec adresse pro-
fessionnelle au 26, Upper Brook Street à Londres W1K 7QE. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée géné-
rale qui se tiendra en 2006.
Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04899. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(032073/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
I.M. & M., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.
H. R. Luxemburg B 114.619.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den zweiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit dem Amtssitz zu Clerf.
Ist erschienen:
Herr Franz Josef Georges, Ingenieur, geboren zu Amel (B), den 23. April 1962, wohnhaft zu B-4761 Büllingen, Roche-
rath 146B.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung I.M. & M., S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ulflingen.
Er kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Ingenieurbüros für die Erstellung und sprachliche Über-
setzung technischer Dokumente, die Schaffung, den Erwerb und die Vermarktung von Informatikprogrammen sowie die
Verwaltung, Beratung und Marketing.
Die Gesellschaft kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und un-
bewegliche Güter vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhän-
gen, für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die
Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.
Sie kann sich auch in Form von Einlagen, Fusion oder sonst wie an jedem Unternehmen, jeder Vereinigung oder jeder
Gesellschaft beteiligen, die einen zusammengehörenden, gleichartigen oder ergänzenden Gegenstand hat oder überdies
den Gegenstand der gegenwärtigen Gesellschaft begünstigt.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert euros (12.500,- EUR) und ist aufgeteilt in hundert-
fünfundzwanzig Anteile (125) Anteile von je hundert Euro (100,- EUR).
Die Geschäftsanteile wurde integral gezeichnet und eingezahlt durch Herrn Franz Josef Georges wie dieses dem un-
terzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Sie sind
gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58963
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der übrigen
Gesellschafter.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.
Titel III. - Verwaltung und Vertretung
Art. 9. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-
wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich
rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der
Gesellschaft sein müssen.
Sie werden vom alleinigen Gesellschafter beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche
ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter
allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Titel IV. - Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den
Jahresabschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen
Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter wahrend
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die. Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese
äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 14. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder
eines der Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf, sondern sie wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen
weitergeführt.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Titel V. - Auflösung und Liquidation
Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere, vom alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Titel VI. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 16. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933 und
das Gesetzt vom 28. Dezember 1992 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen,
werden abgeschätzt auf eintausendzweihundertvierzig Euro (1.240,- EUR).
58964
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm davon Kenntnis gegeben hat dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden,
ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird Herr Franz Josef Georges, vorgenannt, ernannt.
Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: F.J. Georges, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 1
er
mars 2006, vol. 355, fol. 37, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Rodenbour.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(922521/238/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2006.
ARMADILLO LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 107.516.
—
In the year two thousand and six, on the thirty-first of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg, under the denomination of
ARMADILLO LUX HOLDING S.A., R.C. Number B 107.516, having its registered office in Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 12, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 876 of September 10, 2005.
The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated September 5, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 47 of January 6, 2006.
The meeting begins at twelve, Mrs Frédérique Duculot, private employee, with professional address at 66, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address
at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ten thousand
(10,000) shares of a par value of one hundred (100.-) Euro each, representing the total capital of one million (1,000,000.-)
Euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items
on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed
to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1) Increase of the corporate capital of the Company by an amount of two million six hundred thousand (2,600,000.-)
Euro so as to raise it from its present amount of one million (1,000,000.-) Euro to three million six hundred thousand
(3,600,000.-) Euro by the creation and issue of twenty-six thousand (26,000) new shares with a par value of one hundred
(100.-) Euro each.
2) Subscription and payment in cash of the new shares.
3) Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
4) Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two million six hun-
dred thousand (2,600,000.-) Euro so as to raise it from its present amount of one million (1,000,000.-) Euro to three
million six hundred thousand (3,600,000.-) Euro by the creation and issue of twenty-six thousand (26,000) new shares
with a par value of one hundred (100.-) Euro each.
Clerf, den 1. März 2006.
M. Weinandy.
58965
The new shares have been subscribed in the following manner:
a) two thousand (2,000) shares by Mr Paul Van Poecke, Director, residing Voshodal 4, B-2930 Brasschaat,
here represented by Mrs Frédérique Duculot, private employee, with professional address at 66, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Brasschaat, on March 30, 2006;
b) eighteen thousand five hundred and eighty-two (18,582) shares by Mr Marcel Van Poecke, Director, residing 193,
Belgiëlei, B-2018 Antwerp,
here represented by Mrs Frédérique Duculot, prenamed,
by virtue of a proxy given in Antwerp, on March 30, 2006;
c) two thousand one hundred sixty-eight (2,168) shares by Mr André van Gils, Director, residing 24, Hinterbergs-
trasse, CH-6305 Zug,
here represented by Mrs Frédérique Duculot, prenamed,
by virtue of a proxy given in Zug, on March 28, 2006;
d) three thousand two hundred fifty (3,250) shares by Mrs Irina Liner, Director, residing 193, Belgiëlei, B-2018 An-
twerp,
here represented by Mrs Frédérique Duculot, prenamed,
by virtue of a proxy given in Antwerp, on March 30, 2006.
Said proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it, that the amount of two million six hun-
dred thousand (2,600,000.-) Euro is as of now at the free disposal of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution article 3 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth
read as follows:
«Art. 3. The corporate capital is set at three million six hundred thousand Euro (EUR 3,600,000.-), divided into thir-
ty-six thousand (36,000) shares having a par value of one hundred (EUR 100.-) each.»
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at twelve
fifteen.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg, sous la dénomination de ARMADILLO LUX HOLDING S.A., R.C. B N
°
107.516, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 12 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nu-
méro 876 du 10 septembre 2005.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire, en date du 5 septembre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 47 du 7 janvier 2006.
La séance est ouverte à douze heures sous la présidence de Madame Frédérique Duculot, employée privée, avec
adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-
nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-
nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille
(10.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, constituant l’intégralité du capital social d’un mil-
lion (1.000.000,-) d’euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions six cent mille (2.600.000,-) euros pour le porter de
son montant actuel d’un million (1.000.000,-) d’euros à trois millions six cent mille (3.600.000,-) euros par la création
et l’émission de vingt-six mille (26.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.
2) Souscription et libération en espèces des nouvelles actions.
58966
3) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
4) Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’ assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions six cent mille (2.600.000,-)
euros pour le porter de son montant actuel d’un million (1.000.000,-) d’euros à trois millions six cent mille (3.600.000,-)
euros par la création et l’émission de vingt-six mille (26.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent (100,-)
euros chacune.
Les nouvelles actions ont été intégralement souscrites de la manière suivante:
a) deux mille (2.000) actions par Monsieur Paul Van Poecke, Administrateur, demeurant Voshodal 4, B-2930 Brass-
chaat,
ici représenté par Madame Frédérique Duculot, employée privée, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Brasschaat, le 30 mars 2006;
b) dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux (18.582) actions par Monsieur Marcel Van Poecke, Administrateur, de-
meurant 193, Belbiëlei, B-2018 Anvers,
ici représenté par Madame Frédérique Duculot, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Anvers, le 30 mars 2006;
c) deux mille cent soixante-huit (2.168) actions par Monsieur André van Gils, Administrateur, demeurant 24, Hinter-
bergstrasse, CH-6305 Zug,
ici représenté par Madame Frédérique Duculot, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Zug, le 28 mars 2006;
d) trois mille deux cent cinquante (3.250) actions par Madame Irina Liner, Administrateur, demeurant 193, Belgiëlei,
B-2018 Anvers,
ici représentée par Madame Frédérique Duculot, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Anvers, le 30 mars 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de deux millions six cent mille
(2.600.000,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions six cent mille euros (EUR 3.600.000,-), divisé en trente-six mille
(36.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire la présente
minute.
Signé: F. Duculot, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 20, case 5. – Reçu 26.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036005/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.
ARMADILLO LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 107.516.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
440 du 31 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 24 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036006/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.
Luxembourg, le 19 avril 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
58967
ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.844.
—
<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 16 décembre 2005i>
Monsieur Gérald Marie, administrateur de sociétés, né à Paris (France), le 26 juillet 1950, demeurant professionnel-
lement à F-75008 Paris, 21, avenue Montaigne, a été nommé gérant de la société.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04793. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032077/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 19.979.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires et de celui du conseil d’administration du 7 mars 2006i>
1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-
fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé président du conseil d’ad-
ministration et administrateur-délégué jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011; et
2. Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né à Echternach, le 9 avril 1956, ayant son domicile professionnel à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé pour la même période directeur chargé de la
gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’engager ensemble avec Monsieur André Wilwert.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04819. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032078/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
DIMPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 39.794.
—
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2004i>
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
M
e
Fabio Gaggini, avocat, né à Gentilini (Suisse), le 6 mars 1956, demeurant à C-6901 Lugano, via Somaini 10, prési-
dent du conseil d’administration;
BAC MANAGMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.324, ayant son siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie;
A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.322, ayant son siège à
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
<i>Réviseur externe:i>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec
siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032088/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
<i>Pour ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour DIMPEX S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (INTERTRUST) S.A.
Signature
58968
PATRON DIETER HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 115.587.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirty-first day of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
PATRON CAPITAL, L.P. II, a limited partnership, registered in England and having its principal place of business in
Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mrs Valérie Schmit, private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6, rue
Adolphe, by virtue of a proxy given in Tortola, on March 30, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the officiating notary to document the deed
of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association of
which shall be as follows:
A. - Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of PATRON DIETER HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. - Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
58969
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-
ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-
tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of man-
agement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. - Dissolution, Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
58970
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON CAPITAL, L.P. II, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of
December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed
capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite
period:
- Mrs Marjoleine Van Oort, director of company, born on 28th February 1967 in Groningen (The Netherlands), with
professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969 in Messancy (Belgium), with professional
address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on the request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsechs, den einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg.
Ist erschienen:
PATRON CAPITAL, L.P. II, ein limited partnership, eingetragen in England, mit Gesellschaftssitz in Trident Chambers,
Wickhams Cay, BO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
hier vertreten durch Frau Valérie Schmit, Privatangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg, 6,
rue Adolphe, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Tortola, am 30. März 2006.
Diese Vollmacht bleibt, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und den
unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Diese erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité limi-
tée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,
sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON DIETER HOLDING, S.à r.l.
58971
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-
ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den
Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die
Dauer des Mandates fest.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu
jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-
keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im
Namen der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in
Einklang stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung
ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-
heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
58972
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus
welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er/Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich.
D. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, Haupversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
E. - Geschäftsjahr, Konten, Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Januars jeden Jahres und endet am
letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige
Geschäftsführer oder die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkei-
ten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz
nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. - Gesellschaftsauflösung, Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON CAPITAL, L.P. II, gezeichnet.
Diese gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar bewiesen
worden ist.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember
2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-
neunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Die alleinige Gesellschafterin welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der
Gründung der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit als Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft
ernannt:
- Frau Marjoleine Van Oort, «director of company», geboren in Groningen (Niederlande), am 28. Februar 1967,
berufsmäßig wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg;
- Frau Géraldine Schmit, «director of company», geboren in Messancy (Belgien), am 12. November 1969, berufsmäßig
wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg;
58973
- Herr Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in
6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg.
Worüber urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns,
dem Notar, diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: V. Schmit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 99, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035548/230/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 14.171.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 14 mars 2006i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Joseph Naufal, demeurant professionnellement au 4,
Frangoklisias, Paradisos, Amarousion, GR15125 à Athènes (Grèce), de son mandat d’administrateur avec effet au 21 oc-
tobre 2005.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032089/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
BC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.201.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2006i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2005:
- MAZARS, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, en remplacement du commissaire KPMG AUDIT.
Est nommée réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes con-
solidés au 31 décembre 2005:
- MAZARS, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032091/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
CLUB MED ASIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 72.301.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02316, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034155/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
Luxembourg, le 12 avril 2006.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
58974
PATRON DIETER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 115.588.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirty-first day of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
PATRON DIETER HOLDING, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
here represented by Mrs Valérie Schmit, private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6, rue
Adolphe, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on March 31, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the officiating notary to document the deed
of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association of
which shall be as follows:
A. - Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplis-
hment of its purpose including real estate investments.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of PATRON DIETER, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. - Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represen-
tative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
58975
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such mee-
ting. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in wri-
ting, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-
tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of ma-
nagement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. - Dissolution, Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
58976
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON DIETER HOLDING, S.à r.l., aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of
December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed
capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite
period:
- Mrs Marjoleine Van Oort, director of company, born on 28th February 1967 in Groningen (The Netherlands), with
professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969 in Messancy (Belgium), with professional
address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on the request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsechs, den einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg.
Ist erschienen:
PATRON DIETER HOLDING, S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxemburg,
hier vertreten durch Frau Valérie Schmit, Privatangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg, 6,
rue Adolphe, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 31. März 2006.
Diese Vollmacht bleibt, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und den
unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Diese erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft
Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,
sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind einschliesslich jegliche Immobilienanlagen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON DIETER, S.à r.l.
58977
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-
ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-
mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die
Dauer des Mandates fest.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu je-
dem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-
keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-
men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Ein-
klang stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-
heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
58978
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus wel-
chem Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er/Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich.
D. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, Haupversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
E. - Geschäftsjahr, Konten, Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Januars jeden Jahres und endet am
letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige
Geschäftsführer oder die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkei-
ten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz
nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. - Gesellschaftsauflösung, Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON DIETER HOLDING, S.à r.l., ge-
zeichnet.
Diese gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar bewiesen
worden ist.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember
2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-
neunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Die alleinige Gesellschafterin welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der
Gründung der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit als Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft
ernannt:
- Frau Marjoleine Van Oort, «director of company», geboren in Groningen (Niederlande), am 28. Februar 1967,
berufsmäßig wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg;
58979
- Frau Géraldine Schmit, «director of company», geboren in Messancy (Belgien), am 12. November 1969, berufsmäßig
wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg;
- Herr Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in
6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg.
Worüber urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns,
dem Notar, diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: V. Schmit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 99, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035549/230/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
FIBELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.213.
—
<i>Extrait de décisions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mars 2006i>
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire des actionnaires de 2007, les personnes suivantes sont administra-
teurs de la société:
M. James E. Schultz, administrateur de sociétés, né le 19 juillet 1933 à Council Buffs (Iowa, USA), demeurant à Ar-
lington, Virginie, USA, président du Conseil d’Administration;
M. Samuel Herbert Price, administrateur de sociétés, né le 13 janvier 1931 dans le Missouri (USA), demeurant à Dal-
las, 15225 Texas, Etats-Unis d’Amérique, 8509, Townhouse Row;
M. Frank Maiorano, administrateur de sociétés, né le 10 février 1950 à Détroit (Michigan, USA), demeurant à Arling-
ton, Virginie, USA.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032094/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
BH CONSULTING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 75.190.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2006i>
<i>Première résolutioni>
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée Générale Extraordinaire entérine la démission de Monsieur
Petat Bertrand demeurant F-54000 Nancy, 42, avenue Foch, de son post d’administrateur et administrateur-délégué
avec effet au 31 janvier 2006.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination de Mademoi-
selle Ubrich Nathalie demeurant F-54000 Nancy, avenue Foch, 42, au poste d’administrateur et administrateur-délégué.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032227/1549/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
Luxembourg, le 12 avril 2006.
A. Schwachtgen.
<i>Pour FIBELFIN S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme à l’original
FIDUCIAIRE CG.S.
Signature
58980
PATRON ELKE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 115.589.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirty-first day of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
PATRON CAPITAL, L.P. II, a limited partnership, registered in England and having its principal place of business in
Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mrs Valérie Schmit, private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6, rue
Adolphe, by virtue of a proxy given in Tortola, on March 30, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the officiating notary to document the deed
of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association of
which shall be as follows:
A. - Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of PATRON ELKE HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. - Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
58981
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-
ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-
tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the
provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of
December of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of man-
agement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. - Dissolution, Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
58982
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON CAPITAL, L.P. II, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of
December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed
capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite
period:
- Mrs Marjoleine Van Oort, director of company, born on 28th February 1967 in Groningen (The Netherlands), with
professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969 in Messancy (Belgium), with professional
address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on the request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsechs, den einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg.
Ist erschienen:
PATRON CAPITAL, L.P. II, ein limited partnership, eingetragen in England, mit Gesellschaftssitz in Trident Chambers,
Wickhams Cay, BO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
hier vertreten durch Frau Valérie Schmit, Privatangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg, 6,
rue Adolphe, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Tortola, am 30. März 2006.
Diese Vollmacht bleibt, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und den
unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Diese erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft
Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,
sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON ELKE HOLDING, S.à r.l.
58983
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden,
vorausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den
Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die
Dauer des Mandates fest.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu
jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-
keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im
Namen der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in
Einklang stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-
heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
58984
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus
welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er/Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich.
D. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, Haupversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
E. - Geschäftsjahr, Konten, Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Januars jeden Jahres und endet am
letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige
Geschäftsführer oder die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkei-
ten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz
nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. - Gesellschaftsauflösung, Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON CAPITAL, L.P. II, gezeichnet.
Diese gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar bewiesen
worden ist.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember
2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-
neunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Die alleinige Gesellschafterin welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der
Gründung der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit als Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft
ernannt:
- Frau Marjoleine Van Oort, «director of company», geboren in Groningen (Niederlande), am 28. Februar 1967,
berufsmäßig wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg;
- Frau Géraldine Schmit, «director of company», geboren in Messancy (Belgien), am 12. November 1969, berufsmäßig
wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg;
58985
- Herr Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in
6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg.
Worüber urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns,
dem Notar, diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: V. Schmit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 99, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035550/230/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
STARDON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 106.499.
—
Lors d’une résolution signée en date du 10 mars 2006, les associés de la société STARDON INVESTMENTS, S.à r.l.
ont décidé de nommer au poste de gérant de la société STARDON INVESTMENTS, S.à r.l. Monsieur Gérard Becquer,
avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 13 mars 2006 et pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00718. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032096/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
HOFIN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 85.783.
—
Les coordonnées du gérant de la société, Monsieur Giuseppe Hofer ne sont plus Bruneck (BZ), Fraktion Utenheim,
Hebenstreitstrasse 28, mais sont désormais les suivantes:
- Herr Giuseppe Hofer, Geschäftsführer, wohnhaft in I-39012 Meran (BZ), Fragsburgerstrasse 7/a.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(032097/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
AZURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 61.746.550.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 105.413.
—
Lors de la résolution signée en date du 16 mars 2006, l’associé unique de la société AZURE, S.à r.l. a décidé de nom-
mer Monsieur John Anthony Jackson, résidant au 2, Skivo Wynd, Murieston, Livingston, West Lothian EH54 9GY,
Royaume-Uni en tant que gérant suppléant de Monsieur Alan Dick pour une période indéterminée et avec effet immé-
diat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00714. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032105/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.
Luxembourg, le 12 avril 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HOFIN, GmbH
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature.
58986
AUTO MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 115.627.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twelfth of April.
Before us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).
There appeared:
1. Maître Andres Baumgartner, lawyer, born in CH-Altstätten, on January 2nd, 1961, residing professionally in Sihl-
porte 3/Talstrasse, CH-8021 Zurich,
duly represented by Mr Jos Hemmer, employé privé, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered the 17th of March 2006 in Zurich,
2. Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg, on December 10th, 1960, residing professionally in
L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg, on August 15th, 1952, residing professionally in L-1347 Lux-
embourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, re-
main annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
holding company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-
after, a joint stock holding company (société anonyme holding) is herewith formed under the name of AUTO MEDIA
GROUP S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which
are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits
established by the law of July 31st, 1929 on holding companies and by article 209 of the amended law of August 10th,
1915.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three
hundred ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at three hundred and ten thousand Euro (EUR
310,000.-) to be divided into three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each.
58987
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 11th of April 2011, to
increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with incontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds in shares as mentioned below.
The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the existing sharehold-
ers a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by
letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one
A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director,
whose signature legally commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
58988
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the fourth Wednesday of the month of June, at 10 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing at least twenty percent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong
to the usufructuary.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall take
place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed and paid up as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915, as subsequently amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two
thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
Subscriber
Number of shares
subscribed
Amount subscribed to
and paid-up in Euro
1) Maître Andres Baumgartner, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
30,800.-
2) Mrs Martine KAPP, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100.-
3) Mr Jos HEMMER, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31,000.-
58989
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at four.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the
year 2011:
A signatories:
a) Maître Andres Baumgartner, lawyer, born in CH-Altstätten, on January 2nd, 1961, residing professionally in Sihl-
porte 3/Talstrasse, CH-8021 Zurich;
b) Maître Fabio Delco, lawyer, born in CH-Bellinzona, on October 23rd 1967, residing professionally in Sihlporte 3/
Talstrasse, CH-8021 Zurich;
B signatories:
c) Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg, on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de
la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg;
d) Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg, on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
Maître Andres Baumgartner has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general
meeting.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held
in the year 2011:
Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in B-Arlon, on November 16th, 1968, residing professionally at 6A, Circuit de
la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary, who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the
above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known
to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with us, Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille six, le douze avril.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Maître Andres Baumgartner, avocat, né à Altstätten (CH), le 2 janvier 1961, demeurant professionnellement à Si-
hlporte 3/Talstrasse, CH-8021 Zurich,
ici représenté par Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 17 mars 2006 à Zurich.
2. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, demeurant professionnelle-
ment à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
3. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding
qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de AUTO MEDIA GROUP S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
58990
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) qui
sera représenté par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 avril 2011, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’ac-
tions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéficies reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommée par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
58991
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le quatrième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-
missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
58992
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationsi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros
(EUR 2.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011:
Signatures catégorie A:
- Maître Andres Baumgartner, avocat, né à CH-Altstätten, le 2 janvier 1961, demeurant professionnellement à Sihl-
porte 3/Talstrasse, CH-8021 Zurich,
- Maître Fabio Delco, avocat, né à CH-Bellinzona, le 23 octobre 1967, demeurant professionnellement à Sihlporte 3/
Talstrasse, CH-8021 Zurich.
Signatures catégorie B:
- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A, Cir-
cuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,
- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Maître Andres Baumgartner aux fonctions de président du conseil d’ad-
ministration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en
2011:
Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à B-Arlon, le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-
sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.
Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français le texte anglais primera.
Signé: J. Hemmer, M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 avril 2006, vol. 533, fol. 66, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(036112/213/420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.
Souscripteurs
Nombre d’actions
Montant souscrit
souscrites
et libéré en euros
1) Maître Andres Baumgartner, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
30.800,-
2) Mme Martine Kapp, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100,-
3) M. Jos Hemmer, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31.000,-
Grevenmacher, le 18 avril 2006.
J. Gloden.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Mobilestop.com Europe, S.à r.l.
Industrial Development Company S.A.
European Credit (Luxembourg) S.A.
Léon Weiwers, les Héritiers, Luxembourg
Léon Weiwers, les Héritiers, Luxembourg
Heirens Romain, S.à r.l.
Norman International S.A.
Metec Finance S.A.
Skyguards S.A.
Bakker Van Vorst B.V., S.à r.l.
Foncière Kons S.A.
Johnen-Maraite, GmbH
SGL Carbon Luxembourg S.A.
Scarlet, S.à r.l.
Imolux S.A.
Imolux S.A.
Foralim S.A.
Aerium Holdings S.A.
Iona S.A.
FirstCo Investments, S.à r.l.
C-Tec S.A.
Cerfin S.A.
Argelux S.A.
Belleville S.A.
I.M. & M., S.à r.l.
Armadillo Lux Holding S.A.
Armadillo Lux Holding S.A.
Elite Model Management Luxembourg, S.à r.l.
MeesPierson Intertrust Financial Engineering S.A.
Dimpex S.A.
Patron Dieter Holding, S.à r.l.
Associated Consulting Engineers (Holdings) S.A.
BC International S.A.
Club Med Asie S.A.
Patron Dieter, S.à r.l.
Fibelfin S.A.
BH Consulting S.A.
Patron Elke Holding, S.à r.l.
Stardon Investments, S.à r.l.
Hofin, GmbH
Azure, S.à r.l.
Auto Media Group S.A.