This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
56305
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1174
16 juin 2006
S O M M A I R E
COMPAGNIE EUROPEENNE DE LOISIRS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.402.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07007, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030202/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Ada Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
56347
GP Worldwide Investments (Luxembourg), S.à r.l.,
Adam&Eve S.C., Roedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56350
Luxemburg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56317
Apparatur Verfahren S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
56350
GSC European CDO IV S.A., Luxembourg . . . . .
56308
Arcadie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56344
Inox Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56316
Arcadie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56345
Kereda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56331
ATL Location, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . .
56322
Kereda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56331
Ceratizit Luxembourg, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . .
56348
Luxembourg Rent Equipment Holding S.A., Lu-
Ceratizit Luxembourg, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . .
56350
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56347
Cetrel Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56306
Lycaon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56321
CLAC, Compagnie Luxembourgeoise d’Activité
Materis Investors, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
56326
Cynégétique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
56316
Melchior International S.A., Luxembourg . . . . . . .
56332
Compagnie Européenne de Loisirs S.A., Luxem-
Melchior International S.A., Luxembourg . . . . . . .
56333
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56305
Mezzanove Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
56333
Dalgarno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56335
Mezzanove Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
56335
Dalgarno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56337
OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A., Luxem-
Delvino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56345
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56318
Delvino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56347
OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A., Luxem-
Eastgate Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
56306
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56321
EOI European & Overseas Investment, S.à r.l., Lu-
OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56316
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56337
Fluitronics S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56331
OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A., Luxem-
Foncière Medicis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
56350
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56343
General O & R International S.A., Windhof . . . . . .
56322
Tourism Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
56352
GP Worldwide Investments (Luxembourg), S.à r.l.,
Vac Property One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
56322
Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56318
Voyages J.C. S.A., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . . .
56331
Signature.
56306
CETREL RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.845.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le jeudi 2 mars 2006 à 11.00 heures i>
<i>au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourgi>
L’Assemblée prend note de la démission de Monsieur Hemmerling en date du 15 février 2006.
L’Assemblée confirme et renouvelle le mandat d’Administrateur et Président de M. Gilbert Ernst coopté en date du
10 juin 2005.
Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2007 et qui aura à statuer sur les comptes
de l’exercice de 2006.
Après l’Assemblée le conseil se compose comme suit:
M. Gilbert Ernst, demeurant 17, rue Blochausen L-1243 Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
M. Jean-Marc Fandel, Membre, demeurant 16, allée St Hubert, L-8138 Bridel, Administrateur;
M. Jean-Paul Bettendorff, demeurant 15, rue Bruch, L-4975 Bettange/Mess, Administrateur;
M. Gérald Briclot, Sous-Directeur de Cetrel SC, demeurant 10, rue des Aubépines, F-57310 Bertrange, Administra-
teur.
L’Assemblée nomme DELOITTE S.A. comme Réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à
l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2007 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04861. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030148/4685/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
EASTGATE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1114 Luxemburg, 3, rue Nicolas Adames.
H. R. Luxemburg B 115.204.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, den vierundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1. EASTGATE INVEST A.G., mit Sitz in 28, Pilatusstrasse, CH-6052 Hergiswil,
hier vertreten durch Herrn Pierre Schill, «licencié en sciences économiques», mit Berufsanschrift in 18A, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 21. März 2006.
2. MIDWEST HOLDING A.G., mit Sitz in 28, Pilatusstrasse, CH-6052 Hergiswil,
hier vertreten durch Herrn Pierre Schill, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 21. März 2006.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentinnen, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung
einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Unter der Bezeichnung EASTGATE LUXEMBOURG S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Lizenzen er-
werben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen Sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
56307
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck
in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten aus-
üben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend (200.000) USD eingeteilt in 200 Aktien ohne Nennwert.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-
den Aktien.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem an-
wesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftführer oder andere Be-
vollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-
zelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag im Monat Juni um 14 Uhr in Lu-
xemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-
fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheißen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausend-
sechs.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre zweitausendsieben.
56308
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
den Betrag von USD 200.000,- wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Abschätzungi>
Zum Zwecke der Eingeristrierung wird das Kapital abgeschätzt auf einhundertfünfundsechzigtausendneunhundert-
sechs Euro sechsundzwanzig Cent (EUR 165.906,26).
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreitausend Euro (EUR 3.000,-).
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die anfangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Leo Spitzer, geboren am 6. Februar 1948, wohnhaft in CH-6300 ZUG, Baarerstrasse 63;
b) Herr Pierre Schill, geboren am 10. August 1957, wohnhaft in 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
c) Frau Joëlle Lietz, geboren am 28. Dezember 1969, wohnhaft in 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-
lung von zweitausendsieben.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Bevollmächtigten der Komparentinnen, hat derselbe mit Uns No-
tar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Schill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 2, case 7. – Reçu 1.670,98 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030912/230/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
GSC EUROPEAN CDO IV S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 115.206.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the third day of April.
Before Maître Marc Lecuit, civil law notary residing at 13, Grand-rue, 8510 Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Lux-
embourg.
Appeared:
1.- STICHTING GSC I, a foundation (stichting) established under the laws of The Netherlands, registered with the
Amsterdam Chamber of Commerce under number 34.179.935, having its statutory office in The Netherlands at 1, Lo-
catellikade, 1076 AZ Amsterdam;
2.- STICHTING GSC II, a foundation (stichting) established under the laws of The Netherlands, registered with the
Amsterdam Chamber of Commerce under number 34.179.931, having its statutory office in The Netherlands at 1, Lo-
catellikade, 1076 AZ Amsterdam.
Represented by Maître Quentin Hubeau, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private
seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
1. EASTGATE INVEST A.G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Aktien
2. MIDWEST HOLDING A.G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Aktie
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Aktien
Luxembourg, le 4 avril 2006.
A. Schwachtgen.
56309
Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-
ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» (the «Company») which they declared to organize among them-
selves.
Chapter I.- Name, Registered Office, Object, Duration
1. Form, Name
1.1 A Luxembourg public limited company («société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg and by the present articles (the «Articles»).
1.2 The Company exists under the firm name of GSC EUROPEAN CDO IV S.A.
2. Registered Office
2.1 The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to
change the address of the Company inside the municipality of the Company’s registered office.
2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are
likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.
3. Object
3.1 The objects of the Company are, under the benefit of the law dated 22 March 2004 relating to securitisation as
amended from time to time (but without however exercising at any time a professional banking or credit activity), to
invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments, including but not limited to shares, warrants
and equity securities, bonds, notes, rights or participations in senior or mezzanine obligations (including, but not limited
to, senior and mezzanine loans) and in financial derivatives agreements and other debt instruments or securities, trade
receivables or other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) and to
enter into any agreements relating to the acquisition of such domestic or foreign securities or similar instruments. The
Company may dispose in any form and by any means, whether directly or indirectly, of any part or the totality of such
portfolio (in accordance with the transaction documents or agreements entered into by the company) and may grant
pledges, guarantees or other security interests of any kind under any law to Luxembourg or foreign entities. The Com-
pany may further issue securities of any kind the value or the yield of which is limited to specific compartments, assets
or risks, or whose repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of
shares.
3.2 The Company may also:
(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, subordinated notes and other debt
instruments or debt securities, the use of financial derivatives or otherwise and obtain loans or any other form of credit
facility;
(b) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the
Company may provide credit protection to the swap counterparty;
(c) grant security for funds raised, including bonds, obligations and notes issued, and for indemnities given by the
Company;
(d) enter into all necessary agreements, including, but not limited to underwriting agreements, marketing agreements,
management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling
agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements, bank and cash
administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and any agreements creating any
kind of security interest.
3.3 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments
or operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however
without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on holding companies.
4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II.- Capital
5. Capital
The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), divided into thirty-one (31) registered shares
with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each, fully paid up.
6. Form of the Shares
The shares are in registered or bearer form at the request of the shareholders and subject to legal conditions.
7. Payment of shares
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which
the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid up.
8. Modification of capital
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted
in the manner legally required for amending the Articles.
56310
8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III.- Bonds, Notes and other Debt Instruments
9. Registered or bearer Form
The Company may issue bonds, notes or other debt instruments in registered or bearer form. Bonds, notes or other
debt instruments in registered form may not be exchanged or converted into bearer form.
Chapter IV.- Directors, Board of Directors, Independent Auditors
10. Board of Directors
10.1 The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be share-
holders. A legal entity may be a member of the Board of Directors.
10.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6)
years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They
will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the
term of his mandate, he is deemed to be elected for six (6) years from the date of his election.
10.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders
because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority
vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such
election.
11. Meetings of the Board of Directors
11.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed
by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the
Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-
sented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Di-
rector as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing
at a later stage.
11.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman
has a casting vote.
11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
11.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all of
them in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolu-
tions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors’ meetings, duly convened.
11.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in
writing.
11.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-
tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
12. General Powers of the Board of Directors
12.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Directors.
12.2 The Board of Directors is authorised to establish one or various compartments, each of which corresponding
to a distinct part of its estate («patrimoine»).
13. Delegation of Powers
13.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board,
Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such
powers as the Board shall determine. The delegation to a member of the Board of Directors shall be subject to the
prior authorisation of the general meeting of shareholders.
13.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person who need not be Direc-
tors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
13.3 The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.
14. Representation of the Company
In all circumstances, the Company shall be bound by the joint signature of any two Directors or by the single signature
of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors of the Company.
15. Independent Auditor
15.1 One or more independent auditor(s) (réviseur d’entreprises) shall be appointed by the Board of Directors of
the Company, which determines their number, their remuneration and the term of their office. The appointment may,
however, not exceed a period of six (6) years. In case the independent auditors are elected without mention of the term
of their mandate, they are deemed to be elected for six (6) years from the date of their election.
15.2 The independent auditors are re-eligible.
56311
Chapter V.- General Meeting of Shareholders
16. Powers of the General Meeting of Shareholders
16.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall
have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
16.2 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by
registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented
and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements
and formalities of publication.
16.3 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
16.4 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the
Articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders
present or represented.
16.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.
17. Place and Date of the Annual General Meeting of Shareholders
The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice con-
vening the meeting in Luxembourg on the 28th June at 11.00 and for the first time in 2007.
18. Other General Meetings
Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the share-
holders which together represent one fifth of the capital of the Company.
19. Votes
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of
shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.
Chapter VI.- Business Year, Distribution of Profits
20. Business Year
20.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on the December 31st, 2006.
20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents
together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the independent auditors who shall make a report containing comments on such documents.
21. Distribution of Profits
21.1 Each year at least five per cent of the net profits shall be allocated to the legal reserve account. This allocation
is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.
21.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-
tribution of net profits.
21.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VIl.- Dissolution, Liquidation
22. Dissolution, Liquidation
22.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quo-
rum as for the amendment of the Articles.
22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the general meeting of shareholders.
Chapter VIII.- Applicable Law
23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10 August 1915 on
Commercial Companies and amendments thereto as well as the Law of 22 March 2004 on securitisation, as amended
from time to time.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the thirty-one (31) shares as
follows:
Shareholders
Subscribed Capital
Number of Share(s)
Payments
Stichting GSC I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1,000
1
EUR 1,000
Stichting GSC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 30,000
30
EUR 30,000
56312
All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is forthwith at the
free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about three thousand two hundred
fifty-five Euro (EUR 3,255).
<i>First Extraordinary General Meeting of Shareholdersi>
The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed
the following resolutions:
1. The Company’s address is fixed at 1, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors for a maximum period of six (6) years, their mandate expiring on
occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2012:
a) Johannes van Koeverden Brouwer, director, with professional address at 1, allée Scheffer, 2520 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg;
b) Jorge Perez Lozano, director, with professional address at 1, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
c) TMF CORPORATE SERVICES S.A., director, established at 1, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
3. The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-
agement of the business of the Company to one or more of its Directors.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an deux mille six, le trois avril.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence au 13, Grand-rue, 8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duché de
Luxembourg.
Ont comparu:
1.- STICHTING GSC I, une fondation (stichting) de droit néerlandais, immatriculée auprès de la Chambre de Com-
merce d’Amsterdam sous le numéro 34.179.935, ayant son siège social au 1, Locatellikade, 1076 AZ Amsterdam, Pays-
Bas;
2.- STICHTING GSC II, une fondation (stichting) de droit néerlandais, immatriculée auprès de la Chambre de Com-
merce d’Amsterdam sous le numéro 34.179.931, ayant son siège social au 1, Locatellikade, 1076 AZ Amsterdam, Pays-
Bas.
Ici représentées par Maître Quentin Hubeau, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing
privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme (la «Société») qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
1. Forme, Dénomination
1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts (les «Statuts»).
1.2 La Société adopte la dénomination GSC EUROPEAN CDO IV S.A.
2. Siège social
2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse
de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-
ministration.
56313
3. Objet
3.1 L’objet de la Société est, sous bénéfice de la loi du 22 mars 2004 relative aux titrisations, telle que modifiée (mais
sans toutefois exercer à un quelconque moment une activité bancaire ou de crédit professionnelle), d’investir dans un
portefeuille comprenant des titres, nationaux ou étrangers, ou d’autres instruments, incluant mais non limités aux ac-
tions, warrants et autres titres de capital, des obligations, des droits ou des participations dans des obligations contrac-
tuelles prioritaires ou mezzanines (y compris, mais sans limitation, des prêts prioritaires - senior loans - ou des prêts
mezzanine - mezzanine loans) et dans des contrats sur des produits dérivés et autres instruments similaires d’endette-
ment ou de titrisation, des créances commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations (notam-
ment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques) et de conclure des contrats relatifs à
l’acquisition de ces titres, nationaux ou étrangers, ou d’autres instruments. La Société peut disposer sous toute forme
et par tout moyen, soit directement, soit indirectement, de toute part ou de la totalité de ce portefeuille (conformément
aux documents ou contrats opérationnels conclus par la Société) et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de
toutes sortes soumis à une quelconque loi et accordés à des entités luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut
en outre émettre des valeurs mobilières de toute nature dont la valeur ou le rendement sont fonction de comparti-
ments, d’actifs ou de risques déterminés ou dont le remboursement est subordonné au remboursement d’autres titres,
de certaines créances, ou de certaines catégories d’actions.
3.2 La Société peut également:
(a) lever des fonds, et notamment émettre des titres, des obligations, des obligations subordonnées et autres instru-
ments ou titres de dettes, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres et conclure des emprunts ou tout autre
forme de moyen de crédit;
(b) conclure toute forme de dérivé de crédit tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de swap en vertu
desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie;
(c) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l’émission d’obligations et de titres,
et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société;
(d) conclure tous les contrats nécessaires, et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de garantie,
des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d’administration et autres
contrats de services, des contrats de vente, des contrats d’échange sur devises ou taux d’intérêts et tous autres contrats
sur des produits dérivés, des contrats bancaires, des contrats de facilités de crédit, des contrats d’assurance-crédit et
tout contrat portant création de garanties de quelque nature que ce soit.
3.3 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.
4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital
5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR), divisé en trente et une (31) actions nomi-
natives d’une valeur nominale de mille euros (1.000 EUR) chacune, entièrement libérées.
6. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions légales.
7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux
dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à
parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
8. Modification du Capital
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des Statuts.
8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Obligations, Titres obligataires et autres titres représentatifs d’une dette
9. Nominatif ou au Porteur
La Société pourra émettre des obligations, titres obligataires et autres titres représentatifs d’une dette sous forme
nominative ou au porteur. Ces obligations, titres obligataires et autres titres représentatifs d’une dette sous forme no-
minative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.
Titre IV.- Administrateurs, Conseil d’administration, réviseurs d’entreprises
10. Conseil d’administration
10.1 La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. Une personne morale peut être membre du Conseil d’Administration.
10.2 Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne
peut dépasser six (6) ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des
actionnaires.
56314
Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de
la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six (6) ans.
10.3 En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires pour cause de
décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à
son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification
du remplacement effectué.
11. Réunions du conseil d’administration
11.1 Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’Admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les
Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
11.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-
sente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Admi-
nistration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite en
original ou en copie. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le repré-
senter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.
11.4 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque parti-
cipant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu,
dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront ha-
bilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
11.6 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont si-
gnées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs
documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions
votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué.
11.7 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail
ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
11.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.
12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
12.1 Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.
12.2 Le Conseil d’Administration est habilité à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une par-
tie distincte de son patrimoine.
13. Délégation de pouvoirs
13.1 Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la So-
ciété et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs Administrateurs,
directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil
déterminera. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale des actionnaires.
13.2 Le Conseil d’Administration pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes
qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs
émoluments.
13.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
14. Représentation de la société
En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs ou de toute autre
personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs de la Société.
15. Réviseurs d’entreprises
15.1 Un ou plusieurs réviseurs d’entreprises sont nommés par le Conseil d’Administration qui détermine leur nom-
bre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Leur nomination ne pourra toutefois excéder six années. Les ré-
viseurs d’entreprises élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de
six (6) ans.
15.3 Les réviseurs d’entreprises sont rééligibles.
Titre V.- Assemblée générale des actionnaires
16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des actionnaires
16.1 L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exé-
cuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.
16.2 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire
nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils
déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.
56315
16.3 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée annuelle ou ordinaire
des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées, quelles que soient la portion
du capital représentée.
16.4 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes
ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle as-
semblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes légales. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être
valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
16.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne
peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition
légale.
17. Lieu et date de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indi-
qué dans les convocations le 28 du mois de juin à 11.00 heures, et pour la première fois en 2007.
18. Convocation des Assemblées Générales des actionnaires
Tout Administrateur peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande
d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
19. Votes
Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des ac-
tionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
20. Année sociale
20.1 L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la
première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2006.
20.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d’entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.
21. Répartition des bénéfices
21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2 Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices nets.
21.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
22. Dissolution, Liquidation
22.1 La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nom-
més par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VIII.- Loi Applicable
23. Loi Applicable
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures, ainsi que la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle
que modifiée, trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents Statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les trente et une (31)
actions comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
Actionnaires
Capital souscrit
Nombre d’actions
Versements
Stichting GSC I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1.000
1
EUR 1.000
Stichting GSC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 30.000
30
EUR 30.000
56316
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à trois mille deux cent cinquante-
cinq euros (3.255 EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse de la Société est fixée au 1, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur pour une durée maximale de six (6) ans, leur mandat expirant lors de
l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année 2012:
a) Monsieur Johannes van Koeverden Brouwer, administrateur, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, 2520
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
b) Monsieur Jorge Perez Lozano, administrateur, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, 2520 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg; et
c) TMF CORPORATE SERVICES S.A., administrateur, établie et ayant son siège social à 1, allée Scheffer, 2520 Luxem-
bourg, Grand-Duché du Luxembourg.
3. L’assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des
affaires de la Société à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés, connus du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ont signé
avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Q. Hubeau, M. Lecuit.
Enregistré à Redange, le 3 avril 2006, vol. 408, fol. 11, case 7. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030915/243/479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
CLAC, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ACTIVITE CYNEGETIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 79.291.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06062, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030154/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
INOX RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 97.038.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BO06242, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030159/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
EOI EUROPEAN & OVERSEAS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.581.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06723, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030180/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Redange-sur-Attert, le 4 avril 2006.
M. Lecuit.
Signature
<i>Administrateuri>
Signature.
EOI EUROPEAN & OVERSEAS INVESTMENT, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Géranti> / <i>Géranti>
56317
GP WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.).
Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 99.512.
—
In the year two thousand and six, on the seventh of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
GP WORLDWIDE INVESTMENTS, INC, a company governed by the laws of the State of Delaware, with registered
office at 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19803, United States of America, registered with the Secretary of State
of Delaware under n
°
3764360, (GP WORLDWIDE INVESTMENTS, INC or «Shareholder»),
here represented by Ms Geneviève Blauen, company director, with professional address at 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
by virtue of a proxy under private seal given on March 6, 2006.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the single shareholder of a Gesellschaft
mit beschränkter Haftung established in Luxembourg, under the name of KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS (LUX-
EMBOURG), S.à r.l., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on March 2, 2004, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 444 of April 27, 2004.
The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 12, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
The sole Shareholder has recognised to be fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following
agenda:
1. Change of the name of the Company to GP WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. and subse-
quent amendment of Article 1, paragraph 3 of the Company’s Articles of Incorporation.
The single Shareholder then has taken the following resolution:
<i>Resolutioni>
The name of the Company is changed to GP WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
As a consequence Article 1, paragraph 3 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and shall read as
follows:
Art. 1. third paragraph. The Company exists under the name of GP WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEM-
BOURG), S.à r.l.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
party the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am siebten März.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
GP WORLDWIDE INVESTMENTS, INC, eine Gesellschaft, die dem Recht des Staates Delaware unterliegt, mit Ge-
sellschaftssitz in 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19803, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen durch den
Staatssekretär des Staates Delaware unter der Nummer 3764360 (GP WORLDWIDE INVESTMENTS, INC oder «Ge-
sellschafter»),
hier vertreten durch Frau Geneviève Blauen, Verwaltungsratmitglied, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Mala-
des, L-2121 Luxemburg-Kirchberg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 6. März 2006.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar,
der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben wird um mit derselben einregistriert zu werden.
Der alleinige Gesellschafter hat den Notar darum gebeten festzuhalten, dass er der Alleingesellschafter der in Luxem-
burg unter dem Namen KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. eingetragenen Gesellschaft
mit beschränkter Haftung ist, gegründet durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 2. März 2004, wel-
che im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 444 vom 27. April 2004 veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch No-
tar Joseph Elvinger, mit dem Amtsitz in Luxemburg, am 12. August 2005, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Der einzige Gesellschafter erklärt, ausführlich über den Beschluss informiert zu sein, der aufgrund der folgenden Ta-
gesordnung zu fassen ist:
1. Änderung des Namens der Gesellschaft in GP WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. und nach-
folgende Abänderung von Artikel 1, Absatz 3 der Satzung.
Sodann hat der einzige Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:
56318
<i>Beschlussi>
Der Name der Gesellschaft wird in GP WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. abgeändert.
Infolgedessen wird Artikel 1, Absatz 3 der Satzung abgeändert und folgenden Wortlaut haben:
Art. 1. Absatz 3. Der Name der Gesellschaft ist GP WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der vorgenannten
Komparentin diese Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle
einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung Vorrang hat.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, hat dieselbe mit Uns, Notar, ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, vol. 152S, fol. 65, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030921/230/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
GP WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 99.512.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
306 du 7 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030926/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par actions.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.637.
—
In the year two thousand and six, on the sixteenth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.
Was held a general meeting of shareholders of OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., a société en
commandite par actions, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
not yet recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on 21 February 2006, not yet published (hereafter the
«Company»).
The meeting was opened at 5.10 p.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mrs Anne-Catherine Guiot, licencié en droit, residing in Arlon, Belgium.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
3. Subsequent amendment of article 6.6.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III.- That twenty-four thousand eight hundred (24.800) shares of the Company are present or represented at this
meeting.
IV.- That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.
V.- That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-) up to sixty-three thousand four hundred forty-five Euro (EUR 63,445.-), represented by fifty thousand seven
hundred fifty-six (50,756) shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, through the
issue of twenty-five thousand nine hundred fifty-six (25,956) new Class A Ordinary Shares, having a par value of one
Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
56319
All such shares have been entirely paid up for the value of eighteen Euro and thirty-six cents (EUR 18.36) per share
in cash, at a total price of four hundred seventy-six thousand five hundred fifty-four Euro and sixty-eight cents (EUR
476,554.68), out of which thirty-two thousand four hundred forty-five Euro (EUR 32,445.-) have been allocated to the
share capital and four hundred forty-four thousand one hundred nine thousand Euro and sixty-eight cents (EUR
444,109.68) have been allocated to the share premium so that the total amount of four hundred seventy-six thousand
five hundred fifty-four Euro and sixty-eight cents (EUR 476,554.68) is at the disposal of the Company, as it has been
shown to the undersigned notary.
Twenty-five thousand nine hundred fifty-six (25,956) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by OCM
OPPORTUNITIES FUND VI, LP at a total price of four hundred seventy-six thousand five hundred fifty-four Euro and
sixty-eight cents (EUR 476,554.68), out of which thirty-two thousand four hundred forty-five Euro (EUR 32,445.-) have
been allocated to the share capital and four hundred forty-four thousand one hundred nine thousand Euro and sixty-
eight cents (EUR 444,109.68) have been allocated to the share premium,
here represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy given in Los Angeles, California, USA, on 15 March 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the undersigned notary will
remain attached to the present deed to be filed at the same time.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.1 Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of sixty-three thousand four hundred forty-
five Euro (EUR 63,445.-) represented by fully paid up shares, consisting of:
(a) Fifty thousand seven hundred fifty-six (50,756) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»).
All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.»
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.6 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.6 Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which
is fixed at one billion Euro (EUR 1,000,000,000.-) represented by:
Two million four hundred seventy-four thousand three hundred twenty-two Euro and fifty cents (EUR 2,474,322.50)
for a conversion of one million nine hundred seventy-nine thousand four hundred fifty-eight (1,979,458) Series 1 CPECs
into one million nine hundred seventy-nine thousand four hundred fifty-eight (1,979,458) Class A Ordinary Shares with
a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
Seven hundred ninety-eight million twenty thousand five hundred forty-two (798,020,542) Class A Ordinary Shares
having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During a period ending five (5) years
after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the authorized capital in the Luxembourg Official
Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase once, or several times,
the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital. Such new
shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may in its sole discretion de-
termine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new
shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly
subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders shall have otherwise
agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager is expressly authorized to limit or to waive
the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly authorized
director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and
receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase
of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the present article is, as a consequence,
to be adjusted.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with Us, the notary,
this deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, am sechzehnten März.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar wohnhaft in Luxemburg.
Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., a société en com-
mandite par actions, mit Gesellschaftssitz in 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, noch nicht
eingetragen im Handels- und Gesellschafts-register, gegründet am 21. Februar 2006 durch notarielle, noch nicht veröf-
fentlichte Urkunde von des unterzeichneten Notars Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen (nachfolgend die «Gesell-
schaft»), stattgefunden.
56320
Die Versammlung wurde um 17.10 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg,
eröffnet,
welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Frau Anne-Catherine Guiot, licencié en droit, wohnhaft in Arlon, Belgien, zum
Stimmenzähler.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes
zu beurkunden:
I.- Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
3. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.6.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die
Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung
durch die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser
registriert zu werden.
III.- Dass vierzundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien der Gesellschaft in der Hauptversammlung anwesend
beziehungsweise gültig vertreten sind.
IV.- Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten
Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden.
V.- Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-
nungspunkte beraten kann.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen
Wert von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf dreiundsechzigtausendvierhundertfünfundvierzig Euro (EUR
63.445,-) durch fünfzigtausendsiebenhundertsechsundfünfzig (50.756) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und
fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie durch die Ausgabe von fünfundzwanzigtausendneunhundertsechsundfünfzig
(25.956) neuen Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25)
pro Aktie anzuheben.
Sämtliche dieser Aktien wuden vollständig eingezahlt für einen Betrag von achtzehn Euro und sechsunddreissig Cent
(EUR 18.36) pro Aktie in Bar, für einen Gesamtpreis von vierhundertsechsundsiebzigtausendfünfhundertvierundfünfzig
Euro und achtunsechzig Cent (EUR 476.554,68), wovon zweiunddreissigtausendvierhundertfünfundvierzig Euro (EUR
32.445,-) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und vierhundertvierundvierzigtausendeinhundertneun Euro und achtund-
sechzig Cent (EUR 444.109,68) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag von vierhundert-
sechsundsiebzigtausendfünfhundertvierundfünfzig Euro und achtunsechzig Cent (EUR 476.554,68), der Geselleschaft zur
Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde,
fünfundzwanzigtausendneunhundertsechsundfünfzig (25.956) neue Stammaktien der Klasse A wurden von OCM OP-
PORTUNITIES FUND VI, LP zu einem Gesamtpreis von vierhundertsechsundsiebzigtausendfünfhundertvierundfünfzig
Euro und achtunsechzig Cent (EUR 476.554,68) gezeichnet, wovon zweiunddreissigtausendvierhundertfünfundvierzig
Euro (EUR 32.445,-) dem Aktienkapital und vierhundertvierundvierzigtausendeinhundertneun Euro und achtundsechzig
Cent (EUR 444.109,68) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,
hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund von einer Vollmacht gegeben in Los Angeles, Califorina, USA, am 15. März 2006,
welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandanten, den Versammlungsvorstand und den un-
terzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigebogen bleiben wird um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
«Art. 6.1 Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von dreiundsech-
zigtausendvierhundertfünfundvierzig Euro (EUR 63.445,-), durch vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich
wie folgt zusammensetzt:
(a) Fünfzigtausendsiebenhundertsechsundfünfzig (50.756) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils
einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A).
Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-
rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.»
<i>Dritter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.7 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
56321
«Art. 6. 6 Genehmigtes Kapital. Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmig-
tes Kapital, das auf eine Milliarde Euro (EUR 1.000.000.000,-) festgelegt ist und sichwiefolgtzusammensetzt:
Zwei Millionen vierhundertvierundsiebzigtausenddreihundertzweiundzwanzig Euro und fünfzig Cent (EUR
2.474.322,50) für eine Umwandlung von eine Million neunhundertneunundsiebzigtausendvierhundertachtundfünfzig
(1.979.458) CPECs in eine Million neunhundertneunundsiebzigtausendvierhundertachtundfünfzig (1.979.458) Stammak-
tien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Weitere siebenhundertachtundneunzigmillionenzwanzigtausendfünfhundertzweiundvierzig (798.020.542) Stammakti-
en der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-
versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbe-dingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-
schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwär-
tige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Opitz, F. Stolz-Page, A. Guiot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, vol. 152S, fol. 78, case 11. – Reçu 4.765,55 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030944/230/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.637.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
357 du 16 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030946/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
LYCAON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 54.602.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06721, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030184/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
LYCAON S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
56322
GENERAL O & R INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 56.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07115, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030161/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
ATL LOCATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Z.I. Piret.
R. C. Luxembourg B 85.031.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07120, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030163/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
VAC PROPERTY ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 115.405.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourth of April.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company VAC HOLDINGS, S.à r.l. existing under the laws of Luxembourg, with registered office in 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
here represented by Mr Laurent Kind, private employee, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie,
by virtue of one proxy given under private seal in Luxembourg, on March 31, 2006.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), as follows:
Chapter I. Purpose - Name - Duration
Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the fu-
ture, in the form of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of Incorporation.
Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enter-
prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.
The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.
The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management
and the ownership of real estate.
The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The company shall take the name of VAC PROPERTY ONE, S.à r.l.
Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
56323
Chapter II. Corporate capital - Sharequotas
Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hun-
dred (500) sharequotas of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179 (2) of the amended law concerning trade companies, in this case, the articles 200-1 and 200-2 among oth-
ers of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter
and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not
applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-
ally.
Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the as-
sociates.
In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-
associate person.
In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of
article 189 of the Company law.
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the
company.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents
of the company under seal, nor to interfere with its management, in order to exercise their rights they will refer to the
values established by the last balance-sheet and inventory of the company.
Chapter III. Management
Art. 10. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.
Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the col-
lective decisions, each associate has as many votes as sharequotas.
Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.
Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the
corporate capital.
Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders
representing three-quarters of the corporate capital.
Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are
exerciced by the sole shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken
in written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take
regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share
onwers.
Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1
st
of January and terminate on the 31
st
of December.
Chapter IV. Dissolution - Liquidation
Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V. General stipulations
Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Special dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31
st
of December 2006.
<i>Subscription and payment of the sharequotasi>
All the five hundred (500) sharequotas have been subscribed by VAC HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, and fully paid
up so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of
the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
56324
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand six hundred (EUR 1,600.-)
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The shareholders, representing the entire corporate capital and considering themselves duly convened have imme-
diately proceeded to an extraordinary general meeting and have unanimously resolved:
1. The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2. Is appointed as manager:
- Mr Alain Heinz, companies’ director, born in Forbach (France), on the 17
th
of May 1968, professionally residing at
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. The company will be validly bound by the sole signature of the manager.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the mandatory, acting as said before, the said mandatory signed together with Us,
the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société de droit anglais VAC HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 mars 2006.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requière le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d’une société à responsabilité limitée comme suit:
Titre I
er
. Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option,
d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autre-
ment, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous
immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.
La société peut également s’engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rappor-
tant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d’immeubles.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-
riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de VAC PROPERTY ONE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-
ciés.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
56325
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-
ment.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort aux non-associés que moyennant l’accord unanime de
tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration, pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III. Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libération des parts socialesi>
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par VAC HOLDINGS, S.à r.l., préqualifiée, et elles ont
été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trou-
ve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate
expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille six cents (1.600,- EUR) euros.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2. Est désigné comme gérant de la société:
56326
Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnel-
lement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, il a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: L. Kind, A.-J.-J. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 16, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033305/230/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
MATERIS INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 115.395.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of March.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
TRIEF CORPORATION S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 50.162,
here represented by Mr Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, on 27 March 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of MATERIS INVESTORS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or
other offices may be established either in Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
A. Schwachtgen.
56327
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the individual signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance
of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
56328
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first June and ends on the thirty-first May of the next year.
Art. 21. Each year on the thirty-first May, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been subscribed by TRIEF CORPORATION S.A., pre-qualified.
The shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twenty-five thousand Euro (EUR
25,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. This amount of twen-
ty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) consists in twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) for the share
capital of the Company and twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) for the share premium of the Com-
pany.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and shall terminate on 31 May 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro.
<i>Decision of the sole partneri>
The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolu-
tions:
1. The registered office of the Company is set at 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg;
2. TRIEF CORPORATION S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its reg-
istered office at 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 50.162, is appointed as manager of the Company for an indefinite period.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TRIEF CORPORATION S.A., une société constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 50.162,
ici représentée par Monsieur Alexandre Gobert, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 mars 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
56329
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de MATERIS INVESTORS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d’un des gérants.
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
56330
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le premier juin et se termine le trente et un mai de l’année suivante.
Art. 21. Chaque année, au trente et un mai, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par TRIEF CORPORATION S.A., pré-qualifiée.
Les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR
25.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. Cette somme de
vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) consiste en douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) de capital social et douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) de prime d’émission.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 mai 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à deux mille euros.
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg;
56331
2. TRIEF CORPORATION S.A., une société constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 50.162, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Gobert, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 2006, vol. 903, fol. 15, case 8. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033136/239/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.
VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d’Altlinster.
R. C. Luxembourg B 62.639.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07122, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030164/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
FLUITRONICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3514 Dudelange, 37B, route de Kayl.
R. C. Luxembourg B 85.805.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07113, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030169/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
KEREDA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06709, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030192/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
KEREDA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06708, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030193/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Belvaux, le 10 avril 2006.
J.-J. Wagner.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
KEREDA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
KEREDA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
56332
MELCHIOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 103.672.
—
L’an deux mille six, le sept mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de MELCHIOR INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxembourg B Numéro 103.672 ayant son siège
social à Luxembourg, au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
en date du 13 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1330 du 30 décembre
2004.
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74,
rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction de la valeur nominale des actions de la Société de cent euros (EUR 100,-) à dix euros (EUR 10,-), avec
augmentation correspondante du nombre d’actions de trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune à trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
2. Fixation du montant du capital autorisé à vingt-cinq millions d’euros (EUR 25.000.000,-).
3. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des actions de la Société est réduite de cent euros (EUR 100,-) à dix euros (EUR 10,-), avec aug-
mentation correspondante du nombre d’actions de trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune à trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. Les pré-
dites trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, seront réparties à la dili-
gence du conseil d’administration de la Société entre les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le
capital social de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Le montant du capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions d’euros (EUR 25.000.000,-).
<i>Trioisieme résolutioni>
Suite aux deux résolutions précédentes, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à vingt-cinq millions d’euros (EUR 25.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 7 mars 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
56333
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-
res quarante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, vol. 27CS, fol. 84, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030928/230/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
MELCHIOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 103.672.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
308 du 7 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030929/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
MEZZANOVE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MERIDIAN MEZZANINE FINANCE, S.à r.l.).
Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 110.959.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
MEZZANOVE CAPITAL (S.C.A.) SICAR, a partnership limited by shares (société en commandite par actions) formed
as an investment company in risk capital, having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.082, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary dated September 23, 2005, represented by its managing general partner MEZZA-
NOVE CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., a private limited company, having its registered office at 51, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
110.963 (the Shareholder);
here duly represented by Ms Alexandra von Neuhoff von der Ley, attorney-at-law, with professional address in Lux-
embourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal on March 23, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I.- The appearing party is the sole Shareholder of MERIDIAN MEZZANINE FINANCE, S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 110.959, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary dated September 23, 2005 (the Company).
II.- The agenda of the meeting is as follows:
1. Change of the Company’s denomination into MEZZANOVE FINANCE, S.à r.l.;
2. Correction of the address of the registered office of the Company by replacing «boulevard» by «avenue», so that
it reads henceforth as follows: «51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg»; and
3. Appointment of Mr Philippe Minard as manager in replacement of Mr John Mowinckel; Special vote of discharge.
III. The Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to change the Company’s denomination into MEZZANOVE FINANCE, S.à r.l.
As a consequence article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of MEZ-
ZANOVE FINANCE, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of associ-
ation (the Articles).»
Luxembourg, le 21 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
56334
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to correct the Company’s registered office address designation so that it reads henceforth
as follows: «51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg».
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to appoint as manager Mr Philippe Minard, company director, born in Lyon, France on
March 4, 1969, residing at Via Filelfo, N.7, 20145 Milan, Italy in replacement of Mr John Mowinckel, resigning with im-
mediate effect. The Shareholder by special vote grants full discharge to Mr John Mowinckel for the performance of his
duties until this day.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MEZZANOVE CAPITAL (S.C.A.) SICAR, une société en commandite par actions formée sous la forme de société
d’investissement de capital à risque, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.082, constituée suivant acte
du notaire instrumentant, daté du 23 septembre 2005, représentée par son actionnaire gérant MEZZANOVE CAPITAL
MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.963
(l’Actionnaire);
ici dûment représentée par Mlle Alexandra von Neuhoff von der Ley, avocat, résidant professionellement à Luxem-
bourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 23 mars 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l’Associée unique de MERIDIAN MEZZANINE FINANCE, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.959, constituée en vertu d’un acte du notaire ins-
trumentant daté du 23 septembre 2005 (la Société).
II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la Société en MEZZANOVE FINANCE, S.à r.l.;
2. Correction de l’adresse du siège social de la Société en remplaçant «boulevard» par «avenue» de sorte que l’adres-
se se lise de la manière suivante: «51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg»; et
3. Nomination de M. Philippe Minard en qualité de gérant en remplacement de M. John Mowinckel; vote spéciale de
décharge.
III. L’Associé a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide de changer la dénomination de la Société en MEZZANOVE FINANCE, S.à r.l.
En conséquence l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société sous la forme d’une société à responsabilité limitée, sous la déno-
mination de MEZZANOVE FINANCE, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts
(les Statuts).»
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé décide de corriger la désignation de l’adresse du siège social de la Société de telle manière que cette der-
nière soit: «51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg».
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé décide de nommer comme gérant M. Philippe Minard, gérant de société, né à Lyon, France, le 4 mars 1969,
résidant à Via Filelfo, N.7, 20145 Milan, Italie en remplacement de M. John Mowinckel, démissionnant avec effet immé-
diat. L’Actionnaire octroie par vote spécial pleine décharge à M. John Mowinckel pour l’exécution de ses fonctions jus-
qu’à ce jour.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
56335
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. von Neuhoff von der Ley, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 2, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033698/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
MEZZANOVE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MERIDIAN MEZZANINE FINANCE, S.à r.l.).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 110.959.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
400 du 24 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033700/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
DALGARNO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 110.879.
—
In the year two thousand and six, on the fifteenth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under
the denomination of DALGARNO S.A., R.C.S. Luxembourg B Number 110.879, incorporated pursuant to a deed of
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated September 15, 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr 108 of January 17, 2006.
The meeting begins at eleven forty-five a.m., Mr Pierre Claudel, private employee, with professional address at 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Annie Lyon, private employee, with professional address at
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Raphaël Rozanski, private employee, with professional address at 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three thousand
one hundred (3,100.-) shares having a par value of ten (10.-) Euro each, representing the total capital of thirty-one thou-
sand (31,000.-) Euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or represented at
the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented at the meeting, shall remain at-
tached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the capital in the amount of three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) in order to raise it from
thirty-one thousand (EUR 31,000.-) to three hundred thirty-one thousand Euro (EUR 331,000.-) by the issuance of thirty
thousand (30,000.-) shares having a par value of ten (EUR 10.-) each, to be issued with a total issue premium of zero
(EUR 0.-) against cash and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.
2. Subscription of the thirty thousand (30,000.-) new shares by FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. having its
registered office at 50, av. J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
3. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
4. Miscellanous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The subscribed share capital is increased by three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) by the creation and issue
of thirty thousand (30,000.-) new shares with a par value of ten (EUR 10.-) each, so that after this increase the subscribed
capital will amount to three hundred thirty-one thousand Euro (EUR 331,000.-) represented by thirty-three thousand
one hundred (33,100.-) shares having a par value of ten (EUR 10.-) each.
The other shareholder having waived its preferential subscription right, the new shares have been subscribed by FOR-
TIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., prenamed,
here represented by Mr Pierre Claudel, prenamed,
by virtue of a proxy given on March 15, 2006.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
56336
Said proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
The new shares have been fully paid in cash for an amount of three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-), so that
the amount of three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) is as of now available to the Company, as it has been
proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-
forth read as follow:
«Art. 5. The corporate capital is set at three hundred thirty-one thousand Euro (EUR 331,000.-) represented by
thirty-three one hundred (33,100.-) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.»
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de DALGARNO S.A., R.C.S. Luxembourg B Numéro 110.879, constituée suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations N
°
108 du 17 janvier 2006.
La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Pierre Claudel, employé privé,
avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Annie Lyon, employée privée, avec adresse professionnelle
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raphael Rozanski, employé privé, avec adresse professionnelle au 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent
(3.100,-) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après re-
produit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) pour le porter de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent trente et un mille euros (EUR 331.000,-) par la création et l’émission de
trente mille (30.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) bénéficiant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, et libération en espèces ensemble avec une prime d’émission de zéro (EUR 0,-).
2. Souscription des trente mille actions (30.000,-) nouvelles par FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., ayant son
siège social au 50, av. J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par la création et l’émission
de trente mille (30.000,-) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, de sorte qu’après
cette augmentation le capital souscrit s’élève à trois cent trente et un mille euros (EUR 331.000,-) représenté par trente-
trois mille cent (33.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces actions nouvelles ont été entièrement
souscrites par FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., préqualifié,
ici représentée par Monsieur Pierre Claudel, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 mars 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
56337
Les nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces pour un montant de trois cent mille euros (EUR
300.000,-), de sorte que le montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 5, des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent trente et un mille (EUR 331.000,-) représenté par trente-trois mille
(33.100,-) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: P. Claudel, A. Lyon, R. Rozanski, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, vol. 27CS, fol. 90, case 3. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030978/230/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
DALGARNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 110.879.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
352 du 15 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030979/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
OCM/NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par actions.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.638.
—
In the year two thousand and six, on the sixteenth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.
Was held a general meeting of shareholders of OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., a société en com-
mandite par actions, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg not
yet recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on 21 February 2006, not yet published (hereafter the «Company»).
The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne-Catherine Guiot, licencié en droit, residing in Arlon, Belgium.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
3. Subsequent amendment of article 6.6.
II- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III- That twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares of the Company are present or represented at this
meeting.
IV- That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.
V- That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.00) up to sixty-five thousand two hundred seventy Euro (EUR 65,270.00), represented by fifty-two thousand two
Luxembourg, le 29 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
56338
hundred sixteen (52,216) shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, through the
issue of twenty-seven thousand four hundred sixteen (27,416) new Class A Ordinary Shares, having a par value of one
Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
All such shares have been entirely paid up for the value of fourteen Euro and seventy-five cents (EUR 14.75) per share
in cash, at a total price of four hundred four thousand three hundred sixty-one Euro and nineteen cents (EUR
404,361.19), out of which thirty-four thousand two hundred seventy Euro (EUR 34,270.00) have been allocated to the
share capital and three hundred seventy thousand ninety-one Euro and nineteen cents (EUR 370,091.19) have been al-
located to the share premium so that the total amount of four hundred four thousand three hundred sixty-one Euro
and nineteen cents (EUR 404,361.19) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
Twenty-six thousand nine hundred thirty-three (26,933) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by OCM
PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP at a total price of three hundred ninety-seven thousand ninety-five Euro
and thirty-nine cents (EUR 397,095.39), out of which thirty-three thousand six hundred sixty-six Euro and twenty-five
cents (EUR 33,666.25) have been allocated to the share capital and three hundred sixty-three thousand four hundred
twenty-nine Euro and fourteen cents (EUR 363,429.14) have been allocated to the share premium, and
four hundred eighty-three (483) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by OCM PRINCIPAL OPPOR-
TUNITIES FUND III A, LP at a total price of seven thousand two hundred sixty-five Euro and eighty cents (EUR
7,265.80), out of which six hundred three Euro and seventy-five cents (EUR 603.75) have been allocated to the share
capital and six thousand six hundred sixty-two Euro and five cents (EUR 6,662.05) have been allocated to the share pre-
mium,
both here represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of two proxies given in Los Angeles, California, USA, on 15 March 2006.
Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of sixty-five thousand two hundred seventy
Euro (EUR 65,270.00), represented by fully paid up shares, consisting of:
(a) fifty-two thousand two hundred sixteen (52,216) shares Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»);
All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.»
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.6 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.6. Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which
is fixed at one billion euro (EUR 1,000,000,000.00) represented by:
two million sixty-one thousand nine hundred thirty-six Euro and twenty-five cents (EUR 2,061,936.25) for a conver-
sion of one million six hundred forty-nine thousand five hundred forty-nine (1,649,549) Series 1 CPECs into one million
six hundred forty-nine thousand five hundred forty-nine (1,649,549) Class A Ordinary Shares having a nominal value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.
Further seven hundred nine-eight million three hundred fifty thousand four hundred fifty-one (798,350,451) Class A
Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During a period ending
five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the authorized capital in the Luxem-
bourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase once,
or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized
capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may in its
sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be sub-
scribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to
determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent
the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the share-
holders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager is expressly
authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may
delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties
of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts
of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the
present article is, as a consequence, to be adjusted.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with Us, the notary,
this deed.
56339
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, am sechzehnten. März,
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, wohnhaft in Luxemburg.
Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., a société en com-
mandite par actions, mit Gesellschaftssitz in 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, noch nicht
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister, gegründet am 21. Februar 2006 durch notarielle, noch nicht veröf-
fentlichte Urkunde von des unterzeichneten Notars Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen (nachfolgend die «Gesell-
schaft»), stattgefunden.
Die Versammlung wurde um 17.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg, eröff-
net,
welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Frau Anne-Catherine Guiot, licenciée en droit, wohnhaft in Arlon, Belgien, zum Stim-
menzähler.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes
zu beurkunden:
I- Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
3. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.6.
II- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die An-
zahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch
die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser regi-
striert zu werden.
III- Dass vierzundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien der Gesellschaft in der Hauptversammlung anwesend
beziehungsweise gültig vertreten sind.
IV- Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten
Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden.
V- Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-
nungspunkte beraten kann.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seiem gegenwärtigen
Wert von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00) auf fünfundsechzigtausendzweihundertsiebzig Euro (EUR
65.270,00) durch zweiundfünfzigtausendzweihundertsechzehn (52.216) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro
und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie durch die Ausgabe von siebenundzwanzigtausendvierhundertsechzehn
(27.416) neuen Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25)
pro Aktie anzuheben.
Sämtliche dieser Aktien wuden vollständig eingezahlt für einen Betrag von vierzehn Euro und fünfundsiebzig Cent
(EUR 14,75) pro Aktie in Bar, für einen Gesamtpreis von vierhundertviertausenddreihunderteinundsechzig Euro und
neunzehn Cents (EUR 404.361,19), wovon vierundreißigtausendzweihundertsiebzig Euro (EUR 34.270,00) dem Aktien-
kapital zugeteilt wurden und dreihundertsiebzigtausendeinundneunzig Euro und neunzehn Cent (EUR 370.091,19) dem
Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag von vierhundertviertausenddreihunderteinundsechzig
Euro und neunzehn Cent (EUR 404.361,19), der Geselleschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde.
Sechsundzwanzigtausendneunhundertdreiunddreißig (26.933) neue Stammaktien der Klasse A wurden von OCM
PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP zu einem Gesamtpreis von dreihundertsiebenundneunzigtausend fünfund-
neunzig Euro und neundunddreißig Cent (EUR 397.095,39) gezeichnet, wovon dreiundreissigtausendsechsundertsechs-
undsechzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 33.666,25) dem Aktienkapital und
dreiundertdreiundsechzigtausendvierhundertneunundzwanzig Euro und vierzehn Cent (EUR 363.429,14) dem Ausgabe-
aufschlag zugeteilt wurden, und
vierhundertdreiundachtzig (483) neue Stammaktien der Klasse A wurden von OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES
FUND IIIA, LP zu einem Gesamtpreis von siebentausendzweihundertfünfundsechzig Euro und achtzig Cent (EUR
7.265,80) gezeichnet, wovon sechshundertdrei Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 603,75) dem Aktienkapital und
sechstausendsechundertzweiundsechzig Euro und fünf Cent (EUR 6.662,05) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,
beide hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund von zwei Vollmachten gegeben in Los Angeles, Califorina, USA, am 15. März 2006,
welche Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandanten, den Versammlungsvorstand und den un-
terzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
«Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von fünfundsech-
zigtausendzweihundertsiebzig Euro (EUR 65.270,00), durch vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich wie
folgt zusammensetzt:
56340
(a) zweiundfünfzigtausendzweihundertsechzehn (52.216) Stamm-aktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils
einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A);
Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-
rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.»
<i>Dritter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.7 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
«Art. 6.6. Genehmigtes Kapital. Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmig-
tes Kapital, das auf eine Milliarde Euro (EUR 1.000.000.000,00) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:
zwei Millionen einundsechzigtausendneunhundertsechsunddreißig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 2.061.936,25)
für eine Umwandlung von einer Million sechshundertneunundvierzigtausendfünfhundertneunhundvierzig (1.649.549)
CPECs in sechshundertneunundvierzigtausendfünfhundertneunhundvierzig (1.649.549) Stamm aktien der Klasse A mit
einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Weitere siebenhundertachtundneunzig millionen dreihundertfünfzigtausendvierhunderteinundfünfzig (798.350.451)
Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-
versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-
schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwär-
tige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Opitz, F. Stolz-Page, A. Guiot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, vol. 152S, fol. 78, case 10. – Reçu 4.043,61 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
In the year two thousand and six, on the seventeenth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.
Was held a general meeting of shareholders of OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., a société en com-
mandite par actions, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg not
yet recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on 21 February 2006, not yet published (hereafter the «Company»).
The meeting was opened at five p.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Raymond Thill, «maître en droit», residing in Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer, Mrs Anne Guiot, licencié en droit, residing in Arlon, Belgium.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
3. Subsequent amendment of article 6.6.
II- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
A. Schwachtgen.
56341
III- That fifty-two thousand two hundred sixteen (52,216) shares of the Company are present or represented at this
meeting.
IV. That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agen-
da prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.
V- That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of sixty-five thousand two hundred
seventy Euro (EUR 65,270.00) up to one hundred five thousand seven hundred forty-one Euro and twenty-five cents
(EUR 105,741.25), represented by eighty-four thousand five hundred ninety-three (84,593.00) shares, having a par value
of one Euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each, through the issue of thirty-two thousand three hundred seventy-
seven (32,377) new Class A Ordinary Shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each.
All such shares have been entirely paid up for the value of twelve Euro and sixty-eight cents (EUR 12.68) per share
in cash, at a total price of four hundred ten thousand five hundred sixty-two Euro and forty-four cents (EUR 410,562.44),
out of which forty thousand four hundred seventy-one Euro and twenty-five cents (EUR 40,471.25) have been allocated
to the share capital and three hundred seventy thousand ninety-one Euro and nineteen cents (EUR 370,091.19) have
been allocated to the share premium so that the total amount of four hundred ten thousand five hundred sixty-two
Euro and forty-four cents (EUR 410,562.44) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned
notary.
Thirty-two thousand three hundred seventy-seven (32,377) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by
OCM PRINCIPAL EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, LP at a total price of four hundred ten thousand five hundred
sixty-two Euro and forty-four cents (EUR 410,562.44), out of which forty thousand four hundred seventy-one Euro and
twenty-five cents (EUR 40,471.25) have been allocated to the share capital and three hundred seventy thousand ninety-
one Euro and nineteen cents (EUR 370,091.19) have been allocated to the share premium,
represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy given in Los Angeles, California, USA, on 15 March 2006.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of one hundred five thousand seven hundred
forty-one Euro and twenty-five cents (EUR 105,741.25) represented by fully paid up shares, consisting of:
(a) eighty-four thousand five hundred ninety-three (84,593) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»);
All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.»
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.6 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.6. Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which
is fixed at one billion Euro (EUR 1,000,000,000.-) represented by:
four million one hundred twenty-three thousand eight hundred seventy-two Euro and fifty cents (EUR 4,123,872.50)
for a conversion of three million two hundred ninety-nine thousand ninety-eight (3,299,098) Series 1 CPECs into three
million two hundred ninety-nine thousand ninety-eight (3,299,098) Class A Ordinary Shares having a nominal value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.
Further seven hundred ninety-six million seven hundred thousand nine hundred two (796,700,902) Class A Ordinary
Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During a period ending five (5)
years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the authorized capital in the Luxembourg
Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase once, or sev-
eral times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital.
Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may in its sole dis-
cretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and
issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if
the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment
of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders shall
have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager is expressly authorized to
limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any
duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting sub-
scriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After
each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the present article is, as
a consequence, to be adjusted.»
There being no further business on the agenda of the meeting, the chairman closes the meeting at five thirty p.m.
56342
Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, these persons signed together with the notary this deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, am siebzehnten März.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, wohnhaft in Luxemburg.
Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., a société en com-
mandite par actions, mit Gesellschaftssitz in 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, noch nicht
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister, gegründet am 21. Februar 2006 durch notarielle, noch nicht veröf-
fentlichte Urkunde von des unterzeichneten Notars Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen (nachfolgend die «Gesell-
schaft»), stattgefunden.
Die Versammlung wurde um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg,
eröffnet,
welcher Herrn Raymond Thill, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Frau Anne-Catherine Guiot, licenciée en droit, wohnhaft in Arlon, Belgien, zum Stim-
menzähler.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes
zu beurkunden:
I- Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
3. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.6.
II- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die An-
zahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch
die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser regi-
striert zu werden.
III- Dass zweiundfünfzigtausendzweihundertsechzehn (52.216) Aktien der Gesellschaft in der Hauptversammlung an-
wesend beziehungsweise gültig vertreten sind.
IV- Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten
Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden.
V- Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-
nungspunkte beraten kann.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seiem gegenwärtigen
Wert von fünfundsechzigtausendzweihundertsiebzig Euro (EUR 65.270,00) auf einhundertfünftausendsiebenhundertei-
nundvierzing Euro und fünundzwanzig Cent (EUR 105.741,25) durch vierhundachtzigtausendfünfhundertdreiundneunzig
(84.593) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie durch die Ausgabe
von zweinunddreissigtausenddreihundertsiebenundsiebzig (32.377) neuen Stammaktien der Klasse A mit einem Nenn-
wert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie anzuheben.
Sämtliche dieser Aktien wuden vollständig eingezahlt für einen Betrag von zwölf Euro achtundsechzig Cent (EUR
12,68) pro Aktie in Bar, für einen Gesamtpreis von vierhundertzehntausendfünfhundertzweiundsechtzig Euro und
vierundvierzig Cent (EUR 410.562,44), wovon vierzigtausendvierhunderteinundsiebzig Euro und fünfundzwanzig Cent
(EUR 40.471,25) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und dreihundertsiebzigtausendeinundneunzig Euro und neunzehn
Cent (EUR 370.091,19) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag von vierhundertzehntau-
sendfünfhundertzweiundsechtzig Euro und vierundvierzig Cent (EUR 410.562,44), der Geselleschaft zur Verfügung
steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
Zweinunddreissigtausenddreihundertsiebenundsiebzig (32.377) neue Stammaktien der Klasse A wurden von OCM
PRINCIPAL EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, LP zu einem Gesamtpreis von vierhundertzehntausendfünfhundert-
zweiundsechtzig Euro und vierundvierzig Cent (EUR 410.562,44) gezeichnet, wovon vierzigtausendvierhunderteinund-
siebzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 40.471,25) dem Aktienkapital und dreihundertsiebzigtausendeinundneunzig
Euro und neunzehn Cent (EUR 370.091,19) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,
hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund von einer Vollmacht gegeben in Los Angeles, Kalifornien, USA, am 15. März 2006.
Welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandanten, den Versammlungsvorstand und den un-
terzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunkde beigefügt bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
«Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einhundert-
fünftausendsiebenhunderteinundvierzig Euro und fünundzwanzig Cent (EUR 105.741,25), durch vollständig einbezahlte
Aktien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:
56343
(a) vierhundachtzigtausendfünfhundertdreiundneunzig (84.593) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von
jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A);
Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-
rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.»
<i>Dritter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.7 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
«Art. 6.6. Genehmigtes Kapital. Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmig-
tes Kapital, das auf eine Milliarde Euro (EUR 1.000.000.000,00) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:
vier Millionen einhundertdreiundzwanzigtausendachthundertzweiundsiebzig Euro und fünfzig Cent (EUR
4.123.872,50) für eine Umwandlung von drei Millionen zweihundertneunundneunzigtausendachtundneunzig (3.299.098)
CPECs in drei Millionen zweihundertneunundneunzigtausendachtundneunzig (3.299.098) Stammaktien der Klasse A mit
einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Weitere siebenhundertsechsundneunzig Millionen siebenhunderttausendneunhundertzwei (796.700.902) Stammakti-
en der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-
versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr dreissig für geschlos-
sen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-
schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend. Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem
Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Opitz, R. Thill, A. Guiot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, vol. 152S, fol. 79, case 1. – Reçu 4.105,62 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030932/230/397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
OCM/NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.638.
—
Statuts coordonnés suivant les actes n
°
356 du 16 mars 2006 et n
°
365 du 17 mars 2006, déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030935/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
56344
ARCADIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.561.
—
L’an deux mille six, le six mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ARCADIE S.A., R.C.S. Luxembourg
B N
°
en cours d’inscription, établie et avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul
Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 15 février 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
Les statuts de ladite Société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 2 mars 2006, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié
professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme Monsieur Raymond Thill, maître en droit, secrétaire domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Nathalie Jacquemart, employée privée, domiciliée professionnelle-
ment au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cint euros (EUR 100,-) chacune constituant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de
l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au
présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et détention en vue de la location de biens immobiliers sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant par tout moyen, et notamment par voie d’émissions d’obligations ou de tous autres instruments qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnés.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ainsi
que financières, notamment par l’octroi de tout prêt ou garantie, se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptible d’en faciliter la réalisation, y compris la construction de biens immobiliers destinés à la location.»
2. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement
constituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’objet social de la Société est changé et en conséquence, l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et détention en vue de la location de biens immobiliers sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant par tout moyen, et notamment par voie d’émissions d’obligations ou de tous autres instruments qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnés.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ainsi
que financières, notamment par l’octroi de tout prêt ou garantie, se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptible d’en faciliter la réalisation, y compris la construction de biens immobiliers destinés à la location.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: F. Stolz-Page, R. Thill, N. Jacquemart, A. Schwachtgen.
56345
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, vol. 152S, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030988/230/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
ARCADIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.561.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
297 du 6 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030991/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
DELVINO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 110.880.
—
In the year two thousand and six, on the fifteenth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under
the denomination of DELVINO S.A., R.C.S. Luxembourg B Number 110.880, incorporated pursuant to a deed of Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated September 15, 2005 published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Nr 78 of January 12, 2006.
The meeting begins at eleven thirty a.m., Mr Pierre Claudel, private employee, with professional address at 65, boul-
evard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Annie Lyon, private employee, with professional address at
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Raphaël Rozanski, private employee, with professional address at 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three thousand
one hundred (3,100.-) shares having a par value of ten (10.-) Euro each, representing the total capital of thirty-one thou-
sand (31,000.-) Euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or represented at
the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented at the meeting, shall remain at-
tached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the capital in the amount of three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) in order to raise it from
thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to three hundred thirty-one thousand Euro (EUR 331,000.-) by the issuance
of thirty thousand (30,000.-) shares having a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, to be issued with a total issue pre-
mium of zero (EUR 0.-) against cash and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.
2. Subscription of the thirty thousand (30,000.-) new shares by FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. having its
registered office at 50, av. J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
3. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
4. Miscellanous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The subscribed share capital is increased by three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) by the creation and issue
of thirty thousand (30,000.-) new shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, so that after this increase the
subscribed capital will amount to three hundred thirty-one thousand Euro (EUR 331,000.-) represented by thirty-three
thousand one hundred (33,100.-) shares having a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The other shareholder having waived his preferential subscription rights, the new shares have been subscribed by
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., prenamed,
here represented by Mr Pierre Claudel, prenamed,
by virtue of a proxy given on March 15, 2006.
Said proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Luxembourg, le 15 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
56346
The new shares have been fully paid in cash for an amount of three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-), so that
the amount of three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) is as of now available to the Company, as it has been
proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-
forth read as follow:
«Art. 5. The corporate capital is set at three hundred thirty-one thousand Euro (EUR 331,000.-) represented by
thirty-three thousand one hundred (33,100.-) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.»
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven forty-
five.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de DELVINO S.A., R.C.S. Luxembourg B Numéro 110.880, constituée suivant acte reçu par Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N
°
78 du 12 janvier 2006.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Claudel, employé privé, avec adres-
se professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Annie Lyon, employée privée, avec adresse professionnelle
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raphael Rozanski, employé privé, avec adresse professionnelle au 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent
(3.100,-) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après re-
produit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) pour le porter de trente
et un mille (EUR 31.000,-) à trois cent trente et un mille (EUR 331.000,-) par la création et l’émission de trente mille
(30.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) bénéficiant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes, et libération en espèces ensemble avec une prime d’émission de zéro (EUR 0,-).
2. Souscription des trente mille (30.000) actions nouvelles par FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. ayant son siè-
ge social au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par la création et l’émission
de trente mille (30.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, de sorte qu’après
cette augmentation le capital souscrit s’élève à trois cent trente et un mille euros (EUR 331.000,-) représenté par trente-
trois mille cent (33.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces actions nouvelles ont été entièrement
souscrites par FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., préqualifiée,
ici représentée par Monsieur Pierre Claudel, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 mars 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Les nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces pour un montant de trois cent mille euros (EUR
300.000,-), de sorte que le montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
56347
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 5, des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent trente et un mille euros (EUR 331.000,-) représenté par trente-trois
mille cent (33.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-
cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: P. Claudel, A. Lyon, R. Rozanski, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, vol. 27CS, fol. 90, case 2. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031002/230/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
DELVINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 110.880.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
351 du 15 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031003/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.475.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06717, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030186/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
ADA CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 71.875.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 31 mars 2006i>
Modification de l’adresse des administrateurs:
Monsieur Michel Kieffer, réside professionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg;
Monsieur Jean Zeimet, réside professionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg;
Monsieur Angel Caschera réside professionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Modification de l’adresse de l’administrateur-délégué
Monsieur Michel Kieffer, réside professionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Modification de l’adresse du commissaire aux comptes
READ, S.à r.l. est domiciliée au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07163. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030256/1137/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
56348
CERATIZIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mamer, 101, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 17.122.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CERATIZIT
LUXEMBOURG, S.à r.l. constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-
Eich, en date du 30 octobre 1979. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Joseph Kerschen
en date des 22 novembre 1985, 4 décembre 1987 et 7 décembre 1990, suivant acte sous seing privé du 18 avril 2001
(conversion du capital social en euros) et suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date des 18 décembre
2002 et 28 août 2003. Lesdits actes ont été publiés au Mémorial C, numéro 23 du 4 février 1980, numéro 23 du 30
janvier 1986, numéro 37 du 11 février 1988, numéro 182 du 16 avril 1991, numéro 320 du 26 février 2002, numéro 174
du 19 février 2003 et numéro 1044 du 8 octobre 2003. La société est inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 17.122.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Wolter, ingénieur diplômé, demeurant 21, route d’Arlon, L-8550
Noerdange,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gerhard Kerckhoff, conseiller juridique, demeurant 19,
Levelingstrasse, D-54293 Trèves.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur John O’Hara, ingénieur diplômé, demeurant 32, rue de la Montagne,
L-7238 Walferdange.
Tous ici présents et ce acceptant. Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentaire d’ac-
ter que:
- Les associés ainsi que le nombre des parts qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après
avoir été signée par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec celui-ci à la formalité de l’enregistrement.
- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée, la présente assemblée générale extraordinaire peut se
tenir sans convocation préalable.
- La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification des articles 11, 12 et 13 des statuts concernant la gérance.
2) Nomination d’un gérant supplémentaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les articles 11, 12 et 13 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 11. Die Geschäftsführung besteht aus mindestens einem Geschäftsführer. Sie kann, insoweit zutreffend mit der
vorherigen Genehmigung durch den Aufsichtsrat, jedwede Handlung vornehmen, welche dem Gesellschaftszweck ents-
pricht, und die Geschäftsführung hat alle diesbezüglichen Befugnisse, soweit dieselben nicht durch gegenwärtige Satzung
oder durch Gesetz der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung oder den Aufsichtsrat vorbehalten sind.
Die Geschäftsführung kann im besonderen eine Schiedsgerichtsvereinbarung und einen Vergleich abschließen, sowie
mit oder ohne Zahlung auf sämtliche Gerichtsklagen und sonstigen Ansprüche verzichten.
Die Geschäftsführung kann Teile der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in
Bezug auf diese an eines oder mehrere ihrer Mitglieder sowie an Direktoren oder andere Beauftragte übertragen,. Diese
Bevollmächtigten haften in Bezug auf die von ihnen vorgenommene Geschäftsführung aufgrund der gesetzlichen Regeln
des Mandatsvertrages. Der Geschäftsführer oder bei mehreren Geschäftsführern das Gremium der von den Gesells-
chaftern ernannten Geschäftsführer gilt als Geschäftsführung der Gesellschaft.
Die Geschäftsordnung der Geschäftsführung und gegebenenfalls die Geschäftsverteilung unter den verschiedenen
Geschäftsführern unterliegt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat kann weitere beratende Gremien ernennen, dem Aufsichtsratsmitglieder, Direktoren der Gesells-
chaft und/oder gegebenenfalls weitere Personen angehören, zum Zweck der Entwicklung, Durchführung und Überwa-
chung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen und vom Aufsichtsrat genehmigten Unternehmenspolitik.»
«Art. 12. Die Mitglieder der Geschäftsführung werden durch Beschluß der Gesellschafterversammlung für eine von
derselben festgelegte Dauer ernannt oder sind andernfalls auf unbestimmte Zeit ernannt und können durch die Gesel-
lschafterversammlung jederzeit unter Angabe von rechtsmäßigen Gründen abberufen werden.
Die Mitglieder der Geschäftsführung üben, soweit nicht nur ein Geschäftsführer vorhanden ist, die tägliche Geschäfts-
führung kollektiv aus und haben zu zweit Unterschriftsberechtigung für die Gesellschaft, vorbehaltlich einer weiteren
Unterschriftsberechtigung gemäß von der Geschäftsführung beschlossenen Generalvollmacht oder Prokura an für bes-
timmte Rechtsgeschäfte einzeln oder kollektiv zeichnungsberechtigte Personen.
Außer in den Fällen, die der vorherigen Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung oder den Aufsichtsrat
unterliegen, haben dieselben oder deren Delegierte die weitgehendsten Befugnisse zur täglichen Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft.
Die Geschäftsführung ernennt und beruft die Angestellten der Gesellschaft ab und bestimmt die Befugnisse der von
ihr oder ihrem(n) Delegierten ernannten Angestellten sowie deren Gehälter.
Wichtige Handlungen, die hiernach beschrieben sind, unterliegen der Genehmigung durch den Aufsichtsrat.
56349
Der Aufsichtsrat hat den oder die Geschäftsführer bei der Geschäftsführung zu überwachen und genehmigt deren
Geschäftsordnung und gegebenenfalls die Aufteilung der Geschäftsfelder unter deren Mitgliedern.
Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat mindestens jährlich über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäfts-
politik des Unternehmens zu berichten sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand
einer Vorschaurechnung darzustellen (Jahresbericht).
Die Geschäftsführung hat weiter dem Aufsichtsrat regelmässig, mindestens vierteljährlich, über den Gang der Ges-
chäfte und die Lage im Vergleich zur Vorschaurechung unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten
(Quartalsbericht).
Bei wichtigem Anlass ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates unverzüglich zu berichten; ferner ist über Umstände,
die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind, dem Aufsichtsrat unverzüglich
zu berichten (Sonderbericht).
Der Jahresbericht und der Quartalsbericht sind schriftlich zu erstatten. Alle Berichte haben den Grundsätzen einer
gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Berichte müssen auch in angemessener Weise über die
wesentlichen Konzern- und Beteiligungsgesellschaften Aufschluss geben.
Die Geschäftsführung bedarf ausser den im Gesetz oder in dieser Satzung genannten Fällen zur Vornahme folgender
Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats:
a) Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen sowie Erwerb, Veräusserung und Stilllegung von Unternehmen und
Betrieben, wenn diese im Einzelfall den Betrag von einer (1) Million Euro oder den jeweils vom Aufsichtsrat festgelegten
Betrag übersteigen;
b) Erwerb, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften, soweit diese den Betrag von einer halben (0,5) Million
Euro oder den jeweils vom Aufsichtsrat festgelegten Betrag übersteigen;
c) Investitionen, die im einzelnen Anschaffungskosten von einer (1) Million Euro und insgesamt in einem Geschäftsjahr
zwei (2) Millionen Euro oder den jeweils vom Aufsichtsrat festgelegten Betrag übersteigen;
d) Aufnahme von Anleihen, Darlehn und Krediten, die den Betrag von einer halben (0,5) Million Euro im einzeln und
von zwei (2) Millionen Euro insgesamt oder den jeweils vom Aufsichtsrat festgelegten Betrag übersteigen; die
Ausnützung von im Finanzbudget vorgesehenen und bereits genehmigten Kreditrahmen bedarf keiner besonderen Ge-
nehmigung;
e) Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum üblichen Geschäftsbetrieb gehören und den Betrag
von einer halben (0,5) Million Euro im einzeln und einer (1) Million Euro insgesamt in einem Geschäftsjahr oder den
jeweils vom Aufsichtsrat festgelegten Betrag übersteigen;
f) Errichtung und Auflösung von Niederlassungen;
g) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und ähnlichen Haftungen ausserhalb des üblichen Geschäftsbereiches;
h) Alle sonstigen Verträge von besonderer Bedeutung ausserhalb des üblichen Geschäftsbetriebes;
i) Abschluss von Dienstverträgen mit einem Jahresbezug von mehr als einhunderttausend (100.000,00) Euro oder ei-
ner längeren Dauer als zwei Jahren sowie die Zusicherung von Ruhe- und Versorgungsgenüssen oder Umsatz- und
Gewinnbeteiligungen;
j) Erteilung einer Generalvollmacht oder einer Prokura;
k) Aufnahme neuer Produktionsarten oder neuer Geschäftszweige sowie die Aufgabe wesentlicher Betriebsabteilun-
gen und Tätigkeitsgebieten sowie andere Fragen grundsätzlicher Geschäftspolitik;
l) Die Genehmigung der im Jahresbericht enthaltenen Planungen und, soweit daraus bereits ersichtlich, der darin en-
thaltenen Massnahmen, insbesondere das Investitionsprogramm;
m) Angelegenheiten von aussergewöhnlicher Bedeutung in Beteiligungs- oder Tochtergesellschaften, die nicht bereits
unter Punkt a) bis l) erfasst sind, insbesondere Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung oder mit welchen ein
aussergewöhnliches wirtschaftliches Risiko verbunden ist.»
«Art. 13. Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Mitglie-
dern der Geschäftsführung, soweit nur ein Geschäftsführer bestellt ist, durch dessen Unterschrift oder durch die Un-
terschrift der Person oder Personen, welche durch Beschluß der Geschäftsführung hierzu ermächtigt sind.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur David Barth, Dr.-Ing., né le 9 décembre 1965 à Strasbourg (France), de-
meurant 13, rue Klengliller, L-8239 Mamer, comme gérant supplémentaire de la société pour une durée indéterminée.
Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, le présent acte a été signé par les membres du bureau et le notaire instru-
mentaire.
Signé: Th. Wolter, G. Kerckhoff, J. O’Hara, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, vol. 28CS, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(033608/212/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
Luxembourg, le 11 avril 2006.
P. Frieders.
56350
CERATIZIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mamer, 101, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 17.122.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(033612/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
APPARATUR VERFAHREN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06714, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030187/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
FONCIERE MEDICIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 106.779.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06711, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030189/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
ADAM&EVE, Zivilrechtliche Gesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.
H. R. Luxemburg E 3.115.
—
STATUTEN
Die Unterzeichneten:
Arthur Avestisian, 718E, Orange Grove Avenuel, Burbank/USA Ingenieur;
John Preston, 42, rue u Kiem, L-8020 Strassen, Ingenieur;
schliessen mit Wirkung vom 31. März 2006 den Gesellschaftsvertrag einer société civile.
1. Name, Sitz. Der Name der Gesellschaft lautet ADAM&EVE (Société civile).
Der Sitz der Gesellschaft ist 54, route de Remich, L-5442 Roedt Luxemburg.
Das Kapital der Gesellschaft beträgt 150,- EUR.
2. Gegenstand des Unternehmens, Geschäftsjahr. Gegenstand des Unternehmens ist die Registrierung von
EU domain names für den eigenen Bedarf Unternehmenskommunikation sowie eine Unternehmensberatung im Bereich
des Internet.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
3. Gesellschafter, Gesellschaftskapital. Gesellschafter sind Arthur Avestesian und John Preston.
Die Gesellschafter haben keine Bareinlage zu erbringen.
Eine Verpflichtung zur Erhöhung des Gesellschaftskapitals ist nur mit einstimmigem Gesellschaftsbeschluss zulässig.
Je nach Kapitalbedarf stellen die Gesellschafter zu gleichen Teilen die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft dar.
Die Gesellschafter wirtschaften dergestalt, dass die Gesellschaft nicht in eine Unterdeckung gerät und Verluste
produziert. Entnahmen oder Gehälter der Gesellschaft an die Gesellschafter stehen auch unter diesem Vorbehalt und
werden nicht von der Gesellschaft ausbezahlt, wenn keine Liquidität der Gesellschaft vorhanden ist.
Am Kapital sind beteiligt:
1. Arthur Avestesian mit 50%.
2. John Preston mit 50%.
Luxembourg, le 11 avril 2006.
P. Frieders.
APPARATUR VERFAHREN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>FONCIERE MEDICIS S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
56351
4. Gesellschafterkonten. Es gibt zur Zeit nur ein Geschäftskonto, das als Girokonto geführt wird. Die unter 3 auf-
geführten Beteiligungen der Gesellschafter am Gesellschaftskapital werden, sobald eine Kapitaleinlage erfolgt, auf einem
dann einzurichtenden Kapitalkonto verbucht.
Bei einer etwaigen Liquidation der Gesellschaft oder bei Feststellung des Auseinandersetzungsguthabens eines aus-
scheidenden Gesellschafters nimmt nur das Kapitalkonto an den im Unternehmen etwa liegenden stillen Reserven teil.
5. Geschäftsführung, Vertretung, Aufgabenbereiche, Fremdgeschäftsführer, Mehrheitsbeschluss, Ver-
tretung analog zur Geschäftsführung, Beschränkung auf Gesellschaftsvermögen, Wettbewerbsverbot.
Zur Geschäftsführung und Vertretung sind alle Gesellschafter nur gemeinschaftlich berechtigt und verpflichtet. Für jedes
Geschäft ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. Die Zustimmung kann entfallen bei Regelgeschäften mit
einem Wert unter 50,- EUR.
Zur Vertretung sind alle Gesellschafter nur gemeinschaftlich berechtigt und verpflichtet.
Vertretungsmacht und Geschäftsführung kann einem Gesellschafter nur aus wichtigem Grund entzogen werden.
Alle den Gesellschaftern durch Gesetz oder Vertrag zugewiesenen Entscheidungen werden durch einstimmige
Gesellschafterbeschlüsse getroffen.
Aufgabenbereiche:
Die Geschäftsführungsbefugnis wird differenziert, indem:
Gesellschafter John Preston als qeschäftsführender Gesellschafter die operativen Aufgaben der Gesellschaft erfüllt.
Fremdgeschäftsführer:
Ein von den Gesellschaftern einstimmig gewählter fremder Dritter ist berechtigt, alle Massnahmen, die der Geschäfts-
verkehr mit sich bringt, durchzuführen.
Mehrheitsbeschluss:
Zur Geschäftsführung sind alle Gesellschafter auf der Grundlage eines Mehrheitsbeschlusses in der Gesellschafter-
versammlung gemeinschaftlich berechtigt und verpflichtet.
Die Vertretungsbefugnis ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Bei jedem Rechtsgeschäft ist auf diese
Beschränkung Dritten gegenüber hinzuweisen und nur unter Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen
abzuschliessen. Vor Abschluss eines Rechtsgeschäftes ist schriftlich der Nachweis auf die Haftungsbeschränkung beweis-
sicher festzuhalten.
Wettbewerbsverbot:
Ein Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart.
6. Gesellschafterversammlung. Oberstes Beschlussorgan ist die Gesellschafterversammlung.
In der Gesellschafterversammlung hat jeder Gesellschafter eine Stimme.
7. Jahresabschluss. Der Jahresabschluss wird von der Gesellschafterversammlung innerhalb von sechs Monaten
nach Ablauf des Geschäftsjahres aufgestellt. Der Jahresabschluss ist von der Gesellschafterversammlung zu beschliessen.
Der Jahresabschluss mussden steuerrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften entsprechen.
8. Gewinn- und Verlustbeteiligung. Grundlage der Gewinn- und Verlustbeteiligung ist der Jahresabschluss.
Der Gewinn oder Verlust wird nach Köpfen verteilt. Bei einem Gesellschafterwechsel während des Geschäftsjahres
erfolgt die Verteilung zeitanteilig.
9. Entnahmerecht. Alle Gesellschafter sind berechtigt, jeweils monatlich einen Betrag zu entnehmen. Die Entnah-
merechte werden von der Gesellschafterversammlung festgestellt.
10. Vertragsdauer. Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Eine Kündigung ist nur zulässig unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten zum Schluss des Geschäftsjahres.
11. Kündigung und Ausscheiden eines Gesellschafters. Bei Kündigung eines Gesellschafters wird die Gesell-
schaft aufgelöst. Das Auseinandersetzungsguthaben des Ausscheidenden ist aufgrund einer Auseinandersetzungsbilanz
festzustellen, die ohne Bindung an Handels- oder Steuerbilanz nach dem wirklichen Wert der Vermögensgegenstände
unter Berücksichtigung aller Schulden und unter Beachtung der Grundsätze eines vorsichtigen Kaufmanns spätestens
innerhalb von 6 Monaten aufzustellen ist. Hierbei ist vom Liquidationswert auszugehen. Die Auseinandersetzungsbilanz
ist von einem Mitglied der steuerberatenden Berufe zu testieren.
Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem ausscheidenden Gesellschafter innerhalb von sechs Monaten nach
Wirksamwerden der Kündigung auszuzahlen.
12. Erbfolge. Der Tod eines Gesellschafters berührt den Fortbestand der Gesellschaft nicht; sie wird mit den
restlichen Gesellschaftern fortgeführt.
Die Erben werden entsprechend abgefunden.
13. Ausschluss von Gesellschaftern. Die Ausschliessung eines Gesellschafters ist nur bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes in der Person des betroffenen Gesellschafters zulässig.
Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn ein Gesellschafter die Interessen der Gesellschaft in schuldhafter Weise grob
verletzt hat bzw. wenn den übrigen Gesellschaftern eine weitere Zusammenarbeit nicht zuzumuten ist, oder wenn durch
ein Verbleiben des betroffenen Gesellschafters der Bestand der Gesellschaft ernstlich gefährdet wäre.
Ein wichtiger Grund liegt immer vor, wenn über das Vermögen des Gesellschafters rechtskräftig das Konkurs- oder
Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Konkursverfahrens mangels Masse abgelehnt wird.
Zwangsvollstreckungsmassnahmen in Gesellschaftsrechte des Gesellschafters betrieben werden.
14. Abtretung eines Gesellschaftsanteils. Die Abtretung eines Gesellschaftsanteils an einen Dritten ist nur mit
Zustimmung sämtlicher Gesellschafter zulässig.
56352
15. Vertragsänderungen. Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind nur einstimmig möglich. Sie bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Schriftform.
16. Kosten des Vertrages. Die Kosten des Vertrages und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft.
16. Sonstige Vereinbarungen. Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berüh-
ren die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sie haben nicht die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit des gesamten
Vertrages zur Folge. Die unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen sind so umzudeuten, dass der mit ihnen beabsich-
tigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Ist eine Umdeutung nicht möglich, sind die Vertragschliessenden verpflichtet,
eine Vereinbarung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung möglichst
nahe kommt.
Gerichtsstand:
Soweit gesetzlich zulässig, wird als ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag und
über die Wirksamkeit dieser Vereinbarung Luxemburg vereinbart.
Anzuwendendes Recht:
Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich luxemburgisches Recht anwendbar.
Anzahl der Vertragsausfertigungen:
Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhält eine Vertragsausferti-
gung.
Schriftform:
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Auf dieses Schriftformerfordernis kann nur
durch schriftliche Erklärung beider Vertragsteile verzichtet werden.
Luxemburg, den 31. März 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01141. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031492//115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
TOURISM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.336.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle reportée tenue le 15 mars 2006i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes de la Société
suivants avec effet immédiat:
<i>Administrateurs: i>
- Fabio Mazzoni, demeurant professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Joseph Mayor, demeurant professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Benoît Georis, demeurant professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes: i>
WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07031. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030392/587/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.
A. Avestesian / J. Preston
<i>Gesellschafteri> / <i>Gesellschafteri>
Pour extrait
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Compagnie Européenne de Loisirs S.A.
Cetrel Ré S.A.
Eastgate Luxembourg S.A.
GSC European CDO IV S.A.
CLAC, Compagnie Luxembourgeoise d’Activité Cynégétique S.A.
Inox Re S.A.
EOI European & Overseas Investment, S.à r.l.
GP Worldwide Investments (Luxembourg), S.à r.l.
GP Worldwide Investments (Luxembourg), S.à r.l.
OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.
OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.
Lycaon S.A.
General O & R International S.A.
ATL Location, S.à r.l.
Vac Property One, S.à r.l.
Materis Investors, S.à r.l.
Voyages J.C. S.A.
Fluitronics S.A.
Kereda S.A.
Kereda S.A.
Melchior International S.A.
Melchior International S.A.
Mezzanove Finance, S.à r.l.
Mezzanove Finance, S.à r.l.
Dalgarno S.A.
Dalgarno S.A.
OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A.
OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A.
Arcadie S.A.
Arcadie S.A.
Delvino S.A.
Delvino S.A.
Luxembourg Rent Equipment Holding S.A.
Ada Consulting S.A.
Ceratizit Luxembourg, S.à r.l.
Ceratizit Luxembourg, S.à r.l.
Apparatur Verfahren S.A.
Foncière Medicis S.A.
Adam&Eve
Tourism Investment S.A.