logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

50305

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1049

30 mai 2006

S O M M A I R E

(The) 21st Century Advisory S.A., Luxembourg  . .

50340

Kitchens (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

50314

Agility Honn Eechternoach, A.s.b.l., Echternach  . .

50312

Linford, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50352

Alov, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50352

LTD, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50321

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l., Luxembourg . .

50352

Lux Hygiène Service S.A., Differdange. . . . . . . . . . 

50318

Auto-Secours Luxembourg S.A., Nagem  . . . . . . . .

50306

Maat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50324

Bessel Re, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

50331

Menuiserie-Toiture-2000 S.A., Weiswampach  . . . 

50314

BRE/Mannheim I Hotel, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

50341

Merzario International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

50322

BRE/Osnabrück I Hotel, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

50325

Moonraker S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

50340

C.T.A.M., Carlo Tassara Assets Management S.A.,

Morave Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

50321

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50319

Nartal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50323

Cerfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50332

OneSource Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

50309

Coin International, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . .

50324

Oriante S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50306

Coin S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50323

Pearson  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem-

CR  Firenze  Gestion  Internationale  S.A.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50335

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50321

Pearson  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem-

Cypres S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50315

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50340

Diamanten Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

50317

R-Luxinvest S.A., Moersdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50307

Dieleman Art et Bronze International, S.à r.l., Lu-

R-Luxinvest S.A., Moersdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50309

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50317

Remafin Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

50325

Energex Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50317

S.à r.l. Wilmes & Söhne, Diekirch. . . . . . . . . . . . . . 

50306

Euro Lepont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

50321

S.G. Cars, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50351

F.R. Sunrise Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

50332

Serene Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

50319

Financière de Wiltz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

50316

Superspatz, S.à r.l., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . 

50318

Finorsi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50306

Superspatz, S.à r.l., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . 

50319

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme,

Temenos Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 

50316

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50315

Tenderness S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

50311

Fondation Ste Zithe, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

50349

Transco S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

50319

Fourb International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

50333

Unicorn Management (Luxembourg) S.A., Luxem-

G4 Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

50332

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50347

Golf Service S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

50333

Unicorn Management (Luxembourg) S.A., Luxem-

Group  4  Falck  -  Société  de  Surveillance  et  de 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50349

Sécurité S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50325

United Fund Management S.A., Luxembourg . . . . 

50317

Group 4 Falck Technologies Luxembourg, S.à r.l.,

Valmer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50324

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50331

Vienna I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50322

Hansecapital A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . .

50307

Vienna I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50333

Helux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50346

Vienna II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50320

J.J. TL, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50323

Vienna II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50320

J.L. Management S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . .

50324

Vienna III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

50322

50306

S.à r.l. WILMES & SÖHNE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 100.432. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2006, réf. DSO-BM00269, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 27 janvier 2006.

(010330//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

FINORSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 74.661. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 novembre 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée renouvelle, rétroactivement à effet du 21 juin 2005, les mandats d’administrateur de Madame Elisa Fabbri

et de Messieurs Andréa Orsi et Stefano Orsi pour une nouvelle période de six années prenant fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Les administrateurs demeurent professionnellement 2/4 Via S. Andrea, I-40050 Castello d’Argile.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée renouvelle, rétroactivement à effet du 21 juin 2005, le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A., pour une

nouvelle période de six années prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

La société AUDIEX demeure professionnellement 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016402/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

AUTO-SECOURS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8544 Nagem, 2, rue de Hostert.

R. C. Luxembourg B 109.306. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08454, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Nagem, le 9 janvier 2006.

(910578//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.

ORIANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.139. 

Il résulte d’un courrier adressé le 3 mars 2006 à ORIANTE S.A. que M

e

 Yvette Hamilius, administrateur judiciaire de

cette société, a démissionné de ses fonctions avec effet au 16 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021546//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FINORSI S.A., Société Anonyme
A. Orsi / E. Fabbri
<i>Deux Administrateurs

AUTO-SECOURS LUXEMBOURG S.A.
M.-T. Poekes

M

Y. Hamilius.

50307

HANSECAPITAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2714 Luxemburg, 6-12, rue du Fort Wallis.

H. R. Luxemburg B 86.275. 

<i>Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 23. Dezember 2005

Die Sitzung wird um 11.00 Uhr eröffnet.
Nach eingehender Beratung fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Amtsabtretung von Herrn Alhard von Ketelhodt als Verwaltungsratsmitglied wird angenommen.
2. Als Nachfolger im Verwaltungsrat und bis zur Generalversammlung 2007 wird ernannt: RA Serge Bernard, avocat

à la Cour, geboren am 11. November 1969 in Luxemburg, mit Berufsadresse in L-1661 Luxemburg, 95, Grand-rue.

3. Diese Entschlüsse werden bei Gelegenheit der nächsten Generalversammlung der Aktionäre bestätigt.
Da der letzte Beschluss gefasst ist und niemand mehr das Wort verlangt, wird die Sitzung um 11.30 Uhr aufgehoben.

Luxemburg, den 23. Dezember 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00468. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016864/664/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

R-LUXINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6691 Moersdorf, 7, am leweschten Flouer.

H. R. Luxemburg B 95.040. 

Im Jahre zweitausendfünf, den zweiten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner der Gesellschaft R-LUXIN-

VEST S.A. mit Sitz in L-6691 Moersdorf, 7, am leweschten Flouer, 

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 95.040, 
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, im Amtssitz in Bettemburg am 10. De-

zember 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 132 vom 2. März 1999, 

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen im Amtssitz in Niederanven am 14. März

2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 523 vom 21. Juli 2000, 

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alex Weber im Amtssitz in Bascharage am 9. Oktober 2000,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 332 vom 7. Mai 2001, 

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser im Amtssitz in Luxemburg am 28. Juni 2002,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1322 vom 12. September 2002.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Hanns Peter Seidel, Buchprüfer, wohnhaft in Moersdorf.
Er beruft zum Schriftführer Herr Dr. Winfried Konrad Niggemeyer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Trier,
und zum Stimmzähler Herr Hermann Theodor Stute, Systemanalytiker, wohnhaft in Trier.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hin-

fällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF) in dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR).

2. Kapitalaufstockung von dreizehn Euro einunddreissig Cent (13,31 EUR) um das bestehende Kapital von dreissig-

tausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausend Euro
(31.000,- EUR) zu erhöhen, mit Schaffung von eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert mit den gleichen Rechten und
Vorteilen wie die derzeitigen Aktien.

Einzahlung in bar der Kapitalaufstockung durch die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesell-

schaftskapital sowie Zuteilung der Aktien an die Aktionäre in demselben Verhältnis. 

3. Abänderung von Artikel 5 Absatz 1 der Statuten wie folgt:

Art. 5. Das Gesellschaftskaptital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausend (1.000)

Aktien ohne Nennwert.

4. Abänderung von Artikel 9 der Statuten, wie folgt:

Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates beziehungsweise durch die gemeinsamen Unterschriften des Vorsitzenden zusammen mit einem anderen
Verwaltungsratsmitglied verpflichtet, unbeschadet der in Artikel 10 der Satzung vorgesehenen Vollmachten.

5. Abänderung von Artikel 13 Absatz 1 der Statuten wie folgt:

R. Zimmer / F. Sassel
<i>Verwaltungsratmitglied / <i>Verwaltungsratmitglied

50308

Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft oder in dem in der Einberufung an-

gegebenen Ort, am ersten Mittwoch des Monats mai um 11.00 Uhr vormittags.

6. Abänderung von Artikel 14 der Statuten wie folgt:

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
7. Abberufung des bestehenden Verwaltungsrates und Ernennung des neuen Verwaltungsrates sowie Bestätigung des

neuen Kommissars mit Verlängerung des Mandates.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger

Franken (1.250.000,- LUF) in dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR)
umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Kapital aufzustocken mit dreizehn Euro einunddreissig Cent (13,31 EUR) um das

bestehende Kapital von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) auf
einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu erhöhen, und, in Ersetzung der bestehenden Aktien, eintausend (1.000)
neue Aktien ohne Nennwert zu schaffen, mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die derzeitigen Aktien.

Die Einzahlung der dreizehn Euro einunddreissig Cent (13,31 EUR) geschah in bar durch die bestehenden Aktionäre

im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher
dies ausdrücklich bestätigt.

Die neu geschaffenen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung am Kapital, zugeteilt.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 5 Absatz 1 der Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 5. Das Gesellschaftskaptital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausend (1.000)

Aktien ohne Nennwert.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 9 der Statuten abzuändern, wie folgt:

Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates beziehungsweise durch die gemeinsamen Unterschriften des Vorsitzenden zusammen mit einem anderen
Verwaltungsratsmitglied verpflichtet, unbeschadet der in Artikel 10 der Satzung vorgesehenen Vollmachten.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 13 Absatz 1 der Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft oder in dem in der Einberufung an-

gegebenen Ort, am ersten Mittwoch des Monats mai um 11.00 Uhr vormittags.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 14 der Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

<i>Siebenter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den bestehenden Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung abzuberufen und den Mitglie-

der für die Dauer ihres Mandates Entlastung zu erteilen.

Die Versammlung ernennt zu Verwaltungsratsmitgliedern:
1.- Herr Hanns Peter Seidel, Buchprüfer, wohnhaft in L-6691 Moersdorf, 7, am leweschten Flouer.
2.- Herr Dr. Winfried Konrad Niggemeyer, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54295 Trier, Stefan-George-Strasse 13.
3.- Herr Hermann Theodor Stute, Systemanalytiker, wohnhaft in D-54290 Trier, Krahnenstrasse 5.
Ihre Mandate erlöschen bei der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2011.
Die Versammlung bestätigt die Gesellschaft COLAS &amp; LANG, S.à r.l., mit Sitz in L-5752 Frisange, 6, rue de Luxem-

bourg in ihrer Funktion als Kommissar. Das Mandat des Kommissars wird andurch verlängert und erlöscht bei der or-
dentlichen Generalversammlung des Jahres 2011.

Desweiteren beschliesst die Versammlung den Verwaltungsrat zu ermächtigen die tagtägliche Geschäftsführung sowie

die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten an eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.

<i>Verwaltungsratssitzung

Ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:
Herr Dr. Winfried Konrad Niggemeyer, vorbenannt.
Alsdann sind die obengenannten Verwaltungsratsmitglieder zu einer Verwaltungsratssitzung zusammengetreten und

haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Der Verwaltungsrat ernennt zu seinem Vorsitzenden Herrn Hanns Peter Seidel, vorbenannt, mit der Befugnis die Ge-

sellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten, gemäss Artikel 9 der Satzung.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

50309

<i>Kosten

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde werden abgeschätzt auf 850,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten No-

tar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Seidel, W. Niggemeyer, T. Stute, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 2 décembre 2005, vol. 360, fol. 54, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 25. Januar 2006

Im Jahre zweitausendsechs, am fünfundzwanzigsten Januar. 
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner der Gesellschaft R-LUXIN-

VEST S.A. mit Sitz in L-6691 Moersdorf, 7, am leweschten Flouer,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 95.040.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Hanns Peter Seidel, Buchprüfer, wohnhaft in Moersdorf.
Er beruft zum Schriftführer Herr Dr. Winfried Konrad Niggemeyer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Trier,
und zum Stimmzähler Herr Hermann Theodor Stute, Systemanalytiker, wohnhaft in Trier.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern unterzeichnet ist, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hin-

fällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1. Abberufung von Herrn Ralf Stöcker in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsvorsitzender und geschäftsführender

Verwalter.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Infolge der Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Beck im

Amtssitz in Echternach am 2. Dezember 2005, wird Herr Ralf Stöcker, wohnhaft in D-54348 Schweich, Zum Meulenwald
19, mit sofortiger Wirkung in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsvorsitzender und geschäftsführender Verwalter ab-
berufen, mit Entlastung für die Ausführung seines Mandates.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

Moersdorf, den 25. Januar 2006. 

Enregistré à Diekirch, le 27 janvier 2006, réf. DSO-BM00337. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(910728/201/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.

R-LUXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6691 Moersdorf, 7, am leweschten Flouer.

R. C. Luxembourg B 95.040. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(910735/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.

OneSource FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. CARLISLE FINANCE S.A.).

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.360. 

In the year two thousand and six, on the sixth of February.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme) CARLISLE FINANCE

S.A., with registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon, R.C.S. Luxembourg section B number
67.360, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, on the 24th of November
1998, published in the Mémorial C number 96 of the 17th of February 1999, and whose articles of incorporation have

Echternach, den 11. Januar 2006.

H. Beck.

H.P. Seidel / W.K. Niggemeyer / T. Stute.

Echternach, le 30 janvier 2006.

H. Beck.

50310

been modified by deed of the same notary Gérard Lecuit on the 30th of November 1998, published in the Mémorial C
number 129 of the 1st of March 1999, and by deeds of the undersigned notary:

- on the 25th of March 1999, published in the Mémorial C number 465 of the 18th of June 1999;
- on the 29th of March 1999, published in the Mémorial C number 482 of the 24th of June 1999;
- on the 26th of April 1999, published in the Mémorial C number 542 of the 15th of July 1999;
- on the 18th of June 1999, published in the Mémorial C number 700 of the 21st of September 1999;
- on the 6th of August 1999, published in the Mémorial C number 849 of the 13th of November 1999,
with a subscribed capital of thirty-nine thousand five hundred United States Dollars (USD 39,500.-) consisting of three

thousand seven hundred and fifty (3,750) class A shares having a par value of ten United States Dollars (USD 10.-) each
and two hundred (200) class B shares having a par value of ten United States Dollars (USD 10.-) each.

The meeting is presided by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Miss Audrey Coppede, private employee, residing professionally at Luxembourg.
The meeting elects as ballot-judge Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at Luxembourg.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
that the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed ne varietur by the shareholders or their proxy holders and the undersigned
notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities;

that it results from said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices;

that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the points of the agenda, which reads

as follows:

<i>Agenda:

1. Adoption of the name OneSource FINANCE S.A. and subsequent amendment of article 1 of the company’s articles

of association which will have henceforth the following wording: «Art. 1. There is established hereby a société anonyme
under the name of OneSource FINANCE S.A.». 

2. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken by the meeting by unanimous vote.

<i>Resolution

The meeting decides to adopt the name OneSource FINANCE S.A. and to amend accordingly article 1. of the com-

pany’s articles of association which will have henceforth the following wording:

«Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of OneSource FINANCE S.A.» 
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that at the request of the

appearing parties the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same ap-
pearing parties and in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surname,

first name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, den sechsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft CARLISLE

FINANCE S.A., mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 67.360,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Gérard Lecuit, Notar mit dem damaligen Amtssitz in Hesperin-
gen, am 24. November 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 96 vom 17. Februar 1999, und deren Satzung ab-
geändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Gérard Lecuit am 30. November 1998,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 129 vom 1. März 1999, und durch Urkunden des instrumentierenden Notars:

- am 25. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 465 vom 18. Juni 1999;
- am 29. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 482 vom 24. Juni 1999;
- am 24. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 542 vom 15. Juli 1999;
- am 18. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 700 vom 21. September 1999;
- am 6. August 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 849 vom 13. November 1999;
mit einem gezeichneten Kapital von neununddreissigtausendfünfhundert US Dollar (USD 39.500,-), eingeteilt in drei-

tausendsiebenhundertfünfzig Aktien der Klasse A mit einem Nennwert von je zehn US Dollar (USD 10,-) und zweihun-
dert (200) Aktien der Klasse B mit einem Nennwert von je zehn US Dollar (USD 10,-).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

50311

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Fräulein Audrey Coppede, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Raphaël Rozanski, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in Luxem-

burg.

Nachdem das Büro somit gebildet ist, stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden, dass die an-

wesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste ver-
merkt sind, welche nach ne varietur Unterzeichnung durch die Aktionäre oder deren Vertreter sowie durch den
unterzeichneten Notar diesem Protokoll beigebogen bleibt, um mit demselben einregistriert zu werden; 

dass sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, dass sämtliche ausgegebenen Aktien anwesend oder vertreten sind, so

dass gegenwärtige Versammlung ohne vorherige Einberufungsschreiben abgehalten werden kann;

dass gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und rechtsgültig über folgende Tagesord-

nungspunkte beraten darf.

<i>Tagesordnung:

1.- Annahme der Bezeichnung OneSource FINANCE S.A. sowie entsprechende Abänderung des Artikels 1. der Sat-

zung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird: «Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung
OneSource FINANCE S.A.»

2.- Verschiedenes.
Nach eingehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Bezeichnung OneSource FINANCE S.A. zu übernehmen und Artikel 1. der

Satzung der Gesellschaft entsprechend abzuändern, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:

«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung OneSource FINANCE S.A.»
Da die Tagesordnung hiermit erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sieben hundert Euro veranschlagt sind, gehen zu

Lasten der Gesellschaft.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und Deutsch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen

Parteien gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben er-
schienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische
Fassung massgebend. 

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Originalurkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: P. Marx, A. Coppede, R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 février 2006, vol. 535, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019180/231/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2006.

TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.134. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 28 février 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs:
- COSAFIN S.A. domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’Entreprises, demeurant 18A, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., domiciliée à Wilmington (Delaware).
L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
- la FIDUCIAIRE GLACIS, domiciliée au 18A, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statu-

taire approuvant les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00333. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021358/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Junglinster, den 23. Februar 2006.

J. Seckler.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

50312

AGILITY HONN EECHTERNOACH, Verein ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-6434 Echternach, 17, rue André Duchscher.

H. R. Luxemburg F 1.440. 

STATUTEN

Kapitel I. Benennung - Sitz - Dauer - Zweck und Ziel

Art. 1. Der Verein führt den Namen AGILITY HONN EECHTERNOACH (AHE) und ist ein Verein ohne Gewinn-

zweck (A.s.b.l.) und untersteht dem Gesetz vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck sowie alle
dieses Gesetz betreffenden Anpassungen. Der Verein ist dem CLUB LUXEMBOURGEOIS POUR AGILITY (CLA) an-
geschlossen.

Art. 2. Der Sitz ist in Echternach, 17, rue André Duchscher, L-6434 Echternach und seine Dauer unbegrenzt.

Art. 3. Der Verein wurde auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Verein hat zum Zweck und zum Ziel, unter Ausschluss jeder politischen und konfessionellen Tätigkeit:
a) die Dressur aller Hunderassen zu fördern und zu verbessern;
b) die Interessen der Dressurleiter zu wahren;
c) die Ausbildung der Mitglieder im Sinne der Dressur von Hunden;
d) die Veranstalten von Agility - Wettbewerben;
e) die Interessen seiner Mitglieder zu wahren und zu fördern.

Kapitel II. Zusammensetzung und Aufnahme

Art. 5.
- Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt.
- Der Verein besteht aus aktiven, inaktiven und Ehrenmitgliedern.
- Jede unbescholtene Person kann in den Verein aufgenommen werden.
- Wer dem Verein als aktives Mitglied beizutreten wünscht, hat ein schriftliches Aufnahmegesuch an den Vorstand

einzureichen.

- Der Vorstand entscheidet über die provisorische An- oder Nichtannahme.
- Die Ablehnung eines Mitglieds kann ohne Angaben des Vorstandes erfolgen. 
- Berufsmäßige Hundehändler dürfen nicht Mitglied werden.
Über die definitive Mitgliedschaft der aktiven Mitglieder entscheidet die nächstfolgende ordentliche Generalversamm-

lung durch einfache Stimmenmehrheit.

a) Aktive Mitglieder sind alle Vorstandsmitglieder und alle Hundesportler, welche mit ihren Hunden aktiv an Veran-

staltungen teilnehmen, sowie Mitglieder, die im Verein eine Funktion irgendwelcher Art ausüben, und sich verpflichten
gegenwärtige Statuten anzuerkennen.

b) Inaktive Mitglieder sind solche Hundeführer, welche mit ihren Hunden an offiziellen Turnieren teilnehmen, anson-

sten aber dieselben Bedingungen zu erfüllen haben, wie sub a).

c) Zu Ehrenmitgliedern können vom Vorstand ernannt werden, solche Personen, welche dem Verein besondere

Dienste geleistet haben.

Kapitel III. Austritt und Ausschluss

Art. 6. Die Mitgliedschaft erlöscht:
a) durch schriftliche Kündigung an die Adresse des Präsidenten oder des Sekretärs,
b) durch nicht Zahlung der Beiträge.

Art. 7. Der Ausschluss kann vom Vorstand ausgesprochen werden:
a) bei Nichtbezahlen von Schulden gegenüber dem Verein, nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung; die zweite

schriftliche Aufforderung erfolgt spätestens 30 Tage nach der ersten;

b) durch einwandfrei nachgewiesenen Handlungen, welche die Interessen des Vereins schädigen;
c) bei groben Verstößen gegen die Statuten.
Verstöße unter sub a) b) und c) entscheidet provisorisch der Vorstand in geheimer Wahl mit 2/3 Stimmenmehrheit,

nachdem der Beschuldigte seine Verteidigungsgründe mündlich geltend machen konnte.

Der definitive Ausschluss erfolgt erst mit 2/3 Stimmenmehrheit in der nächstfolgenden Generalversammlung.
Der erstverhängte Ausschluss ist aber sofort wirksam.
Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat kein Anspruch auf irgendeinen Vermögensanteil des Vereins.

Kapitel IV. Verwaltung

Art. 8. Der Verein wird durch einen Vorstand verwaltet, welcher von der Generalversammlung gewählt wird, und

sich aus 5-11 Mitgliedern zusammensetzt.

Die AGILITY HONN EECHTERNOACH sind bei gleichzeitiger Unterschrift vom Präsidenten oder dessen Stellver-

treter und vom Sekretär rechtlich gebunden.

Art. 9.
a) Um Vorstandsmitglied zu werden, muss der Kandidat 2 Jahre Mitglied des Vereins sein, und wenigstens 18 Jahre

alt sein;

b) der Vorstand besteht aus: Präsident, Vize-Präsident, Sekretär, Kassierer und 1-7 Beisitzenden;
c) die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung für die Dauer von 4 Jahren gewählt;

50313

d) der Präsident, der Sekretär und Kassierer werden vom Vorstand gewählt;
e) die Kandidaturen für den Vorstand müssen schriftlich 8 Tage vor Beginn der Generalversammlung beim Präsiden-

ten oder Sekretär eingereicht werden;

f) die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus;
g) scheidet im Laufe des Jahres ein Vorstandsmitglied aus, so kann es durch den nächsten Ersatzkandidaten für die

Dauer des übernommenen Mandats ersetzt werden;

h) der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins.
Die Sitzungen werden durch einfaches Schreiben oder Drucksache einberufen, wenn es die Interessen des Vereins

verlangen;

i) die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet den Vorstandssitzungen beizuwohnen.
Wenn ein Mitglied mehr als 3x unentschuldigt fehlt, kann der Vorstand dasselbe seines Amtes entheben;
j) in Erfüllung seiner Mission hat der Vorstand die weitgehendsten Machtbefugnisse.
Alles was nicht ausdrücklich der Generalversammlung durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Statuten vorbehalten

ist, fällt unter seine Zuständigkeit;

k) bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder dessen Stellvertreter;
I) von jeder Sitzung wird ein Protokoll angefertigt;
m) jede ordnungsgemäss einberufene Vorstandssitzung, in der die Majorität anwesend ist, ist beschlussfähig.
Sie beschliesst mit Stimmenmehrheit;
n) das Kassenbuch, worin alle Finanzoperationen eingetragen werden, wird einmal jährlich von den Kassenrevisoren

geprüft.

Zur Kontrolle der Abrechnungen werden in der Generalversammlung jährlich 2 Kassenrevisoren gewählt.
Dieselben dürfen dem Vorstand des Vereins nicht angehören.

Kapitel V. Generalversammlung

Art. 10.
a) Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im ersten Trimester statt. Der Vorstand kann jedesmal eine

ausserordentliche Generalversammlung einberufen, wenn die Interessen des Vereins es verlangen.

Die Mitglieder werden schriftlich eingeladen, und zwar 14 Tage im voraus. 
Die Einladungen enthalten die Tagesordnung, sowie eventuelle Vorschläge der Mitglieder;
b) Der Präsident oder dessen Stellvertreter übernimmt den Vorsitz der Generalversammlung;
c) die Generalversammlung ist immer beschlussfähig und kann gültig tagen, gleichviel wieviele Mitglieder auch immer

anwesend sind.

Sie umfasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, in Übereinstimmung mit den Artikeln 7 und 8 des Gesetzes vom

21. April 1928. 

Die Veröffentlichungen müssen in Übereinstimmung mit Artikel 9 desselben Gesetzes erfolgen.
Alle Mitglieder sind stimmberechtigt.

Art. 11. Die Tagesordnung der Generalversammlung muss folgende Punkte enthalten:
a) Ansprache des Präsidenten,
b) Tätigkeitsbericht,
c) Kassenbericht,
d) Bericht der Kassenrevisoren,
e) Wahl der Vorstandsmitglieder,
f) Wahl der Kassenrevisoren,
g) Festsetzung des Jahresbeitrages,
h) Programmvorschau,
i) Anträge,
j) Annahme, Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes,
k) Verschiedenes.

Art. 12. Über die Sitzung der Generalversammlung wird ein Protokoll angefertigt, das vom Präsidenten und vom

Sekretär unterschrieben wird.

Art. 13. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Kapitel VI. Statutenänderung

Art. 14. Vorschläge zu Statutenänderungen, die von 1/20 der Mitglieder, die auf der jährlichen Mitgliederliste einge-

tragen sind, und unterschrieben sind, müssen in die Tagesordnung der Generalversammlung aufgenommen werden.

Eine 2/3 Majorität der anwesenden Mitglieder ist zu einer Statutenänderung erforderlich.

Kapitel VII. Auflösung

Art. 15. Die Auflösung des Vereins kann nur unter Beachtung des Gesetzes vom 21. April 1928 erfolgen.

Art. 16. Bei Auflösung des Vereins fällt das Barvermögen dem Wohltätigkeitsbüro der Gemeinde Echternach zu und

das Material wird der CLA zur Verfügunggestellt.

50314

Kapitel VIII. Vermögen des Vereins

Art. 17.
a) das Vermögen des Vereins besteht aus den jährlichen Beiträgen der Ehrenmitgliedern, den aktiven und inaktiven

Mitgliedern, welche jeweils in der Generalversammlung festgesetzt werden, sowie aus Einnahmen von Veranstaltungen,
Spenden, Subsidien, usw;

b) die Gelder dürfen nur zum Ausbau des Vereins und zur Förderung des Hundesports verwendet werden;
c) das Gesamtvermögen ist Eigentum des Vereins.

Kapitel IX. Verschiedene Bestimmungen

a) Jedes Mitglied, welches mit einem Hund dem Verein beitritt, muss im Besitze einer gültigen Haftpflichtversicherung

sein.

b) Jedes Mitglied hat das Recht auf kostenlose Beratung in allen den Hund betreffenden Fragen.
c) Jedes Mitglied hat kostenlosen Zutritt zu dem Agilityfeld, jedoch müssen die Anweisungen des Trainers oder

dessen Stellvertreters befolgt werden.

d) Die Mitglieder sind verpflichtet die Interessen des Vereins und ihrer Dachorganisation in jeder Hinsicht zu gewäh-

ren und ihren finanziellen Verpflichtungen pünktlich nachzukommen.

e) Sämtliche finanziellen Verpflichtungen gegenüber der C.L.A., werden vom Vorstand vorgestreckt und müssen

jedoch vom Mitglied auf das Club-Konto überwiesen werden.

f) Jedes Mitglied bezahlt einen jährlich festgelegten Beitrag.
g) Wechselt ein Hund den Besitzer und dieser möchte aktives Mitglied werden, wird der volle Beitrag verlangt.
h) Die Gelder dürfen nur für den Aufbau des Vereins, für die Förderung der Dressur und des Agilitysportes sowie

für die Verpflichtungen gegenüber der Dachorganisation d.h. der C.L.A. verwendet werden.

i) Der AGILITY HONN-EECHTERNOACH Verein lehnt jegliche Verantwortung für Unfälle ab, die während Veran-

staltungen oder Versammlungen vorkommen können, ausgenommen, dass der Betroffene gemäss den Bestimmungen
der Haftpflichtversicherung des Vereins versichert ist.

j) Mitglieder des Vereins dürfen nur mit Genehmigung des Vorstandes in sportlichen Angelegenheiten gerichtliche

Klage einreichen.

Bei eventuellem gerichtlichem Freispruch können weder aktive, noch inaktive Mitglieder aus dem Freispruch Rechte

und Ansprüche gegenüber dem Verein geltend machen.

k) Alle durch diese Statuten nicht vorgesehenen Fälle werden vom Vorstand des Vereins gefällt, falls sie nicht schon

durch die Statuten oder durch das Gesetz vom 21. April 1928 behandelt worden sind.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01868. – Reçu 474 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022853//153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

MENUISERIE-TOITURE-2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.

R. C. Luxembourg B 108.801. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2006, réf. DSO-BM00425, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 janvier 2006.

(910588//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2006.

KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 40.357. 

Nous vous informons du changement de l’adresse de l’Administrateur Yat Hung David Fu Chok Woo comme suit:
A1, 4th Floor, Elm Tree Towers, 8 Chun Fai Road, Tai Hang, Hong Kong, China.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00306. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021244/683/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature

<i>KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

50315

CYPRES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.088. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 23 février 2006 à 15.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN

S.A., Administrateurs et de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021360/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

FONDATION INTERNATIONALE CATHOLIQUE DU SCOUTISME.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg G 10. 

1. COMPTE DE FONCTIONNEMENT (PERTES ET PROFITS) AU 31.12.2005 

2. BILAN AU 31.12.2005 

BUDGET 2006 

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Charges

2004

2005 Produits  

2004

2005

EUR

EUR

EUR

EUR

Subvention annuelle CICS M . . . . 

7.000,00

7.000,00 Intérêts et agios reçus   . . . . . 

152,03

41,44

Subvention annuelle CICS-EM   . . 

4.645,00

4.000,00 Coupons encaissés Fonds B  . 

8.162,47

10.023,71

Frais de banque  . . . . . . . . . . . . . . 

44,57

149,21 Coupons encaissés Fonds C  . 

5.290,50

5.378,78

Commissions d’encaissement  . . . 

1.480,30

345,72 Intérêts courus payés. . . . . . . 

-14,25

 0,00

Droits de garde titres  . . . . . . . . . 

300,31

200,51 Proratas d’agios sur titres  . . . 

-1.441,59

-271,79

Frais d’enreg. et dépôt légal  . . . . 

35,00

 98,30 Intérêts courus sur obligations 

 5.069,92

3.566,26

Résultat de change   . . . . . . . . . . . 

4.261,78

Intérêts courus année précéd. 

-6.427,86

-5.069,92

Prorata d’agios sur titres . . . . . . . 

1.441,59

Plus-values sur titres  . . . . . . . 

0,00

2.117,43

Intérêts courus payés à l’achat  . . 

14,25

Moins-values sur titres  . . . . . 

0,00

-1.436,51

Frais administratifs . . . . . . . . . . . . 

470,00

 0,00 Résultat de change . . . . . . . . . 

-4.261,78

 7.883,19

Sous-total   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.692,80

11.791,74

Résultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-7.445,74

10.440,85

Total charges . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.247,06

22.232,59 Total produits  . . . . . . . . . . . . 

 6.529,44

22.232,59

Actif

2004

2005 Passif 2004

2005

EUR

EUR

EUR

EUR

Placements en titres: . . . . . . . . . .  271.135,89 239.240,37 Capital:
Disponible: 

Fonds A  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.772,60

2.772,60

Compte épargne à vue  . . . . . . . . 

1.724,03

0,00 Fonds B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  153.934,09 161.912,22

Compte courant KBL. . . . . . . . . .  10.615,86

36.187,41 - ancien fonds en USD   . . . . . 

7.898,75

7.898,75

Compte courant Dexia . . . . . . . . 

19.992,50 - donations au fonds B   . . . . . 

11.460,00

0,00

Réalisable: 

Fonds C  . . . . . . . . . . . . . . . . .  119.926,00 115.962,13

Intérêts courus  . . . . . . . . . . . . . . 

5.069,92

3.566,26 Résultat de l’année . . . . . . . . . 

-7.445,74

10.440,84

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288.545,70 298.986,54 Total passif   . . . . . . . . . . . . . .  288.545,70 298.986,54

Dépenses:

2005

2006 Recettes: 2005

2006

EUR

EUR

EUR

EUR

Subvention CICS Mondiale  . . . . . 

7.000,00

8.500,00 Intérêts et agios . . . . . . . . . . . 

50,00

50,00

Subvention CICS/EM . . . . . . . . . . 

4.000,00

4.500,00 Proprata d’agios sur titres . . . 

 -300,00

-300,00

Frais de banque  . . . . . . . . . . . . . . 

300,00

350,00 Total coupons Fonds B  . . . . . 

8.000,00

8.300,00

Commissions d’encaissement  . . . 

280,00

300,00 Total coupons Fonds C . . . . . 

4.100,00

4.850,00

Droits de garde titres  . . . . . . . . . 

250,00

250,00 Intérêts courus sur obl.

Frais d’enreg.et dépôt légal . . . . . 

100,00

100,00 Plus-value sur titres . . . . . . . . 

1.000,00

Frais de publications. . . . . . . . . . . 

0,00

2.500,00 Résultat de change . . . . . . . . . 

250,00

Frais administratifs . . . . . . . . . . . . 

350,00

1.000,00  

Sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.280,00

17.500,00 Sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.850,00

14.150,00

50316

Révision par le commissaire aux comptes Nico Picard, docteur en mathématiques, le 12 février 2006. 
Comptes et bilan 2005 et budget 2006 approuvés par l’assemblée générale du 18 février 2006 à Rome.
pour extrait conforme, Luxembourg le 23 février 2006. 

<i>Extrait de l’assemblée générale du 18 février 2006 à Rome (conseil d’administration)

 Le mandat de Gebhard Transier est renouvelé, Gerard A. Scanlan est admis au conseil d’administration et nommé

vice-président. Msgr Richard LaRoque est admis comme membre du CA. La démission de Jordi Camps I Aguade a été
acceptée. Jean Tiquet est nommé secrétaire du CA.

Nico Picard est désigné comme réviseur aux comptes pour l’exercice courant 2006. 

Luxembourg, le 23 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05594. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(021011//64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

FINANCIERE DE WILTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.521. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 20 février 2006 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des administrateurs
COSAFIN S.A., Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus
et du Commissaire aux Comptes
Monsieur Pierre Schill
pour un terme venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 30 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00337. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021365/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

TEMENOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.792. 

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2006

<i>Première décision

Les actionnaires décident de révoquer LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. (257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg) de

son poste de réviseur d’entreprises et de le relever de son mandat.

<i>Deuxième décision

Les actionnaires décident de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxem-

bourg) au poste de réviseur d’entreprises, pour une durée d’un an, expirant à la date de l’assemblée générale annuelle
(2006).

Luxembourg, le 13 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00052. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021708/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-430,00

-3.350,00

Total dépenses . . . . . . . . . . . . . . .

11.850,00

14.150,00 Total recettes . . . . . . . . . . . . . 

11.850,00

14.150,00

R. Richter
<i>Trésorier

Pour extrait conforme
R. Richter
<i>Trésorier

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

G. Koukis / M. Raïssis
<i>Président / <i>Secrétaire Directeur

50317

ENERGEX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.245. 

Il résulte d’une lettre de démission du 24 février 2006 que la société anonyme, AUDIEX S.A., a démissionné de son

mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

La convention de domiciliation conclue entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET ENERGEX ENGINEERING S.A.

est dénoncée avec effet au 1

er

 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00019. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021372//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

DIAMANTEN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.282. 

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 25 janvier 2006

En vertu de l’acte de transfert de parts, daté du 25 janvier 2006, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,

9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 100 parts sociales d’une valeur de 125 euros chacune, à la société BOXTONE LIMITED, City House, 6 Karaiskakis

Street, CY-3032 Limassol, Chypres.

Luxembourg, le 22 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021375/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

UNITED FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.575. 

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d’administration de la société du 20 juin 2002

Le Conseil d’Administration de UNITED FUND MANAGEMENT S.A. («la Société») décide de transférer le siège

social de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2002. Le nouveau siège social est 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021379/3085/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

DIELEMAN ART ET BRONZE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 37.629. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2005

L’assemblée décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg à 10A, rue Henri M.

Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021428/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Luxembourg, le 28 février 2006.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Gérant

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

DIELEMAN ART ET BRONZE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

50318

LUX HYGIENE SERVICE S.A.., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 62A, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 62.673. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 16 février 2006, nous vous prions d’apporter le changement suivant

au registre de commerce.

Le siège social est transféré à L-4620 Differdange, 62A, rue Emile Mark.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021522/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

SUPERSPATZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.017. 

L’an deux mille six, le six février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Weber, commerçant, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 44, Grand-rue;
2.- Monsieur Ben Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes;
3.- Monsieur Tun Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes;
ici représenté par Monsieur Claude Weber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 janvier 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;
4.- Mademoiselle Elodie Weber, étudiante, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Claude Weber, Monsieur Ben Weber et Monsieur Tun Weber, prénommés, sont les seuls associés de

la société à responsabilité limitée SUPERSPATZ, avec siège social à L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 avril 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C, numéro 373 du 7 août 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11
décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 686 du 3 mai 2002, modifiée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C, numéro 926 du 10 septembre 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 51.017.

2. Monsieur Claude Weber, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Mademoiselle Elodie We-

ber, prénommée, ici présente et ce acceptant, dix (10) parts sociales de la société à responsabilité limitée SUPERSPATZ,
prénommée.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,00) que le cédant

reconnaît avoir reçu de la cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

3. La cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et elle a droit aux revenus et bénéfices

dont ces parts sont productives à partir de ce jour.

La cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
4. Tous les associés déclarent expressément accepter la cession de parts qui précède.
5. Monsieur Claude Weber, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter la cession de

parts qui précède au nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les
sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l’article 1690 du Code civil.

6. Ensuite, les associés décident unanimément de modifier l’article six des statuts de la société comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent

(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune, entièrement libérées.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:  

7. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
8. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

Luxembourg, le 27 février 2006.

Signature.

1.- Monsieur Claude Weber, commerçant, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 44, Grand-rue, soixante-dix

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- Monsieur Ben Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes, dix parts sociales  . .

10

3.- Monsieur Tun Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes, dix parts sociales  . .

10

4.- Mademoiselle Elodie Weber, étudiante, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes, dix parts so-

ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

50319

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Weber, B. Weber, E. Weber, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, vol. 152S, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017717/227/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

SUPERSPATZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.017. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017719/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

SERENE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.487. 

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021547/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

C.T.A.M., CARLO TASSARA ASSETS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 113.494. 

Le Conseil d’Administration constate et confirme que toutes les actions ont été libérées à 100% en date du 17 janvier

2006.

Luxembourg, le 15 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021558/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

TRANSCO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle «Um Monkeler».

H. R. Luxemburg B 25.082. 

<i>Auszug des Protokolls der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 13. Januar 2006

Die Versammlung stimmt dem Vorschlag einstimmig zu Herrn Thomas März, wohnhaft in D-66540 Neunkirchen,

Süssbachweg 25 als neues Verwaltungsratsmitglied aufzunehmen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023113/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

Luxembourg, le 16 février 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 16 février 2006.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

MAZARS
Unterschrift

50320

VIENNA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 111.122. 

Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été

transféré du 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1

er

 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 23 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06015. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021596/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

VIENNA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.122. 

Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales daté du 26 janvier 2006 que VIENNA I, S.à r.l., ayant son siège

social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 111.121, a transféré 2 parts sociales qu’elle détenait dans la Société à VIENNA III, S.à r.l., ayant son
siège social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 113.868.

Les associés de la Société sont désormais les suivants:  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales daté du 19 janvier 2006 que VIENNA I, S.à r.l., ayant son siège

social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 111.121, a transféré 1 part sociale qu’elle détenait dans la Société à VIENNA III, S.à r.l., ayant son siège
social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 113.868.

Les associés de la Société sont désormais les suivants:  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05673. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021679/1035/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Nom des associés

Nombre de Parts Sociales

VIENNA I, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.017

VIENNA III, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.020

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Nom des associés

Nombre de Parts Sociales

VIENNA I, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.019

VIENNA III, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.020

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

50321

EURO LEPONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.878. 

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 21 février 2006, lors de l’Assemblée Générale de la société

- La démission de Marion Muller en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Denis Bour, employé privé,

demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé administrateur en son
remplacement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021568/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

LTD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 107.285. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion des gérants tenue en date du 20 février 2006

II est porté à la connaissance de tous qu’en date du 28 septembre 2005, la société GAIA HOLDING, S.à r.l. a cédé

50 parts sociales qu’elle détenait dans la société à THE BLUE LINE HOLDING, S.à r.l. Partant, la société THE BLUE
LINE HOLDING, S.à r.l. est devenue propriétaire de la totalité des parts sociales de la société.

Luxembourg, le 20 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021573/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

MORAVE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.410. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02583, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024837/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

CR FIRENZE GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.417. 

Il résulte du procès-verbal de Conseil d’Administration du 12 décembre 2005 que le Conseil a pris, entre autres, la

résolution suivante:

<i>Troisième résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix, de nommer Monsieur Henry Kelly, demeurant 4, rue J.-P.

Lanter, L-5943 Itzig, en qualité de Codirecteur Général délégué à la gestion journalière de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021630//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

EURO LEPONT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 16 mars 2006.

Signature.

CR FIRENZE GESTION INTERNATIONALE S.A.
G. Fiorini

50322

VIENNA III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 113.868. 

Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été

transféré du 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1

er

 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 23 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06013. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021588/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

VIENNA I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.200.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 111.121. 

Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été

transféré du 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1

er

 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 23 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021600/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

MERZARIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.542. 

<i>Extrait des résolutions prises au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2006

1. Les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg, de leurs mandats d’Administrateur de catégorie B sont acceptées avec effet à la
date de la présente assemblée.

2. Les mandats des administrateurs de catégorie A de Monsieur Dario Bornati, directeur, demeurant à Via Bugatti

Ettore n

°

 13, Milan (Italie) et de Monsieur Riccardo Vincenzo Alloisio, directeur, demeurant à Via Isola Caprera n

°

 2,

Verolanuova (Italie) sont révoqués avec effet à la date de la présente assemblée.

3. Le nombre des administrateurs est réduit de 4 à 3, à répartir entre 2 administrateurs de catégorie A et un admi-

nistrateur de catégorie B.

4. Monsieur Antonino Santoro, consultant financier, demeurant au via Ricasoli Bettino, n

°

 2 à Milan; Monsieur Fran-

cesco Rosario Albano, employé privé, demeurant au via In Arcione, 98 à Rome sont nommés comme nouveaux admi-
nistrateurs de catégorie A, et Monsieur Fabio Pollino, employé privé, demeurant au contrada Conte Coop Sperone,
Palazzina n

°

 2, Messina, est nommé comme nouvel administrateur de catégorie B. Leurs mandats viendront à échéance

lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2011.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01700. – Reçu 14 euros.

(023334/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MERZARIO INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

50323

J.J. TL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 100.640. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 6 janvier 2006

Les décisions suivantes ont été prises par Monsieur José Alconada Iglesias, associé unique:

<i>Premièrement

Madame Nereyda Altagracia Fernandez Sanchez est révoquée de ses fonctions de gérante technique avec effet

immédiat.

<i>Deuxièmement

Monsieur Aconada est nommé gérant unique de la J.J. TL, S.à r.l.

<i>Troisièmement

La société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02824. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021680//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

NARTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.600. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

2 janvier 2006 que:

1. L’Assemblée accepte la démission de Madame Catherine Schorderet, employée privée, élisant domicile au 2, rue

Bellot, CH-1206 Genève.

2. L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Madame Bernadette Jacquemoud,

employée privée, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève. Son mandat est confirmé en date de ce jour et
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021690/2329/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

COIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.303. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 17 janvier 2006

que:

- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2005;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021711/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

J.J. TL, S.à r.l.
J.A. Iglesias
<i>Associé unique

Signature.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signature / Signature

50324

VALMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.665. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

2 janvier 2006 que:

L’Assemblée accepte la démission de Madame Catherine Schorderet, en sa qualité de Commissaire aux Comptes de

la société, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, Madame Bernadette

Jacquemoud, employée privée, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève. Son mandat est confirmé en date de
ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00154. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021696/2329/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

MAAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.783. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le

2 janvier 2006 que:

L’Assemblée accepte la démission de Madame Catherine Schorderet, en sa qualité d’Administrateur, employée

privée, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Madame Bernadette Jacquemoud,

employée privée, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève. Son mandat est confirmé en date de ce jour et
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021699/2329/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

COIN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.421. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 19 décembre 2005

que:

- l’assemblée renomme le gérant sortant, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la

prochaine assemblée approuvant les comptes 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021712/695/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

J.L. MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7216 Bereldange, 16, rue Bour.

R. C. Luxembourg B 79.490. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 février 2006

L’Assemblée décide de renouveler pour une durée de six années les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Jan Hamelink, administrateur de sociétés, demeurant Hollekenstraat, 23 à B-9960 Assenede.
- Monsieur Adriaan De Feijter, administrateur de sociétés, demeurant 3, rue de Bridel à L-7344 Steinsel.
L’Assemblée décide de nommer pour une durée de six années:
- Madame Lucy Jeannette Hamelink, demeurant Hollekenstraat, 23 à B-9960 Assenede au poste d’administrateur de

la société en remplacement de Maître René Faltz.

Signature.

Signature.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures

50325

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
L’Assemblée décide de renouveler pour une durée de six années le mandat de commissaire aux comptes de:
- LOMAC S.A.,société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 41, avenue de la Gare

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 22.206.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02162. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023157/263/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

GROUP 4 FALCK - SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 9.546. 

Après délibération l’assemblée générale extraordinaire réunie au siège de la société en date du 25 novembre 2005 a

pris à l’unanimité la résolution suivante:

- d’accepter la démission de Monsieur Lawrence Canu, 20, allée du Sorbier, F-76520 Franqueville Saint Pierre, en sa

qualité d’administrateur et président du conseil d’administration;

- de nommer Monsieur Danny Vandormael, demeurant à Hennegouwpad, 25, B-8670 Oostduinkerke, comme admi-

nistrateur et président du conseil d’administration à partir du 1

er

 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021723//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

REMAFIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 82.093. 

Il résulte de deux lettres recommandées adressées en date du 1

er

 mars 2006 à la société que BOULDER TRADE Ltd

et que COSTALIN Ltd ont démissionné en tant qu’administrateurs de la société REMAFIN INVEST S.A.

De même, il résulte d’une lettre recommandée qu’à partir du 1

er

 mars 2006, le commissaire aux comptes FIDUCI-

AIRE FIBETRUST a déposé son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01613. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023091//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

BRE/OSNABRÜCK I HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 114.672. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-third day February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, not yet registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Ms Virginie Lepage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 23 February 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Par mandat du conseil d’administration
A. Lorentz
<i>Directeur financier

FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

50326

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,

lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/OSNABRÜCK I HOTEL, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-

ments of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

50327

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,

and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Com-

pany.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

Of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

50328

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The 500 shares have been subscribed as follows:
- 500 shares by BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-

pearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences be-
tween the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, noch nicht eingetragen im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister,

hier vertreten durch Frau Virginie Lepage, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Februar 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft

Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die
«Gesellschaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften, neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften

und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,

die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb,
die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der

Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen

Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

50329

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/OSNABRÜCK I HOTEL, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt
werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an, Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der

Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des

Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an

Vermögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen
werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei
Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder

einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär
bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der
Geschäftsführerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der

Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen
Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein

Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm,
Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden
Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles
Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort
abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates
vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.

50330

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen

Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der
Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen

werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die
Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der

Hauptversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, zustehen.

Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die

Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der

Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung
legt Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 500 Anteile wurden von BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.

50331

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: V. Lepage, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 février 2006, vol. 435, fol. 70, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): E. Weber.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(023243/242/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

GROUP 4 FALCK TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 19.541. 

Après délibération l’assemblée générale extraordinaire réunie au siège de la société en date du 25 novembre 2005 a

pris à l’unanimité la résolution suivante:

- d’accepter la démission de Monsieur Lawrence Canu, 20, allée du Sorbier, F-76520 Franqueville Saint Pierre, en sa

qualité d’administrateur et président du conseil d’administration;

- de nommer Monsieur Danny Vandormael, demeurant à Hennegouwpad, 25, B-8670 Oostduinkerke, comme admi-

nistrateur et président du conseil d’administration à partir du 1

er

 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021725//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

BESSEL RE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 113.035. 

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l’associé unique en date du 20 février 2006 à 18.00 heures

- L’associé unique a pris acte de la démission de l’un des gérants, en la personne de Monsieur Marc Koeune et a

nommé en son remplacement, Monsieur Stefano Matteo Tommaso Bordone, citoyen italien, né à I-Milan, le 9 mars 1962
et domicilié Via F. De Sanctis 34, à I-20141 Milan.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022741/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

Mersch, den 9. März 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
<i>Par mandat du conseil d’administration
A. Lorentz
<i>Directeur financier

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un gérant

50332

G4 SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 17.614. 

Après délibération l’assemblée générale extraordinaire réunie au siège de la société en date du 25 novembre 2005 a

pris à l’unanimité la résolution suivante:

- d’accepter la démission de Monsieur Lawrence Canu, 20, allée du Sorbier, F-76520 Franqueville Saint Pierre, en sa

qualité d’administrateur et président du conseil d’administration;

- de nommer Monsieur Danny Vandormael, demeurant à Hennegouwpad, 25, B-8670 Oostduinkerke, comme admi-

nistrateur et président du conseil d’administration à partir du 1

er

 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021726//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

F.R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.819. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 24 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 24 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, actuellement en
vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de MONTBRUN REVISION, S.à
r.l., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05955. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021730/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

CERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.027. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été
révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommé aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l.,
précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05983. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021740/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour extrait conforme
<i>Par mandat du conseil d’administration
A. Lorentz
<i>Directeur financier

<i>Pour F.R. SUNRISE HOLDING S.A. Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour CERFIN S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

50333

FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.056. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 2 décembre 2005

<i>Résolutions

L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, DELOITTE S.A. et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, pour les exercices se

terminant aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 à
la fonction de Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021744/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

GOLF SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 45.592. 

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 février 2006 que:
1. Madame Josina van Dam, demeurant 8, Laan Van Kronenburg NL-1183 AS Amstelveen, a été nommée comme

nouveau Commissaire aux comptes pour une durée de 1 an en remplacement de Monsieur Peter Luc Oei,
démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021750/1285/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

VIENNA I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.121. 

Il résulte d’un premier contrat de transfert de parts sociales daté du 26 janvier 2006 que APAX WW NOMINEES

LIMITED, ayant son siège social au 15, Portland Place, London W1B 1PT, dont le numéro d’immatriculation est le
04693597, a transféré 1 part sociale qu’elle détenait dans la Société à VIENNA IV, S.à r.l., ayant son siège social au 16,
Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 113.870.

Les associés de la Société sont désormais les suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il résulte d’un second contrat de transfert de parts sociales daté du 26 janvier 2006 que APAX WW NOMINEES

LIMITED, ayant son siège social au 15, Portland Place, London W1B 1PT, dont le numéro d’immatriculation est le
04693597, a transféré 1 part sociale qu’elle détenait dans la Société à VIENNA V, S.à r.l., ayant son siège social au 16,

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Nom des associés

Nombre de Parts Sociales

APAX WW NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.019

VIENNA IV, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.020

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

50334

Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 113.869.

Les associés de la Société sont désormais les suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il résulte d’un troisième contrat de transfert de parts sociales daté du 26 janvier 2006 que APAX WW NOMINEES

LIMITED, ayant son siège social au 15, Portland Place, London W1B 1PT, dont le numéro d’immatriculation est le
04693597, a transféré 1 part sociale qu’elle détenait dans la Société à VIENNA VI, S.à r.l., ayant son siège social au 16,
Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 113.874.

Les associés de la Société sont désormais les suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il résulte d’un quatrième contrat de transfert de parts sociales daté du 26 janvier 2006 que APAX WW NOMINEES

LIMITED, ayant son siège social au 15, Portland Place, London W1B 1PT, dont le numéro d’immatriculation est le
04693597, a transféré 1 part sociale qu’elle détenait dans la Société à VIENNA VII, S.à r.l., ayant son siège social au 16,
Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 113.842.

Les associés de la Société sont désormais les suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il résulte d’un cinquième contrat de transfert de parts sociales daté du 30 janvier 2006 que APAX WW NOMINEES

LIMITED, ayant son siège social au 15, Portland Place, London W1B 1PT, dont le numéro d’immatriculation est le
04693597, a transféré 1 part sociale qu’elle détenait dans la Société à VIENNA VIII, S.à r.l., ayant son siège social au 16,

Nom des associés

Nombre de Parts Sociales

APAX WW NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.018

VIENNA IV, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

VIENNA V, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.020

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Nom des associés

Nombre de Parts Sociales

APAX WW NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.017

VIENNA IV, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

VIENNA V, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

VIENNA VI, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.020

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Nom des associés

Nombre de Parts Sociales

APAX WW NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.016

VIENNA IV, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

VIENNA V, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

VIENNA VI, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

VIENNA VII, S.à r.l.

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.020

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

50335

Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 111.142.

Les associés de la Société sont désormais les suivants:  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021758/1035/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 730,635,500.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.716. 

In the year two thousand and five, on the twenty-first of December at 14.30 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

(the «Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under sec-
tion B number 100.716, incorporated by a notarial deed of the undersigned notary enacted on April 29, 2004, whose
articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number
690 of July 6, 2004. The articles of incorporation have been modified by a notarial deed of the undersigned notary en-
acted on December 24, 2004, and which has been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associ-
ations, number 681 of July 11, 2005 (the «Articles»).

The meeting is presided by Charles De Kerchove, jurist in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Patrick Van Hees, jurist in Luxembourg and the meeting elects as scrutineer

Patrick Van Hees, jurist in Luxembourg. 

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the 7,306,355 (seven million three hundred and six thousand three hun-

dred and fifty-five) shares of USD 100 (one hundred US Dollars) each, representing the whole capital of the Company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder
expressly states that it has been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Waiving of notice right;
2.- Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2,778,699,700 (two billion seven hundred sev-

enty-eight million six hundred ninety-nine thousand seven hundred United States Dollars) by the issue of 27,786,997
(twenty-seven million seven hundred eighty-six thousand nine hundred ninety-seven) new shares with a nominal value
USD 100 (one hundred United States Dollars) each in favour of PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS N

°

 2 LTD (the

«Contributor»);

3.- Subscription by the Contributor and payment of the 27,786,997 (twenty-seven million seven hundred eighty-six

thousand nine hundred ninety-seven) new shares issued by the Contributor by way of a contribution of all its assets and
liabilities to the Company;

4.- New composition of the shareholding of the Company;
5.- Amendment of article eight of the articles of association of the Company relating to the share capital in order to

reflect the new share capital of the Company amounting to USD 3,509,335,200 (three billion five hundred nine million
three hundred thirty-five thousand two hundred United States Dollars) pursuant to the above resolutions;

6.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

Nom des associés

Nombre de Parts Sociales

APAX WW NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.015

VIENNA IV, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

VIENNA V, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

VIENNA VI, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

VIENNA VII, S.à r.l.

1

VIENNA VIII, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.020

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

50336

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2,778,699,700 (two billion seven

hundred seventy-eight million six hundred ninety-nine thousand seven hundred United States Dollars), so as to raise it
from its present amount of USD 730,635,500 (seven hundred thirty million six hundred thirty-five thousand five hundred
United States Dollars) to USD 3,509,335,200 (three billion five hundred nine million three hundred thirty-five thousand
two hundred United States Dollars) by the issue of 27,786,997 (twenty-seven million seven hundred eighty-six thousand
nine hundred ninety-seven) new shares with a nominal value USD 100 (one hundred United States Dollars) each (the
«New Shares») in favour of PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS N

°

 2 LTD (the «Contributor»), subject to the pay-

ment of a share premium of USD 3,405,123,055 (three billion four hundred five million one hundred twenty-three thou-
sand fifty-five United States Dollars) (the «Share Premium») of which (i) USD 3,127,253,085 (three billion one hundred
twenty-seven million two hundred fifty-three thousand eighty-five United States Dollars) shall be allocated to a distrib-
utable reserve and of which (ii) USD 277,869,970 (two hundred seventy-seven million eight hundred sixty-nine thousand
nine hundred seventy United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

The whole is fully paid up by way of a contribution of all the assets and liabilities owned by the Contributor, in the

framework of an all assets and liabilities contribution to the Company amounting to a total value of USD 6,183,822,755
(six billion one hundred eighty-three million eight hundred twenty-two thousand seven hundred fifty-five United States
Dollars).

<i>Third resolution

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares referred

to above by its contribution in kind of all its assets and liabilities to the Company.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr Patrick Van Hees, residing in Messancy, Belgium. The

Contributor declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them up by the contribution of the assets
and liabilities hereafter described, subject to the payment of a share premium for a total amount of USD 3,405,123,055
(three billion four hundred five million one hundred twenty-three thousand fifty-five United States Dollars) of which (i)
USD 3,127,253,085 (three billion one hundred twenty-seven million two hundred fifty-three thousand eighty-five United
States Dollars) shall be allocated to a distributable reserve and of which (ii) USD 277,869,970 (two hundred seventy-
seven million eight hundred sixty-nine thousand nine hundred seventy United States Dollars) shall be allocated to the
legal reserve.

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributor through a contribution in

kind of all its assets and liabilities as defined in article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971
as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, the prenamed company, having its registered office in the European Un-

ion, in exchange of the issuance of the New Shares, represents all its assets and liabilities (entire property), and is doc-
umented in the copy of the interim balance sheet of the Contributor as of 20 December 2005, which will remain
hereafter attached, signed by the Company’s managers.

The assets and liabilities contributed to the Company are composed of:

<i>Assets

- 92,387 (ninety-two thousand three hundred eighty-seven) shares of common stock, par value USD 100 (One Hun-

dred United States Dollars) per share, in PEARSON INC., a company incorporated under the laws of State of Delaware,
United States of America, having its executive offices at 1330 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, which
shares of common stock are valued at USD 6,164,359,355 (six billion one hundred sixty-four million three hundred fifty-
nine thousand three hundred fifty-five United States Dollars);

- cash at bank amounting to USD 20,463,400 (twenty million four hundred sixty-three thousand four hundred United

States Dollars).

<i>Liabilities

- debt owed to PEARSON OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of England and

Wales, having its registered office at 80 Strand, London WC2R 0RL, United Kingdom, amounting to USD 1,000,000 (one
million United States Dollars) pursuant to a loan agreement entered into by PEARSON OVERSEAS HOLDINGS LIM-
ITED and PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS N

°

 2 LIMITED on 6 December 2005.

And, any and all assets and liabilities held by the Contributor that would exist at the date of the contribution, not

mentioned because unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations which would be
attached thereto in any manner whatsoever.

50337

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is USD 6,183,822,755 (six billion one hundred eighty-three million eight

hundred twenty-two thousand seven hundred fifty-five United States Dollars), i.e. EUR 5,172,582,815 at the European
Central Bank currency rate fixed on December 20th, 2005 at USD 1.1955 against EUR 1. Such evaluation has been ap-
proved by the board of managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 20 December
2005, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene the managers of the Company, such as duly represented by Mr Patrick Van Hees, pre-named,

in accordance with the stipulations of the statement of contribution value established by the managers on 20 December
2005, who require the notary to act what follows:

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this con-
tribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out,

the shareholding of the Company is now composed of:

- PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED: 7,306,355 (seven million three hundred and six thousand three

hundred and fifty-five) shares; and

- PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS N

°

 2 LTD: 27,786,997 (twenty-seven million seven hundred eighty-six

thousand nine hundred ninety-seven) shares.

The sole shareholder of the Company recognizes and acknowledges that PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS

N

°

 2 LTD immediately becomes a shareholder of the Company and can efficiently take part to the vote of the resolution

to be taken below.

The notary acts that the 35,093,352 (thirty-five million ninety-three thousand three hundred fifty-two) shares, rep-

resenting the whole capital of the Company, is represented so that the meeting can validly decide on the resolution to
be taken below.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it

is unanimously resolved to amend the first paragraph of article eight (the second paragraph remaining the same) of the
Articles to be read as follows:

«The share capital of the Company is set at USD 3,509,335,200 (three billion five hundred nine million three hundred

thirty-five thousand two hundred United States Dollars), represented by 35,093,352 (thirty-five million ninety-three
thousand three hundred fifty-two shares with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each».

<i>Tax exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg capital company by a contribution in kind consisting

of all the assets and liabilities of a capital company having its registered office in a member State of the European Union
(United Kingdom), nothing withheld or excepted, carried out to the Company, the Company expressly requests, for
the contribution described above made by the Contributor, the application of article 4-1 (four-one) of the Luxembourg
law dated 29 December 1971, as modified by the Luxembourg law of 3 December 1986, which provides for capital duty
exemption.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand Euro.

There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre à 14h30.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS,

S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siége social au 65, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
la section B numéro 100.716 et constituée par un acte notarié du 29 avril 2004 du notaire soussigné et dont les statuts
ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 690 de 6 juillet 2004. Les statuts

50338

de la Société ont été modifiés par acte notarié du notaire soussigné en date du 24 décembre 2004, tel que publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 681 du 11 juillet 2005 (les «Statuts»).

L’assemblée est présidée par Mr Charles De Kerchove, jurist in Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Patrick Van Hees, jurist in Luxembourg,
et l’assemblée choisit comme scrutateur M. Patrick Van Hees, jurist in Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique, présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Ladite liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées
aux présentes pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 7.306.355 (sept millions trois cent six mille trois cent cinquante-cinq) parts

sociales d’une valeur nominale de USD 100 (cent dollars américains) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de la Société, sont représentées, de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à
l’ordre du jour, dont l’associé unique a été préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Renonciation au droit de convocation;
2.- Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 2.778.699.700 (deux milliards sept cent soixan-

te-dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents dollars américains), par l’émission de 27.786.997
(vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de USD 100 (cent dollars américains) chacune en faveur de PEARSON LUXEMBOURG HOLDING N

°

 2 LTD

(l’«Apporteur»);

3.- Souscription et paiement par l’Apporteur de toutes les 27.786.997 (vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-six

neuf cent quatre-vingt-dix-sept) nouvelles parts sociales au moyen d’un apport en nature de tous ses éléments d’actifs
et de passifs à la Société;

4.- Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5.- Modification de l’article huit des Statuts de la Société concernant le capital social de la Société pour refléter le

nouveau capital social de la Société d’un montant de USD 3.509.335.200 (trois milliards cinq cent neuf millions trois cent
trente-cinq mille deux cents dollars américains) suite aux résolutions précédentes;

6.- Divers.
Après que l’associé unique ait approuvé ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution 

Il est décidé que l’associé unique de la Société renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à

cette assemblée générale; l’associé unique reconnaît qu’il a été suffisamment informé de l’ordre du jour et qu’il se con-
sidère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points à l’ordre
du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition
de l’associé unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution 

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de USD 2.778.699.700 (deux milliards sept cent

soixante-dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents dollars américains), de manière à l’augmenter
de son montant actuel de USD 730.635.500 (sept cent trente millions six cent trente-cinq mille cinq cents dollars amé-
ricains) à USD 3.509.335.200 (trois milliards cinq cent neuf millions trois cents trente-cinq mille deux cents dollars amé-
ricains), par l’émission de 27.786.997 (vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de USD 100 (cent dollars américains) chacune (les «Nouvelles Parts So-
ciales») en faveur de PEARSON LUXEMBOURG HOLDING N

°

 2, S.à r.l. (l’«Apporteur»), sujet au paiement d’une pri-

me d’émission de USD 3.405.123.055 (trois milliards quatre cent cinq millions cent vingt-trois mille cinquante-cinq
dollars américains) (la «Prime d’Emission») de laquelle (i) USD 3.127.253.085 (trois milliards cent vingt-sept millions
deux cent cinquante-trois mille quatre-vingt-cinq dollars américains) sont alloués à un poste distribuable du bilan et de
laquelle (ii) USD 277.869.970 (deux cent soixante-dix-sept millions huit cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-dix
dollars américains sont alloués à la réserve légale.

La totalité est entièrement libérée par un apport en nature de tous les actifs et passifs détenus par l’Apporteur, dans

le cadre d’un apport de tous ses actifs et passifs, pour une valeur totale s’élevant à un montant de USD 6.183.822.755
(six milliards cent quatre-vingt-trois millions huit cent vingt-deux mille sept cent cinquante-cinq dollars américains).

<i>Troisième résolution 

Il est décidé unanimement d’accaepter la souscription et le paiement par l’Apporteur des Nouvelles Parts Sociales

décrites précédemment, par un apport en nature de tous ses actifs et passifs à la Société.

<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes l’Apporteur, ici représenté par M. Patrick Van Hees, résidant à Messancy, Belgique.

L’Apporteur déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales de la Société et les payer par l’apport en nature consistant
dans les actifs et passifs tels que définis ci-après, sujets au paiement d’une prime d’émission d’un montant total de USD
3.405.123.055 (trois milliards quatre cent cinq millions cent vingt-trois mille cinquante-cinq dollars américains) de la-
quelle (i) USD 3.127.253.085 (trois milliards cent vingt-sept millions deux cent cinquante-trois mille quatre-vingt-cinq
dollars américains) sont alloués à un poste distribuable du bilan et de laquelle (ii) USD 277.869.970 (deux cent soixante-
dix-sept millions huit cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-dix dollars américains) sont alloués à la réserve légale.

50339

Les Nouvelles Parts Sociales aussi bien que la Prime d’Emission ont été totalement libérées par un apport en nature

de tous ses actifs et passifs tels que définis par l’article 4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971
amendée qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Description de l’apport

L’apport fait par l’Apporteur, société précitée, ayant son siège social dans l’Union Européenne, en échange de l’émis-

sion des Nouvelles Parts Sociales, représente l’intégralité de ses actifs et passifs («universalité») et est conforme à la
copie du bilan intermédiaire de l’Apporteur au 20 décembre 2005 qui restera attachée au présent acte, signée par les
gérants de la Société.

Les actifs et passifs apportés à la Société sont constitués comme suit:

<i>Actifs

- 92.387 (quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-sept) part sociale de USD 100 (cent dollars) chacune déte-

nues dans PEARSON INC., une société constituée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amériques, ayant
son siège social sis 1330 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, d’une valeur de USD 6.164.359.355 (six mil-
liards cent soixante-quatre millions trois cent cinquante-neuf mille trois cent cinquante-cinq dollars américains);

- liquidités sur un compte bancaire d’un montant de USD 20.463.400 (vingt millions quatre cent soixante-trois mille

quatre cents dollars américains).

<i>Passifs

- Une dette due à PEARSON OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, une société constituée en vertu du droit de l’Angle-

terre et du Pays de Galles, ayant son siège social sis 80 Strand, Londres WC2R 0RL, Royaume-Uni, d’un montant de
USD 1.000.000 (un million de dollars américains) en vertu d’un contrat de prêt conclu entre PEARSON OVERSEAS
HOLDINGS LIMITED et PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS N

°

 2 LIMITED le 6 décembre 2005.

Ainsi que tous les actifs et passifs détenus par l’Apporteur qui pourraient exister à ce jour, même non mentionnés

car non connus, qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements et obligations qui pourraient s’y rattacher
de quelque manière que ce soit.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à USD 6.183.822.755 (six milliards cent quatre-vingt-trois millions

huit cent vingt-deux mille sept cent cinquante-cinq dollars américains), c’est-à-dire EUR 5.172.582.815 au taux de change
pratiqué par la Banque Centrale Européenne, actuellement fixé à USD 1,1955 pour EUR 1. Cette évaluation a été ap-
prouvée par le conseil de gérance de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport en date 20
décembre 2005 qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec l’acte.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de cet apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des

stipulations du rapport d’évaluation établissant la valeur de l’apport à la date du 20 décembre 2005, qui prient le notaire
d’acter que:

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qua-

lité de gérants de la Société en raison de l’apport en nature décrit ci-dessus, ils consentent expressément à la description
de l’apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité de la souscription et de la libération.

<i>Quatrième résolution 

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’apport ayant été entièrement réalisé, l’actionnariat de la Société est

à présent composé comme suit:

- PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED: 7.306.355 (sept millions trois cent six mille trois cent cinquante-

cinq) parts sociales; et

- PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS N

°

 2 LTD: 27.786.997 (vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-six mille

neuf cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales.

L’associé unique de la Société reconnaît que PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS N

°

 2 LTD devient immédiate-

ment associé de la Société et peut efficacement prendre part au vote de la résolution à prendre ci-dessous.

Le notaire constate que les 35.093.352 (trente-cinq millions quatre-vingt-treize mille trois cent cinquante-deux) parts

sociales, représentant la totalité du capital de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement
décider de la résolution devant être prise ci-dessous.

<i>Cinquième résolution 

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’apport ayant été entièrement réalisé, il est unanimement décidé de

modifier l’article huit paragraphe premier des Statuts (le deuxième paragraphe restant inchangé) et de lui donner la te-
neur suivante:

«Le capital de la Société est fixé à USD 3.509.335.200 (trois milliards cinq cent neuf millions trois cent trente-cinq

mille deux cents dollars américains), représenté par 35.093.352 (trente-cinq millions quatre-vingt-treize mille trois cent
cinquante-deux) parts sociales d’une valeur nominale de USD 100 (cent dollars américains) chacune.»

<i>Demande d’exonération du droit d’apport

Considérant qu’il s’agit d’une augmentation de capital d’une société de capitaux luxembourgeoise par apport en na-

ture consistant en tous les actifs et passifs d’une société de capitaux ayant son siège social dans un Etat membre de

50340

l’Union Européenne (Royaume-Uni), rien n’étant retenu ni excepté, simultanément à la Société, la Société demande ex-
pressément pour l’apport décrit ci-dessus fait par l’Apporteur, l’application de l’article 4-1 (quatre-un) de la loi luxem-
bourgeoise du 29 décembre 1971, ainsi que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l’exonération du droit
d’apport.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital social, s’élève à environ huit mille euros.

Aucune autre affaire n’ayant à être traitée, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. De Kerchove, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026682/211/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.716. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 40812 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 mars 2006.

(026683/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

THE 21st CENTURY ADVISORY S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 80.519. 

DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire de THE 21st CENTURY ADVISORY S.A. (la «Société») qui s’est tenue le 30

décembre 2005 a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

Les livres et documents sociaux resteront déposés auprès de BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD

EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg où ils seront conservés pendant cinq ans.

Les fonds non distribués aux actionnaires et aux créanciers de la Société à la clôture de la liquidation et qui sont dus

aux actionnaires et aux créanciers sont déposés auprès de la Caisse des Consignations à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022707/1183/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

MOONRAKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 43.272. 

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 22 février 2006

1) Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010 les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration: 

M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C., président du conseil d’administration et administrateur-délégué, né le 24

février 1951 à Luxembourg;

M. Gérard Matheis, conseil économique, administrateur-délégué, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg;
M. Paul Marx, docteur en droit, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette.

Luxembourg, le 24 février 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Le Liquidateur

50341

Les trois administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

<i>Commissaire aux comptes: 

La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte (en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l.), R.C.S. Luxembourg
B 58.545.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024038/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

BRE/MANNHEIM I HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 114.681. 

 STATUTES 

In the year two thousand six, on the twenty-third day February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, not yet registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Ms Virginie Lepage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 23 February 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,

lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/MANNHEIM I HOTEL, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

<i>Pour <i>MOONRAKER S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

50342

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-

ments of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,

and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Com-

pany.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

50343

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The 500 shares have been subscribed as follows:
- 500 shares by BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-

pearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences be-
tween the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

50344

Ist erschienen:

BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister,

hier vertreten durch Frau Virginie Lepage, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Februar 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-

ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ges-

ellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesells-
chaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften

und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,

die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb,
die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreic-

hung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Di-

enstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/MANNHEIM I HOTEL, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaft-

santeile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals ver-
treten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesells-

chaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zahl-

ungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-

mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

50345

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ein-

en Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäfts-
führerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführ-

errat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sit-

zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-

den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haup-

tversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

50346

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißig-

sten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 500 Anteile wurden von BRE/NINE HOTEL Holding, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister un-
ter Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar, gegenwärtige Urkunde
unterzeichnet.

Gezeichnet: V. Lepage, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 février 2006, vol. 435, fol. 71, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): E. Weber.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(023297/242/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

HELUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.639. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40618 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 mars 2006.

(024809/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Mersch, den. 9. März 2006.

H. Hellinckx.

J. Elvinger
<i>Notaire

50347

UNICORN MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.657. 

In the year two thousand six, on the fourteenth of February at 12:30 p.m. 
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UNICORN MANAGEMENT (LUXEMBOURG)

S.A., having is registered office in L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by a notarial deed of September
13, 1999, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 896 of November 26, 1999. The Articles of Incorpora-
tion have been amended for the last time by a notarial deed dated August 7, 2002, published in the Mémorial, Recueil
Spécial C, number 1500 of October 17, 2002.

The meeting was presided by Yannick Deschamps, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Hélène Subtil-Jastrzebski, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Fédérique Lefèvre, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman requests the undersigned notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list, that all the 5.000 (five thousand) shares representing the entire share capital

are present or represented, which allows to disregard the usual convening notices, the shareholders present or repre-
sented recognize that they have been duly convened and declare that they have been informed of the agenda by previous
communication.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To change Article 3 of the Articles of Incorporation to comply with the purpose of Chapter 14 of the Luxembourg

Law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investments, as amended.

2. To appoint DELOITTE S.A. as independent auditor and to modify the corresponding article accordingly.
3. To update the Articles of Incorporation if necessary.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to modify the object of the Company.
Article three of the Articles of Incorporation is replaced as follows:

«Art. 3. The Company’s purpose is to serve as manager of UNICORN INVESTMENT SICAV and is consisting of

activities generally governed by Chapter 14 of the Luxembourg law of December 20, 2002 relating to undertakings for
collective investment. The Company may not engage in activities other than the management of Undertakings for Col-
lective Investment and shall not serve as manager of other Luxembourg funds.

The Company may also carry out any operation, within the territory of the Grand Duchy of Luxembourg or abroad,

which is directly or indirectly related, in whole or in part, to its corporate object.»

<i>Second resolution

The Meeting decides to amend article 18 by deleting the existing contents and replacing by: «The accounts of the

Company shall be audited by an external auditor. The external auditor shall be appointed and removed by the share-
holders at the general meeting who shall determine his office term and fees.»

The meeting decides to appoint DELOITTE S.A. with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

as external auditor for the statutory year of 2006.

<i>Third resolution

The meeting approves to delegate the day-to-day management and the representation of the Company to several

Directors.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to add the following sentence under paragraph 3 of article 12 of the Articles: «in the event that

in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have the casting vote».

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences be-
tween the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze février à 12.30h.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

50348

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société UNICORN MANAGEMENT

(LUXEMBOURG) S.A., avec son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte notarié du
13 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 896 du 26 novembre 1999 et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte notarié du 7 août 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1500 du 17 octobre
2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Yannick Deschamps, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Hélène Subtil-Jastrzebski, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Frédérique Lefèvre, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

III.- Que les 5.000 (cinq mille) actions représentant l’intégralité du capital social étant présentes ou représentées à la

présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’Article 3 des statuts pour le mettre en conformité avec l’objet du Chapitre 14 de la loi luxem-

bourgeoise du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.

2. Nomination de DELOITTE S.A., avec siège social 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg comme réviseur d’en-

treprises et modification de l’article correspondant.

3. Mise à jour des Statuts si nécessaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
L’Article trois des statuts est remplacé comme suit:

«Art. 3. L’objet de la Société est de servir comme gestionnaire de UNICORN INVESTMENT SICAV et consiste en

toute activité prévue par le chapitre 14 de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement
collectif. La Société ne pourra pas s’engager dans des activités autre que la gestion d’organismes de placement collectif
et ne pourra pas gérer d’autres fonds luxembourgeois.

La Société pourra également effectuer toutes opérations, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, liées di-

rectement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’amender l’article 18 en supprimant le contenu existant et en le remplaçant par: «Les comptes

de la Société seront audités par un réviseur d’entreprises. Le réviseur d’entreprise sera nommé et révoqué par les ac-
tionnaires réunis en assemblée générale qui fixera ses émoluments, ainsi que la durée de son mandat.»

L’assemblée décide de nommer DELOITTE S.A., avec siège social 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg comme

réviseur d’entreprises pour l’année statutaire 2006.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée approuve la délégation de la gestion journalière des affaires ainsi que la représentation de la société à

des membres du Conseil d’Administration.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’ajouter la phrase suivante sous le paragraphe 3 de l’article 12 des statuts: «Au cas où, lors d’une

réunion du Conseil, il y a égalité de voix pour et contre une décision, le président aura une voix prépondérante.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par son nom, prénom, état et de-

meure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Deschamps, H. Subtil-Jastrzebski, F. Lefèvre, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 février 2006, vol. 435, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026793/242/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

Mersch, le 28 février 2006.

H. Hellinckx.

50349

UNICORN MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.657. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026794/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.

FONDATION Ste ZITHE. 

Siège social: L-2763 Luxembourg, 32, rue Ste Zithe.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005 (en euros)                             

Mersch, le 14 mars 2006.

H. Hellinckx.

<i>Actif

31.12.2005 31.12.2004

A. Capital souscrit non versé
B. Frais d’Etablissement
C. Actif immobilisé

I.

Immobilisations incorporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

1. Frais de recherche et de développement
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires 
3. Fonds de commerce 
4. Acomptes versés 

II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

1. Terrains et constructions 
2. Installations techniques et machines 
3. Autres installations, outillage et mobilier
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 

III. Immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

1. Parts dans des entreprises liées
2. Créances sur des entreprises liées
3. Participations
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
5. Titres ayant le caractère d’immobilisations
6. Autres prêts
7. Actions propres

Total de l’actif immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

D. Actif circulant

I.

Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.000,00

0,00

1. Matières premières et consommables
2. Produits en cours de fabrication
3. Produits finis et marchandises
4. Acomptes versés
5. Immeubles destinés à la revente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.000,00

0,00

II. Créances 

1. Créances résultant de ventes et prestations de services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

2. Créances sur des entreprises liées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

0,00

0,00

4. Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.496,00

0,00

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.496,00

0,00

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an

III. Valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493.197,00

500.750,00

1. Parts dans entreprises liées 
2. Actions propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

3. Autres valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493.197,00

500.750,00

IV. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . . 1.386.095,17

821.656,89

Total de l’actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.155.788,17 1.322.406,89
E. Comptes de régularisation

Total de l’Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.155.788,17 1.322.406,89
<i>Passif

31.12.2005 31.12.2004

50350

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE ALLANT 

 DU 1

er

 JANVIER 2005 AU 31 DECEMBRE 2005 (en euros)                

A. Capitaux propres

I.

Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 25.000,00

 25.000,00

II. Primes d’émission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

III. Réserve de réévaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

IV. Réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

1.  Réserve légale
2. Réserve pour actions propres
3. Réserves statutaires 
4. Autres réserves

V.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.297.406,89 1.003.257,98

VI. Résultats de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

778.867,97

294.148,91

VI’. Acompte sur dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

VII. Subventions d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

VIII. Plus-values immunisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

Total des capitaux propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.101.274,86 1.322.406,89
B. Provisions pour risques et charges

1. Provisions pour pensions et obligations similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

2. Provisions pour impôts
3. Autres provisions

Total des provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

C. Dettes

1. Emprunts obligataires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

2. Dettes envers des établissements de crédit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

3. Acomptes reçus sur commandes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

4. Dettes sur achats et prestations de services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.160,86

0,00

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.160,86

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an

5. Dettes représentées par des effets de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

6. Dettes envers des entreprises liées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation

0,00

0,00

8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

9. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51.352,45

0,00

a)  dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51.352,45

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 

Total des dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54.513,31

0,00

D. Comptes de régularisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.155.788,17 1.322.406,89

2005

2004

A. Charges

1. Réduction du stock de produits finis et en cours de fabrication 
2. a) Consommation de marchandises et de matières premières et consommables 

b) Autres charges externes

3. Frais de personnel 

a) Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90.929,92

0,00

b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements
c) Pensions complémentaires
d) Autres charges sociales

4. a) Corrections de valeur sur frais d’établissement et sur immobilisations corpo-

relles et incorporelles 

b) Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.053,00

0,00

5. Autres charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

121.073,75

199.028,45

6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières

faisant partie de l’actif circulant 

7. Intérêts et charges assimilées

a)  Concernant des entreprises liées
b) Autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

956,72

482,00

50351

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS 

 AU 31 DECEMBRE 2005

1. Généralités
La Fondation Sainte Zithe («la Fondation»), établissement d’utilité publique, a été constituée le 28 décembre 1994

pour une durée illimitée.

 Son capital est de 25.000,- EUR
 La Fondation a pour objet (extrait des statuts du 23 décembre 2005): 
«. . . 
a) Die umfassende Versorgung aller in Luxemburg wie im Ausland lebenden Schwestern, die der Kongregation

«Schwestern Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel» mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 32, rue Sainte Zithe, (nachfolgend
«die Kongregation» genannt) angehören.

 Hierzu gehört die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Lebensraumes, Aus- und Weiterbildung, Behandlung und

Verpflegung in Krankheit und Alter sowie die Voraussetzungen für ein religiöses Leben in Gemeinschaft gemäß den Sat-
zungen der Kongregation.

 b) Die Förderung der Krankenhaus-, Alten- und Betreuungseinrichtungen, die im Sinne der Gründer der Kongrega-

tion fortzuführen sind.

 In Afrika, insbesondere in Malawi, gehört neben der Gesundheitsversorgung umfassende Entwicklungsarbeit zu den

Aufgaben der Kongregation. Hierzu sind Maßnahmen gegen Hunger und Unterernährung sowie Bildungsarbeit und Ge-
sundheitsvorsorge zu rechnen.

 Die Stiftung soll unbeschadet ihrer Aktivitäten im Ausland dauerhaft karitative Aufgaben in Luxemburg wahrnehmen.
 c) Die Förderung eines religiösen, kulturellen und sozialen Rahmens für alte, verlassene oder notleidende Personen.
d) Die Unterstützung aller Projekte oder Initiativen, die diesen Tätigkeitsbereichen entsprechen.

...»

2. Situation au 31 décembre 2005
 Avec un total bilantaire de 2.155.788,17 EUR, la Fondation génère un bénéfice de l’exercice de 778.867,97 EUR 
 Les comptes annuels ont été préparés en accord avec les principes comptables généralement admis au Luxembourg. 
 Aucune opération particulière n’est à signaler pour l’année 2005.
 Les produits d’exploitation se composent principalement de dons de toutes natures reçus par la Fondation.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05128. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(020083//162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

S.G. CARS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8088 Bertrange, 1, Domaines Ormilles.

R. C. Luxembourg B 43.741. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03127, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008911.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

10. Charges exceptionnelles
11. Impôts sur le résultat 
12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus
13. Résultat de l’exercice (bénéfice de l’exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778.867,97

294.148,91

Total des Charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998.881,36

493.659,36

B. Produits

1. Montant net du chiffre d’affaires
2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication
3. Travaux effectués par l’entreprise pour elle-même et portés à l’actif
4. Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958.371,39

461.147,79

5. Produits de participations

a)  Provenant d’entreprises liées
b) Autres produits de participations

6. Produits d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé
7. Autres intérêts et produits assimilés

a)  Provenant d’entreprises liées
b) Autres produits et produits assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.509,97

32.511,57

 9. Produits exceptionnels
10. Résultat de l’exercice (perte de l’exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total des Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998.881,36

493.659,36

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Signature.

50352

LINFORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 106.300. 

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de transfert de parts du 28 février 2006 que la société WORLDGATE HOLDINGS LIMITED

(société enregistrée à Cyprus sous le numéro HE 156853), ayant son siège social au 38 Regeanas Street, Nicosia,
CY-1010 Cyprus, a cédé 100 parts sociales de la Société LINFORD, S.à r.l. à la société VALFIN NOMINEES LIMITED
(société enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 3565022), ayant son siège social à BKB, York House, Empire way,
Wembley, Middlesex, HA9 0QL, United Kingdom.

Suite à ce transfert, les parts sociales de la Société LINFORD, S.à r.l. sont réparties comme suit: 
WORLDGATE HOLDINGS LIMITED ne détient désormais plus aucune part; VALFM NOMINEES LIMITED détient

100 parts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021635//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

ALOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 632.125,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.414. 

Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été

transféré du 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1

er

 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 23 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06004. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021638/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

APAX KNOWLEDGE SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.437.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.374. 

Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été

transféré du 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1

er

 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 23 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021652/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
BELVAUX NOMINEES LIMITED
Signature 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

S.à r.l. Wilmes &amp; Söhne

Finorsi S.A.

Auto-Secours Luxembourg S.A.

Oriante S.A.

Hansecapital A.G.

R-Luxinvest S.A.

R-Luxinvest S.A.

OneSource Finance S.A.

Tenderness S.A.

Agility Honn Eechternoach

Menuiserie-Toiture-2000 S.A.

Kitchens (Luxembourg) S.A.

Cypres S.A.

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme

Financière de Wiltz

Temenos Luxembourg S.A.

Energex Engineering S.A.

Diamanten Holding, S.à r.l.

United Fund Management S.A.

Dieleman Art et Bronze International, S.à r.l.

Lux Hygiène Service S.A..

Superspatz, S.à r.l.

Superspatz

Serene Investment S.A.

C.T.A.M. S.A., Carlo Tassara Assets Management

Transco S.A.

Vienna II, S.à r.l.

Vienna II, S.à r.l.

Euro Lepont S.A.

LTD, S.à r.l.

Morave Holding S.A.

CR Firenze Gestion Internationale S.A.

Vienna III, S.à r.l.

Vienna I, S.à r.l.

Merzario International S.A.

J.J. TL, S.à r.l.

Nartal S.A.

Coin S.A.

Valmer S.A.

Maat S.A.

Coin International, S.à r.l.

J.L. Management S.A.

Group 4 Falck - Société de Surveillance et de Sécurité

Remafin Invest S.A.

BRE/Osnabrück I Hotel, S.à r.l.

Group 4 Falck Technologies Luxembourg

Bessel Re, S.à r.l.

G4 Services

F.R. Sunrise Holding S.A.

Cerfin S.A.

Fourb International S.A.

Golf Service S.A.

Vienna I, S.à r.l.

Pearson Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Pearson Luxembourg Holdings, S.à r.l.

The 21st Century Advisory S.A.

Moonraker S.A.

BRE/Mannheim I Hotel, S.à r.l.

Helux Holding S.A.

Unicorn Management (Luxembourg) S.A.

Unicorn Management (Luxembourg) S.A.

Fondation Ste Zithe

S.G. Cars

Linford, S.à r.l.

Alov, S.à r.l.

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l.