This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
49729
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1037
27 mai 2006
S O M M A I R E
SHORENDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.064.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00780, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022479/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
APN Property Holdings (No. 5), S.à r.l., Luxem-
H. D. Construct, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . .
49767
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49758
Hellas Participations (Luxembourg) S.A., Luxem-
APN Property Holdings (No. 5), S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49772
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49759
Hellas Participations (Luxembourg) S.A., Luxem-
C.F.I.M. Compagnie Financière d’Investissements
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49774
Mobiliers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49776
IPC International Project Cooperation S.A., Luxem-
CanGro Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
49761
burg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49767
CanGro Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
49763
Logic Park Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49774
Castor International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
49760
Luxembourg Placement Fund Management Com-
DAB Investments Luxembourg SNC, Luxem-
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49775
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49776
Luxicav, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49775
Demar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49776
Mercante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49764
Editions Culturelles et Professionnelles S.A., Stein-
Nightwatch Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
49766
fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49730
Orange Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
49753
Ehinger & Armand von Ernst Fund Management
Pollux Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
49730
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49775
Shorender S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49729
Ereme S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49760
Solar Screen International S.A., Mamer . . . . . . . .
49774
Fiduciaire Billon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49759
SPE Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49752
Gentiane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49774
Trial Trois, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
49760
Green Alpha, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
49730
Trial Trois, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
49761
Green Alpha, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
49732
UBS (Lux) Structured Sicav 2, Luxembourg . . . . .
49764
Green Alpha, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
49752
UBS (Lux) Structured Sicav 2, Luxembourg . . . . .
49764
GUS Luxembourg 2005, S.à r.l., Luxembourg . . . .
49765
UBS (Lux) Structured Sicav, Luxembourg . . . . . .
49763
GUS Luxembourg 2005, S.à r.l., Luxembourg . . . .
49766
UBS (Lux) Structured Sicav, Luxembourg . . . . . .
49763
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
49730
EDITIONS CULTURELLES ET PROFESSIONNELLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 92.081.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01697, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2006.
(024197//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
POLLUX PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.252.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 7 février 2006i>
L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnel-
lement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la société pour une durée illimitée
avec effet immédiat.
2. Nomination de Mademoiselle Carole Caspari, née le 25 octobre 1970 à Wermelskirchen (Allemagne), résidant
professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une
durée illimitée avec effet immédiat.
3. Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05356. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021354/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
GREEN ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 2,000,000.-.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.244.
—
In the year two thousand and five, on the thirteenth day of the month of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the associates of GREEN ALPHA, S.à r.l., (the «Company»), a société
à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on 13th
July 2005 by deed of the notary Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions. The articles of incorporation of the Company were last amended on 12 September 2005.
The meeting was presided by M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Cintia Martins, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer Céline
Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all eighty thousand shares (80,000) shares in issue in the Company were
represented at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of
the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items of the agenda.
2. That the agenda of the meeting was as follows:
- Contribution in kind and in cash to the freely distributable share premium of the Company by GREEN MANAGE-
MENTBETEILIGUNGS, GmbH & Co. KG, an existing shareholder of the Company (without increase of the issued share
capital) of a claim of EUR 4,669,000.- due to GREEN MANAGEMENTBETEILIGUNGS, GmbH & Co. KG by GANYMED
347. V V, Gmbh (the «Kind Contribution») and a contribution in cash of EUR 696,000.-, approval of the valuation of
EUR 4,669,000.- of the Kind Contribution
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Pour extrait
Signature
49731
After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:
<i>Sole resolutioni>
The meeting of the Company unanimously resolved to accept the contribution in kind and in cash to the freely dis-
tributable share premium of the Company (without increase of the issued share capital) by GREEN MANAGEMENT-
BETEILIGUNGS, Gmbh & Co. KG of a claim of EUR 4,669,000.- due by GANYMED 347. V V, Gmbh to GREEN
MANAGEMENTBETEILIGUNGS, GmbH & Co. KG, (the «Kind Contribution») and an amount of EUR 696,000.- in cash.
Evidence of the Kind Contribution and of the contribution in cash has been shown to the undersigned notary.
The meeting then noted that the above Kind Contribution has been the subject of a report of the board of managers
of the Company dated 13th September 2005.
The conclusion of such report reads as follows:
«In view of the above the Board of Managers believes that the value of the contribution in kind being a non interest
bearing claim against GANYMED 347. V.V., Gmbh amounts to EUR 4,669,000.-.»
Pursuant to the above, the meeting unanimously resolved to value the total contribution (cash and kind) at five million
three hundred sixty five thousand Euro (EUR 5,365,000.-) to be allocated to the share premium of the Company.
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at fifty-eight thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le 13
ème
jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de GREEN ALPHA, S.à r.l., (la «Société»), une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 13 juillet 2005
par acte du notaire Joseph Elvinger, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts
de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 12 septembre 2005.
L’assemblée a été présidée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Il fut nommé comme secrétaire M
e
Cintia Martins, maître en droit, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur
M
e
Céline Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont repris dans une liste de pré-
sence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera
annexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.
Il appert de ladite liste de présence, que les quatre-vingt mille (80.000) parts sociales en émission dans la Société
étaient représentées à l’assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir été préalablement informés
de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les
points portés à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
- Apport en nature et en espèce à la prime d’émission librement distribuable de la Société par GREEN MANAGE-
MENTBETEILIGUNGS, Gmbh & Co. KG, un associé actuel de la Société (sans augmentation du capital social émis) d’une
créance d’un montant de EUR 4.669.000,- due à GREEN MANAGEMENTBETEILIGUNGS, Gmbh & Co. KG par
GANYMED 347. V V, GmbH (l’«Apport en Nature») et un apport en espèce d’un montant de EUR 696.000,-, approba-
tion de l’évaluation de l’Apport en Nature à un montant de EUR 4.669.000,-.
Après délibération, l’assemblée a décidé à l’unanimité ce qui suit:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée de la Société a décidé à l’unanimité d’accepter l’apport en nature et en espèce à la prime d’émission
librement distribuable de la Société (sans augmentation du capital social émis) par GREEN MANAGEMENTBETEILI-
GUNGS, GmbH & Co. KG d’une créance d’un montant de EUR 4.669.000,- due par GANYMED 347. V V, Gmbh à
GREEN MANAGEMENTBETEILIGUNGS, GmbH & Co. KG, (l’«Apport en Nature») ainsi que d’un montant de EUR
696.000,- en espèces.
Preuve de l’Apport en Nature ci-dessus et de l’apport en espèces a été apportée au notaire soussigné.
L’assemblée a ensuite noté que l’Apport en Nature a fait l’objet d’un rapport du conseil de gérance de la Société daté
du 13 septembre 2005.
Le rapport contient la conclusion suivante:
«Sur base de ce qui précède, le Conseil de Gérance estime que la valeur de l’apport en nature à savoir une créance
sans intérêts sur GANYMED 347. V. V., GmbH s’élève à EUR 4.669.000,-.»
Conformément à ce qui précède, l’assemblée a décidé à l’unanimité d’évaluer l’apport total (en espèces et en nature)
à affecter à la prime d’émission de la Société à un montant de cinq millions trois cent soixante-cinq mille euros (EUR
5.365.000,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
49732
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son aug-
mentation du capital social et sont estimés à cinquante-huit mille euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des parties comparan-
tes, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, qu’à la demande des mêmes parties com-
parantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise faisant foi.
Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, C. Martins, C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 150S, fol. 7, case 8. – Reçu 53.650 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040265/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.
GREEN ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.244.
—
In the year two thousand and five, on the twelfth day of the month of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the associates of GREEN ALPHA, S.à r.l. (the «Company»), a société
à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on 13th
July 2005 by deed of the notary Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
The meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Me Cintia Martins, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer Me
Céline Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all five hundred (500) shares in issue in the Company were represented at
the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that
the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items of the agenda.
2. That the agenda of the meeting was as follows:
(A) Amendment and restatement of the issued share capital of the Company by:
1. the creation of nine (9) classes of shares namely Class A1, Class A2, Class A3, Class B1, Class B2, Class B3 and
Class C1, Class C2 and Class C3 with such rights and obligations as set out in the amended articles of incorporation of
the Company pursuant to item C of the agenda;
2. the re-classification the 500 existing issued shares in the Company into 500 Class A1 Shares;
3. the increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to
two million Euro (EUR 2,000,000) by
(a) the issue of
(i) a total of 19,500 Class A1 shares
(ii) a total of 20,000 Class A2 shares
(iii) a total of 20,000 Class A3 shares
(iv) a total of 4,000 Class B1 shares
(v) a total of 4,000 Class B2 shares
(vi) a total of 4,000 Class B3 shares
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each and for a total aggregate subscription price (nominal and
premium) for the new Class A1, A2, A3, and B1, B2 and B3 Shares of fifty three million nine hundred and eighty seven
thousand and five hundred Euro (EUR 53,987,500)
(b) the issue of
(i) a total of 2,667 Class C1 shares
(ii) a total of 2,667 Class C2 shares, and
(iii) a total of 2,666 Class C3 shares
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each and a subscription price at nominal of twenty-five Euro (EUR
25) each being a total aggregate subscription price for the new class C1, C2 and C3 Shares of two hundred thousand
Euro (EUR 200,000);
(c) subscription to the new shares by the subscribers set out hereafter and payment of the aggregate total subscrip-
tion price thereof by way of contribution in cash of a total amount of fifty four million one hundred and eighty seven
thousand and five hundred Euro (EUR 54,187,500), allocation of an amount of one million and nine hundred and eighty
seven thousand five hundred Euro (EUR 1,987,500) to the issued share capital account, of an amount of two hundred
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
J. Elvinger.
49733
thousand Euro (EUR 200,000) to the legal reserve (being 10% of the issued share capital) and the balance of fifty two
million Euro (EUR 52,000,000) to the freely distributable share premium account, consequential amendment of article
5 of the articles of incorporation and waiver (to the extent required) of existing pre-emption subscription rights of ex-
isting shareholders (the proxyholder being expressly authorised to agree to any amendment or changes to in particular
any of the figures or amounts herein contained).
(B) Amendment of the year end of the Company so as to provide for a first financial year from the date of incorpo-
ration to 30th April 2006 and thereafter each year from the 1st day of the month of May to the last day of the month
of April of the following year and consequential amendment of the articles.
(C) Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company substantially in the form as attached
to the proxies, the proxyholder being however expressly authorised and empowered to make, and agree to, such chang-
es and amendments as deemed appropriate.
(D) Determination of the number of Board Members at five (5) members, confirmation of the mandate of the existing
board members for an undetermined period and qualification thereof as Class A Board Member and election of Mrs
Ingrid Moinet, residing in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg born on 5th December 1975, in Bastogne, Belgium
as Class A Board Member and of Mr Desmond Mitchell, chartered accountant, residing in 123 Buckingham Palace Road,
London SW1W 9SL, United Kingdom, born on 24th August 1957 in Wells, United Kingdom as Class B Board Member,
each for an undetermined period so that the Board shall be composed as follows:
(i) Yann Duchesne, A Board Member
(ii) Julian Huxtable, A Board Member
(iii) Gerard Becquer, A Board Member
(iv) Ingrid Moinet, A Board Member and
(v) Desmond Mitchell B Board Member
After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
The meeting unanimously resolved to amend and restate of the issued share capital of the Company by the creation
of nine (9) classes of shares namely Class A1, Class A2, Class A3, Class B1, Class B2, Class B3 and Class C1, Class C2
Subscriber
Class
Number
of shares
Doughty Hanson & Co IV Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
5,640
Doughty Hanson & Co IV Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
6,080
Doughty Hanson & Co IV Nominees Three Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
1,464
Doughty Hanson & Co IV Nominees Four Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
5,250
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
1,066
Total Class A1 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,500
Advent Green (Cayman) Limited, with registered office at c/o M&C Corporate Services Limited,
PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
B1
4,000
Total Class B 1 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,000
Green Managementbeteiligungs, GmbH & Co. KG with registered office at Kurt-Schumacher
Strasse 18-20, 53113 Bonn, Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C1
2,467
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C1
200
Total Class C1 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,667
Doughty Hanson & Co IV Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
5,783
Doughty Hanson & Co IV Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
6,237
Doughty Hanson & Co IV Nominees Three Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
1,502
Doughty Hanson & Co IV Nominees Four Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
5,385
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
1,093
Total Class A 2 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000
Advent Green (Cayman) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2
4,000
Total Class B 2 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,000
Green Managementbeteiligungs, GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C2
2,467
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C2
200
Total Class C2 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,667
Doughty Hanson & Co IV Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
5,783
Doughty Hanson & Co IV Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
6,236
Doughty Hanson & Co IV Nominees Three Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
1,502
Doughty Hanson & Co IV Nominees Four Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
5,386
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
1,093
Total Class A 3 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000
Advent Green (Cayman) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B3
4,000
Total Class B 3 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,000
Green Managementbeteiligungs, GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C3
2,466
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C3
200
Total Class C3 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,666
49734
and Class C3 with such rights and obligations as set out in the amended articles of incorporation of the Company pur-
suant to item C of the agenda.
The meeting then resolved to re-classify the 500 existing issued shares in the Company into 500 Class A1 Shares.
The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500) to two million Euro (EUR 2,000,000) by (a) the issue of a total of 19,500 Class A1 shares, a total of 20,000
Class A2 shares, a total of 20,000 Class A3 shares, a total of 4,000 Class B1 shares, a total of 4,000 Class B2 shares, a
total of 4,000 Class B3 shares, with a nominal value of twenty-five Euro (25) each and for a total aggregate subscription
price (nominal and premium) for the new Class A1, A2, A3, and B1, B2 and B3 Shares of fifty three million nine hundred
and eighty seven thousand and five hundred Euro (EUR 53,987,500) and (b) the issue of a total of 2,667 Class C1 shares,
a total of 2,667 Class C2 shares, and a total of 2,666 Class C3 shares with a nominal value of twenty-five Euro (25) each
and a subscription price at nominal of twenty-five Euro (EUR 25) each being a total aggregate subscription price for the
new class C1, C2 and C3 Shares of two hundred thousand Euro (EUR 200,000) to the subscribers as set out in the
agenda to the meeting (waiving any preferential subscription rights as appropriate (if any)).
Thereupon the subscribers (as set out in the agenda) represented by proxies, which proxies shall be registered to-
gether with the present deed, subscribed to the new shares as set in the agenda to the meeting against the total payment
of the aggregate total subscription price by way of contribution in cash of a total amount of fifty four million one hundred
and eighty seven thousand and five hundred Euro (EUR 54,187,500).
Evidence of the contribution in cash of a total amount of fifty four million one hundred and eighty seven thousand
and five hundred Euro (EUR 54,187,500) has been shown to the undersigned notary.
The meeting thereupon resolved to allocate the total amount so received as set out in the agenda of the meeting and
to amend article 5 of the articles of incorporation as set out in the restated articles hereafter.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to amend the year end of the Company so as to provide for a first financial year from the date
of incorporation to 30th April 2006 and thereafter each year from the 1st day of the month of May to the last day of
the month of April of the following year and to consequentially amend the articles of the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to completely amend and restate the articles of incorporation of the Company as set out here-
after taking into account the resolutions above and making such further amendments to have the articles of the Com-
pany read as follows:
Amended and restated Articles of Incorporation
Art. 1. Denomination. Between the initial subscribers and those who become holders of the Shares (parts so-
ciales) thereafter, a limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name GREEN ALPHA, S.à r.l. (the
«Company») is constituted and existing, governed by these Articles of Incorporation and the relevant legislation.
Art. 2. Object, purpose. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, preferred equity cer-
tificates and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its port-
folio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg
or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures as
well as any other securities.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs (including shareholders or affiliates), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company does not come to an end by
the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any Shareholder.
Art. 4. Registered office
4.1. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary General
Meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.
4.2. The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Man-
agers.
4.3. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
4.4. In the event that the Board of Managers, should determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any inter-
ested parties by the Board of Managers.
49735
Art. 5. Share Capital
5.1. The issued share capital of the Company is set at two million Euro (EUR 2,000,000) divided into twenty thousand
(20,000) Class A 1 Shares, twenty thousand (20,000) Class A 2 Shares and twenty thousand (20,000) Class A 3 Shares
(Class A1, Class A2 and Class A 3 being each a separate class of Shares but together referred to as «Class A»), four
thousand (4,000) Class B 1 Shares, four thousand (4,000) Class B 2 Shares and four thousand (4,000)Class B3 Shares
(Class B1, Class B2 and Class B3 being each a separate class of Shares but together referred to as «Class B») and two
thousand six hundred and sixty seven (2,667) Class C1 Shares, two thousand six hundred and sixty seven (2,667) Class
C2 Shares and two thousand six hundred and sixty six (2,666) Class C3 Shares (Class C1, Class C2 and Class C3 being
each a separate class of Shares but together referred to as «Class C»), each Share with a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.
5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles of Incorporation subject to the provisions set out in article 6 and
article 7 respectively.
Art. 6. Pre-emptive rights
6.1. If Shares or rights to acquire, or securities convertible or exchangeable for Shares (the «Rights») of the Company
are proposed to be issued for cash (other than in connection with or in preparation for an Initial Public Offering), then
the Shareholders shall, subject as set out hereunder, have the pre-emptive right (the «Pre-emptive Right») to subscribe
in cash on the proposed terms for their Pre-emptive Right Pro Rata Share of such Shares or as the case may be Rights.
The «Pre-emptive Right Pro Rata Share» of a Shareholder shall be, at any given time, (i) such aggregate nominal amount
of Shares (or as the case may be Rights) proposed to be issued for cash multiplied by (ii) a quotient, the numerator of
which is the total nominal amount of Shares of such Shareholder and the denominator of which is the total nominal
amount of Shares issued and outstanding before giving effect to the new issuance, rounded down (such rounding down
in relation to the entitlement of a Class A Shareholder to be applied in relation to the aggregate number of Shares to
which all the Class A Shareholders are entitled, the Class A Shareholders being responsible for agreeing the split of that
number between themselves) to the nearest whole number dividable by the nominal value of the Shares (as if any Rights
had been exercised) and any Shares or Rights proposed to be issued that remain after such rounding down shall not be
issued.
6.2 If the Company proposes to issue debt instrument or certificates or take a shareholder loan (the «Company In-
struments») either together with Shares or Rights, the Pre-emptive Right of each Shareholder (to such Shares or Rights,
if any) is subject to such Shareholder subscribing to (or granting) such Company Instruments on a equal basis.
6.3. In the event of a proposed issue of Shares (or as the case may be Rights) for that Pre-emptive Right arises under
this article 6, the Company shall give the Shareholders written notice to their addresses inscribed in the Register of
Shareholders (the «Pre-emptive Notice») of its intention to issue Shares (or as the case may be Rights) and Instruments
(if any) for cash, the price, the identity of the proposed subscriber(s) or offerees, the principal terms upon which it pro-
poses to issue the same. The Shareholders shall have 10 (ten) Business Days from the delivery date of any Pre-emptive
Notice to agree to subscribe for Shares (or as the case may be Rights) and Company Instruments up to their Pre-
emptive Right Pro Rata Share (in each case calculated prior to the issuance) for the price and upon the terms specified
in the Pre-emptive Notice by giving written notice to the Company stating therein the number of Shares (or as the case
may be Rights) and Instruments (if any) to be subscribed. Any Shareholder having not favourably responded in writing
to the Company within such ten (10) Business Days period shall be deemed to have declined to exercise his Pre-emptive
Right and to have waived any rights thereunder.
6.4. If, on any issue of Shares (or as the case may be Rights) to which the Pre-emptive Rights under article 6.1 apply,
those Pre-emptive Rights are not exercised in respect of all Shares (or as the case may be Rights) proposed to be issued,
the Shares (or as the case may be Rights) not taken up shall be offered again to those Shareholders who have exercised
their Pre-emptive Rights («Accepting Shareholders») pursuant to the procedure set out in article 6.3, and, if there is
more than one Accepting Shareholder, in such proportion as the respective Pre-emptive Right Pro Rata Shares of the
Accepting Shareholders bear to each other. This process shall be repeated in one or more further rounds amongst those
Persons who are, in respect of the last round, Accepting Shareholders until either all Shares (or as the case may be
Rights) proposed to be issued have been subscribed for or none of the Accepting Shareholders in the last round wishes
to subscribe for further Shares (or as the case may be Rights).
6.5. Any Shares issued upon exercise of the Pre-emptive Right of a Shareholder pursuant to this article 6, shall be
issued to the relevant Shareholder in the Class A, Class B or Class C of Shares (respectively) in which such Shareholder
holds Shares in the Company and any Rights so issued shall give right to acquire or be convertible or exchangeable into
Shares of the Class A, Class B or Class C of Shares (respectively) already held by such Shareholder.
6.6.The Pre-emptive Rights set out in this article 6 may be waived by the Shareholders entitled thereto in writing at
any time.
Art. 7. Reduction of share capital
7.1.The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation
of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such
Class(es).
7.2. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Classes
of Shares, the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class(es) of Shares shall receive from the Company
an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined herebelow) for each Share of the relevant Class(es)
held by them and cancelled.
7.3. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount (as defined below)
by the number of Shares in issue in the Class(es) of Shares to be repurchased and cancelled.
49736
7.4. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the
General Meeting on the basis of interim accounts of the Company (the «Interim Accounts») as of a date no earlier than
eight (8) days before the date of the relevant repurchase, the reduction of the share capital and the cancellation of the
shares of the relevant Class(es) pursuant to the below:
7.5. The Total Cancellation Amount for Classes A1, A2 and A3 and Classes B1, B2 and B3 and Classes C1, C2 and
C3 shall be the Available Amount unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner pro-
vided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than the Available Amount.
7.6. The Total Cancellation Amount for each of the Classes of Shares repurchased and the Cancellation Value per
Share shall be determined for the period starting on the day of incorporation of the Company or on the day after the
date of the latest Interim Accounts required under article 7.4 (respectively) and ending on the date of the Interim Ac-
counts required under article 7.4. for the relevant determination.
7.7. The «Available Amount» is constituted of the total amount of net profits of the Company (including carried for-
ward profits but (i) less the result, if positive, of any losses (including carried forward losses) expressed as a positive
minus any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) less any sums to be placed
into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles) as set out in the Interim Accounts referred to
in article 7.4.
7.8. Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class(es), the Cancellation Value Per Share
will become due and payable by the Company.
Art. 8. Board of Managers
8.1. The Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers») appointed as a collegiate body by
the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The members of the Board
of Managers (each a «Board Member») need not be Shareholders. The Board of Managers shall be composed of the
number of members determined by the General Meeting of Shareholders by a resolution of Shareholders (save for the
period between one or more resignations and new appointments thereupon) pursuant to the provisions of articles 8.3.
and in accordance with the provisions of article 17.4.(i) and duly recorded in the minutes of such Meeting elected pur-
suant to the provisions of this article 8.
8.2. The Board Members are appointed and removed from office by a simple majority decision of the General Meeting
of Shareholders pursuant to article 17.4(i) which determines their powers and the term of their mandates. If no term
is indicated the Managers are appointed for an undetermined period. The Managers may be re-elected but also their
appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
8.3. The Board of Managers shall always be composed so that:
8.3.1. up to four (4) Board Members shall be appointed by the General Meeting of Shareholders from a list of candi-
dates proposed by the Class A Shareholders representing a simple majority of the Class A Shares (such Board Members
referred to as «Class A Board Members») and,
8.3.2. for as long as (i) the Class B Shares represent more than 10% of the issued share capital of the Company and
(ii) such Class B Shares representing 10% of the issued share capital are owned by the Advent Entities (or their Affiliates),
one (1) Board Member shall be appointed by the General Meeting of Shareholders from a list of candidates proposed
by the Class B Shareholders representing a simple majority of the Class B Shares (such Board Member referred to as
«Class B Board Member»).
8.4. The Class A Shareholders and the Class B Shareholders (to the extent the rights set out in article 8.3.2 apply)
representing the simple majority of Shares of the Class concerned waive (with respect to Class A, in part or in full), for
such period of time as the relevant Class may determine, the right of the relevant Class to propose candidates for Board
elections as provided for herein. In the event the Class A Shareholders and Class B Shareholders (to the extent the
rights set out in article 8.3.2 apply) representing the simple majority of Shares of the Class concerned decide to termi-
nate such waiver and notify the Company thereof in writing, the Company shall within one (1) month of receipt of such
notice proceed to convening of a General Meeting of Shareholders for the election of Board Members as appropriate.
In the event the Class B Shareholders do not provide for a list of candidates as provided for in article 8.3. within 10 days
after having been requested to do so by the Company, they shall be deemed to have waived the right to nominate can-
didates. In the event of any such waiver (whether express or deemed) the General Meeting of Shareholders may deter-
mine the number of the Board Members accordingly or freely choose such Board Members.
8.5. The Board of Managers shall appoint a chairman of the Board among the A Board Members.
Art. 9. Board Proceedings
9.1.The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Board Members is present or
represented at a meeting.
9.2. Meetings of the Board of Managers shall be called by the chairman of the Board of Managers or any two Board
Members with at least seven (7) days prior notice, unless corporate affairs require a shorter notice period or for urgency
(down to 12 hours). The convening notice may be waived by the unanimous consent given in writing or by fax, cable,
telegram, email or telex of all Managers. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
9.3. Meetings of the Board of Managers may be held physically or, in all circumstances, by way of conference call (or
similar means of communication which permit the participants to communicate with each other). The Board of Manag-
ers may further in all circumstances take decisions by way of unanimous written resolutions. Resolutions in writing ap-
proved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at a Board of Managers’ meeting. In
such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by mail, courier, electronic mail or telefax.
49737
9.4. Any Board Member may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call or by other sim-
ilar means of communication allowing all Board Members taking part in the meeting to hear one another. The partici-
pation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any Board Member may
act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
Board Member as his proxy. A Board Member may represent more than one of his colleagues.
9.5. Decisions of the Board of Managers shall be taken by the favourable votes of the majority of the Board Members
present or represented at the relevant meeting.
9.6. The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman of the Board, the chairman
of the relevant meeting provided it is a Class A Board Member or by any two Board Members at least one of which
always needs to be an A Board Member. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the Board or two Board Members at least one of which needs
to be always an A Board Member.
Art. 10. Board Powers, Binding Signatures
10.1.The Board of Managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to au-
thorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers
not expressly reserved by the law or by the Articles of Incorporation to the General Meeting shall be within the com-
petence of the Board of Managers. Vis-à-vis third parties the Board of Manager has the most extensive powers to act
on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company not reserved by law or the Articles of Incorporation to the General Meeting or as may be provided herein.
10.2. The Company will be bound by the signature of any two Board Members one of which at least must always be
an A Board Member of the Company or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory
power shall have been delegated by the Board of Managers or by any two Board Members (including by way of repre-
sentation) at least one of which needs to be always an A Board Member.
Art. 11. Board Indemnification
11.1.The Board Members are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-
pany, they are responsible for the performance of their duties.
11.2. Subject to the exceptions and limitations listed in article 11.3. below, every person who is, or has been, a Board
Member or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against
liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or pro-
ceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Board Member
or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words «claim», «action», «suit»
or «proceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals)
actual or threatened and the words «liability» and «expenses» shall include without limitation attorneys’ fees, costs,
judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.
11.3. No indemnification shall be provided to any Board Member or officer:
11.3.1. Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross neg-
ligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
11.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not
in the interest of the Company; or
11.3.3. In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or
by the Board of Managers.
11.4. The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any
Board Member or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such
Board Member or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person.
Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and
officers, may be entitled by contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon re-
ceipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 12. Conflicts. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or entity
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Board Members or of–ficers of the Company is
interested in or is a manager, director, officer or employee of such other corporation or entity. Any Board Member or
officer of the Company who serves as manager, director, officer or employee of any corpora–tion or entity with which
the Company shall contract or otherwise engage in business shall not solely by reason of such affiliation with such other
corporation or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such con-
tract or other business.
Art. 13.Transfer of Shares
13.1. Except as provided for by mandatory provisions of law, any Transfer restrictions set out in the present Articles
may be waived by Shareholders representing at least 75% of the Shares issued in the Company.
13.2. Except as otherwise specifically set out in these Articles of Incorporation, any Transfers of Shares (or Rights)
(between Shareholders or to Persons other than the Shareholders (the 'non-Shareholders')) shall always be subject to,
and will be effective and recognised by the Company only if realised in compliance with, the provisions set out in these
Articles of Incorporation. Any recognition or inscription of a Transfer of Shares will be subject to compliance with the
provisions set out in the present Articles of Incorporation.
49738
13.3. Transfers of Shares (or Rights) shall be subject to the approval of Shareholders representing at least 75% (three-
quarters) of the share capital of the Company.
13.4. Unless Majority Class A Consent has been received no Transfer of Shares to any Person may be made by any
Shareholder (the «Transferor») unless at the same time the same proportion of the Transferor’s Company Instruments
(and Rights) (if any) of the Company Instruments (and Rights) held by it as the Shares to be Transferred bears to the
total of the Shares held by it immediately prior to such Transfer (in each case calculated by reference to nominal value)
are Transferred to the same Person.
13.5. Any Transfer of Shares or Company Instrument (or Rights) (if any) shall in addition as otherwise set out in the
present Articles of Incorporation and in particular articles 14 and 15, be subject to the Transferee in each case, in the
event a shareholder or like agreement (if any) exists at that time between all or part of the Shareholders and the Com-
pany, becoming a party to such agreement.
Art. 14. Tag Along
14.1. With respect to any proposed Transfer of all or part of their Shares and Company Instruments (and Rights) if
any) by the Class A Shareholders or the Class B Shareholders (and subject to articles 15 and 16), to a Tag Third Party
(a «Proposed Tag-Along Transfer») (a «Selling Shareholder»), each other Shareholder who exercises its right under ar-
ticle 14 (a «Tagging Shareholder») shall have the right to require the proposed Transferee (a «Proposed Transferee»)
to acquire from the Tagging Shareholder Shares in an aggregate nominal amount equal to (rounded to the nearest whole
number permitted by law as a minimum nominal amount of a Share):
where:
«A» is the aggregate nominal amount of Shares proposed to be directly or indirectly transferred to the Proposed
Transferee in the Proposed Tag-Along Transfer (such Shares the «Sale Shares»),
«B» is the aggregate nominal amount of all Shares then in issue, subject to such adjustment as the Board may resolve
is appropriate, and
«C» is the aggregate nominal amount of Shares owned by the Tagging Shareholder;
at the same price per Share and at the same price per Company Instrument (and Rights) if any) (based each time on
its nominal amount) and upon the same terms and conditions (including, without limitation, time of payment and form
of consideration) as to be paid and given to the Selling Shareholder provided that such price is agreed with a bona fide
third party purchaser on commercial arms’ length basis between the Selling Shareholder and the Proposed Transferee.
In order to be entitled to exercise its right to Transfer Shares and Company Instrument (and Rights) (if any) to the
Proposed Transferee pursuant to this Article the Tagging Shareholder is expected (subject to any constraints in their
constitutional documents) to make or give to the Proposed Transferee the same representations, warranties, covenants
and indemnities as the Selling Shareholder agrees to make in connection with the Proposed Tag-Along Transfer (other
than non-compete covenants). The Tagging Shareholder will be responsible for its proportionate share of the costs of
the Proposed Tag-Along Transfer to the extent not paid or reimbursed by the Proposed Transferee or the Company.
14.2. The Selling Shareholder shall give written notice to each other Shareholder and the Company of each Proposed
Tag-Along Transfer at least 5 (five) Business Days prior to signing a definitive agreement (which must contain a provision
requiring the acquisition of Shares and Company Instruments (and Rights) (if any) that are subject to any tag-along rights
under this Article that are exercised) relating to the Proposed Tag-Along Transfer providing details of the Proposed
Transferee and proposed amount and form of consideration, other terms and conditions of payment offered by the Pro-
posed Transferee and details of any other material terms including the representations, warranties, covenants and in-
demnities to be made or given. The Selling Shareholder shall then not more than 5 (five) Business Days after the signing
of the definitive agreement relating to the Proposed Tag-Along Transfer, give notice in writing (the 'Initial Tag-Along
Notice') confirming or restating the nominal amount of the Shares and Company Instruments (and Rights) (if any) pro-
posed to be so transferred, the name and address of the Proposed Transferee, the proposed amount and form of con-
sideration, other terms and conditions of payment offered by the Proposed Transferee and the Selling Shareholder will
deliver or cause to be delivered to the other Shareholders copies of all transaction documents relating to the Proposed
Tag-Along Transfer promptly as the same become available. The tag-along rights provided by this Article must be exer-
cised by the Tagging Shareholder within 5 (five) Business Days after its receipt of the Initial Tag-Along Notice from the
Selling Shareholder by means of a written notice to the Selling Shareholder indicating the desire of the Tagging Share-
holder to exercise its rights and specifying the aggregate nominal amount of Shares and Company Instruments (and
Rights) (if any) it desires to sell (a «Tag-Along Notice») up to the maximum calculated under article 14.1. If no Tag-Along
Notice is received by the Selling Shareholder pursuant to this article 14.2, the Selling Shareholder shall, subject to article
13, have the right for a 60 (Sixty) Business Day period from the date of the Initial Tag-Along Notice to sell to the Pro-
posed Transferee up to the total nominal amount of Shares and Company Instruments (and Rights) (if any) proposed to
be directly or indirectly Transferred to the Proposed Transferee on terms and conditions no more favourable in any
respect to the Selling Shareholder than those stated in its notice to the other Shareholders. If a Tag Along Notice(s) is
(are) received by the Selling Shareholder it may only Transfer, subject to the provisions of the present Articles, the
amount of Shares and Company Instruments (and Rights) (if any) set out in the Initial Tag-Along Notice less the amount
of Shares and Company Instruments (and Rights) (if any) set out in the Tag Along Notice(s) and the Proposed Transferee
shall acquire the Shares and Company Instruments (Rights) (if any) from the Tagging Shareholder(s) set out in the Tag-
Along Notice(s).
A
-- xC
B
49739
Art. 15. Drag Along
15.1. In the event that the Class A Shareholders wish to Transfer to a bona fide Third Party purchaser other than a
Permitted Transferee (a «Proposed Drag-Along Transfer») all or part of their Shares and Company Instruments (and
Rights) (if any), then upon the request of the Class A Shareholders and provided they shall have given notice as required
under article 15.2, each other Shareholder (a «Dragged Shareholder») will transfer (and hereby grants a call option to
the Class A Shareholders in respect thereto) to such Proposed Transferee such part of its Shares and Company Instru-
ments (and Rights) (if any) as equals the maximum amount of Shares and Company Instruments (and Rights) (if any) that
it would be permitted to Transfer were it exercising a tag-along right pursuant to article 14 at the same price per Share
and at the same price per Company Instruments (and Rights) (if any)) (in relation each time to its nominal amount and
upon the same terms and conditions (including, without limitation, time of payment and form of consideration) as to be
paid and given to the Class A Shareholders. The Dragged Shareholders will each be responsible for their proportionate
share of the costs of the Proposed Drag-Along Transfer to the extent not paid or reimbursed by the Proposed Trans-
feree or the Company.
15.2. The Class A Shareholders will give notice to the Dragged Shareholders of each Proposed Drag-Along Transfer
as soon as practicable after reaching commercial agreement in respect of any such sale but in any event not less than
ten (10) Business Days prior to signing a definitive agreement (which must contain a provision requiring the acquisition
of Shares and Company Instruments (and Rights) (if any) that are subject to a drag-along under this article 15) for the
consummation of the Proposed Drag-Along Transfer, setting forth the nominal amount of Shares and Company Instru-
ments (and Rights) (if any) proposed to be so transferred, the name and address of the Proposed Transferee, the pro-
posed amount and form of consideration, other terms and conditions of payment offered by the Proposed Transferee
and details of any other terms which the relevant Class A Shareholder deems material including the representations,
warranties, covenants and indemnities to be given. The Class A Shareholders will deliver or cause to be delivered to
Dragged Shareholders copies of all transaction documents relating to the Proposed Drag-Along Transfer promptly as
the same become available.
Art. 16. Priority of Tag and Drag along. If both article 14 and article 15 apply to a single transaction, the drag
along rights set forth in article 15 shall have priority over the tag-along rights set forth in article 14.
Art. 17. Shareholder Decisions
17.1. All Shareholders’ decisions are taken by the General Meeting of Shareholders. However, the holding of a meet-
ing is not compulsory as long as the number of Shareholders is less than twenty-five and in such case Shareholders’ res-
olutions may be validly passed in writing. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company or any valid
written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of Shareholders of the Company.
17.2. Each Shareholder may take part in General Meetings or written resolutions. Each Shareholder has a number of
votes equal to the number of Shares he owns and may validly act at any meeting of Shareholders through a special proxy.
17.3. Meetings shall be called by the Board of Managers by convening notice addressed by registered mail or courier
service to Shareholders to their address appearing in the Register of Shareholders held by the Company at least eight
(8) days prior to the date of the Meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a Meeting the
Meeting may be held without prior notice. In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent
to the Shareholders at their addresses inscribed in the register of Shareholders held by the Company at least 8 days
before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the
majority as set out herein for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the
date set out therein). Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice.
17.4. (i) Save as provided under (ii) and (iii) hereafter, decisions of the General Meeting shall be validly adopted if
approved by Shareholders representing more than half of the total number of Shares then in issue. (ii) Any amendment
of the Articles of Incorporation are taken a favourable decision of (x) a majority of the Shareholders (y) representing at
least three quarters of the total number of Shares then in issue (regardless of Class) and (iii) decisions to change of
nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the Shares in issue.
17.5. In case and for as long as the Company has more than 25 Shareholders, an annual General Meeting shall be held
on 30th May at 11:00 A.M. of each year. If such day is not a Business Day, the Meeting shall be held on the immediately
following Business Day.
Art. 18. Information Shareholders. The financial statements are at the disposal of the Shareholders at the reg-
istered office of the Company. Shareholders shall further be provided such information as provided for by law.
Art. 19. Accounting Year. The accounting year of the Company begins on 1st May of each year and ends on 30th
April of the same year.
Art. 20. Annual Accounts, auditor
20.1. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the Board of Managers.
20.2. The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 Shareholders be subject to the su-
pervision of a statutory auditor (or as the case may be an independent auditor (réviseur d’entreprises). In such case the
auditor shall be elected by the General Meeting of Shareholders. Such auditor in office may be removed at any time by
the General Meeting of Shareholders with or without cause.
Art. 21. Dividends
21.1. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
21.2. The Shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the
Board of Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to
49740
be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried for-
ward, distributable reserves and available share premium but decreased by losses carried forward and sums to be allo-
cated to a reserve to be established by law.
21.3. The balance may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of Shareholders.
21.4. The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of
Shareholders as provided for under article 17(i). The General Meeting of Shareholders may decide to allocate any
amount out of the share premium account to the legal reserve account.
Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be
but do not need to be Shareholders and who are appointed by the General Meeting of Shareholders who will specify
their powers and remunerations.
22.2 Upon closure of the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company will be attributed to the
Shareholders.
Art. 23. Sole Shareholder. If, and as long as one Shareholder holds all the Shares of the Company, the Company
shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 24. Definitions
Advent: Means Advent International Corporation
Advent Entities: Means Advent and Global Private Equity IV Limited Partnership, Global Private Equity IV A Limited
Partnership, Global Private Equity IV B Limited Partnership, Global Private Equity IV C Limited Partnership, Global Pri-
vate Equity IV D Limited Partnership, Advent Partners GPE IV Limited Partnership and Advent Partners II Limited Part-
nership
Affiliate: Means, when used with respect to a specified Person, any Subsidiary of such Person and any other Person,
in relation to which such specified Person itself is a Subsidiary or which is a Subsidiary of the same Person in relation to
which the specified Person itself is a Subsidiary (a) in relation to Advent and the Advent Entities (or any of them) only,
any fund managed and/or advised by Advent and/or any Subsidiary thereof, any trustee or nominee in relation to such
fund or to the Advent Entities and any collective management investment scheme operated and/or advised by Advent
or any Subsidiary in relation thereto and (b) in relation to Class A Shareholders (or any of them) only, the funds managed
and/or advised by DH and/or any Subsidiary thereof, any trustee or nominee in relation to such funds or to the Class
A Shareholders and any collective management investment scheme operated and/or advised by DH or any Subsidiary in
relation thereto
Articles of Incorporation: Means the present articles of incorporation of the Company
Board of Managers or Board: Means the board of managers (conseil de gérance) of the Company appointed pursuant
to the Articles of Incorporation
Business Days: Means days on which banks in Frankfurt am Main, Germany, London, United Kingdom and Luxem-
bourg City, Luxembourg are open for the transaction of normal commercial businessClass Means Class A, Class B or
Class C as appropriate
Class: Means Class A, Class B or Class C as appropriate
Class A: Means Class A1, Class A 2 and Class A 3
Class A Shareholders: Means the holders of Class A1, Class A2 and Class A3 Shares
Class A Shares: Means the Shares of Class A1, Class A2 and Class A3 of the Company Class A1 Means Class A1 of
Shares of the Company
Class A1: Means Class A1 of Shares of the Company
Class A2: Means Class A2 of Shares of the Company
Class B: Means Class B1, Class B2 and Class B3
Class B Shareholders: Means the holders of Class B1, Class B2 and Class B3
Class B Shares: Means the Shares of Class B1, Class B2 and Class B3 of the Company
Class B1: Means Class B1 of Shares of the Company
Class B2: Means Class B2 of Shares of the Company
Class B3: Means Class B3 of Shares of the Company
Class C: Means Class C1, Class C2 and Class C3
Class C Shareholders: Means the holders of Class C1, Class C2 and Class C3 Shares
Class C Shares: Means the Shares of Class C1, Class C2 and Class C3 of the Company
Class C1: Means Class C1 of Shares of the Company
Class C2: Means Class C2 of Shares of the Company
Company: Means GREEN ALPHA, S.àr.l.
49741
Company Instruments: Means any debt instrument or certificates or shareholder loans (if any) issued or taken by the
Company as referred to in article 6.2
DH: Means Doughty Hanson & Co Limited whose registered number is 2978632 and whose registered address is 45
Pall Mall, London, SW1Y 5JG
DH Group: Means DH and any of its Subsidiaries from time to time
DH Partnerships: Doughty Hanson & Co IV Limited Partnership Number One; Doughty Hanson & Co IV Limited
Partnership Number Two, Doughty Hanson & Co IV Limited Partnership Number Three and Doughty Hanson & Co IV
Limited Partnership Number Four
General Meeting: Means the general meeting of Shareholders (regardless of class)
Initial Public Offering: Means the first public offering of any class of equity securities that (x) results in a listing of such
class of securities on a recognised securities exchange and (y) involves such number or amount of such class of securities
as represents at least the minimum free equity float requirement of the respective stock exchange / market segment
Majority Class A: Means Shareholders holding a simply majority of the Class A Shares
Majority Class A Consent: Means the consent by the Majority Class A
Permitted Transferee: Means any individual and any Person to whom (or to whose nominee) Shares are transferred
in a Transfer (or through a subscription of new Shares) permitted under these Articles (or any shareholders or like
agreement entered into between the Shareholders and the Company (if any) who is required by the terms of these
Articles to, and does, accede to such agreement (if any), and includes any Person to whom a Permitted Transferee of
any Shareholder (or a Permitted Transferee of a Permitted Transferee) further transfers Shares as permitted hereunder
and who is required under the present Articles to, and does, accede to such agreement (if any)
Person: means any individual and any corporation, limited liability company, partnership, trust, joint stock company,
unincorporated association, joint venture, governmental authority or other legal entity whatsoever
Register of Shareholders: Means the register of shareholders of the Company
Shareholders: Means the holders of Shares
Shares: Means all the shares (parts sociales) of the Company regardless of class
Subsidiaries: Means a specified Person controlled by another Person, i.e. in which that other Person currently or at
the relevant point in time holds directly or indirectly a majority of the voting rights, or in which such other Person di-
rectly or indirectly has the right to appoint or remove a majority of such specified Persons’ management, or directly or
indirectly has the right to exercise a dominant influence over such specified Person, whether by virtue of their articles
of association or a control or other agreement, including a specified Person under common control (control having the
meaning as set out before) of such other Person
Tag Third Party: Means any Third Party and includes with in case of a transfer of Class A Shares, any Affiliate in which
the Class A Shareholders or the DH Partnerships (including for these purposes participants in any DH co-investment
schemes) do not directly or indirectly hold the entire economic ownership or, in the case of a Transfer of Class B Shares
by the Advent Entities, any Affiliate in which the Advent Entities (including for these purposes participants in Advent co-
investment schemes) do not directly or indirectly hold the entire economic ownership
Third Party: Means any Person which is not a Shareholder nor an Affiliate of Shareholder
Transfer: Means any transfer of one or more Shares or any direct, indirect or other right or interest therein in any
manner whatsoever including by way of a sale, disposal, transfer, pledge, encumbrance, charge or otherwise; and to
Transfer, Transferee, Transferring or Transferred, Transferable shall be construed accordingly
Art. 25. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the Shareholders
refer to the relevant legislation.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting, in view of the amended and restated articles resolved to set the number of Board Members at five (5)
members and in view of the proposals submitted in accordance with the articles to confirm the mandate of the existing
board members for an undetermined period and qualify such board members as Class A Board Members. The meeting
then appointed Mrs Ingrid Moinet as additional Class A Board Member and Mr Desmond Mitchell as Class B Board Mem-
ber, each for an undetermined period so that the Board shall be composed as follows:
(vi) Yann Duchesne, A Board Member
(vii) Julian Huxtable, A Board Member
(viii) Gerard Becquer, A Board Member
(ix) Ingrid Moinet, A Board Member and
(x) Desmond Mitchell, B Board Member
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at five hundred sixty-one thousand Euro (EUR 561,000).
49742
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le douzième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de GREEN ALPHA, S.àr.l. (la «Société»), une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée en date du 13
juillet 2005 par acte du notaire Joseph Elvinger, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Cintia Martins, maître en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommée secrétaire et Céline Larmet, maître en droit,
demeurant à Luxembourg, a été nommée scrutateur.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter ce que:
1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste
de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste
restera annexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.
Il apparait de ladite liste de présence que l’ensemble des cinq cents (500) parts sociales émises dans la Société étaient
représentées à l’assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l’ordre
du jour de sorte que l’assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés
à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
(A) Modification et redétermination du capital social émis de la Société par:
1. la création de neuf(9) classes de parts sociales à savoir, la Classe A1, la Classe A2, la Classe A3, la Classe B1, la
Classe B2, la Classe B3 et la Classe C1, la Classe C2 et la Classe C3 avec les droits et obligations tels que prévus dans
les statuts modifiés de la Société conformément au point C de l’ordre du jour;
2. la reclassification des 500 parts sociales existantes émises par la Société en 500 parts sociales de Classe A1;
3. l’augmentation du capital social émis de la Société pour passer de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) à deux
millions d’euros (EUR 2.000.000) par
(a) l’émission d’
(i) un total de 19.500 parts sociales de Classe A1
(ii) un total de 20.000 parts sociales de Classe A2
(iii) un total de 20.000 parts sociales de Classe A3
(iv) un total de 4.000 parts sociales de Classe B1
(v) un total de 4.000 parts sociales de Classe B2
(vi) un total de 4.000 parts sociales de Classe B3
avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune pour un prix total de souscription (nominal et prime)
pour les nouvelles Classes de Parts Sociales A1, A2, A3, et B1, B2, et B3 de cinquante trois millions neuf cent quatre-
vingt- sept mille cinq cents euros (EUR 53.987.500);
(b) l’émission d’:
(i) un total de 2.667 parts sociales de Classe C1
(ii) un total de 2.667 parts sociales de Classe C2, et
(iii) un total de 2.666 parts sociales de Classe C3
avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et un prix de souscription au nominal de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune, le montant total du prix de souscription pour les nouvelles classes de Parts Sociales C1, C2
et C3 étant de deux cent mille euros (EUR 200.000);
(c) souscription des nouvelles parts sociales par les souscripteurs repris dans la liste ci-dessous et paiement du mon-
tant total du prix de souscription par le biais d’un apport en espèce d’un montant total de cinquante quatre millions cent
quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 54.187.500), affectation d’un montant de un million neuf cent quatre-vingt-
sept mille cinq cents euros (EUR 1.987.500) au compte du capital social émis, d’un montant de deux cents mille euros
(EUR 200.000) à la réserve légale (représentant 10% du capital social émis) et du solde de cinquante deux millions euros
(EUR 52.000.000) au compte de la prime d’émission librement distribuable, modification en conséquence de l’article 5
des statuts et renonciation (dans les limites requises) aux droits de préemption de souscription existants des associés
actuels (le mandataire étant expressément autorisé à accepter toute modification ou changement en particulier relatifs
aux chiffres ou montants contenus dans la présente)
Souscripteur
Classe
Nombre
de parts
sociales
Doughty Hanson & Co IV Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
5.640
Doughty Hanson & Co IV Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
6.080
Doughty Hanson & Co IV Nominees Three Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
1.464
Doughty Hanson & Co IV Nominees Four Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
5.250
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1
1.066
Total des Parts Sociales de Classe A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.500
49743
(B) Modification de la fin de l’année sociale de la Société afin que la première année sociale débute à la date de cons-
titution et se termine le 30 Avril 2006 et que chaque année sociale postérieure débute le 1
er
jour du mois de mai et se
termine le dernier jour du mois d’avril de l’année suivante et modification en conséquence des statuts.
(C) Modification et refonte des statuts de la Société essentiellement en la forme tel qu’attaché dans la procuration,
le mandataire étant cependant expressément autorisé et investi des pouvoirs de faire et d’accepter les changements et
modifications qu’il jugera approprié.
(D) Fixation du nombre de Membres du Conseil à cinq (5) membres. Confirmation du mandat des membres actuels
du conseil pour une durée illimitée et qualification de ce fait comme Membres du Conseil de Classe A et élection de
Mme Ingrid Moinet, résidant à 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg née le 5 décembre 1975 à Bastogne, Belgique
comme Membre du Conseil de Classe A et de Mr Desmond Mitchell, commissaire aux comptes, résidant à 123 Buckin-
gham Palace Road, London SW1W 9SL, Royaume-Uni, né le 24 Août 1957 à Wells, Royaume-Uni comme Membre du
Conseil de Classe B, chacun pour une durée indéterminée de sorte que le Conseil de Gérance est composé comme suit:
(i) Yann Duchesne, Membre du Conseil A
(ii) Julian Huxtable, Membre du Conseil A
(iii) Gérard Becquer, Membre du Conseil A
(iv) Ingrid Moinet, Membre du Conseil A
(v) Desmond Mitchell, Membre du Conseil B
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé à l’unanimité de modifier et de réévaluer le capital social émis de la Société par la création de
neuf (9) classes de parts sociales à savoir la Classe A1, la Classe A2, la Classe A3, la Classe B1, la Classe B2, la Classe
B3 et la Classe C1, la Classe C2 et la Classe C3 avec les droits et obligations tels que prévus dans les statuts modifiés
de la Société conformément au point C de l’ordre du jour.
L’assemblée a ensuite décidé de reclassifier les 500 parts sociales existantes émises par la Société en 500 parts sociales
de Classe A1.
L’assemblée a décidé l’augmentation du capital social émis de la Société pour passer de douze mille cinq cent euros
(EUR 12.500) à deux millions d’euros (EUR 2.000.000) par (a) l’émission d’un total de 19.500 parts sociales de Classe
A1, un total de 20.000 parts sociales de Classe A2, un total de 20.000 parts sociales de Classe A3, un total de 4.000
parts sociales de Classe B1, un total de 4.000 parts sociales de Classe B2, un total de 4.000 parts sociales de Classe B3,
avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune pour un prix total de souscription (nominal et prime)
pour les nouvelles Classes de Parts Sociales A1, A2, A3, et B1, B2, et B3 de cinquante trois millions neuf cent quatre-
vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 53.987.500) et (b) l’émission d’un total de 2.667 parts sociales de Classe C1, d’un
total de 2.667 parts sociales de Classe C2, et d’un total de 2.666 parts sociales de Classe C3 avec une valeur nominale
Advent Green (Cayman) Limited, with registered office at c/o M&C Corporate Services Limited,
PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-
lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B1
4.000
Total des Parts Sociales de Classe B 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
Green Managementbeteiligungs, GmbH & Co. KG with registered office at Kurt-Schumacher
Strasse 18-20, 53113 Bonn, Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C1
2.467
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C1
200
Total des Parts Sociales de Classe C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.667
Doughty Hanson & Co IV Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
5.783
Doughty Hanson & Co IV Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
6.237
Doughty Hanson & Co IV Nominees Three Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
1.502
Doughty Hanson & Co IV Nominees Four Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
5.385
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
1.093
Total des Parts Sociales de Classe A 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
Advent Green (Cayman) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2
4.000
Total des Parts Sociales de Classe B 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
Green Managementbeteiligungs, GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C2
2.467
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C2
200
Total des Parts Sociales de Classe C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.667
Doughty Hanson & Co IV Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
5.783
Doughty Hanson & Co IV Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
6.236
Doughty Hanson & Co IV Nominees Three Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
1.502
Doughty Hanson & Co IV Nominees Four Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
5.386
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3
1.093
Total des Parts Sociales de Classe A 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
Advent Green (Cayman) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B3
4.000
Total des Parts Sociales de Classe B 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
Green Managementbeteiligungs, GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C3
2.466
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C3
200
Total des Parts Sociales de Classe C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.666
49744
de vingt- cinq euros (EUR 25) chacune et un prix de souscription au nominal de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, le
montant total du prix de souscription pour les nouvelles classes de Parts Sociales C1, C2 et C3 étant de deux cent mille
euros (EUR 200.000) aux souscripteurs indiqués dans l’ordre du jour de l’assemblée (renonçant à tout droit de sous-
cription préférentiel si besoin (le cas échéant)).
Suite à quoi, les souscripteurs (tels qu’indiqués dans l’ordre du jour) représentés par procuration, lesquelles seront
enregistrées avec le présent acte, ont souscrit aux nouvelles parts sociales telles que reprises dans l’ordre du jour de
l’assemblée en contrepartie du paiement de l’ensemble du prix total de souscription au moyen d’un apport en espèces
d’un montant total de cinquante-quatre millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 54.187.500).
Preuve de l’apport en espèces d’un montant total de cinquante quatre millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
euros (EUR 54.187.500) a été soumise au notaire instrumentant.
L’assemblée a ensuite décidé d’affecter le montant total ainsi reçu de la manière prévue dans l’ordre du jour de l’as-
semblée et de modifier l’article 5 des statuts de la façon reprise ci-après dans les statuts refondus.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier la fin de l’année sociale de la Société afin que la première année sociale débute à la
date de constitution et se termine le 30 avril 2006 et que chaque année sociale postérieure débute le 1
er
jour du mois
de mai et se termine le dernier jour du mois d’avril de l’année suivante et de modifier les statuts en conséquence.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé d’entièrement modifier et de refondre les statuts de la Société de la manière prévue ci-après,
prenant en compte les résolutions précédentes de sorte que le contenu des statuts de la Société sera le suivant:
Status modifiés et refondus
Art . 1
er
. Dénomination. Il est créé et existe entre les souscripteurs initiaux et tous ceux qui deviendront déten-
teurs de Parts Sociales, par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GREEN ALPHA, S.à r.l.
(la «Société») régie par les présents Statuts et la loi applicable.
Art . 2. Objet. L’objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ou dans d’autres entités, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d’actions, obligations, reconnaissances de dettes,
titre de créance, des certificats de participation préférentielle au capital et tout autre titre de tout type et l’exercice du
droit de propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société pourra également
détenir des intérêts dans des sociétés en commandite simple et poursuivre ses activités à travers des succursales établies
à Luxembourg ou à l’étranger.
La Société pourra emprunter de l’argent de quelque manière que ce soit et procéder au placement privé d’obligations
et de titres de créances ainsi que d’autres titres.
De manière générale, elle pourra prêter assistance (que soit par le biais de prêts, d’avances, de garanties, en se por-
tant caution ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie
du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris associés ou affiliés). Elle pourra prendre toute mesure de
contrôle et de surveillance et procéder à toute opération qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement et au déve-
loppement de son objet social.
Finalement, la Société pourra réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières ou autre, qui sont
en relation directe ou indirecte dans tous les domaines afin de faciliter la réalisation de son objet social.
Art . 3. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société n’est pas dissoute par la mort, la suspen-
sion des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité de l’un de ses Associés.
Art . 4. Siège social
4.1. La Société a son siège social à Luxembourg Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré à tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire de ses Associés
délibérant de la manière prévue pour la modification des Statuts.
4.2. L’adresse du siège social pourra être transférée à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil
de Gérance.
4.3. La Société pourra avoir des bureaux et succursales tant à Luxembourg qu’à l’étranger.
4.4. Au cas où, de l’avis du Conseil de Gérance, des développements extraordinaires d’ordre politiques, économiques
ou sociaux de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée entre
le siège social et des personnes situées à l’étranger sont arrivés ou sont imminents, le siège social pourra être provisoi-
rement transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le Con-
seil de Gérance.
Art . 5. Capital social.
5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000) divisé en vingt mille (20.000)
Parts Sociales de Classe A 1, vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe A 2 et vingt mille (20.000) Parts Sociales de
Classe A 3 (la Classe A 1, la Classe A 2 et la Classe A 3 étant chacune une classe séparée de Parts Sociales mais définies
ensemble comme la «Classe A»), quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe B 1, quatre mille (4.000) Parts Sociales
de Classe B 2 et quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe B 3 (la Classe B1, la Classe B 2 et la Classe B3 étant chacune
une classe séparée de Parts Sociales mais définies ensemble comme la «Classe B») et deux mille six cent soixante-sept
(2.667) Parts Sociales de Classe C1, deux mille six cent soixante-sept (2.667) Parts Sociales de Classe C 2 et deux mille
49745
six cent soixante-six (2.666) Parts Sociales de Classe C 3 (la Classe C 1, la Classe C 2 et la Classe C 3 étant chacune
une classe séparée de Parts Sociales mais définies ensemble comme la «Classe C»), ayant chacune une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25) et ayant les droits et obligations décrits dans les présents Statuts.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des Associés adoptée de la ma-
nière requise pour la modification des présents Statuts sous réserve des dispositions prévues à l’article 6 respectivement
à l’article 7.
Art . 6. Droits de préemption
6.1. S’il est proposé d’émettre des Parts Sociales ou des droits d’acquérir, ou des titres convertibles ou échangeables
en Parts Sociales (les «Droits») de la Société en contrepartie d’espèces (autre qu’en connexion avec ou en préparation
d’une Offre Publique Initiale), alors les Associés auront, sous réserve des dispositions ci-dessous, le droit de préemption
(le «Droit de Préemption») pour souscrire en espèces selon les conditions proposées, à leur Droit de Préemption pro-
portionnellement à leur part sur ces Parts Sociales ou, le cas échéant, Droits. La «Part Proportionnelle du Droit de
Préemption» d’un Associé, correspondra, à tout moment, (i) au montant nominal global des Parts Sociales (ou, le cas
échéant, des Droits) proposés à l’émission en contrepartie d’espèces multiplié par (ii) un quotient, dont le numérateur
est le montant nominal total de Parts Sociales d’un Associé et dont le dénominateur est le montant nominal total des
Parts Sociales émises et en circulation avant la mise en oeuvre de la nouvelle émission, arrondi vers le bas (cet arron-
dissement vers le bas concernant le droit d’un Associé de Classe A sera appliqué en relation avec le nombre total de
Parts Sociales auxquelles tous les Associés de Classe A ont droit, les Associés de Classe A étant responsables de s’en-
tendre sur la répartition de ce nombre entre eux) jusqu’au nombre entier le plus proche divisible par la valeur nominale
des Parts Sociales (comme si tous les Droits avaient été exercés) et toutes les Parts Sociales ou Droits proposés à l’émis-
sion mais restants suite à cet arrondissement vers le bas ne seront pas émis.
6.2. Si la Société propose d’émettre des titres de créances ou des certificats ou de conclure un prêt d’Associé (les
«Instruments de Société») soit ensemble avec des Parts Sociales ou Droits, le Droit de Préemption de chaque Associé
(sur ces Parts Sociales ou le cas échéant Droits) est conditionné par la souscription de l’Associé à (ou l’octroi de) ces
Instruments de Société sur une base équivalente.
6.3. Au cas où une émission de Parts Sociales (ou les cas échéant de Droits) est proposée pour laquelle un Droit de
Préemption naît en application du présent article 6, la Société notifiera aux Associés par écrit à leurs adresses inscrites
dans le Registre des Associés (l’«Avis de Préemption») de son intention d’émettre des Parts Sociales (ou le cas échéant,
des Droits) et des Instruments (s’il y en a) en contrepartie d’espèces, le prix, l’identité du/des souscripteur(s) proposé(s)
ou offreurs, les conditions principales auxquelles elle propose d’émettre ces derniers. Les associés disposeront de 10
(dix) Jours Ouvrables à partir de la date de délivrance de tout Avis de Préemption pour accepter de souscrire aux Parts
Sociales (ou le cas échéant aux Droits) et aux Instruments De Société jusqu’à concurrence de leur Part Proportionnelle
de Droit de Préemption (calculée, dans chaque cas, avant l’émission) en contrepartie d’un prix et conformément aux
conditions spécifiées dans l’Avis de Préemption en adressant un avis écrit à la Société indiquant le nombre de Parts So-
ciales (ou le cas échéant, Droits) et Instruments (s’il y en a) à souscrire. Tout Associé n’ayant pas répondu favorablement
par écrit à la Société endéans cette période de dix (10) Jours Ouvrables sera considéré comme ayant refusé d’exercer
son Droit de Préemption et d’avoir renoncé à tous droits y relatif.
6.4. Au cas où, lors d’une émission de Parts Sociales (ou le cas échéant de Droits) à laquelle les Droits de Préemption
prévus à l’article 6.1 s’appliquent, ces Droits de Préemption ne sont pas exercés par rapport à toutes les Parts Sociales
(ou le cas échéant, les Droits) proposées à l’émission, les Parts Sociales (ou le cas échéant, les Droits) qui n’auront pas
été souscrites seront à nouveau offert(e)s aux Associés ayant exercés leur Droit de Préemption (les «Associés Accep-
tants») selon la procédure établie à l’article 6.3 et, au cas où il y aurait plus d’un Associé Acceptant, proportionnellement
à la Part Proportionnelle de Droit de Préemption respective des Associés Acceptants. Ce procédé sera répété en un
ou plusieurs tours entre les Personnes qui sont, par rapport au dernier tour, des Associés Acceptants jusqu’à ce que
soit toutes les Parts Sociales (ou le cas échéant, les Droits) proposées à l’émission aient été souscrit(e)s ou aucun des
Associés Acceptants dans le dernier tour ne désire souscrire à des Parts Sociales supplémentaires (ou le cas échéant,
Droits).
6.5. Toutes Parts Sociales émises suite à l’exercice par un Associé du Droit de Préemption conformément au présent
article 6, seront émises à l’Associé pertinent de la Classe A, Classe B ou Classe C de Parts Sociales (respectivement)
dans laquelle cet Associé détient des Parts Sociales dans la Société et tout Droit ainsi émis donnera le droit d’acquérir
ou de convertir ou d’échanger en Parts Sociales de la Classe A, Classe B ou Classe C de Parts Sociales (respectivement)
déjà détenues par cet Associé.
6.6. Les Associés qui bénéficient de Droits de Préemption prévus au présent article 6 peuvent, à tout moment, y re-
noncer par écrit.
Art. 7. Réduction du capital social
7.1. Le capital social de la Société pourra être réduit par l’annulation de Parts Sociales y compris par l’annulation de
l’ensemble d’une ou de plusieurs Classes entières de Parts Sociales par le rachat ou l’annulation de toutes les Parts So-
ciales émises dans cette/ces Classe(s).
7.2. Dans le cas d’une réduction du capital social par le rachat et l’annulation d’une ou de plusieurs Classes de Parts
Sociales, les détenteurs de Parts Sociales de la/des Classe(s) de Parts Sociales rachetées et annulées recevront de la
Société un montant égal à la Valeur d’Annulation Par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chaque Part Sociale
de la/des Classe(s) concernée(s) détenue par eux et annulée.
7.3. La Valeur d’Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d’Annulation (tel que définit
ci-dessous) par le nombre de Parts Sociales émises dans la/les Classe(s) de Parts Sociales qui seront rachetées et annu-
lées.
49746
7.4. Le Montant Total d’Annulation sera un montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l’Assem-
blée Générale sur la base de comptes intérimaires de la Société (les 'Comptes Intérimaires') à une date qui ne pourra
être antérieure de huit jours à la date du rachat concerné, la réduction du capital social et l’annulation des Parts Sociales
de la/des Classe(s) concernée(s) conformément à ce qui suit:
7.5. Le Montant Total d’Annulation pour les Classes A1, A2 et A3 et pour les Classes B1, B2 et B3 et les Classes C1,
C2 et C3 sera le Montant Disponible sauf décision contraire de l’Assemblée Générale des Associés selon la procédure
prévue pour une modification des Statuts étant entendu que le Montant Total d’Annulation ne doit jamais être supérieur
au Montant Disponible.
7.6. Le Montant Total d’Annulation pour chaque Classe de Parts Sociales rachetée et la Valeur d’Annulation par Part
Sociale seront déterminés pour la période débutant au jour de la constitution de la Société ou le lendemain de la date
des derniers Comptes Intérimaires requis à l’article 7.4 (respectivement) et terminant à la date des Comptes Intérimai-
res requis à l’article 7.4 pour la détermination concernée.
7.7. Le «Montant Disponible» est constitué du montant total des profits nets de la Société (y compris les profits re-
portés à nouveau mais (i) moins le résultat, s’il est positif, de toutes les pertes (y compris les pertes reportées à nouveau)
exprimées par un chiffre positif moins toutes les primes d’émission librement distribuables et les autres réserves libre-
ment distribuables et (ii) moins toutes les sommes qui doivent être placées en réserve(s) conformément aux exigences
de la loi ou des Statuts) tel qu’il ressort des Comptes Intérimaires auxquels il est fait référence à l’article 7.4.
7.8. A compter du rachat et de l’annulation des Parts Sociales de la/des Classe(s) concernée(s), la Valeur d’Annulation
Par Part Sociale sera due et exigible par la Société.
Art. 8. Conseil de Gérance
8.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») nommé comme un organe collégial par
l’Assemblée Générale des Associés conformément aux dispositions reprises ci-après. Les membres du Conseil de Gé-
rance (chacun un «Membre du Conseil») n’ont pas besoin d’être Associés. Le Conseil de Gérance sera composé du
nombre de membres déterminé par une décision des Associés lors d’une Assemblée Générale des Associés (sauf pour
la période entre une ou plusieurs démission(s) et les nouvelles nominations qui s’ensuivent) conformément aux dispo-
sitions de l’article 8.3 et en respectant les dispositions de l’article 17.4.(i) et dûment actées dans le procès-verbal de
cette Assemblée, nommés conformément aux dispositions du présent article 8.
8.2. Les Membres du Conseil sont nommés et révoqués de leur poste par une décision à la majorité simple de l’As-
semblée Générale des Associés conformément à l’article 17.4(i) qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs man-
dats. Si aucune durée n’est prévue, les Gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les Gérants pourront
être réélus mais leur nomination pourra également être révoquée avec ou sans cause (ad nutum) à tout moment.
8.3. Le Conseil de Gérance sera toujours composé de sorte que:
8.3.1 jusqu’à quatre (4) Membres du Conseil soient nommés par l’Assemblée Générale des Associés à partir d’une
liste de candidats proposés par les Associés de Classe A représentant une majorité simple des Parts Sociales de Classe
A (ces Membres du Conseil étant désignés comme 'Membres du Conseil de Classe A' et,
8.3.2 pour aussi longtemps que (i) les Parts Sociales de Classe B représentent plus de 10% du capital social émis de
la Société et que (ii) ces Parts Sociales de Classe B représentant 10% du capital social émis de la Société sont détenues
par les Entités Advent (ou leurs Affiliés), un (1) Membre du Conseil sera nommé par l’Assemblée Générale des Associés
à partir d’une liste de candidats proposés par les Associés de Classe B représentant une majorité simple des Parts So-
ciales de Classe B (ce Membre du Conseil étant désigné comme le «Membre du Conseil de Classe B»).
8.4. Les Associés de Classe A et les Associés de Classe B (dans la mesure où les droits définis à l’article 8.3.2. s’ap-
pliquent) représentant une majorité simple des Parts Sociales concernées renoncent (s’agissant des Parts Sociales de
Classe A, partiellement ou totalement), pour une période de temps que la classe concernée détermine, au droit de la
Classe concernée de proposer des candidats pour les élections du Conseil tel que prévu au présent article. Au cas où
les Associés de Classe A et les Associés de Classe B (dans la mesure où les droits définis à l’article 8.3.2. s’appliquent)
représentant une majorité simple des Parts Sociales de la Classe concernée décident de mettre un terme à cette renon-
ciation et en notifie la Société par écrit, la Société devra procéder, dans un délai de un (1) mois à compter de la réception
de cette notification, à la convocation de l’Assemblée Générale des Associés pour l’élection des Membres du Conseil
tel qu’approprié. Au cas où les Associés de Classe B ne fournissent pas une liste de candidats ainsi que le prévoit l’article
8.3. dans les 10 jours qui suivent la demande de la Société de fournir la liste, ils seront considérés comme ayant renoncé
au droit de nommer des candidats. En cas d’une telle renonciation (qu’elle soit expresse ou implicite) l’Assemblée Gé-
nérale des Associés peut déterminer le nombre de Membres du Conseil en conséquence ou les choisir librement.
8.5. Le Conseil de Gérance nommera un président du Conseil au sein des Membres du Conseil de Classe A.
Art. 9. Procédures au sein du Conseil de Gérance
9.1. Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité des Membres du
Conseil sont présents ou représentés à une réunion.
9.2. Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le président du Conseil de Gérance ou deux Mem-
bres du Conseil moyennant avis de convocation donné au moins sept (7) jours avant l’Assemblée, à moins que les affaires
de la Société ne requièrent une période de préavis plus courte ou en cas d’urgence (réduit à 12heures). Il pourra être
renoncé à l’avis de convocation par un accord unanime donné par tous les Gérants par écrit ou par fax, câble, télégram-
me, email ou télex. Des avis de convocation séparés ne seront pas nécessaires pour des réunions individuelles tenues
aux époques et lieux prescrits par un programme adopté antérieurement par résolution du Conseil de Gérance.
9.3. Les réunions du Conseil de Gérance pourront être tenues physiquement ou, dans toutes les circonstances, par
le biais de conférences téléphoniques (ou de moyens de communication similaires permettant à tous les participants de
communiquer entre eux). Le Conseil de Gérance pourra, en plus, dans toutes les circonstances, prendre des décisions
par voie de résolution écrite adoptée à l’unanimité. Les résolutions approuvées par écrit et signées par tous les Gérants
49747
auront le même effet que les résolutions adoptées lors d’une réunion du Conseil de Gérance. Dans ces cas, les résolu-
tions ou décisions devront être prises expressément, quelles soient formulées par écrit ou par voie de résolution cir-
culaire transmise par courrier, porteur, courrier électronique ou télécopie.
9.4. Tout Membre du Conseil pourra participer à n’importe quelle réunion du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par d’autres moyens de communication similaires permettant à tous les Membres du Conseil prenant
part à la réunion de s’entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à la
participation en personne à ladite réunion. Tout Membre du Conseil pourra agir à toute réunion du Conseil de Gérance
en nommant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre Membre du Conseil comme son mandataire.
Un Membre du Conseil pourra représenter plus d’un de ses collègues.
9.5. Les décisions du Conseil de Gérance sont prises moyennant les votes favorables de la majorité des Membres du
Conseil présents ou représentés à la réunion concernée.
9.6. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance devront être signés par le président du Conseil, le pré-
sident de la réunion concernée à condition qu’il s’agisse d’un Membre du Conseil de Classe A ou par deux Membres du
Conseil dont au moins un est obligatoirement un Membre du Conseil A. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux
qui devront être produits dans des procédures judiciaires ou à toute autre fin devront être signés par le président du
Conseil ou deux Membres du Conseil dont au moins un est obligatoirement un Membre du Conseil de Classe A.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil, Signatures engageant la Société
10.1. Le Conseil de Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour auto-
riser et/ou accomplir tous les actes de disposition et d’administration tombant dans les limites de l’objet social de la
Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l’Assemblée Générale seront de la
compétence du Conseil de Gérance. Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus d’agir pour
le compte de la Société dans toutes les circonstances et de faire, autoriser et approuver tous les actes et opérations
relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les Statuts à l’Assemblée Générale ou tel que cela pourra être
prévu par les présents Statuts.
10.2. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux Membres du Conseil dont un au moins sera toujours
un Membre du Conseil de Classe A de la Société ou par la signature conjointe ou la signature unique de toute personne
ou des personnes auxquelles ce pouvoir de signature aura été conféré par le Conseil de Gérance ou par deux Membres
du Conseil (y compris par la voie de la représentation) dont un au moins sera toujours un Membre du Conseil de Classe
A.
Art. 11. Indemnités du Conseil
11.1. Les Membres du Conseil ne seront pas personnellement tenus responsables pour les dettes de la Société. En
tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs mandats.
11.2. Sous réserve des exceptions et limitations prévues à l’article 11.3 ci-dessous, toute personne qui est, ou a été,
un Membre du Conseil ou un fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large
permise par la loi pour la responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celle-ci en relation
avec une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire qui la rend insolvable en tant que partie ou autrement en
vertu du fait qu’elle est ou a été Membre du Conseil ou fondé de pouvoir ainsi que pour tous les montants qu’elle aurait
payés ou supportés afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes «prétention», «action», «poursuite» ou
«procédure judiciaire» s’appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou
autres, y compris les appels) actuels ou possibles et les termes «responsabilité» et «dépenses» incluront sans limitation
les honoraires d’avocat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d’une transaction et autres montants.
11.3. Aucune indemnisation ne sera due à un Membre du Conseil ou à un fondé de pouvoir:
11.3.4. En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Associés en raison d’un abus de
pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d’imprudence dans l’accomplissement de ses devoirs découlant de sa
fonction;
11.3.5. Pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non
dans l’intérêt de la Société; ou
11.3.6. En cas de transaction, à moins que la transaction n’ait été approuvée par une cour d’une juridiction compé-
tente ou par le Conseil de Gérance.
11.3.7. Le droit d’être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque Membre du Conseil et n’af-
fectera pas tout autre droit dont un Membre du Conseil ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ulté-
rieurement. Il subsistera à l’égard d’une personne ayant cessé d’être Membre du Conseil ou fondé de pouvoir et se
transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet ar-
ticle n’affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les
gérants et fondés de pouvoir en vertu d’un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses supportées en relation avec la préparation d’une défense et la représentation dans le cadre d’une pré-
tention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant
toute décision finale sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l’engagement par ou pour comp-
te du fondé de pouvoir ou le gérant de rembourser ce montant s’il est finalement décidé qu’il n’aurait pas eu droit à une
indemnisation conformément au présent article.
Art. 12. Conflits. Aucun contrat ou transaction autre entre la Société et toute autre société ou entité ne sera af-
fectée ou viciée par le fait qu’un ou plusieurs Membres du Conseil ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt
dans ou est administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité. Tout Membre du
Conseil ou fondé de pouvoir de la Société agissant en qualité d’administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé de
toute société ou entité avec laquelle la Société a conclu un contrat ou est autrement en relation d’affaires ne sera, pour
49748
la seule raison de cette affiliation avec cette autre société ou entité, empêchée de prendre part et de voter ou agir en
toute matière en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.
Art. 13. Transfert de Parts Sociales
13.1. A l’exception de ce qui est prévu par les dispositions légales impératives, il pourra être renoncé à toute restric-
tion de Transfert prévue par les présents Statuts moyennant décision des Associés représentant au moins 75% du capital
social émis de la Société.
13.2. A moins qu’il en soit spécifiquement disposé autrement dans les présents Statuts, tout Transfert de Parts So-
ciales (ou de Droits) (entre Associés ou aux Personnes autres que les Associés (les «non-Associés»)) sera toujours sujet
à, et ne sera effectif et reconnu par la Société que s’il est réalisé conformément aux dispositions prévues dans les pré-
sents Statuts. Toute reconnaissance ou inscription d’un Transfert de Parts Sociales sera conditionnée par le respect des
dispositions prévues par les présents Statuts.
13.3. Les Transferts de Parts Sociales (ou de Droits) seront soumis à l’approbation des Associés représentant au
moins 75% (trois-quarts) du capital social de la Société.
13.4. A moins qu’un Accord Majorité Associés Classe A n’ait été obtenu, aucun Transfert de Parts Sociales par un
Associé (le «Cédant») à toute Personne ne peut avoir lieu, sauf si simultanément un nombre proportionnel d’Instru-
ments De Société (et Droits) (le cas échéant) détenus par le Cédant, parmi les Instruments De Société (et Droits) est
équivalent au total des Parts Sociales détenues par celui-ci immédiatement avant ce Transfert (dans tous les cas calculé
sur base de la valeur nominale) sont Transférés à la même Personne.
13.5 Tout Transfert de Parts Sociales ou, le cas échéant, d’Instrument De Société (ou de Droits) sera, en plus, à moins
qu’il n’en soit disposé autrement dans les présents Statuts et en particulier aux articles 14 et 15, sujet dans chaque cas
à l’adhésion du Cessionnaire à tout pacte d’associés ou accord du même type existant (le cas échéant) à ce moment là
entre tous ou une partie des Associés et la Société.
Art. 14. Tag Along
14.1. Au cas où les Associés de Classe A ou de Classe B proposent un Transfert de toute ou partie de leurs Parts
Sociales et d’Instruments De Société (et Droits) (le cas échéant et sous réserve des articles 15 et 16) à une Partie Tierce
du Tag (une «Proposition de Transfert Tag-Along») (un «Associé Cédant»), tout autre Associé qui exerce les droits que
lui confère l’article 14 (un «Associé Tagging») aura le droit d’exiger du Cessionnaire proposé (un «Cessionnaire Propo-
sé») d’acquérir de l’Associé Tagging des Parts Sociales d’un montant nominal total égal à (arrondi au nombre entier le
plus proche permis par la loi comme montant nominal minimum par Part Sociale):
où:
«A» correspond au montant nominal total de Parts Sociales dont le transfert est directement ou indirectement pro-
posé au Cessionnaire Proposé dans le cadre de la Proposition de Transfert Tag-Along (ces Parts Sociales les «Parts So-
ciales Cédées»),
«B» correspond au montant nominal total de toutes les Parts Sociales alors émises, sous réserve d’ajustements que
le Conseil estimerait être appropriés, et
«C» correspond au montant nominal total de Parts Sociales détenues par l’Associé Tagging;
au même prix par Part Sociale et au même prix par Instrument De Société (et Droits) (le cas échéant) (à chaque fois
basé sur son montant nominal) et selon les mêmes termes et conditions (y compris, sans limitation, l’échéance de paie-
ment, et mode de paiement) tel qu’il doit être payé et donné à l’Associé Cédant à condition que ce prix soit convenu
avec un tiers acquéreur de bonne foi et selon des conditions commerciales de marché entre l’Associé Cédant et le Ces-
sionnaire Proposé. L’Associé Cédant est tenu (sous réserve de toute contrainte dans leurs documents constitutifs), pour
pouvoir exercer son droit de Transférer des Parts Sociales et des Instruments De Société (et Droits) (le cas échéant)
au Cessionnaire Proposé conformément au présent Article, de faire ou de donner au Cessionnaire Proposé des décla-
rations, garanties, stipulations et indemnités identiques à celles que l’Associé Cédant accepte de faire en relation avec
la Proposition de Transfert Tag-Along (autre qu’une clause de non concurrence). L’Associé Tagging sera redevable de
sa part proportionnelle des coûts engendrés par la Proposition de Transfert Tag-Along dans la limite des coûts non
payés ou non remboursés par le Cessionnaire Proposé ou par la Société.
L’Associé Cédant notifiera par écrit à tout autre Associé de la Société et la Société de toute Proposition de Transfert
Tag-Along au moins 5 (cinq) Jours Ouvrables avant la signature d’un accord définitif (lequel doit contenir une disposition
exigeant l’acquisition de Parts Sociales et d’Instruments De Société (et Droits) (le cas échéant) qui sont soumis à des
droits tag-along en application du présent Article et qui sont exercés) en relation avec la Proposition de Transfert Tag-
Along fournissant des détails sur le Cessionnaire Proposé et le montant proposé ainsi que le mode de paiement, autres
termes et conditions de paiement offerts par le Cessionnaire Proposé et des détails sur toutes les autres clauses subs-
tantielles y compris les déclarations, garanties, dispositions et indemnités à faire ou à donner. L’Associé Cédant devra
ensuite et pas plus tard que 5 (cinq) Jours Ouvrables après que la signature d’un accord définitif concernant la Proposi-
tion de Transfert Tag-Along soit intervenue, notifier par écrit («l’Avis Initial Tag-Along») une confirmation et un rappel
du montant nominal des Parts Sociales et des Instruments De Société (et Droits) (le cas échéant) dont le transfert est
ainsi proposé, le nom et l’adresse du Cessionnaire Proposé, le montant et le mode de paiement proposés, d’autres ter-
mes et conditions de paiement offerts par le Cessionnaire Proposé, et l’Associé Cédant délivrera ou fera parvenir aux
autres Associés, le plus rapidement possible, des copies de tous les documents portant sur la transaction en relation
avec la Proposition de Transfert Tag-Along dès qu’ils sont disponibles. Les droits tag-along prévus au présent Article
doivent être exercés par l’Associé Tagging endéans les 5 (cinq) Jours Ouvrables après réception de l’Avis Initial Tag-
A
-- xC
B
49749
Along de la part de l’Associé Cédant par le biais d’un avis écrit à l’Associé Cédant indiquant le désir de l’Associé Tagging
d’exercer ses droits et spécifiant le montant nominal total de Parts Sociales et d’Instruments De Société (et Droits) (le
cas échéant) qu’il souhaite vendre (un «Avis Tag-Along») jusqu’au maximum calculé conformément à l’article 14.1. Si
aucun Avis Tag-Along ne parvient à l’Associé Cédant conformément au présent article 14.2, celui-ci aura, sous réserve
de l’article 13, le droit pendant une période de 60 (soixante) Jours Ouvrables à compter de la date de l’Avis Initial Tag-
Along de céder au Cessionnaire Proposé jusqu’à concurrence du montant nominal total de Parts Sociales et d’Instru-
ments De Société (et Droits) (le cas échéant) dont le Transfert a été directement ou indirectement proposé au Ces-
sionnaire Proposé selon des termes et conditions qui ne peuvent, en tout état de cause, être plus favorables, à l’Associé
Cédant que ceux indiqués dans son avis aux autres Associés. Si un/des Avis Tag-Along parviennent à l’Associé Cédant,
il pourra uniquement Transférer, sous réserve des dispositions des présents Statuts, le montant de Parts Sociales et
d’Instruments De Société (et Droits) (le cas échéant) fixé dans l’Avis Initial Tag-Along déduction faite du montant de
Parts Sociales et d’Instruments De Société (et Droits) (le cas échéant) fixé dans la/les Avis Tag Along et le Cessionnaire
Proposé devra acquérir les Parts Sociales et les Instruments De Société (Droits) (le cas échéant) de(s) Associé(s) Tag-
ging indiqués(s) dans la/les Notice Tag-Along.
Art. 15. Drag Along
15.1. Au cas où les Associés de Classe A désirent Transférer toute ou partie de leurs Parts Sociales ou Instruments
De Société (et Droits) (le cas échéant) à une Partie Tierce acquéreuse de bonne foi autre qu’un Cessionnaire Autorisé
(une «Proposition de Transfert Drag-Along»), alors sur demande des Associés de Classe A et à condition qu’ils aient
procéder à la notification prévue à l’article 15.2, tout autre Associé (un «Associé Dragged») transférera (et de la sorte
accordera un call option aux Associés de Classe A) au Cessionnaire Proposé une partie de ses Parts Sociales et Instru-
ments De Société (et Droits) (le cas échéant) égale au montant maximum de Parts Sociales et d’Instruments De Société
(et Droits) (le cas échéant) qu’il lui serait permis de Transférer dans le cadre de l’exercice de droits de tag-along con-
formément à l’article 14 à un prix identique par Part Sociale et à un prix identique par Instruments De Société (et Droits)
(le cas échéant) (en rapport, à chaque fois, avec son montant nominal et selon les mêmes termes et conditions (y com-
pris, sans limitation, l’échéance de paiement et le mode de paiement) à celui qui doit être donné et payé aux Associés
de Classe A. Les Associés Dragged seront chacun redevable pour leur part proportionnelle des coûts engendrés par la
Proposition de Transfert Drag-Along dans la mesure des coûts non payés ou remboursés par le Cessionnaire Proposé
ou par la Société.
15.2. Les Associés de Classe A notifieront aux Associés Dragged chaque Proposition de Transfert Drag-Along, le plus
tôt possible après avoir conclu un accord commercial concernant toute cession de ce type mais en tout état de cause
pas plus tard que dix (10) Jours Ouvrables précédant la signature de l’accord définitif (lequel doit contenir une disposi-
tion exigeant l’acquisition de Parts Sociales et d’Instruments De Société (et Droits) (le cas échéant) qui sont soumis à
un drag-along en application de l’article 15) pour la mise en oeuvre de la Proposition de Transfert Drag-Along, fixant le
montant nominal de Parts Sociales et d’Instruments De Société (et Droits) (le cas échéant) dont le transfert est ainsi
proposé, le nom et l’adresse du Cessionnaire Proposé, le montant et la forme de paiement proposés, d’autres termes
et conditions de paiement offerts par le Cessionnaire Proposé et les détails de toutes autres clauses que l’Associé de
Classe A en question estime être substantielles y compris les déclarations, garanties, stipulations et indemnités à donner.
Les Associés de Class A délivreront ou feront parvenir le plus rapidement possible, des copies des documents portant
sur la transaction en relation avec la Proposition de Transfert Drag-Along dès qu’ils sont disponibles.
Art. 16. Tag and Drag along prioritaires
Au cas où les articles 14 et 15 s’appliquent à une transaction unique, les droits drag-along tels que prévus à l’article
15 prévaudront sur les droits tag-along prévus à l’article 14.
Art. 17. Décisions des Associés.
17.1. Toutes les décisions des Associés sont prises par l’Assemblée Générale des Associés. Toutefois, la tenue d’une
assemblée n’est pas obligatoirement requise aussi longtemps que le nombre des Associés est inférieur à vingt-cinq et
dans un tel cas, les décisions des Associés peuvent valablement être prises par écrit. Toute assemblée des Associés de
la Société régulièrement constituée ou toute décision valable prise par écrit (le cas échéant) représentera l’Assemblée
Générale des Associés en tant qu’organe de la Société.
17.2. Chaque Associé pourra prendre part aux Assemblées Générales ou aux décisions écrites. Il aura un nombre de
voix égal au nombre de Parts Sociales qu’il détient et pourra valablement agir aux assemblées des Associés par l’inter-
médiaire d’un mandataire.
17.3. Les Assemblées seront convoquées par le Conseil de Gérance moyennant un avis de convocation adressé par
lettre recommandée ou porteur aux Associés à leur adresse apparaissant dans le registre des Associés détenu par la
Société au moins huit (8) jours avant la date de l’Assemblée. Si l’entièreté du capital social de la Société est représentée
à une Assemblée, l’Assemblée pourra valablement se tenir sans avis de convocation. Dans le cas des décisions prises par
écrit, le texte de ces décisions sera envoyé aux Associés à leur adresse mentionnée dans le registre des Associés détenu
par la Société au moins 8 jours avant la date effective proposée pour ces résolutions. Ces résolutions deviendront ef-
fectives moyennant l’accord de la majorité tel que prévu dans ces Statuts pour les décisions collectives (ou en respectant
les conditions de majorité à la date prévue dans les présents Statuts). Les décisions écrites à l’unanimité pourront être
passées à tout moment sans délai de préavis.
17.4. (i) Sous réserve des dispositions aux points (ii) et (iii) ci-dessous, les décisions de l’Assemblée Générale seront
valablement adoptées si elles sont approuvées par les Associés représentant plus de la moitié du nombre total de Parts
Sociales alors en émission. (ii) Des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par une décision
favorable (x) d’une majorité des Associés (y) représentant au moins trois-quarts du nombre total de Parts Sociales alors
49750
en émission (sans considération de la Classe) et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société
seront prises par les Associés représentant 100% des Parts Sociales en émission.
17.5. Dans le cas, et aussi longtemps que, la Société compte plus 25 Associés, une Assemblée Générale annuelle se
tiendra chaque année, le 30 mai à 11.00 heures du matin. Si ce jour n’est pas un Jour Ouvrable, l’Assemblée se tiendra
le Jour Ouvrable qui suivra immédiatement cette date.
Art. 18. Information des Associés. Les rapports financiers sont à la disposition des Associés au siège social de la
Société. La Société fournira en plus aux Associés toutes les informations telles que requises par la loi.
Art. 19. Année comptable. L’année comptable de la Société commence le 1er mai de chaque année et se termine
le 30 avril de la même année.
Art. 20. Comptes annuels, commissaire aux comptes
20.1.Chaque année, à la fin de l’année comptable, les comptes annuels de la Société seront préparés par le Conseil
de Gérance.
20.2. Les opérations de la Société seront, si la Société compte plus de 25 Associés, soumises au contrôle d’un com-
missaire aux comptes (ou le cas échéant à un réviseur d’entreprise). Dans un tel cas, le commissaire aux comptes sera
nommé par l’Assemblée Générale des Associés. Ce commissaire aux comptes pourra être révoqué à tout moment par
l’Assemblée Générale des Associés avec ou sans cause.
Art. 21. Dividendes
21.1. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera placé sur un compte de réserve légale. Cette déduction cessera d’être
obligatoire lorsque le compte de réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
21.2. Les Associés pourront décider de payer des dividendes intérimaires sur base d’un arrêté de compte préparé
par le Conseil de Gérance, prouvant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le
montant à distribuer ne pourra pas excéder les profits réalisés depuis la fin du denier exercice comptable augmenté des
profits reportés et des réserves distribuables et prime d’émission disponible, mais diminué des pertes reportées et des
sommes devant être allouées à la réserve établie par la loi.
21.3. La balance pourra être distribuée aux Associés moyennant décision de l’Assemblée Générale des Associés.
21.4. Le compte de prime d’émission pourra être distribué aux Associés moyennant décision de l’Assemblée Géné-
rale des Associés tel que prévu à l’article 17(i). L’Assemblée Générale des Associés pourra décider d’allouer tout mon-
tant du compte de prime d’émission au compte de réserve légale.
Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. Dans le cas où la Société est dissoute, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront,
mais ne devront pas être Associés et qui seront nommés par l’Assemblée Générale des Associés qui spécifiera leurs
pouvoirs et rémunérations.
22.2. A la clôture de la liquidation de la Société, les avoirs qui resteront après paiement du passif seront distribués
aux Associés.
Art. 23. Associé unique. Si, et aussi longtemps qu’un Associé détiendra toutes les Parts Sociales de la Société, la
Société existera comme une société unipersonnelle conformément à l’article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi seront applicables.
Art. 24. Définitions
Accord Majorité Associés Classe A Consent: Signifie l’accord de la Majorité Classe A
Advent: Signifie Advent International Corporation.
Affilié: Signifie lorsque utilisé en relation avec une Personne spécifiée, toute Filiale de cette Personne et toute autre
Personne en rapport avec laquelle cette Personne spécifiée est elle-même une Filiale ou qui est une Filiale de la même
Personne en rapport avec laquelle la Personne spécifiée est elle-même une Filiale (a) en relation avec Advent et une
Entité Advent (ou l’une d’entre elles) seulement, tout fonds géré et/ou conseillé par Advent et/ou toute Filiale de celui-
ci, tout fiduciaire ou nominee en relation avec ce fonds ou avec des Entités Advent et tout fonds commun de gestion
organisé et/ou conseillé par Advent ou une Filiale de cette dernière et (b) en relation avec des Associés de Classe A (ou
l’un d’entre eux) seulement, les fonds gérés et/ou conseillés par DH et/ou toute Filiale de ce dernier, tout fiduciaire ou
nominee en rapport avec ce fonds ou les Associés de Classe A et tout fonds commun de gestion placement organisé
et/ou conseillé par DH ou toute Filiale de ce dernier.
Assemblée Générale: Signifie l’assemblée générale des Associés (sans prendre en compte la classe)
Associés: Signifie les détenteurs de Parts Sociales
Associé de Classe A: Signifie les détenteurs de Parts Sociales de Classe A1, Classe A2 et Classe A3
Associés de Classe B: Signifie les détenteurs de Classe B1, Classe B2 et Classe B3
Associés de Classe C: Signifie les détenteurs de Parts Sociales de Classe C1, Classe C2 et Classe C3
Associations DH: Doughty Hanson & Co IV Limited Partnership Number One; Doughty Hanson & Co IV Limited
Partnership Number Two, Doughty Hanson & Co IV Limited Partnership Number Three et Doughty Hanson & Co IV
Limited Partnership Number Four
49751
Cessionnaire Autorisé: Signifie tout individu et toute Personne à qui (ou aux nominee desquels) des Parts Sociales
sont transférées dans le cadre d’un Transfer (ou par souscription à de nouvelles Parts Sociales) permit par les présents
statuts (ou tout pacte d’associé ou accord du même type conclu entre les Associés et la Société (le cas échéant) qui,
par application des termes des présents Statuts, est tenu de participer et participe à un tel accord (le cas échéant), et y
compris toute Personne à laquelle le Cessionnaire Autorisé de tout Associé (ou un Cessionnaire Autorisé d’un Ces-
sionnaire Autorisé) transfert, en outre, des Parts Sociales ainsi que le permettent les statuts et qui, par application des
présents Statuts, est tenu de participer et participe à un tel accord (le cas échéant).
Classe: Signifie Classe A, Classe B ou Classe C tel qu’approprié
Classe A: Signifie Classe A1, Classe A2 et Classe A3
Classe A1: Signifie les Parts Sociales de Classe A1 de la Société
Classe A2: Signifie les Parts Sociales de Classe A2 de la Société
Classe B: Signifie Classe B1, Classe B2 et Classe B3
Classe B1: Signifie les Parts Sociales de Classe B1 de la Société
Classe B2: Signifie les Parts Sociales de Classe B2 de la Société
Classe B3: Signifie les Parts Sociales de Classe B3 de la Société
Classe C: Signifie Classe C1, Classe C2 et Classe C3
Classe C1: Signifie les Parts Sociales de Classe C1 de la Société
Classe C2: Signifie les Parts Sociales de Classe C2 de la Société
Conseil de Gérance ou Conseil: Signifie le Conseil de Gérance de la Société nommé conformément aux Statuts
DH: Signifie Doughty Hanson & Co Limited inscrit sous le numéro 2978632 et dont le siège social est au 45 Pall Mall,
London, SW1Y 5JG
Entités Advent: Signfie Advent and Global Private Equity IV Limited Partnership, Global Private Equity IV A Limited
Partnership, Global Private Equity IV B Limited Partnership, Global Private Equity IV C Limited Partnership, Global
Private Equity IV D Limited Partnership, Advent Partners GPE IV Limited Partnership and Advent Partners II Limited
Partnership
Filiales: Signifie une Personne spécifiée contrôlée par une autre Personne, c’est-à-dire dans laquelle cette autre Per-
sonne actuellement ou à un point déterminé dans le temps détient directement ou indirectement une majorité des
droits de vote, ou dans laquelle cette autre Personne a, directement ou indirectement, le pouvoir de nommer ou de
révoquer une majorité de la gestion de ces Personnes spécifiées, ou a, directement ou indirectement, le droit d’exercer
une influence dominante sur cette Personne spécifiée, soit par voie des statuts ou par un contrôle, ou autre contrat, y
compris une Personne spécifiée sous contrôle commun (contrôle ayant la même signification que ci-dessus) de cette
autre Personne
Groupe DH: Signifie DH et toute filiale de temps en temps
Instruments de Société: Signifie tout titre de créance ou certificats ou prêts d’Associés (le cas échéant) émis ou conclu
par la Société tels que décrits à l’article 6.2
Jours Ouvrables: Signifie les jours pendant lesquels les banques à Francfort am Main, Allemange, Londres, Royaume-
Uni et Luxembourg-Ville, Luxembourg sont ouvertes pour effectuer des transactions commerciales normales.
Majorité Classe A: Signifie Associés détenant une majorité simple des Parts Sociales de Classe A
Offre Publique Initiale: Signifie la première offre publique d’une classe de titres de capital qui (x) résulte dans la cota-
tion de cette classe de titres sur un marché financier reconnu et (y) qui implique un nombre et un montant de cette
classe de titres représentant au moins le seuil minimum de transactions requises sur le marché financier/segment du
marché concerné
Partie Tierce: Signifie toute Personne qui n’est ni un Associé ni un Affilié de l’Associé
Partie Tierce Tag: Signifie toute Partie Tierce y compris dans le cadre d’un transfert de Parts Sociales de Classe A,
tout Affilié dans lequel les Associés de Classe A ou les Associations DH (y compris, pour ces besoins, les participants
de tout schéma d’investissement commun DH) ne détiennent pas directement ou indirectement l’entièreté de la pro-
priété économique ou, en cas de Transfert de Parts Sociales de Classe B par les Entités Advent, tout Affilié dans lequel
les Entités Advent (y compris, pour ces besoins, les participants de tout schéma d’investissement commun DH) ne dé-
tiennent pas directement ou indirectement l’entièreté de la propriété économique
Parts Sociales: Signifie toutes les Parts Sociales de la Société sans prendre en compte la Classe
Parts Sociales de Classe A: Signifie les Parts Sociales de Classe A1, Classe A2 et Classe A3 de la Société
Parts Sociales de Classe B: Signifie les Parts Sociales de Classe B1, Classe B2 et Classe B3 de la Société
Parts Sociales de Classe C: Signifie les Parts Sociales de Classe C1, Classe C2 et Classe C3 de la Société
Personne: Signifie tout individu et toute société, société à responsabilité limitée, association, fiducie, joint stock com-
pany, association non statutaire, joint venture, autorité gouvernementale ou toute autre entité légale
49752
Registre des Associés: Signifie le registre des associés de la Société
Société: Siginifie GREEN ALPHA, S.àr.l.
Statuts: Signifie les présents Statuts de la Société.
Transfert: Signifie tout transfert d’une ou plusieurs Parts Sociales ou autre ou d’un droit direct, indirect ou fiduciaire
ou d’un intérêt dans ces Parts Sociales d’une quelconque manière y compris par voie de vente, disposition, transfert,
gage, hypothèque, garantie ou autrement; et Transférer, Transférant ou Transféré, Transférable doit se comprendre en
conséquence
Art. 25. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les Associés se réfèrent à la légis-
lation applicable.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée, sur base des statuts modifiés et refondus, a décidé de fixer le nombre de Membres du Conseil à cinq
(5) membres et en considération des propositions soumises en conformité avec les statuts de confirmer le mandat des
membres actuels du conseil pour une période indéterminée et de qualifier ces membres du conseil comme Membres
du Conseil de Classe A. L’assemblée a ensuite nommé Mme Ingrid Moinet comme nouveau Membre du Conseil A et
Mr. Desmond Mitchell comme Membre du Conseil de Classe B, chacun pour une période indéterminée de sorte que le
Conseil est composé comme suit:
(i) Yann Duchesne, Membre du Conseil A
(ii) Julian Huxtable, Membre du Conseil A
(iii) Gérard Becquer, Membre du Conseil A
(iv) Ingrid Moinet, Membre du Conseil A
(v) Desmond Mitchell, Membre du Conseil B
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société suite à l’aug-
mentation du capital social sont estimés à cinq cent soixante et un mille euros (EUR 561.000,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent procès-
verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; qu’à la demande desdits comparants, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, C. Martins, C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 150S, fol. 7, case 2. – Reçu 541.875 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043346/211/1279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
GREEN ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.244.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n° 39422 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 16 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger.
(043349/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
SPE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.402.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022364/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
49753
ORANGE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.679.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of February.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1. The company KROON VASTGOED B.V., registered under number 30059321 in the «handelsregister van de Kam-
er van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht», with registered office at Utrecht, the Netherlands, and with its address
at 3572BS Utrecht, The Netherlands, Biltstraat 206, represented by Mr Sinan Sar, employee, residing professionally in
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a power of attorney given under private
seal.
2. The company SEDELA B.V., registered under number 30165735 in the «handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Utrecht», with registered office at Bilthoven, The Netherlands, and with address at
3723JH Bilthoven, The Netherlands, Sweelincklaan 70, represented by Mr Sinan Sar, pre-named, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
3. The company ORE II HOLDING. LTD, registered under number HE 168268, with registered office at Cyprus, 3030
Limassol, 35, Theklas Lysiotis Street, Eagle star house, 6th floor, represented by Mr Sinan Sar, pre-named, by virtue of
a power of attorney given under private seal.
Such powers of attorney having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented by Mr Sinan Sar, pre-named, have stated that they have formed a private limited
company whose articles of association have been fixed as follows:
Art. 1. Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is
hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws in
force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of association.
Art. 2. The company’s name is ORANGE HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
decision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at EUR 12,750.- (twelve thousand seven hundred and fifty Euro) represented by
510 (five hundred and ten) sharequotas of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, which have been subscribed as follows:
The subscribers state and acknowledge that each sharequota has been fully paid up so that the amount of EUR
12,750.- (twelve thousand seven hundred and fifty Euro) is now at the free disposal of the corporation and proof thereof
has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
1. The company KROON VASTGOED B.V., registered under number 30059321 in the «handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht», with registered office at Utrecht, the Netherlands, and with
its address at 3572BS Utrecht, the Netherlands, Biltstraat 206, one hundred and seventy sharequotas . . . . . . . . . 170
2. The company SEDELA B.V., registered under number 30165735 in the «handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Utrecht», with registered office at Bilthoven, the Netherlands, and with address
at 3723JH Bilthoven, The Netherlands, Sweelincklaan 70, one hundred and seventy sharequotas . . . . . . . . . . . . .
170
3. The company ORE II HOLDING LTD, registered under number HE 168268, with registered office at Cyprus,
3030 Limassol, 35, Theklas Lysiotis Street, Eagle star house, 6th floor, one hundred and seventy sharequotas . . .
170
Total: five hundred and ten sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510
49754
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-
ally.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-
ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufruc-
tuary only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-
proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general share-
holders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to
the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.
Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-
ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific
current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at
a rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general
expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-
ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an
end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the
assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-
ties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the
majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
49755
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by
the management or any other person appointed by the shareholders.
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Special dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2006.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed,
are estimated to about one thousand two hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital, held
an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they
have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated.
<i>First resolutioni>
The public limited company MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, with registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager for an unlimited duration with
the power to bind the company in all circumstances by his sole signature.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows French and English, states herewith that on request of the attorney the present
incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same attorney and in case of
divergences between the French and the English text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. La société KROON VASTGOED B.V., inscrite sous le numéro 30059321 au «Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Utrecht», avec siège social à Utrecht, Pays-Bas, et avec adresse à 3572BS Utrecht, Pays-
Bas, Biltstraat 206, représentée par Monsieur Sinan Sar, employé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration établie sous seing privé.
2. La société SEDELA B.V., inscrite sous le numéro 30165735 au «Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Utrecht», avec siège social à Biltoven, Pays-Bas, et avec adresse à 3723JH, Bilthoven, Pays-Bas, Swee-
lincklaan 70, représentée par Monsieur Sinan Sar, prénommé, en vertu d’une procuration établie sous seing privé.
3. La société ORE II HOLDING LTD, inscrite sous le numéro HE 168268, avec siège social à Chypre, 3030 Limassol,
35, Theklas Lysiotis Street, Eagle Star House, 6th floor, représentée par Monsieur Sinan Sar, pre-nommé, en vertu d’une
procuration établie sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et les comparantes, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, représentées par M. Sinan Sar, pre-nommé, ont déclaré avoir constitué une société à
responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est
formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de ORANGE HOLDING, S.à r.l.
49756
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même
groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement.
Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou
les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.750,- (douze mille sept cent cinquante euros) représenté par 510 (cinq cent
dix) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, qui ont été souscrites comme suit:
Les souscripteurs comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a été intégralement libérée
de sorte que la somme de EUR 12.750,- (douze mille sept cent cinquante euros) est dès à présent à la libre disposition
de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les
assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-
ment.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint
survivant.
En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-
tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances
en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
1. La société KROON VASTGOED B.V., inscrite sous le numéro 30059321 au «Handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht», avec siège social à Utrecht, Pays-Bas, et avec adresse à 3572BS
Utrecht, Pays-Bas, Biltstraat 206, cent soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
2. La société SEDELA B.V., inscrite sous le numéro 30165735 au «Handelsregister van de Kamer van Koophan-
del en Fabrieken voor Utrecht», avec siège social à Biltoven, Pays-Bas, et avec adresse à 3723JH, Bilthoven, Pays-
Bas, Sweelincklaan 70, cent soixante-dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
3. La société ORE II HOLDING LTD, inscrite sous le numéro HE 168268, avec siège social à Chypre, 3030
Limassol, 35, Theklas Lysiotis Street, Eagle Star House, 6th floor, cent soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . .
170
Total: cinq cent dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510
49757
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas
de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant
seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs
signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les
quinze jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance
ou par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu’ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de cet acte, s’élève à environ mille deux cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la société les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire, et après s’être déclarés valablement convoqués en connaissance de l’ordre
du jour, et après avoir délibéré, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée gérante pour une durée indéterminée. Elle a le pouvoir d’engager
la société en toutes circonstances par sa seule signature.
49758
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas
de divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Sar, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 mars 2006, vol. 535, fol. 92, case 1. – Reçu 127,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023289/231/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
APN PROPERTY HOLDINGS (No. 5), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP INVESTMENT FOURTEEN, S.à r.l.).
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 109.675.
—
In the year two thousand and six, on the third of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CEREP INVESTMENT FOURTEEN, S.à r.l. (the
«Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
incorporated on 6th July 2005 by deed of the undersigned, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations under Number C 1286.
The meeting was presided by M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary M
e
Karl Pardaens, maître en droit, residing in Luxembourg and as scrutineer M
e
Mathilde Lattard, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The member represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list signed by the
proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from the said attendance list, all two hundred and fifty (250) shares in issue in the Company and the
sole member was represented at the general meeting and the member of the Company declared that it had prior
knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the
agenda.
2. That the agenda of the meeting is as follows:
- Change of the name of the Company from CEREP INVESTMENT FOURTEEN, S.à r.l. to APN PROPERTY HOL-
DINGS (No. 5), S.à r.l. and consequential amendment of article 4 of the articles of association of the Company
After deliberation the following resolution was unanimously taken:
<i>Sole resolutioni>
It was unanimously resolved to change the name of the Company from CEREP INVESTMENT FOURTEEN, S.à r.l. to
APN PROPERTY HOLDINGS (No. 5), S.à r.l. and to consequentially amend article 4 of the articles of association of the
Company.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are
estimated at one thousand Euro.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties he-
reto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading the present deed the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trois février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de CEREP INVESTMENT FOURTEEN, S.à r.l. (la «So-
ciété»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, cons-
Junglinster, le 10 mars 2006.
J. Seckler.
49759
tituée le 6 juillet 2006 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous
le numéro C 1286.
L’assemblée a été présidée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Il fut nommé comme secrétaire M
e
Karl Pardaens, maître en droit, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur
M
e
Mathilde Lattard, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. L’associé représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’il détient sont repris dans une liste de présence signée
par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée au présent
acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.
Il appert de ladite liste de présence que toutes les deux cent cinquante (250) parts sociales émises par la Société ainsi
que le seul associé étaient représentés à la présente assemblée générale et le seul associé de la Société a déclaré avoir
été préalablement informé de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée était comme suit:
- Changement du nom de la Société de CEREP INVESTMENT FOURTEEN, S.à r.l. en APN PROPERTY HOLDINGS
(No. 5), S.à r.l. et modification consécutive de l’article 4 des statuts de la Société.
Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
Il a été unanimement décidé de changer le nom de la Société de CEREP INVESTMENT FOURTEEN, S.à r.l. en APN
PROPERTY HOLDINGS (No. 5), S.à r.l. et de modifier l’article 4 des statuts de la Société en conséquence.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
sont estimés à mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, K. Pardaens, M. Lattard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023690/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
APN PROPERTY HOLDINGS (N°5), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP INVESTMENT FOURTEEN, S.à r.l.).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 109.675.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
41438, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 mars 2006.
(023692/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 18, rue d’Orange.
R. C. Luxembourg B 48.841.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
16 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
2 du 3 janvier 1995.
—
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf.
LSO-BN00593, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021566/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Luxembourg, le 24 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.
Signature
49760
CASTOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.248.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 7 février 2006i>
L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnel-
lement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la société pour une durée illimitée
avec effet immédiat.
2. Nomination de Mademoiselle Carole Caspari, née le 25 octobre 1970 à Wermelskirchen (Allemagne), résidant
professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une
durée illimitée avec effet immédiat.
3. Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05348. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021366/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
EREME, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 6.152.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> février 2006i>
L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes LUX-FIDUCIAI-
RE CONSULTING, S.à r.l., 12, rue Ste Zithe, 2763 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Tom Loesch, commis-
saire aux comptes démissionnaire, pour une durée qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui va
approuver les comptes annuels au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04274. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021565/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
TRIAL TROIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LIGHT BAR, S.à r.l.).
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 93.531.
—
L’an deux mille six, le vingt-cinq janvier.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LIGHT BAR, S.à
r.l., ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 42-44, rue d’Hollerich, inscrite au Registre du Commerce et des So-
ciétés à Luxembourg, section B sous le numéro 93.531, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 mai 2003, publié au Mémorial C n
°
607 du 4 juin 2003, page 29.135.
L’assemblée est présidée par Monsieur Ludovic Casanova, indépendant, demeurant à Dudelange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste à L-1450 Luxembourg.
L’assemblée désigne Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg comme scrutatrice.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les deux cents (200) parts, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination sociale de la société de LIGHT BAR, S.à r.l. en TRIAL TROIS, S.à r.l.
2.- Modification afférente de l’article quatre des statuts.
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour EREME
i>Signature
49761
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de LIGHT BAR, S.à r.l. en TRIAL TROIS, S.à r.l.
et décide de modifier en conséquence l’article quatre des stauts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 4. La société prend la dénomination de TRIAL TROIS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Casanova, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, vol. 27CS, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023681/211/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
TRIAL TROIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LIGHT BAR, S.à r.l.).
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 93.531.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41312 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 mars 2006.
(023683/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
CanGro HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SETAUKET, S.à r.l.).
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 112.759.
—
In the year two thousand five, the twenty-ninth day of December.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of SETAUKET, S.à r.l., a Luxem-
bourg société à responsabilité limitée with registered office at 12, rue Léon Thyes in L-2636 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112.759 (the Company). The Company has
been incorporated on 9 December 2005 pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
There appeared CanGro HOLDING, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mr Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 28th, 2005,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the Company’s name into CanGro HOLDING, S.à r.l. and subsequent amendment of article 4 of the
articles of association of the Company (the Articles).
2. Amendment of article 12, fourth paragraph, of the Articles.
3. Revocation of Mr Joost Tulkens as manager of the Company effective immediately.
4. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to change the Company’s name into CanGro HOLDING, S.à r.l. and resolves to amend and
hereby amends article 4 of the Articles, which will henceforth read as follows:
«Art. 4. The Company will have the name CanGro HOLDING, S.à r.l.»
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 12, fourth paragraph, which will henceforth read as follows:
Luxembourg, le 20 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
49762
«The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two managers of the Company.»
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to revoke the mandate of Mr Joost Tulkens as manager of the Company effective on the date
hereof.
As a result of the above, the board of managers of the Company is composed as follows:
- Mr Philip Dougall, manager, and
- Mr Bart Zech, manager.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as
a result of the present deed are estimated to be approximately 1,500.- EUR.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed. by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de SETAUKET, S.à r.l., une so-
ciété à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.759 (la Société). La So-
ciété a été constituée le 9 décembre 2005 par acte de M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
A comparu CanGro HOLDING, LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l’Etat du De-
laware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique (l’Associé Unique),
ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion donnée le 28 décembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L’Assemblée a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de la dénomination sociale en CanGro HOLDING, S.à r.l. et modification subséquente de l’article 4
des statuts de la Société (les Statuts).
2. Modification de l’article 12, quatrième paragraphe, des Statuts.
3. Révocation de M. Joost Tulkens en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.
4. Divers.
III. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en CanGro HOLDINGS, S.à r.l. et décide de modifier et par
la présente modifie l’article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société aura la dénomination CanGro HOLDING, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 12, quatrième paragraphe, des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux gérants de la Société».
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de révoquer M. Joost Tulkens en tant que gérant de la Société avec effet à la date de la présente
assemblée.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Philip Dougall, gérant, and
- M. Bart Zech, gérant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui pourraient incomber à la Société à la suite du pré-
sent acte sont estimés à environ 1.500,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergen-
ces entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
49763
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec Nous, le notaire.
Signé: B. Beerens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(023686/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
CanGro HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SETAUKET, S.à r.l.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 112.759.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
41066 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 mars 2006.
(023687/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 101.286.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2006i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2007:
- M. Andreas Jacobs;
- M. Mario Cueni;
- M. Henrik de Koning;
- M. Gilbert Schintgen;
- M. Aloyse Hemmen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021713//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 101.286.
—
Le bilan au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BO00705, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
(021715//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Luxembourg, le 9 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
<i>Pour UBS (LUX) STRUCTURED SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
<i>Pour UBS (LUX) STRUCTURED SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Director i> / <i>Directori>
49764
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV 2, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.240.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2006i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2007:
- M. Andreas Jacobs;
- M. Mario Cueni;
- M. Henrik de Koning;
- M. Gilbert Schintgen;
- M. Aloyse Hemmen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00706. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021716//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV 2, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.240.
—
Le bilan au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BO00707, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
(021720//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
MERCANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.776.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 novembre 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2009:
<i>Signataire catégorie A:i>
- Monsieur Antonio Pettinato, expert-comptable, demeurant à Padova (Italie).
<i>Signataires catégorie B:i>
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire
à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Luxembourg, le 14 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01010. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023836/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
<i>Pour UBS (LUX) STRUCTURED SICAV 2
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
<i>Pour UBS (LUX) STRUCTURED SICAV 2
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
Pour extrait conforme
Signature
49765
GUS LUXEMBOURG 2005, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 807,021,175.-.
Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 112.060.
—
In the year two thousand and six, on the third day of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
GUS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Luxembourg,
having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Sole Sharehold-
er»),
hereby represented by Mr Eric Isaac, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned notary
to record that the appearing party is the sole shareholder of GUS LUXEMBOURG 2005, S.à r.l., a société à responsa-
bilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 112.060, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of 12 October 2005, not yet published in the
Mémorial C, the articles of which have last been amended by deed of the undersigned notary of 17 October 2005, not
yet published in the Mémorial C, and whose share capital is set at eight hundred seven million twenty-one thousand one
hundred seventy-five Euro (EUR 807,021,175.-) (the «Company»).
The appearing party, as hereinabove mentioned, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To change the financial year of the Company so that it shall start on the first (1st) day of April of a given year and
end on the thirty-first (31st) day of March of the following year.
2. To amend article 18 of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of the financial year of
the Company.
Thereupon, the Sole Shareholder passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith start on the first
(1st) day of April of a given year and end on the thirty-first (31st) day of March of the following year.
The Sole Shareholder further resolved that the current financial year started on the eighteenth (18th) day of October
2005 shall end on the thirty-first (31st) day of March 2006.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 18 of the articles of association of the Company which shall forthwith
read as follows:
«Art. 18. Financial year. The financial year begins on the first (1st) day of April and ends on the thirty-first (31st)
day of March of the following year.»
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned, notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le troisième jour de février.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
GUS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l’«Associé Unique»),
représentée aux fins des présentes par M. Eric Isaac, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, aux ter-
mes d’une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant, agissant en sa capacité d’associé unique de la Société, a requis le notaire soussigné de prendre acte
que le comparant est le seul et unique associé de GUS LUXEMBOURG 2005, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.060, cons-
tituée suivant acte du notaire soussigné, du 12 octobre 2005, non encore publié au Mémorial C, les statuts de laquelle
ont été modifiés dernièrement par acte du notaire soussigné en date du 17 octobre 2005, non encore publié au Mémo-
49766
rial C, et dont le capital social est fixé à huit cent sept millions vingt et un mille cent soixante-quinze euros (EUR
807.021.175,-) (la «Société»).
Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à interve-
nir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’année sociale de la Société de sorte qu’elle commence le premier (1
er
) jour du mois d’avril d’une
année donnée et finisse le trente et unième (31
e
) jour du mois de mars de l’année suivante.
2. Modification de l’article 18 des statuts de la Société, afin de refléter le changement de l’année sociale de la Société.
L’Associé Unique a alors pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de changer l’année sociale de la Société de sorte qu’elle commence le premier (1
er
) jour
du mois d’avril d’une année donnée et finisse le trente et unième (31
ème
) jour du mois de mars de l’année suivante.
L’Associé Unique a décidé que l’année sociale en cours, commencée le dix-huitième (18
ème
) jour du mois d’octobre
2005, se clôture le trente et unième (31
ème
) jour du mois de mars 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de modifier l’article 18 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 18. Année sociale. L’année sociale commence le premier (1
er
) jour du mois d’avril et se termine le trente et
unième (31
ème
) jour du mois de mars de l’année suivante.»
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Isaac, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023684/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
GUS LUXEMBOURG 2005, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 112.060.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41441 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 mars 2006.
(023685/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
NIGHTWATCH INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.320.750.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 103.553.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la Société tenue à Luxembourg en date du 17 fé-
vrier 2006 que la résolution suivante a été adoptée:
- La société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.477, a été nommée commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 24 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05966. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021603/1035/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Luxembourg, le 22 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
49767
H. D. CONSTRUCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mertzig.
R. C. Luxembourg B 106.646.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 9 mars 2006, réf. DSO-BO00054, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mertzig, le 9 mars 2006.
(922632//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2006.
IPC INTERNATIONAL PROJECT COOPERATION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2121 Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
H. R. Luxemburg B 114.705.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, den zweiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin n
°
196.711, eine Gesellschaft mit Sitz in 4 Custume Place, Athlone, Republik
Irland,
hier vertreten durch Frau Geneviève Blauen, Gesellschatfsverwalterin, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Ma-
lades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Sark, am 16. Februar 2006,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R.C. Dublin n
°
196.706, eine Gesellschaft mit Sitz in 4 Custume Place, Athlone,
Republik Irland,
hier vertreten durch Frau Ingrid Heintz, Sekretärin, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
burg-Kirchberg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Sark, am 16. Februar 2006.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Mandatare und den unterzeichneten Notar, dieser
Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentinnen, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen
gemäss folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung IPC INTERNATIONAL PROJECT COOPE-
RATION S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, wel-
cher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Immobilien, der Handel als Makler mit Immobilen, die
Immobilienverwaltung sowie die Projektfinanzierung. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unter-
nehmen beteiligen oder solche erwerben.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt dreiunddreissigtausend Euro (EUR 33.000,-), eingeteilt in dreihundertdreissig
(330) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) je Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-
jenigen Aktien, welche durch Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien
ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-
schlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsände-
rungen.
HD CONSTRUCT, S.à r.l.
Signature
49768
Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung das Kapital
aufzustocken, abzustimmen, gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungspri-
vileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen dies zu tun unter Be-
rücksichtigung von Artikel 32-3 (5) Abschnitt 2 desselben Gesetzes.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
oder Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine A oder B Zeichnungsbefugnis.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-
berufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige
Wahl vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden bestimmen. Im Fall dessen Abwesenheit kann der Vorsitz der Sitzung
einem anwesenden Verwaltungsratmitglied anvertraut werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, angenommen und unterschrieben durch alle Verwaltungsratmitglieder, hat ebenso
Gültigkeit wie ein in einer Sitzung des Verwaltungsrates gefasster Beschluss.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-
deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.
Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Gene-
ralversammlung unterworfen.
Art. 7. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtskräftig verpflichtet durch die Kollektivunterschrift von einem
Verwaltungsratsmitglied mit A Zeichnungsbefugnis zusammen mit einem Verwaltungsratsmitglied mit B oder durch die
einzelne Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats im Rahmen seiner Befugnisse.
Art. 8. Die Gesellschaft verpflichtet sich alle Verwaltungsratmitglieder zu entschädigen für Verluste, Schäden oder
Ausgaben, die sie verwirken könnten im Zusammenhang mit irgendeiner Klage oder irgendeinem Prozess, an dem sie
beteiligt wären in ihrer früheren oder aktuellen Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied, ausgenommen im Falle wenn
sie in solch einer Klage oder Prozess schlussendlich für grobe Fahrlässigkeit oder absichtlich schlechte Verwaltung ver-
urteilt werden.
Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen, dieselben werden auf sechs Jahre ernannt.
Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 22. März um 15.00 Uhr in Luxemburg am Gesell-
schaftssitz oder an jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag
statt.
Art. 12. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 13. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-
heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.
Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Art. 14. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend
die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende auszuzahlen.
Art. 15. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden
ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
49769
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2007.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
Die Aktien wurden alle vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von dreiunddreis-
sigtausend Euro (EUR 33.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, der dies
ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgesellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausendeinhundert Euro (EUR 2.100,-).
<i>Gründungsversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a) Verwaltungsratsmitglied mit A Zeichnungsbefugnis:
- Herr Michael Merten, Kaufmann, geboren am 5. März 1958 in Wiesbaden, wohnhaft in 34, Schiersteinerstrasse, D-
65187 Wiesbaden, Deutschland.
b) Verwaltungsratsmitglieder mit B Zeichnungsbefugnis:
- Herr Gérard Muller, Ökonomist, geboren am 28. Dezember 1943 in Petingen, mit Berufsanschrift in 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg,
- Herr Marc Schmit, Direktor, geboren am 13. Mai 1959 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Ma-
lades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.
3) Es wird zum Kommissar ernannt:
- Herr Marco Ries, «réviseur d’entreprises», geboren am 6. Januar 1959 in Esch-sur-Alzette, mit Berufsanschrift in
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung
des Jahres 2011.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2121 Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
6) Unter Zugrundelegung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der gegenwärti-
gen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte Herrn Michael Merten, vorgenannt,
zum Delegierten des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechts-
kräftig binden kann.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen, haben dieselben
mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:
In the year two thousand and six, on the twenty-second of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin n
°
196.711, a company with registered office at 4 Custume Place, Athlone, Re-
public of Ireland,
here represented by Mrs Geneviève Blauen, company director, with professional address at 231, Val des Bons Ma-
lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
by virtue of a proxy under private seal given in Sark, on February 16, 2006,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R.C. Dublin n
°
196.706, company with registered office at 4 Custume Place,
Athlone, Republic of Ireland,
here represented by Mrs Ingrid Heintz, secretary, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg,
by virtue of a proxy under private seal given in Sark, on February 16, 2006.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting through their mandatories, have decided to form amongst themselves a limited liability
company (société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.
1) ROSEVARA LIMITED, vorgenannt, zweihundertzwanzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, vorgenannt, einhundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Total: dreihundertdreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
49770
Art. 1. There is hereby formed a limited liability company (société anonyme) under the name of IPC INTERNA-
TIONAL PROJECT COOPERATION S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meet-
ing of shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The Company’s object is the buying and selling of real estate, the business as agent with real estate, the ad-
ministration of real estate as well as the financing of projects. The Company may take participations in or acquire anal-
ogous or similar companies.
Art. 3. The corporate capital is set at thirty-three thousand Euro (EUR 33,000.-), divided into three hundred and
thirty (330) shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, save where the Law pre-
scribes the registered form.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the amended law on commercial companies.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
The general meeting called to deliberate either on the increase of capital or the authorization to increase the capital,
in accordance with Article 32-1 of the law on commercial companies, may limit or waive the preferential subscription
right of the existing shareholders or may authorize the Board to do it under the provisions set forth in Article 32-3 (5)
second paragraph of the law on commercial companies.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall have an A or B signature power.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency,
Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting
of the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need
not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.
Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the signatures of a Director with
A signature power together with a Director with B signature power or by the individual signature of a delegate of the
Board within the limits of his powers.
Art. 8. Every Director of the Company shall be indemnified by the Company against all losses, damages or expenses
which any such Director may incur or become liable to by reason of any action or proceeding in his quality of passed
or present Director, except for the case where in such action or proceeding, he shall be finally condemned for gross
negligence or wilful mismanagement.
Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 10. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
49771
Art. 11. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-
dicated in the convening notices on March 22 at 3.00 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-
ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 13. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company.
It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 14. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915, as amended, the Board of
Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 15. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.
2) The first annual general meeting shall take place in 2007.
<i>Subscription and Paymenti>
The above-named parties have subscribed the shares as follows:
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-three thousand Euro (EUR 33,000.-) is forth-
with at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness
to it.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on Commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about two thousand one hundred Euro (EUR
2,100.-).
<i>Constitutive meetingi>
Here and now, the abovenamed parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves
as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Director with A signature power:
- Mr Michael Merten, businessman, born on 5 March 1958 in Wiesbaden, residing at 34, Schiersteinerstrasse, D-65187
Wiesbaden, Germany.
b) Directors with B signature power:
- Mr Gérard Muller, economist, born on 28 December 1943 in Pétange, with professional address at 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
- Mr Marc Schmit, Director, born on 13 May 1959 in Luxembourg, with professional address at 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
3) The following has been appointed Auditor:
- Mr Marco Ries, «réviseur d’entreprises», born on January 6, 1959 in Esch-sur-Alzette, with professional address at
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
5) The Company shall have its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
6) In conformity with Article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies and Article 6 of the Articles
of Incorporation, the general meeting authorises the Board of Directors to appoint from its members Mr Michael
Merten, prenamed, as managing-director, who may validly bind the Company by his sole signature.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the mandatories of the appearing parties, said
mandatories signed together with Us, the notary, the present original deed.
Signé: G. Blauen, I. Heintz, A. Schwachtgen.
1) ROSEVARA LIMITED, prenamed, two hundred and twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, prenamed, one hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Total: three hundred and thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
49772
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 45, case 9. – Reçu 330 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023735/230/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
HELLAS PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 106.169.
—
In the year two thousand and six, on the twentieth day of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company HELLAS PARTICIPATIONS (LUXEM-
BOURG) S.A., having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered with the Lux-
embourg trade register, under the number B 106.169, incorporated by a deed received by Maître Léon Thomas known
as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, on February 15, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
592 dated June 20, 2005 (hereinafter referred to
as «the Company»).
The articles of incorporation of the Company have been amended by a deed received by the undersigned notary pub-
lic on May 26, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
1017 dated October 11, 2005.
The articles of incorporation of the Company have been amended by a deed received by the undersigned notary
public on January 4, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The extraordinary general meeting is opened at three fifteen p.m. by Maître Pierre Metzler, lawyer, residing in
Luxembourg, acting as Chairman.
The Chairman appoints Ms Peggy Olinger, secretary, residing in Luxembourg, as Secretary of the meeting.
The general meeting of the shareholders appoints as Scrutineer Maître Sonja Streicher, lawyer, residing in Luxem-
bourg.
These three individuals constitute the Board of the meeting.
Having thus been constituted, the Board of the meeting draws up the attendance list which, having been signed ne
varietur by the shareholders or the proxy holders representing the shareholders, by the members of the Board and the
notary public will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed with the present
deed with the registration authorities.
The Chairman declares and requests the notary public to state that:
I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR
600,000.- (six hundred thousand Euro) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly
deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.
II. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 14, paragraph 1 of the Articles of Incorporation of the Company, which will henceforth have
the following wording:
«The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole signature of Mr Leonidas Bobolas
or by the joint signature of any other two directors.»
2. Miscellaneous.
Upon discussion and no one asking for further details, the extraordinary meeting of the shareholders unanimously
took the following resolution:
<i>Resolutioni>
The extraordinary shareholders’ meeting resolved to amend the Article 14, paragraph 1 of the Articles of Incorpo-
ration of the Company, which will henceforth have the following wording:
«The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole signature of Mr Leonidas Bobolas
or by the joint signature of any other two directors.»
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman
brought the meeting to a close at three thirty p.m.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentionned at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing per-
sons, it is specified that in case of divergences between the English and the German text, the English version will be
prevailing.
The present deed, having been read and translated into a language known by the persons appearing, the said persons
appearing signed together with us, the notary, the present deed.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
A. Schwachtgen.
49773
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendsechs, den zwanzigsten Februar.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, mit Amtssitz Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft HELLAS PARTICIPATIONS (LU-
XEMBOURG) S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handelsre-
gister Luxemburg, unter der Nummer B 106.169, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Léon Thomas,
genannt Tom Metzler, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg - Bonneweg, am 15. Februar 2005, veröffentlicht im Amtsblatt,
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
592 vom 20. Juni 2005 (nachfolgend «die Gesellschaft»), zusam-
mengefunden.
Die Satzung der Gesellschaft wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 26. Mai
2005 abgeändert und veröffentlicht im Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
1017 vom 11.
Oktober 2005.
Die Satzung der Gesellschaft wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. Januar
2006 abgeändert und noch nicht veröffentlicht im Amtsblatt, Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Die außergewöhnliche Hauptversammlung wird um fünfzehn Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Maître Pierre
Metzler, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt Frau Peggy Olinger, Sekretärin, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär der Hauptver-
sammlung.
Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt Maître Sonja Streicher, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum
Stimmenzähler.
Diese drei Personen bilden den Vorstand der Hauptversammlung.
Im Anschluss an die Ernennung des Vorstands der Hauptversammlung stellt dieser die Anwesenheitsliste auf, welche,
nach ne varietur Unterzeichnung durch die Aktionäre oder die Bevollmächtigten der Aktionäre, die Vorstandsmitglieder
und den Notar, zusammen mir den Vollmachten als Anlage an vorliegender Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung
verbleibt.
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar zu beurkunden:
I. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor, dass sämtliche Aktionäre die das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe
von EUR 600.000,- (sechshunderttausend Euro) vertreten, bei der Hauptversammlung anwesend oder rechtsgültig ver-
treten sind. Die Hauptversammlung kann daher rechtsgültig, ohne vorangehende Einberufung, über sämtliche Verhand-
lungspunkte der Tagesordnung beraten und entscheiden.
II. Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist folgende:
<i>Tagesordnung:i>
1. Abänderung des Artikels 14, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft,der zukünftig wie folgt lautet:
«Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die einzige Unterschrift von Herrn Leonidas
Bobolas oder durch gemeinsame Unterschrift von zwei anderen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.»
2. Verschiedenes.
Nachdem die Hautversammlung der Aktionäre die Erklärungen des Vorsitzenden gutgeheißen hat, und sich als recht-
gültig einberufen und zusammengesetzt ansieht, fasst sie einstimmig, nach vorangegangener Beratung, folgenden
Beschluss:
<i>Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, Artikel 14, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern,
welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben wird:
«Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die einzige Unterschrift von Herrn Leonidas
Bobolas oder durch gemeinsame Unterschrift von zwei anderen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.»
Da keine weiteren Punkte der Tagesordnung offen stehen und keine weiteren Fragen gestellt werden, schließt der
Vorsitzende die Versammlung um fünfzenh Uhr dreissig.
Aufgenommen in Luxemburg, an dem zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten Datum.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ver-
langen der obigen erschienenen Personen auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlan-
gen derselben erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung ist die englische Fassung maßgeblich.
Nach Vorlesung des Dokumentes an die erschienenen Personen, haben diese gemeinsam mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: P. Metzler, P. Olinger, S. Streicher, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024559/230/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
A. Schwachtgen.
49774
HELLAS PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 106.169.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
233 du 20 février 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024560/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
SOLAR SCREEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8221 Mamer, 1, rue Cunégonde.
R. C. Luxembourg B 22.286.
—
Comme chaque année, les bénéfices sont réinvestis dans l’activité courante et aucun dividende n’est distribué aux
actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00535, a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
(021675/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
LOGIC PARK EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 113.569.
—
EXTRAIT
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2006, FFF VERMÖGENSVERWALTUNG HOLDING, GmbH, une so-
ciété existant selon les lois allemandes, ayant son siège social au Philipp-Reis-Strasse 14, D-63303 Dreieich, Allemagne,
a cédé trente-huit (38) parts sociales de la Société, et LEPE VERMÖGENSVERWALTUNG, GmbH, une société existant
selon les lois allemandes, ayant son siège social au Philipp-Reis-Strasse 14, D-63303 Dreieich, Allemagne, a cédé douze
(12) parts sociales de la Société, ensemble cinquante (50) parts sociales, à JOGI VERMÖGENSVERWALTUNG HOL-
DING, GmbH, une société existant selon les lois allemandes, ayant son siège social au Rösslerstrasse 12, D-65193 Wies-
baden, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00479. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021701//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
GENTIANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 74.063.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire le 16 juin 2005i>
5. L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’Administrateur de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin
Nijar et Romain Thillens et Pierre Hoffmann, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2011. De
même, l’Assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l.
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06111. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021752/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
<i>Pour LOGIC PARK EUROPE, S.à r.l.
i>I. Lentz
<i>Mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
49775
EHINGER & ARMAND VON ERNST FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.878.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 8 février 2006i>
Est élu au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2007:
- M. Sascha Walker, Morgartenstrasse 1, 8039 Zürich, Schweiz.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00700. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021722//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.180.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 10 janvier 2006i>
Est élu au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2007:
- M. René Egger, Robert Blumstrasse 6, 5454 Bellikon, Schweiz.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00698. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021724//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
LUXICAV, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.337.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 janvier 2006 à 11.00 heures au siège sociali>
L’assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un an.
<i>Conseil d’administration:i>
Marco Bus, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Admi-
nistrateur;
Stefano Ciccarello, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Administrateur;
Nathalie de Meyere, GENERALI LUXEMBOURG S.A., 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, Administrateur.
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
ERNST & YOUNG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00736. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021745/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
<i>Pour EHINGER & ARMAND VON ERNST FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
<i>Pour LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
Pour extrait conforme
<i>LUXICAV, SICAV
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
49776
DEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.067.
—
<i>Décision de l’Assemblée Générale des actionnaires du 15 février 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 15 février 2006, le mandat de commissaire aux
comptes de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue de Michel Rodange, L-2340 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été
révoqué.
La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05978. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021738/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
C.F.I.M. COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS MOBILIERS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.532.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 mars 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021749/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
DAB INVESTMENTS LUXEMBOURG SNC, Société en nom collectif.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.188.
—
Le bilan au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01019, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022405/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
<i>Pour DEMAR S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
MM. Dominique Billion, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Shorender S.A.
Editions Culturelles et Professionnelles S.A.
Pollux Properties, S.à r.l.
Green Alpha, S.à r.l.
Green Alpha, S.à r.l.
Green Alpha, S.à r.l.
SPE Finance, S.à r.l.
Orange Holding, S.à r.l.
APN Property Holdings (No. 5), S.à r.l.
APN Property Holdings (N˚5), S.à r.l.
Fiduciaire Billon, S.à r.l.
Castor International, S.à r.l.
Ereme
Trial Trois, S.à r.l.
Trial Trois, S.à r.l.
CanGro Holding, S.à r.l.
CanGro Holding, S.à r.l.
UBS (Lux) Structured Sicav
UBS (Lux) Structured Sicav
UBS (Lux) Structured Sicav 2
UBS (Lux) Structured Sicav 2
Mercante S.A.
GUS Luxembourg 2005, S.à r.l.
GUS Luxembourg 2005, S.à r.l.
Nightwatch Investments, S.à r.l.
H. D. Construct, S.à r.l.
IPC International Project Cooperation S.A.
Hellas Participations (Luxembourg) S.A.
Hellas Participations (Luxembourg) S.A.
Solar Screen International S.A.
Logic Park Europe, S.à r.l.
Gentiane S.A.
Ehinger & Armand von Ernst Fund Management Company S.A.
Luxembourg Placement Fund Management Company S.A.
Luxicav, Sicav
Demar S.A.
C.F.I.M. Compagnie Financière d’Investissements Mobiliers
DAB Investments Luxembourg SNC