This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
48625
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1014
24 mai 2006
S O M M A I R E
A.P.S.I., S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48628
duction d’Energie Renouvelable, Luxembourg . .
48630
ACM New Alliance (Luxembourg) S.A., Luxem-
Hipper S.A. - Société Internationale pour la Pro-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48627
duction d’Energie Renouvelable, Luxembourg . .
48631
Alpha Factoring, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
48654
Immobilière de Warken S.A., Luxembourg . . . . .
48635
Annandale International S.A., Luxembourg . . . . . .
48653
Kether S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48626
Asia Consumer Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .
48650
Lahndrik Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48637
Asia Consumer Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .
48652
Lyrane Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
48626
Barsac Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
48668
Macquarie Industrie Beteiligungen S.A., Luxem-
BHF-Bank International S.A., Luxembourg . . . . . .
48653
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48626
Blacksmith Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
48649
Micros-Fidelio Luxembourg, S.à r.l., Münsbach. . .
48629
BRE/Bielefeld I Hotel, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . .
48638
Micros-Fidelio Luxembourg, S.à r.l., Münsbach. . .
48629
BRE/Frankfurt I Hotel, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . .
48644
Nedamo Consolidated S.A., Luxembourg . . . . . . .
48636
BRE/Perlach I Hotel, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . .
48662
Neocell, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48636
C.A.L., Centrale d’Approvisionnement Luxem-
Pharmacies Européennes Holding S.A., Luxem-
bourgeoise, GEIE, Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48637
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48643
(La) Capite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48654
Philos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48667
Cariges S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .
48667
Placements Financiers et Industriels S.A., Luxem-
CB Commercial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48629
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48635
Cebarre Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
48653
Poseidon Luxco Holdings, S.à r.l., Senningerberg .
48626
Comaga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48654
Provence S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .
48661
Corisa S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . .
48668
Rosalia Real Estate AG, Leudelange . . . . . . . . . . . .
48669
Daninvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48668
Russell Bedford Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
48653
Daninvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48668
S.G. Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48660
Deodara S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .
48672
SCI Teberu, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48636
Doulu Investissement S.A. Luxembourg, Luxem-
SeeReal Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . .
48632
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48652
SeeReal Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . .
48634
Doulu Investissement S.A. Luxembourg, Luxem-
Société Luxembourgeoise d’Intermédiaires de
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48652
Commerce, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48660
Doumart Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48635
Swedmec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48661
Efisia Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
48632
T.B.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48654
Fiduciaire Auditlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
48643
TD Retail, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . .
48661
Fiduciaire Nationale, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
48649
Tradegro Holdings Limited, Luxembourg Branch,
Finropa Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48660
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48661
Finropa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
48661
Traditional Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48630
Full Music Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48654
Vitony S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48637
G & P Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
48668
Vitony S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48637
Gold Broker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48630
Vulcan Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Hipper S.A. - Société Internationale pour la Pro-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48627
48626
LYRANE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.636.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40935 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 mars 2006.
(022367/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.255.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 mars 2006.
(022368/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
KETHER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 93.473.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41263 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 mars 2006.
(022370/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
POSEIDON LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 109.509.
—
EXTRAIT
En date du 28 février 2006, l’associé unique de la Société, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
106.232, a accepté la démission en tant que gérant de la Société de Monsieur Paul Davey, Senior Vice-Président, né le
11 juillet 1964 à Connecticut, Etats-Unis d’Amérique, demeurant au 7 Campden House Terrace, Kensington Church
Street, Londres W8 4BQ, Royaume-Uni, avec effet au 28 février 2006, et a décidé de nommer Monsieur Jerome Truzzo-
lino, Senior Vice-Président, né le 10 février 1964 à New York, Etats-Unis d’Amérique, demeurant au 2 Willa Way, Mas-
sapequa, New York 117 58, Etats-Unis d’Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet au 28 février 2006.
Dès lors, les gérants de la Société, nommés pour une durée indéterminée, sont:
- M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), ayant son
adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique.
- Mme Sophie Van Oosterom, Vice-Président (Londres), née le 20 juin 1972 à Haarlemmermeer (Pays-Bas), ayant son
adresse professionnelle au 25, Bank Street, 29th Floor, Londres E14 5LE, Royaume-Uni.
- M. John Mc Carthy, Administrateur, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au
40 Hamstead Grove, Londres NW3 6SR, Royaume-Uni.
- Monsieur Jerome Turzzolino, Senior Vice-Président, né le 10 février 1964 à New York, (Etats-Unis d’Amérique),
demeurant au 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58, Etats-Unis d’Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01173. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022546/4170/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
ATOZ
Signature
48627
VULCAN HOLDINGS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 68.095.225,-.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 103.022.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat de transfert d’actions daté du 9 décembre 2005 conclu entre (1) VULCAN HOLDINGS
LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée existante sous l’empire des lois du Grand-Duché du Luxem-
bourg ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg; (2) STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
VULCAN HOLDINGS, une fondation existante sous l’empire des lois des Pays-Bas ayant son siège social à Naritaweg
165 Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas en tant qu’acheteur et (3) Carlo Soors, résidant à Rijelstraat 114, 8820
Torhout, Belgique; (4) Paul Houben résidant à North River Side 620, St Clair, MI 48079USA; (5) Eddy Van Steyvoort
résidant à Steenweg 237 A, 3570 Alken, Belgique; (6) Bernard Vandewiele résidant à Lareveenstraat 7, 1980 Zemst-Laar
Belgique; (7) Peter Pecinovsky, résidant à Dopheidestraat 17, 3600 Gent, Belgique; (8) Karel Croes résidant à Moggewei-
destraat 21, 3750, Alken, Belgique; (9) Antoine Engelen, résidant à Neerstraat 32, 3582 Koersel, Belgique; (10) Eric
Willekens, résidant à Voort 60, 2440 Geel, Belgique; (11) Rudy Herman résidant à Kraaikant 62A, 3221 Nieuwrode,
Belgique; (12) Stephan Kessel résidant à Salinenstrasse 30, 30952 Ronnenberg, Allemagne et (13) Alexander Toeldte
résidant à Dr Lammermoor 15, St Héliers, Auckland, Nouvelle-Zélande en tant que vendeurs («les Gérants») que les
136.000 actions souscrites par les Gérants dans la société VULCAN HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée
en date du 9 décembre 2005 ont été cédées ce même jour à la fondation STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
VULCAN HOLDINGS, prénommée.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02236. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat de transfert d’actions daté du 15 juin 2005 conclu entre (1) VULCAN HOLDINGS LUXEM-
BOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée existante sous l’empire des lois du Grand-Duché du Luxembourg
ayant son siège social au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg; (2) STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VUL-
CAN HOLDINGS, une fondation existante sous l’empire des lois des Pays-Bas ayant son siège social à Naritaweg 165
Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas en tant qu’acheteur et (3) Carlo Soors, résidant à Rijelstraat 114, 8820
Torhout, Belgique; (4) Paul Houben résidant à North River Side 620, St Clair, MI 48079USA; (5) Eddy Van Steyvoort
résidant à Steenweg 237 A, 3570 Alken, Belgique; (6) Bernard Vandewiele résidant à Lareveenstraat 7, 1980 Zemst-Laar,
Belgique; (7) Peter Pecinovsky, résidant à Dopheidestraat 17, 3600 Gent, Belgique; (8) Karel Croes résidant à Moggewei-
destraat 21, 3750, Alken, Belgique; (9) Antoine Engelen, résidant à Neerstraat 32, 3582 Koersel, Belgique; (10) Eric
Willekens, résidant à Voort 60, 2440 Geel, Belgique; et (11) Rudy Herman résidant à Kraaikant 62A, 3221 Nieuwrode,
Belgique en tant que vendeurs (les «Gérants») que les trente-deux mille (32.000) actions souscrites par les Gérants dans
la société VULCAN HOLDINGS <i>Luxembourgi>, S.à r.l., prénommée en date du 15 juin 2005 ont été cédées ce même jour
à la fondation STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VULCAN HOLDINGS, prénommée.
Luxembourg, le 5 janvier 2006
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02239. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022384/1005/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.408.
—
Les comptes annuels au 31 mai 2005, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises y relatif, enregistrés à Luxem-
bourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01597, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022662/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
<i>Pour VULCAN HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>D. Marliani
<i>Mandatairei>
<i>Pour VULCAN HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>D. Marliani
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 24 février 2006.
Signature.
48628
A.P.S.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wiltz.
R. C. Luxembourg B 99.115.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
1. La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Re-
gistre de commerce et de sociétés sous le numéro B 98.905, ici représentée par son administrateur-délégué la société
DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés sous le numéro B 98.510, elle-même représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien,
consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,
2. Monsieur Philippe Sourdeau, gérant de société, demeurant à B-1480 Tubize, 144/5, rue de la Déportation, ici re-
présenté par Monsieur Benoît de Bien, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à B-Tubize, le
11 janvier 2006,
lesquels comparants ont exposé au notaire:
- que la société A.P.S.I., S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de résidence
à Wiltz, en date du 18 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, de l’année
1995, page 31575,
- qu’elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 3.320,
- qu’elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (50) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (250,- EUR) chacune,
- que les comparants sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité limitée
A.P.S.I., S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
Ensuite la comparante, agissant comme prédit a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Cession de partsi>
Les associés cèdent, l’intégralité de leurs parts sociales à la fondation privée InFin, dont le siège social est sis Ricardo
Arias Street, Advanced Tower, 11th floor, Panama City, Panama, représentée par Monsieur Jorge G. Lombardi Dutari,
avec adresse professionnelle à Panama City, Ricardo Arias Street, Advanced Tower, 11th floor, lui-même représenté
par Monsieur Benoît de Bien, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Capellen, le 11 janvier
2006.
Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations
attachées aux parts cédées.
Le prix de la cession a été réglé antérieurement à la signature du présent acte.
<i>Approbation de cession de partsi>
Les gérants, la société DELMA, préqualifiée, et Monsieur Philippe Sourdeau, demeurant à B-1480 Tubize, 114/5, rue
de la Déportation, ici représenté par Monsieur Benoît de Bien préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé,
donnée à B-Tubize, le 11 janvier 2006, déclarent accepter ladite cession au nom de la société A.P.S.I., S.à r.l. conformé-
ment à l’article 1690 nouveau du Code civil et n’avoir entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse
arrêter l’effet de la susdite cession. Ensuite l’associé unique, représenté comme prédit, a requis le notaire instrumentant
d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de dissoudre la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique approuve les comptes de liquidation basés sur la situation comptable au 31 décembre 2005, date à
laquelle la société a cessé toute d’activité.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique accepte la reprise des actifs et de deux dettes après apurement de toutes les charges de liquidation
suivant rapport de liquidation fourni au Notaire instrumentant et qui restera annexé au présent acte.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de donner décharge aux gérants jusqu’à la date de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée au 31 décembre 2005.
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’an-
cien siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
48629
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s’élè-
vent approximativement à la somme de 950,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée auX comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. De Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 19 janvier 2006, vol. 319, fol. 95, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(915156/2724/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 février 2006.
CB COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 96.543.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme CB COMMER-
CIAL S.A. tenue extraordinairement en date du 6 février 2006 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:
- L’assemblée a approuvé la décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2005 de nommer la
société CARDINAL TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société
TEMPLE AUDIT SC, démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.
<i>Commissaire aux comptes:i>
CARDINAL TRUSTEES LIMITED, 9, Pelican Drive, Columbus Centre, Road Town (Tortola), Iles Vierges
Britanniques.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN01971. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022418/4642/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
MICROS-FIDELIO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 62.500,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 100.796.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2004 que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistré à Luxem-
bourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01196, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022695/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
MICROS-FIDELIO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 62.500,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 100.796.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2005 que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistré à Luxem-
bourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01200, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022696/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Wiltz, le 3 février 2006.
A. Holtz.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Signature.
Signature.
48630
TRADITIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 69.093.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 janvier 2006 que:
- Monsieur Riccardo Moraldi a démissionné de sa fonction d’administrateur.
- Monsieur Bruno Beernaerts, né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant professionnellement à L-2220
Luxembourg, 560, rue de Neudorf a été nommé nouvel administrateur, son mandat expirant à l’issue de la prochaine
assemblée générale qui se tiendra en l’an 2011.
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. a démissionné en tant que Commissaire aux Comptes.
- Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant
professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis a été nommé Commissaire aux Comptes son mandat
expirant à l’issue de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en l’an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00789. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022420/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
GOLD BROKER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 70.933.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 janvier 2006i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 janvier 2006 que:
- Monsieur Riccardo Moraldi a démissionné de sa fonction d’administrateur.
- Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975 demeurant professionnellement à L-2220 Luxem-
bourg, 560, rue de Neudorf a été nommé nouvel administrateur, son mandat expirant à l’issue de la prochaine assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2011.
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. a démissionné en tant que Commissaire aux Comptes.
- Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône-et-Loire (France), le 25 septembre 1968, demeu-
rant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis a été nommé Commissaire aux Comptes, son mandat
expirant à l’issue de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en l’an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022469/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
HIPPER S.A. - SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE
RENOUVELABLE, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 113.485.
—
L’an deux mille six, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Antonella Graziano, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-
nyme HIPPER S.A. - SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE, ayant
son siège social à Luxembourg,
en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise en sa réunion du 28 décembre 2005.
Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la
comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) La société anonyme HIPPER S.A. - SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE
RENOUVELABLE a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 décembre 2005, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
48631
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 16.000
(seize mille) actions de EUR 2,- (deux euros) chacune.
3) Conformément à l’article 3 des statuts, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial
à concurrence de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR
32.000,- (trente-deux mille euros) à EUR 1.532.000,- (un million cinq cent trente-deux mille euros), le cas échéant par
l’émission de d’actions nouvelles de EUR 2,- (deux euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes,
aux conditions et modalités qu’il fixera.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
4) Par décision du 28 décembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à la réalisation d’une pre-
mière tranche d’augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé à concurrence de cinq cent trente-deux euros
(EUR 532,-) pour porter le capital souscrit ainsi de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à
trente-deux mille cinq cent trente-deux euros (EUR 32.532,-) par la création et l’émission de deux cent soixante-six
(266) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, émise avec une prime d’émission de
cent trente-huit virgule soixante-deux soixante euros (138,6260) par action, soit une prime d’émission globale de trente-
six mille huit cent soixante-quatorze virgule cinquante-deux euros (EUR 36.874,52).
Les deux cent soixante-six (266) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées par un versement en
espèces, de sorte que la somme de trente-sept mille quatre cent six virgule cinquante-deux euros (EUR 37.406,52)
faisant cinq cent trente-deux euros (EUR 532,-) pour le capital et trente-six mille huit cent soixante-quatorze virgule
cinquante-deux euros (EUR 36.874,52) pour la prime d’émission a été mise à la disposition de la Société.
Les documents justificatifs de la souscription ainsi que du versement en espèces ont été présentés au notaire soussi-
gné, qui le constate expressément.
5) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, les trois premiers alinéa de l’article 3 des statuts sont modifiés
et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 3. (alinéas 1
er
, 2, 3). Le capital social est fixé à EUR 32.532,- (trente-deux mille cinq cent trente-deux euros)
représenté par 16.266 (seize mille deux cent soixante-six) actions de EUR 2,- (deux euros) chacune.
Toutes les actions seront au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 1.499.468,- (un mil-
lion quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-huit euros) pour le porter de son montant actuel de
EUR 32.532,- (trente-deux mille cinq cent trente-deux euros) à EUR 1.532.000,- (un million cinq cent trente-deux mille
euros), le cas échéant par l’émission de d’actions nouvelles de EUR 2,- (deux euros) chacune, jouissant des mêmes droits
que les actions existantes.»
<i>Version anglaise des trois premiers alinéas de l’article 3 des statuts:i>
«The corporate capital is fixed at EUR 32,532.- (thirty-two thousand five hundred and thirty-two Euro) represented
by 16,266 (sixteen thousand two hundred and sixty-six) shares of EUR 2.- (two Euro) each.
The shares shall be in bearer form or in registered form at the Shareholder’s request.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by EUR 1,499,468.- (one million four
hundred and ninety-nine thousand four hundred and sixty-eight Euro) in order to raise it form EUR 32,532.- (thirty-two
thousand five hundred and thirty-two Euro) to EUR 1,532,000.- (one million five hundred and thirty-two thousand Euro)
as the case may be by the issue of new shares of a par value of EUR 2.- (two Euro) each, having the same rights as the
existing shares.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de EUR 2.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Graziano, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 janvier 2006, vol. 435, fol. 25, case 1. – Reçu 374,07 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023388/242/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
HIPPER S.A. - SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE
RENOUVELABLE, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 113.485.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023390/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Mersch, le 9 février 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 3 mars 2006.
H. Hellinckx.
48632
EFISIA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.703.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration de la société tenue au siège social le 23 février 2006i>
Le Conseil d’Administration a décidé de déléguer à Alvar Virkus, administrateur de la société, demeurant profession-
nellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la repré-
sentation de la société, en ce qui concerne cette gestion. Cette délégation s’est faite dans le respect de l’autorisation
préalable octroyée par l’assemblée générale des actionnaires du 23 février 2006. Il aura le pouvoir de signature
individuel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01282. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 23 février 2006, lors de l’Assemblée Générale de la sociétéi>
- La démission de Pascale Loewen, Jean-Marc Faber et Marc Muller en tant qu’administrateurs de la société a été
acceptée.
- Alvar Virkus, né le 10 décembre 1968 à Kivioli (Estonie), demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882
Luxembourg, Märt Meerits, né le 13 février 1974 à Tallinn (Estonie), demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll,
L-1882 Luxembourg et Kiril Marinov Deltchev, né le 15 juillet 1959 à Sofia (Bulgarie), demeurant professionnellement
au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg ont été nommé administrateurs en leur remplacement. Les nouveaux Admi-
nistrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.
- Le Conseil d’Administration est autorisé, conformément à l’article 8 des statuts, à désigner un administrateur-
délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01283. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022421/717/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
SeeReal TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 112.913.
—
In the year two thousand and six, on the eleventh of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SeeReal TECHNOLOGIES S.A., (R.C.S. Luxem-
bourg, section B number 112.913) (hereinafter, the «Corporation»), having its registered office in Luxembourg, incor-
porated by deed of the undersigned notary, on December 14, 2005.
The meeting is presided over by Mrs Claire Sablot, company secretary, with professional address at L-1528 Luxem-
bourg, 3, boulevard de la Foire.
The chairman appoints as secretary Mr Marc Albertus, private employee, with professional address at L-1528 Lux-
embourg, 5, boulevard de la Foire.
The meeting elects as scrutineer Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address
at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The chairman declares and requests the notary to record:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- As it appears from the attendance list, all the 20.168 (twenty thousand one hundred and sixty-eight) shares are
represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.
III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Increase of capital in the amount of EUR 45,000.-, to raise it from EUR 2,016,800.- to EUR 2,061,800.- by the issu-
ance of 450 shares of EUR 100.- each, to be issued with a total issue premium of EUR 955,000.- and benefiting of the
same rights and advantages as the presently issued shares.
2. Subscription of the 450 new shares by I2I HOLDING S.A., 3, boulevard de la Foire L-1528, Luxembourg, paid-up
in cash.
EFISIA INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
EFISIA INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
48633
3. Amendment of the first paragraph of article five of the by-laws, which henceforth will read as follows:
Art. 5. first paragraph. «The subscribed capital of the company is fixed at EUR 2,061,800.- (two million sixty-one
thousand eight hundred Euro) divided into 20,618 (twenty thousand six hundred eighteen) shares with a par value of
EUR 100.- (one hundred Euro) each.»
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the capital by an amount of EUR 45,000.- (forty-five thousand Euro) to raise it from
EUR 2,016,800.- (two million sixteen thousand eight hundred Euro) to EUR 2,061,800.- (two million sixty-one thousand
eight hundred Euro) by the issuance of 450 (four hundred and fifty) shares of EUR 100.- (one hundred) each, to be issued
with a total issue premium of EUR 955,000.- (nine hundred fifty-five thousand Euro) and benefiting of the same rights
and advantages as the presently issued shares.
The meeting admits the Company I2I HOLDING S.A., having its registered office in L-1528 Luxembourg, 3, boulevard
de la Foire to the subscription of the new shares, the other shareholders waiving their preferential subscription right.
<i>Subscription and paymenti>
With the agreement of all the shareholders, the 450 (four hundred and fifty) new shares are subscribed by I2I
HOLDING S.A. predesignated,
here represented by Mrs Claire Sablot, prenamed, by virtue of a proxy hereto attached.
The new shares thus subscribed are fully paid up in cash, so that the amount of EUR 1,000,000.- (one million Euro),
whereof EUR 45,000.- (forty-five thousand Euro) are allocated to the capital and EUR 955,000.- (nine hundred fifty-five
thousand Euro) to the issue premium, is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article five of the by-laws is amend and will hence-
forth read as follows:
Art. 5. first paragraph. «The subscribed capital of the company is fixed at EUR 2,061,800.- (two million sixty-one
thousand eight hundred Euro) divided into 20,618 (twenty thousand six hundred eighteen) shares with a par value of
EUR 100.- (one hundred Euro) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 12,500.-.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le onze janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SeeReal TECHNOLOGIES
S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 112.913) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 décembre 2005.
L’assemblée est présidée par Madame Claire Sablot, «company secretary», demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Albertus, employé privé, demeurant professionnellement à
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant
professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Monsieur président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les 20.168 (vingt mille cent soixante-huit) actions sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée et
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite con-
naissance.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 45.000,- pour le porter de EUR 2.016.800,- à EUR
2.061.800,- par l’émission de 450 actions nouvelles de EUR 100,- chacune, à émettre avec une prime d’émission totale
de EUR 955.000,- (neuf cent cinquante-cinq mille euros), ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
48634
2.- Souscription des 450 actions nouvelles par I2I HOLDING S.A., 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, à
libérer en espèces.
3.- Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. premier paragraphe. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.061.800,- (deux millions soixante
et un mille huit cents euros) représenté par 20.618 (vingt mille six cent dix-huit) actions d’une valeur nominale de EUR
100,- (cent euros) chacune.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 45.000,- (quarante-cinq mille euros) pour le
porter de EUR 2.016.800,- (deux millions seize mille huit cents euros) à EUR 2.061.800,- (deux millions soixante et un
mille huit cents euros) par l’émission de 450 (quatre cent cinquante) actions nouvelles de EUR 100,- (cent euros) cha-
cune, à émettre avec une prime d’émission totale de EUR 955.000,- (neuf cent cinquante-cinq mille euros), ayant les
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
L’Assemblée admet la société I2I HOLDING S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire, à
la souscription des actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les 450 (quatre cent cinquante) actions nouvelles sont souscrites par la société
I2I HOLDING S.A., prédésignée,
ici représentée par Madame Claire Sablot, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, ci-annexée.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR
1.000.000,- (un million d’euros), faisant EUR 45.000,- (quarante-cinq mille euros) pour le capital et EUR 955.000,- (neuf
cent cinquante-cinq mille euros) pour la prime d’émission, se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. premier paragraphe. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.061.800,- (deux millions soixante
et un mille huit cents euros) représenté par 20.618 (vingt mille six cent dix-huit) actions d’une valeur nominale de EUR
100,- (cent euros) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 12.500,-.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: C. Sablot, M. Albertus, L. Hansen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 janvier 2006, vol. 435, fol. 9, case 12. – Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023357/242/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
SeeReal TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 112.913.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023358/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Mersch, le 24 janvier 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 3 mars 2006.
H. Hellinckx.
48635
DOUMART CONSULTING S.A., Société Anonyme,
(anc. DOUMART HOLDING S.A.).
Siège social: L-1420 Luxembourg, 260, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 98.791.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 2005i>
<i>Première résolutioni>
Suite à la démission de leur mandat d’administrateurs des personnes suivantes:
- Monsieur Pierre, Fernand, Ghislain Dumont, cadre, domicilié au 68, rue de Musy à B-6600 Bastogne;
- Monsieur Dominique Goulem, cadre, domicilié à Tontelerwee, 54, L-8552 Oberpallen,
l’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires
pour un mandat de trois ans, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2008
relative à l’année 2007, les personnes suivantes:
- Monsieur David Missenard, consultant, demeurant 260, avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg;
- Madame Dominique Martelleur, mère de famille, demeurant à B-6700 Arlon, Ch. Glissisbour 16, Frassem.
L’assemblée renouvelle pour une durée de trois le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre Doumont,
consultant, demeurant à B-6700 Arlon, Ch. Glissisbour 16, Frassem.
Son mandat prendra également fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2008, relative à l’année
2007.
L’assemblée générale nomme en tant que commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans la FIDUCIAIRE
REUTER ET HUBERTY, S.à r.l., ayant son siège social 134, route d’Arlon à L-8008 Strassen.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs-délégués pendant la même durée que leur mandat d’administrateur, Messieurs
Doumont Jean-Pierre et Missenard David, ci-avant nommés.
<i>Troisième résolutioni>
La société sera, dans tous cas, engagée par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués, dont obligatoi-
rement celle de Monsieur Doumont Jean-Pierre. En cas de délégation de pouvoirs à un tiers par le conseil d’administra-
tion, la signature de Monsieur Doumont Jean-Pierre sera également requise sur cette délégation de pouvoir.
Strassen, le 16 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04100. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022482/578/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
PLACEMENTS FINANCIERS ET INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 77.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01078, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023124/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
IMMOBILIERE DE WARKEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 66.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01757, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
(023208/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Signature.
<i>Pouri> <i>IMMOBILIERE DE WARKEN S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>R. Thillens
48636
SCI TEBERU, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 257A, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg E 2.552.
—
Il résulte d’une convention de cession de parts d’intérêts sous seing privé du 12 janvier 2001, que Monsieur Marco
Bei, demeurant à Bascharage, a cédé 50 parts d’intérêts sur les 100 qu’il détenait dans la société SCI TEBERU à Monsieur
Franco Tega, demeurant à Luxembourg, et 50 parts d’intérêts à Monsieur Nico Russo, demeurant à Livange.
En conséquence, à compter du 12 janvier 2001, la répartition du capital social de la SCI TEBERU est comme suit:
En outre les associés constatent que Monsieur Marco Bei a démissionné de son poste de gérant avec effet au 12
janvier 2001.
Sont confirmés comme gérants de la société Monsieur Franco Tega et Monsieur Nico Russo. La société est valable-
ment engagée en toutes circonstances sous la signature individuelle d’un de ses gérants.
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08970. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(022491/820/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
NEOCELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 111.978.
—
Il résulte de deux conventions de transfert de parts sociales datées du 24 janvier 2006, que l’associé unique de
NEOCELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, est à compter de cette date:
- CROWNFEX LIMITED, une société de droit chypriote, ayant son siège social au 27 Pindarou Street, Alpha Business
Center, 1060 Nicosie, Chypre, enregistrée au Registre du Commerce de Chypre sous le numéro 133349.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00782. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022494/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
NEDAMO CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.051.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 février 2006i>
1. L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateurs de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé,
avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A.,
ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
2. L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Gilles Jacquet, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Monsieur David Giannetti, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et LUX BUSINESS MANAGEMENT,
S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 20 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05693. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022495/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
1. Monsieur Franco Tega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 parts d’intérêts
2. Monsieur Nico Russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 parts d’intérêts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts d’intérêts
F. Tega / N. Russo
<i>Gérant / Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
48637
C.A.L., CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT LUXEMBOURGEOISE,
Groupement Européen d’Intérêt Economique.
Siège social: L-4710 Pétange, 28, rue d’Athus.
R. C. Luxembourg D 5.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Bureau tenue le jeudi 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2005i>
Les débats ont été ouverts par le Président.
Il a été arrêté ce qui suit:
1. Départ d’un membre au 1
er
septembre 2005.
1) La société ARS GROUPE, S.à r.l., 7, Bohey à L-9647 Doncols, représentée par M. Arthur Schmitt ou Mme Claudia
Garcia.
2. Nouvelle liste des membres du groupement depuis le 1
er
septembre 2005:
1) SUD BOISSONS, S.à r.l., 24-30, rue d’Athus à L-4710, Pétange représentée par M. Pierre Dall’Asparago ou Mme
Viviane Kreins-Guelff;
2) CARFRANK DISTRIBUTION, S.à r.l., 13, route d’Arlon à L-8832 Rombach, représentée par M. Frank Melchior
ou M. Nicolas Melchior;
3) OLSEM-MAGLICA, 5, Place du Marché à L-5555 Remich, représentée par M. Fernand Olsem;
4) DPS, S.à r.l., 2, rue des Tilleuls à L-8832 Rombach, représentée par M. Denis Van den Abbeel ou M. Stéphane Van
den Abbeel;
5) RUWA, S.à r.l., 32, rue des Martyrs à L-3739 Rumelange, représentée par M. Aloyse Pier;
6) MUNHOWEN S.A., 30, rue des Scillas à L-2529 Howald, représentée par M. Daniel Thilmany ou M. Pouillon;
7) RIAL & CO S.e.c.s., 4, rue de Stavelot à L-9964 Huldange, représentée par Monsieur Rickal;
8) JOHANNS & CIE, S.à r.l., 69, route de Luxembourg à L-8440 Steinfort, représentée par Fons Johanns.
Lu et approuvé par l’ensemble des membres du bureau, soit:
Pétange, le 1
er
septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03576. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(022592/578/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
LAHNDRIK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 14.622.
—
Le bilan abrégé au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01592, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022669/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
VITONY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 87.513.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01380, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022698/318/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
VITONY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 87.513.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01384, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022697/318/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
P. Dall’Asparago / A. Pier / A. Pier
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
Luxembourg, le 9 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
Signature.
48638
BRE/BIELEFELD I HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxemburg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 114.671.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-third day February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, not yet registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Frau Virginie Lepage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal in Luxembourg, on 23 February 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. - Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,
lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplis-
hment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of BRE/BIELEFELD I HOTEL, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of
managers.
B. - Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represen-
tative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
48639
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-
ments of the Company.
C. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,
and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a ma-
nager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the sha-
reholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the
Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represen-
ted at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of
shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
48640
E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of
December of the same year.
Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The 500 shares have been subscribed as follows:
500 shares by BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-appea-
ring party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister,
hier vertreten durch Frau Virginie Lepage, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Februar 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-
ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
48641
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften
und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb,
die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen
Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/BIELEFELD I HOTEL, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.
B. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die
drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die
Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an
Vermögensgütem oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen
werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei
Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-
nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsfüh-
rerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
48642
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen
Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates
vertreten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen
Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-
den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. - Geschäftsjahr, Kontengewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. - Gesellschaftsauflösung, Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
48643
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 500 Anteile wurden von BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendneunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: V. Lepage, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 février 2006, vol. 435, fol. 71, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): E. Weber.
Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
erteilt.
(023239/242/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
PHARMACIES EUROPEENNES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.650.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40783 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 mars 2006.
(022674/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 29.760.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00690, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022677//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Mersch, den 9. März 2006.
H. Hellinckx.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
48644
BRE/FRANKFURT I HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxemburg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 114.682.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-third day February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, not yet registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Ms Virginie Lepage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal in Luxembourg, on 23 February 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. - Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,
lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-
istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of BRE/FRANKFURT I HOTEL S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.
B. - Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
48645
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-
ments of the Company.
C. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,
and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-
pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Com-
pany.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
48646
E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The 500 shares have been subscribed as follows:
500 shares by BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences be-
tween the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche übersetzung des englischen textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister,
hier vertreten durch Frau Virginie Lepage, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Februar 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-
ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
48647
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften
und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb,
die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen
Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/FRANKFURT I HOTEL, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.
B. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die
drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-
nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsfüh-
rerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
48648
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. - Entscheidungen des alleinigen gesellschafters, Hauptversammlungen der gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-
den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. - Geschäftsjahr, Kontengewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. - Gesellschaftsauflösung, Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
48649
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
500 Anteile wurden von BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendneunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter Sektion B Nummer 96323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: V. Lepage, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 février 2006, vol. 435, fol. 71, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): E. Weber.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
erteilt.
(023299/242/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
BLACKSMITH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 104.230.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40392 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 mars 2006.
(022676/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 15.319.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00691, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022680//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Mersch, den 9. März 2006.
H. Hellinckx.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
48650
ASIA CONSUMER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 40,000.-.
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 112.698.
—
In the year two thousand and six, on the second day of February.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, represented
by its general partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, a Jersey limited company having its registered office
at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commis-
sion under number 87453;
2. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, L.P., a limited partnership governed by the
laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street, Grand Cayman,
Cayman Islands, represented by its general partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, prenamed;
hereby represented by Mrs Emanuela Brero, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies.
The meeting of the shareholders is presided by Mrs Emanuela Brero, director of corporate administration;
who appoints as secretary Mr Daniel Boone, attorney at law;
The meeting appoints as scrutineer Mrs Raffaella Quarato, attorney-at-law.
The appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary to enact the follow-
ing:
That they are the current shareholders (collectively the «Shareholders» or the «Subscribers» or individually a «Share-
holder») of the company ASIA CONSUMER HOLDINGS, S.à r.l (the «Company»), a société à responsabilité limitée
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613
Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under section B, number
112.698.
That the Shareholders have decided to vote on all the items of the following agenda:
(i) Decision to increase the subscribed capital by an amount of EUR 385,000.- (three hundred eighty-five thousand
EUR) to bring it from its present amount of EUR 40,000.- (forty thousand Euro) to EUR 425,000.- (four hundred and
twenty-five thousand Euro) by the issuance of 15,400 (fifteen thousand four hundred) new shares (parts sociales) of EUR
25.- (twenty-five Euro) (the «New Shares»).
(ii) Decision to accept the subscription of the New Shares by the current shareholders of the Company by payment
in cash of the New Shares; and
(iii) Decision to amend art. 6.1, paragraph 1 («Share capital») of the articles of association of the Company, which
shall thereafter read as follows:
«The Company’s corporate capital is fixed at EUR 425,000.- (four hundred twenty-five thousand Euro) represented
by 17,000 (seventeen thousand) shares («parts sociales») of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and
entirely paid up».
That, on the basis of the above agenda, the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders, represented as stated here-above decide to increase the subscribed capital of the Company by an
amount of EUR 385,000.- (three hundred eighty-five thousand Euro) to bring it from its present amount of EUR 40,000.-
(forty thousand Euro) to EUR 425,000.- (four hundred twenty-five thousand Euro) by the issuance of 15,400 (fifteen
thousand four hundred) New Shares (parts sociales) of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, having the same rights and
obligations as the existing shares and to have them subscribed and entirely paid up by the Shareholders:
<i>Subscription - Paymenti>
The Shareholders, represented as stated here-above, declare to subscribe to 15,400 (fifteen thousand four hundred)
New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, as follows:
All the New Shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the
counter-value of an amount of EUR 385,000.- (three hundred eighty-five thousand Euro) is now available to the Com-
pany, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders, represented as stated above, decide to amend Ar-
ticle 6 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:
Art. 6.1. paragraph 1 («Share capital»). «The Company’s corporate capital is fixed at EUR 425,000.- (four hun-
dred twenty-five thousand Euro) represented by 17,000 (seventeen hundred) shares («parts sociales») of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up».
Shareholders
Subscribed News Shares
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,908
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, L.P . . . . . . . . . . . . . . .
2,492
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,400
48651
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
For the purpose of registration, the increase of capital is valued at 385,000.- EUR (three hundred eight-five thousand
Euro).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 5,500.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P., un limited partnership constitué sous les lois des Iles Caïmans,
ayant son siège social à PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, représenté par
son associé gérant CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, une société basée à Jersey, ayant son siège social au
22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, enregistrée auprès du Financial Services Commission
sous le numéro 87453;
2. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, L.P., un limited partnership constitué sous les
lois des Iles Caïmans, PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, représenté par son
associé gérant CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, précité;
ici représenté(e/s) par Madame Emanuela Brero, résidant à Luxembourg, en vertu de deux procurations.
L’assemblée est présidée par Madame Emanuela Brero, gérante de sociétés;
qui nomme comme secrétaire Monsieur Daniel Boone, avocat à la Cour.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Raffaella Quarato, avocate.
Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui
suit:
Qu’elles sont les associés actuels (les «Associés Actuels» ou les «Souscripteurs» ou individuellement l’«Associé Ac-
tuel») de ASIA CONSUMER HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, régie par le droit
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, enregistrée auprès
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.698.
Que les Associés Actuels ont décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
(i) Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 385.000,- (trois cent quatre-vingt-cinq
mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 40.000,- (quarante mille euros) à EUR 425.000,- (quatre
cent vingt-cinq mille euros), par l’émission de 15.400 (quinze mille quatre cents) Nouvelles Parts Sociales d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) (les «Nouvelles Parts Sociales»);
(ii) Décision d’accepter la souscription des Nouvelles Parts Sociales par les Associés Actuels et paiement de ces parts
sociales par apport intégral en numéraire; et
(iii) Décision de modifier l’article 6.1 des statuts de la Société (Capital souscrit) qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 425.000,- (quatre cent vingt-cinq mille euros) représenté par 17.000 (dix-sept mille)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées».
Que, sur la base de cet agenda, les Associés Actuels ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés Actuels, représentés comme susmentionné, décident d’augmenter le capital social d’un montant de EUR
385.000,- (trois cent quatre-vingt-cinq mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 40.000,- (soixante
mille euros) à EUR 425.000,- (quatre cent vingt-cinq mille euros) par l’émission 15.400 (quinze mille quatre cents) Nou-
velles Parts Sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), chacune des Nouvelles Parts Sociales ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et de les laisser souscrire et libérer entièrement par les
Associés Actuels:
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Les Associés Actuels, représentés comme susmentionné, déclarent souscrire à 15.400 (quinze mille quatre cents)
Nouvelles Parts Sociales et les libérer entièrement à leur valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, com-
me suit:
Associés Actuels
Nombre de Nouvelles Parts Sociales
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.908
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, L.P. . . . . .
2.492
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.400
48652
Toutes les parts sociales ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) moyennant un apport en numéraire
de sorte que la contre valeur d’un montant de EUR 385,000.- (trois cent quatre-vingt-cinq mille euros) se trouve à
présent à la disposition de la Société, preuve en étant donnée au notaire.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la précédente résolution, les Associés Actuels, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de
modifier l’article 6 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
Art. 6.1. paragraphe 1
er
(Capital souscrit). «Le capital social est fixé à EUR 425.000,- (quatre cent vingt-cinq
mille euros) représenté par 17.000 (dix-sept mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Dans le cadre de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à EUR 385.000,- (trois cent-quatre-vingt-cinq
mille euros).
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la Société à raison du
présent acte, sont estimés à EUR 5.500,-.
Le notaire instrumentant, qui maîtrise la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent
acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, dressé et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: E. Brero, D. Boone, R. Quarato, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 27, case 7. – Reçu 3.850 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023183/208/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
ASIA CONSUMER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 425.000.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 112.698.
—
Statuts coordonnés en date 2 février 2006, suite à l’acte n
°
46 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de rési-
dence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023185/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
DOULU INVESTISSEMENT S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 95.055.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00925, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023237/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
DOULU INVESTISSEMENT S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 95.055.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00927, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023241/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
Signature.
48653
ANNANDALE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 39.539.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00692, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022683//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
BHF-BANK INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 10.008.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01402, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2006.
(022686//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 72.990.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00703, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2006.
(022688//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
CEBARRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.187.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 décembre 2005i>
- Les démissions de Messieurs François Mesenburg, Pierre Mestdagh et Jean-Paul Reiland de leur mandat d’Adminis-
trateur sont acceptées.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec
siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux
Administrateurs. Les mandats des sociétés MADAS, S.à r.l., FINDI, S.à r.l. et LOUV, S.à r.l. viendront à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(022690/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Signature
<i>Administrateuri>
BHF-BANK INTERNATIONAL
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
Certifié sincère et conforme
<i>CEBARRE HOLDING S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature / Signature
48654
COMAGA S.A., Société Anonyme,
(anc. LEISURE INVESTMENT S.A.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.612.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01618, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023122/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
T.B.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.105.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01615, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023125/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
FULL MUSIC SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.073.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00836, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
(023126/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
LA CAPITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.
R. C. Luxembourg B 68.183.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01074, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023127/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
ALPHA FACTORING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.697.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eighth day of February.
Before the undersigned Maître Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SILVER POINT CAPITAL FUND, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware,
United States of America, having its registered office at The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilming-
ton, New Castle County, Delaware 19801,
here represented by Mrs Ginka Côme-Lambrich, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
and
SILVER POINT CAPITAL OFFSHORE FUND, LTD., a limited liability company incorporated and existing under the
laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box
908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Mrs Ginka Côme-Lambrich, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>FULL MUSIC SERVICES S.A.
i>FIDUCIAIRE FORIG SC
Signature
Signature.
48655
These proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the
deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:
A. - Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities and participations of any kind and the administration,
control and development of its portfolio. The Company may guarantee, grant loans or otherwise assist the companies
in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
In addition, the purpose of the Company is to do factoring business, including financing, sale and acquisition of receiv-
ables and collection of such receivables (including initiating and leading of any judicial or other proceedings) in Luxem-
bourg or any other foreign country, by itself or by its affiliated companies.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of ALPHA FACTORING, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the City of Luxembourg by decision of the sole manager or, as the case may be, by means of a resolution of the board
of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. - Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) represented by two thousand (2,000)
shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred to new
shareholders subject to the prior approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
Art. 8. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital or, as the case may be, by the sole shareholder.
Art. 9. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. - Management
Art. 11. The Company is to be managed by one or several managers, who does/do not need to be shareholders.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The
manager(s) is/are appointed by the shareholder(s) who fix(es) the term of his/their office. The manager(s) may be dis-
missed freely at any time by the shareholder(s), without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).
The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-
agers, by the joint signature of any two members of the board of managers or the signature of any person to whom such
signatory power shall be delegated by the sole manager/the board of managers. The sole manager / board of managers
may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 12. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a manager and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of
meeting. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of managers, but in his absence the
managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or electronic transmission of each manager.
Separate notice shall also not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have
declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
48656
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the
genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present
or represented at such meeting.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which
may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two man-
agers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. - Collective decisions of the shareholders, Decisions of the sole shareholder
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he/
it owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he/it holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 18. A sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 19. The Company’s financial year Commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 20. Each year as of the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare a record
of the assets and liabilities of the Company as well as a profit and loss account. The credit balance of the profit and loss
account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the
Company. Each shareholder may inspect the above record and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim
dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. - Dissolution, Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or, as the case
may be, by the sole shareholder which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them unless otherwise agreed in writing or, as
the case may be, to the sole shareholder.
Neither a merger nor consolidation of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or
consolidation of any other entity or entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash,
securities or other consideration) of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation
within the meaning of this Article 22, unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in
connection with or intended to be a plan of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
One thousand (1,000) shares have been subscribed by SILVER POINT CAPITAL FUND, L.P., as aforementioned, for
a total price of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-).
One thousand (1,000) shares have been subscribed by SILVER POINT CAPITAL OFFSHORE FUND, LTD., as afore-
mentioned, for a total price of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-).
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-), entirely allocated
to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
48657
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entire subscribed capital,
have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period of time:
- Frederick H. Fogel, Corporate Counsel, born on 19 January 1960 in New Jersey, United States of America, residing
140, Riverside Drive, New York, NY 10024, United States of America;
- James Mallory Karp, Investment Manager, born on 15 January 1966 in Rhode Island, «United States of America,
residing at 28, Hestercombe Avenue, London SW65LG, England;
- Michel van Krimpen, lawyer, born on 19 February 1968 in Rotterdam, The Netherlands, residing 14, rue Oster, L-
8146 Bridel, Luxembourg;
- Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in The Hague, The Netherlands, residing 39, rue Anatole
France, L-1530 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status
and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am achten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Hellinckx mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
SILVER POINT CAPITAL FUND, L.P., eine Gesellschaft gegründet und existierend nach dem Recht von Delaware,
Vereinigte Staaten von Amerika, mit Sitz in The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801,
hier vertreten durch Frau Ginka Côme-Lambrich, Jurist, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf Grund einer
Vollmacht unter Privatschrift.
und
SILVER POINT CAPITAL OFFSHORE FUND, LTD., eine Gesellschaft, gegründet und existierend nach dem Recht
der Cayman Islands, mit Sitz in Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 908 GT, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands.
hier vertreten durch Frau Ginka Côme-Lambrich, Jurist, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf Grund einer
Vollmacht unter Privatschrift.
Diese Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
In ihrer oben beschriebenen Eigenschaft ersuchen die erschienenen Parteien den unterzeichneten Notar, die Satzung
einer Gesellschaft mit beschränkten Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründen, wie folgt zu
beurkunden:
A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft
Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (nachstehend die
«Gesellschaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
in seiner jeweils gültigen Fassung sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften
und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, in denen sie eine
direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften
oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.
Zweck der Gesellschaft ist zudem die Ausübung von Factoringgeschäften, einschließlich Finanzierung, Verkauf und Er-
werb von Forderungen und Sammeln solcher Forderungen (einschließlich des Einleitens und Führens sämtlicher gericht-
licher oder anderer Verfahren) in Luxemburg oder in jedem anderen Land durch sie selbst oder durch verwandte
Unternehmen.
48658
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der
Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ALPHA FACTORING, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder
gegebenenfalls durch Beschluss des Geschäftsführerrates an jeden anderen Ort in Luxemburg-Stadt verlegt werden. Die
Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland
eröffnen.
B. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) aufgeteilt in zweitausend (2.000) Anteile
mit einem Wert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Anteile der Gesellschaft sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können nur mit vorheriger
Zustimmung der Mehrheit der übrigen Gesellschafter, die einem Anteil von drei Viertel am Gesellschaftskapital entspre-
chen muss, an neue Gesellschafter übertragen werden.
Art. 8. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die einem Anteil
von drei Vierteln am Gesellschaftskapital entsprechen muss, oder ggf. durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters
abgeändert werden.
Art. 9. Die Gesellschaft erkennt nur jeweils einen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer müssen einen einzigen
Vertreter ernennen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 10. Durch den Tod, die zeitweilige Aufhebung von Rechten, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines
Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.
C. - Geschäftsführung
Art. 11. Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht
Gesellschafter sein müssen.
Gegenüber Dritten hat/haben der/die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse, unter allen Umständen im
Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck
stehen, auszuführen und zu erlauben. Der/die Geschäftsführer wird/werden durch den/die Gesellschafter ernannt, der/
die dessen/deren Amtsdauer festsetzt/festsetzen. Der/die Geschäftsführer kann/können jederzeit ohne Angabe eines
rechtfertigenden Grundes («cause légitime») durch den/die Gesellschafter abberufen werden.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen nur durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder im Falle
mehrerer Geschäftsführer durch die gemeinsame Zeichnung durch zwei Geschäftsführer oder durch die Unterschrift
jeder Person verpflichtet, der die Befugnis zur Unterzeichnung durch den alleinigen Geschäftsführer bzw. den Geschäfts-
führerrat erteilt worden ist. Der alleinige Geschäftsführer/der Geschäftsführerrat kann besondere Vollmachten auf
Grund notariell beglaubigter oder privatschriftlicher Urkunde erteilen.
Art. 12. Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden ernennen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht und der für
das Führen der Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrates und der Gesellschafterversammlungen zuständig ist.
Der Geschäftsführerrat tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem
Einberufungsschreiben genannten Ort. Der Vorsitzende leitet alle Geschäftsführerratssitzungen und Hauptversammlun-
gen, aber in seiner Abwesenheit können die Geschäftsführer mit der Mehrheit der Anwesenden einen anderen vorläu-
figen Vorsitzenden ernennen.
Jedes Geschäftsführerratsmitglied erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem geplanten Sitzungsdatum ein
Einberufungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen die Natur der Dringlichkeit im Einberufungsschreiben
anzugeben ist. Durch schriftliche oder per Fax oder E-Mail gegebene Einwilligung eines jeden Geschäftsführers kann auf
das Einberufungsschreiben verzichtet werden.
Ein Einberufungsschreiben ist auch für solche Sitzungen nicht erforderlich, bei denen alle Geschäftsführer anwesend
oder vertreten sind und erklären, dass sie vor der Sitzung von der Tagesordnung Kenntnis hatten, sowie für einzelne
Sitzungen, die zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden, die vorher durch Beschluss des Geschäftsführerrates
festgesetzt wurden.
Jeder Geschäftsführer kann sich an jeder Sitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, den er
schriftlich, auch per Faxschreiben oder, wenn die Herkunft erwiesen ist, per E-Mail, ernannt hat.
Der Geschäftsführerrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend
oder vertreten ist. Entscheidungen werden mit einer Mehrheit der an einer solchen Sitzung anwesenden oder vertre-
tenen Geschäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann durch eine Konferenzschaltung oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel an einer
Sitzung teilnehmen unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme
an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.
Der Geschäftsführerrat kann einstimmige Beschlüsse auf einem oder mehreren voneinander getrennten ähnlichen
Dokumenten durch Rundschreiben fassen, wenn er seine Zustimmung schriftlich, per Fax, per E-Mail oder durch jedes
andere Kommunikationsmittel erteilt. Die Gesamtheit solcher Dokumente bildet das als Beweis der Beschlussfassung
geltende Protokoll.
48659
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der
Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden, vom Sekretär oder
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer dies sein sollte, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. - Entscheidungen der Hauptversammlung der Gesellschafter, Entscheidungen des alleinigen
Gesellschafters
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Eine Satzungsänderung erfordert die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Ein alleiniger Gesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Abschnitt XII des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung zustehen.
E. - Geschäftsjahr, Konten, Gewinnausschüttungen
Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 20. Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und der/die Geschäftsführer
stellt/stellen ein Verzeichnis aller Aktiva und Passiva und eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Das positive Ergebnis
der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Belastungen und Rückstellungen
ist der Nettogewinn der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Verzeichnis und die
Bilanz nehmen.
Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Ab-
schlagszahlungen auf Dividenden können in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen werden.
F. - Auflösung, Liquidation
Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter legen die Be-
fugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Sofern nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse
zur Verwertung des Vermögens und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Überschuss wird unter den Gesellschaf-
tern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt, insofern keine anderen schriftlichen Vereinbarun-
gen getroffen wurden, oder an den alleinigen Gesellschafter ausgeschüttet.
Weder eine Fusion noch eine Zusammenführung der Gesellschaft mit einer oder mehreren Rechtsträgern, noch eine
Fusion oder Zusammenführung einer oder mehrerer Rechtsträger mit der Gesellschaft, noch ein Verkauf, eine Über-
tragung, ein Leasing oder Tausch (gegen Geld, Sicherheiten oder anderweitige Gegenleistung) aller oder eines Teils der
Aktiva der Gesellschaft soll eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 22 bedeuten, es sei denn, diese Fusion, diese
Zusammenführung, dieser Verkauf, diese Übertragung, dieses Leasing oder dieser Tausch steht in Verbindung mit einer
völligen oder soll abzielen auf eine völlige Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft.
Art. 23. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung geregelt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Tausend (1.000) Anteile wurden von SILVER POINT CAPITAL FUND, L.P., vorgenannt, gezeichnet für einen Gesamt-
preis von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-).
Tausend (1.000) Anteile wurden von Silver Point Capital Offshore Fund, LTD., vorgenannt, gezeichnet für einen
Gesamtpreis von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-).
Alle Anteile wurden vollständig einbezahlt, so dass die Summe von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-), die vollständig
dem Gesellschaftskapital zugewiesen wird, von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 2.500,- geschätzt.
48660
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Kapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg;
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
- Frederick H. Fogel, Corporate Counsel, geboren am 19. Januar 1960 in New Jersey, Vereinigte Staaten von Amerika,
wohnhaft in 140, Riverside Drive, New York, NY 10024, Vereinigte Staaten von Amerika;
- James Mallory Karp, Investment Manager, geboren am 15. Januar 1966 in Rhode Island, Vereinigte Staaten von
Amerika, wohnhaft in 28, Hestercombe Avenue, London SW65LG England;
- Michel van Krimpen, Jurist, geboren am 19. Februar 1968 in Rotterdam, Niederlande, wohnhaft 14, rue Oster, L-
8146 Bridel, Luxemburg;
- Hille-Paul Schut, Jurist, geboren am 29. September 1977 in Den Haag, Niederlande, wohnhaft 39, rue Anatole
France, L-1530 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Erschienenen
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Abweichungen
zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Côme-Lambrich, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 février 2006, vol. 435, fol. 50, case 7. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.
(023420/242/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INTERMEDIAIRES DE COMMERCE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 83.121.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01645, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023134/1137/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
S.G. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 87.516.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01642, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023135/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
FINROPA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (dissoute).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.637.
—
Le bilan pour la période du 9 avril 2001 (date de constitution) au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8
mars 2006, réf. LSO-BO01454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023136/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Mersch, den 28. Februar 2006
H. Hellinckx.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 16 février 2006.
Signature.
48661
PROVENCE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 20.956.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00835, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
(023128/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
TD RETAIL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 101.620.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01737, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023129/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
FINROPA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (dissoute).
Siège social: L1470 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.638.
—
Le bilan pour la période du 9 avril 2001 (date de constitution) au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8
mars 2006, réf. LSO-BO01455, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023137/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
SWEDMEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.144.
—
Le bilan pour la période du 18 juin 2004 (date du constitution) au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars
2006, réf. LSO-BO01456, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023138/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
TRADEGRO HOLDINGS LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.
Siège social de la société mère: 7490 South Africa, 36 Stellenberg Road, Parow Industria.
Adresse de la succursale: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 89.393.
—
Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01573, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023273/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
<i>Pouri> <i>PROVENCE S.A. HOLDING
i>FIDUCIAIRE FORIG S.C.
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
Luxembourg, le 16 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
48662
BRE/PERLACH I HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxemburg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 114.683.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-third day February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, not yet registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Ms Virginie Lepage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal in Luxembourg, on 23 February 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. - Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,
lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-
istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of BRE/PERLACH I HOTEL S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.
B. - Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
48663
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-
ments of the Company.
C. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,
and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-
pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Com-
pany.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
48664
E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The 500 shares have been subscribed as follows:
- 500 shares by BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/WLANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of
time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences be-
tween the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister,
hier vertreten durch Frau Virginie Lepage, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Februar 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-
ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft
Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
48665
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften
und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb,
die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der
Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen
Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/PERLACH I HOTEL, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.
B. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die
drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-
nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsfüh-
rerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
48666
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann - mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-
den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. - Geschäftsjahr, Konten, Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. - Gesellschaftsauflösung, Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
48667
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 500 Anteile wurden von BRE/NINE HOTEL HOLDING, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendneunhundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
Sitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister un-
ter Sektion B Nummer 96323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: V. Lepage, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 février 2006, vol. 435, fol. 70, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): E. Weber.
Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(023301/242/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
CARIGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 46.153.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00616, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2006.
(023244/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
PHILOS S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02107, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023242/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Mersch, den 19. März 2006.
H. Hellinckx.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Signature.
48668
DANINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 87.558.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01754, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
(023192/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
DANINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 87.558.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01753, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
(023198/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
CORISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 87.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00618, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
(023245/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
G & P PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 82.889.
—
Le bilan clos au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01866, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023441/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
BARSAC INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00863, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023400/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
<i>Pour DANINVEST S.A.
i>J. Nicolas
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour DANINVEST S.A.
i>J. Nicolas
<i>Administrateur déléguéi>
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 9 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Signature.
48669
ROSALIA REAL ESTATE AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 114.710.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, den vierundzwanzigsten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.
Sind erschienen:
1. Die Aktiengesellschaft ROSALIA S.A., mit Sitz in L-3372 Leudelange, 28, am Bann;
hier vertreten durch Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann, handelnd in
ihrer Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates und allein vertretungsberechtigt;
2. Herr Günter Thiel, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann,
hier vertreten durch Frau Ulrike Holbach, vorbenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche dieser
Urkunde beigelegt bleibt, um mit dieser eingetragen zu werden.
Diese Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchen die unterzeichnete Notarin die Satzung einer Aktien-
gesellschaft, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck
Art. 1.
Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung ROSALIA REAL ESTATE
AG gegründet.
Art. 2.
(1) Der Sitz der Gesellschaft ist Leudelange.
(2) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis durch einfachen Beschluss, Büros, Verwaltungszentren, Niederlassungen,
Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Leudelange und durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.
(4) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxem-
burg als auch im Ausland zu errichten.
(5) Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.
Art. 3.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4.
(1) Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter welcher Form auch immer an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme
von allen anderen Anlageformen. Gesellschaftszweck ist ferner die Übernahme der Geschäftsführung von Gesellschaf-
ten.
(2) Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder Gesellschaften, die
derselben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.
(3) Darüber hinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller,
mobiliarer und immobiliarer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit
allen vergleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks
fördern können, vornehmen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen aufnehmen.
Aktienkapital - Aktien
Art. 5.
(1) Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- (einunddreissigtausend) Euro und ist eingeteilt in
100 (hundert) Aktien mit einem Nennwert von je 310,- (dreihundertzehn) Euro; das Aktienkapital wurde vollständig
eingezahlt.
(2) An Stelle von Einzelaktien können nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt
werden.
(3) Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
(4) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurück erwerben.
(5) Das gezeichnete und genehmigte Kapital der Gesellschaft kann darüber hinaus gemäß Beschluss der Generalver-
sammlung und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in einem oder mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt
werden.
48670
(6) Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt.
Das genehmigte Kapital beträgt 310.000,- EUR (dreihundertzehntausend Euro), eingeteilt in 1.000 (tausend) Aktien.
Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag an,
das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingun-
gen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann gültigen gesetzlichen Bestim-
mungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Gesetzes
wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungs-
rates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den bestehenden Ak-
tionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist
oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien
und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen.
Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung,
wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen,
respektiv genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom Gesetz vorgesehen,
vorzunehmen.
Art. 6.
Die Gesellschaft wird nur einen Eigentümer pro Aktie anerkennen. Für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen
gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, zu suspen-
dieren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer benannt wird; die gleichen Regeln
werden angewandt für den Fall eines zwischen einem Nießbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nu-proprié-
taire») oder zwischen einem Pfandschuldner und Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.
Verwaltung - Überwachung
Art. 7.
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre
sein müssen, besteht, die von der Hauptversammlung für eine Dauer, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, ernannt
werden, und die jederzeit abberufen werden können.
Art. 8.
(1) Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der
nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Verwaltungsratssit-
zungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen sind vom
Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu unterschreiben.
(2) Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von irgend zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates
unterzeichnet.
(3) Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an
dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammenkommen.
(4) Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder
vertreten ist.
(5) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Kabel,
Telegramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied
des Verwaltungsrates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
(6) Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die
Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.
(7) In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, denen alle Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich zustimmen
müssen, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.
(8) Die schriftliche Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder kann durch Unterzeichnung eines einzigen
Dokuments oder auf mehrfachen Abschritten eines identischen Beschlusses stehen und durch Brief, Telefax, Telegramm
oder Fernschreiben bestätigt werden.
Art. 9.
(1) Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im
Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptver-
sammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.
(2) Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der
Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem
vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des Verwal-
tungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglieder sein müssen)
übertragen, die nach einer vom Verwaltungsrat festgelegten Geschäftsordnung beraten und beschließen.
(3) Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an Personen, die nicht zwingenderweise Verwal-
tungsratsmitglied sein müssen, übertragen.
Art. 10.
Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
vertreten. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft auch durch die Einzelunterschrift von Per-
sonen vertreten, denen die tägliche Geschäftsführung übertragen wurde. Ferner wird die Gesellschaft durch die Einzel-
schrift von Personen vertreten, die der Verwaltungsrat entsprechend bevollmächtigt hat.
48671
Art. 11.
Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, die von der
Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden. Die Hauptversammlung legt auch die Anzahl, Bezüge und die
Dauer ihres Mandates fest, wobei die Mandatsdauer 6 Jahre nicht überschreiten kann.
Hauptversammlung
Art. 12.
Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der
Gesellschaft zu beraten und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu fassen.
Art. 13.
(1) Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-
gegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Freitag des Monates Juni in Luxemburg um 15.00 Uhr und zum ersten
Mal im Jahre 2007.
(2) Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
(3) Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Haupt-
versammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenom-
men. Dabei gewährt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.
(4) Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,
dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder
Bekanntmachung abgehalten werden.
Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung
Art. 14.
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres.
(2) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31.
Dezember 2006.
Art. 15.
(1) Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskosten gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen erstellen.
(2) Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der
jährlichen Geschäftskonten zusammen mit ihrem Bericht und anderen gesetzlich erforderlichen Dokumenten den
Kommissaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, die daraufhin ihren Bericht erstatten.
(3) Die jährlichen Geschäftskosten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und
alle gesetzlich erforderlichen Dokumente werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor dem Datum, an dem die
Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen Bürostunden Einsicht nehmen
können.
(4) Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschrei-
bungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, die von Verwaltungsrat festgestellt werden,
bildet den Reingewinn.
(5) Jedes Jahr werden fünf Prozent von Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
(6) Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschafts-
kapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur treuen Verfügung der Hauptversammlung.
(7) Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividende anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
(8) Vorschüsse auf Dividende können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.
Auflösung - Liquidation
Art. 16.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natür-
liche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden, die über
diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Art. 17.
Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt:
Der Nachweis über diese Zahlungen ist der unterzeichnenden Notarin erbracht worden, so dass der Betrag von
31.000,- (einunddreissigtausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht.
Aktionär Gezeichnetes Eingezahltes
Anzahl
Kapital
Kapital
Kapital
Kapital
ROSALIA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.690
30.690
99
Günter Thiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
310
1
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
31.000
100
48672
<i>Bescheinigungi>
Die unterzeichnende Notarin erklärt hiermit, die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden
sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass
ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr 1.500,- (tausend fünfhundert) Euro geschätzt.
<i>Außerordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann;
b) Herr Josef Ting, Privatangestellter, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann;
c) Herr Volker Wentz, Privatangestellter, Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 28, am Bann;
3. Zum Kommissar wird ernannt:
LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Zithe, eingetragen im Firmen- und
Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 49.280.
4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3372 Leudelange, 28, am Bann.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr
2011.
6. Das Mandat des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der nächsten ordentlichen Hauptver-
sammlung.
7. In Abweichung von Artikel 10 der Statuten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift
von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied vertreten.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, der amtierenden Notarin nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unterschrieben.
Gezeichnet: U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2006, vol. 914, fol. 86, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023776/272/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
DEODARA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 87.318.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00620, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
(023246/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2006.
B. Moutrier.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Lyrane Invest S.A.
Macquarie Industrie Beteiligungen S.A.
Kether S.A.
Poseidon Luxco Holdings, S.à r.l.
Vulcan Holdings Luxembourg
ACM New Alliance (Luxembourg) S.A.
A.P.S.I., S.à r.l.
CB Commercial S.A.
Micros-Fidelio Luxembourg, S.à r.l.
Micros-Fidelio Luxembourg, S.à r.l.
Traditional Company S.A.
Gold Broker Holding S.A.
Hipper S.A. - Société Internationale pour la Production d’Energie Renouvelable
Hipper S.A. - Société Internationale pour la Production d’Energie Renouvelable
Efisia Investments Holding S.A.
SeeReal Technologies S.A.
SeeReal Technologies S.A.
Doumart Consulting S.A.
Placements Financiers et Industriels S.A.
Immobilière de Warken S.A.
SCI Teberu
Neocell, S.à r.l.
Nedamo Consolidated S.A.
C.A.L., Centrale d’Approvisionnement Luxembourgeoise
Lahndrik Holdings S.A.
Vitony S.A.
Vitony S.A.
BRE/Bielefeld I Hotel, S.à r.l.
Pharmacies Européennes Holding S.A.
Fiduciaire Auditlux, S.à r.l.
BRE/Frankfurt I Hotel, S.à r.l.
Blacksmith Holding, S.à r.l.
Fiduciaire Nationale, S.à r.l.
Asia Consumer Holdings, S.à r.l.
Asia Consumer Holdings, S.à r.l.
Doulu Investissement S.A. Luxembourg
Doulu Investissement S.A. Luxembourg
Annandale International S.A.
BHF-Bank International
Russell Bedford Luxembourg, S.à r.l.
Cebarre Holding S.A.
Comaga S.A.
T.B.C. S.A.
Full Music Services S.A.
La Capite S.A.
Alpha Factoring, S.à r.l.
Société Luxembourgeoise d’Intermédiaires de Commerce, S.à r.l.
S.G. Lux, S.à r.l.
Finropa Finance, S.à r.l.
Provence S.A. Holding
TD Retail
Finropa Luxembourg, S.à r.l.
Swedmec, S.à r.l.
Tradegro Holdings Limited, Luxembourg Branch
BRE/Perlach I Hotel, S.à r.l.
Cariges S.A.
Philos S.A.H.
Daninvest S.A.
Daninvest S.A.
Corisa S.A.
G & P Properties, S.à r.l.
Barsac Invest S.A.
Rosalia Real Estate AG
Deodara S.A.