This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
48049
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1002
22 mai 2006
S O M M A I R E
MANESTAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 83.260.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-
BO00541, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021846/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
ACII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48051
FFTW Funds Selection, Sicav, Luxembourg . . . . .
48088
ACII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48052
Funds Management Company S.A., Luxembourg.
48086
Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.,
G&P Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . . .
48092
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48064
Gestion Premier Fund S.A., Luxembourg . . . . . . .
48086
Adlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48050
GIV Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
48052
Agence Immobilière Weckbecker S.A., Luxem-
GIV Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
48063
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48073
Ifonas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48090
APV (Gebomsa), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
48064
Interportfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48089
Arkas Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48095
Kanaka Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
48051
Artimon S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48092
KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
48096
Bailiff S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48096
Kisling Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48083
Balzac, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48092
Kisling Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48083
CMC Capital Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .
48073
Manestan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48049
DWS Hedge, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
48085
Metro International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48094
DWS Investment S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
48050
Metropartecipazioni S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48085
Eugénie Patri Sébastien ("EPS") S.A., Luxem-
Millicom International Cellular S.A., Bertrange . .
48090
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48064
Pembrooke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48087
Euroline Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
48063
Sam Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48088
Events Company Trading S.A., Luxembourg . . . . .
48088
Sobim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48087
Farfisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48084
Société Financière Grandvaux S.A. Holding, Lu-
Farfisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48084
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48084
Ferotron S.A., Betzdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48081
Socofigest Investment S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
48089
Ferotron S.A., Betzdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48081
Syrval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48087
Ferotron S.A., Betzdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48082
Toyfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48096
Ferotron S.A., Betzdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48082
TPE Coaching, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . . . . . . . .
48071
Ferotron S.A., Betzdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48082
Transcom WorldWide S.A., Bertrange . . . . . . . . .
48093
Ferotron S.A., Betzdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48082
UBAM, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48087
Ferotron S.A., Betzdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48082
W Industries Finances S.A., Luxembourg . . . . . . .
48051
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
48050
DWS INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 25.754.
—
<i>Beschluss des Verwaltungsratesi>
Die Unterzeichneten, welche alle Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind, entscheiden im Umlaufver-
fahren gemäß Artikel 7 und 8 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
1. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Oliver Behrens, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,
sowohl sein Mandat als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied als auch das Mandat als Mitglied des Verwaltungs-
rates mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 niederlegt.
2. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Dr. Stephan Kunze, Mainzer Landstraße 178-190,
D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.
3. Es wird beschlossen, mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herrn Günter Graw, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxemburg, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft neben Frau Doris
Marx und Herrn Klaus-Michael Vogel als Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.
Er ist damit berechtigt, die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich umfassend in allen Belangen der täglichen Ge-
schäftsführung gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Geschäftsführer oder einem anderen Ver-
tretungsberechtigten zu vertreten.
4. Es wird festgestellt, dass sich der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung demnach ab dem 1. Januar 2006 wie
folgt zusammensetzt:
<i>Verwaltungsrat:i>
Axel G. Benkner (Vorsitzender),
Klaus-Michael Vogel (Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied),
Dr. Stephan Kunze,
Udo Behrenwaldt,
Ernst Wilhelm Contzen.
<i>Geschäftsführung:i>
Klaus-Michael Vogel,
Doris Marx,
Günter Graw.
Die obengenannten Beschlüsse wurden vom Verwaltungsrat zum 1. Januar 2006 unterzeichnet.
Luxemburg, den 23. Januar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03243. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017966//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
ADLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.424.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date
du 15 février 2006, enregistré à Redange-sur-Attert, le 16 février 2006, volume 408, folio 2, case 1, que la société ano-
nyme ADLUX S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés, section B, numéro 55.424, que les actionnaires ont a l’unanimité:
- prononcé la clôture de liquidation de la société,
- décidé que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Redange-sur-Attert, le 3 mars 2006.
(021641/243/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
E.W. Contzen / K.-M. Vogel / U. Behrenwaldt / A.G. Benkner.
Pour copie conforme à l’original
J. Elvinger
<i>Notairei>
M. Lecuit
<i>Notairei>
48051
W INDUSTRIES FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.294.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00674, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021831/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
KANAKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.535.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00678, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021841/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
ACII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.793.
—
L’an deux mille six, le dix-sept février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1.- Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 16, ave-
nue de la Porte-Neuve,
2.- Monsieur Saïd Benzahraa, employé, demeurant à B-1000 Bruxelles, 1, Petite rue des Brigittines,
ici représenté par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 3 février 2006,
3.- Madame Céline Kham, agent immobilier, demeurant à L-1925 Luxembourg, 24, rue Fanny Leclerc,
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 4 novembre 2005.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Madame Céline Kham, prénommée, représentée comme dit, agissant en sa qualité de gérante de la société à res-
ponsabilité limitée ACII, S.à r.l., avec siège social à L-1925 Luxembourg, 24, rue Fanny Leclerc, constituée suivant acte
reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 14 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 948 du 23 septembre 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg sous la section B et le numéro 101.793, déclare accepter au nom de la société, conformément à l’article
190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l’article 1690 du
Code Civil, la cession de cent vingt-cinq (125) parts sociales, en date du 4 novembre 2005, par Madame Céline Kham,
prénommée, représentée comme dit, à Monsieur Patrick Meunier, prénommé, au prix de sept cent cinquante euros
(EUR 750,00).
2. Monsieur Patrick Meunier, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Monsieur Saïd Benzahraa,
représenté comme dit et acceptant par son représentant prénommé, les cent vingt-cinq (125) parts sociales qu’il détient
dans la société à responsabilité limitée ACII, S.à r.l., prénommée.
La cession qui précède est faite moyennant le prix d’un euro (EUR 1,00), que le cédant reconnaît avoir reçu du ces-
sionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.
3. Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et il a droit aux revenus et bénéfices
dont ces parts sont productives à partir de ce jour.
Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
4. Tous les associés déclarent expressément accepter la cession de parts qui précède.
W INDUSTRIES FINANCES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>KANAKA HOLDING S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
48052
5. Madame Céline Kham, prénommée, agissant en sa qualité de gérante de la société, déclare accepter la cession de
parts qui précède au nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les
sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l’article 1690 du Code civil.
6. Ensuite, Monsieur Saïd Benzahraa, seul associé de la société après réalisation de la cession de parts qui précède,
décide de modifier l’article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Saïd Benzahraa, employé, demeurant à B-1000
Bruxelles, 1, Petite rue des Brigittines.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.»
7. L’associé unique, représenté comme dit, décide de changer l’objet social de la société et de modifier, par consé-
quent, l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, l’échange de produits de grande consommation ainsi que tous actes
commerciaux, d’importation et d’exportation de ces produits.
En général, la société pourra procéder à toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et
financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
8. L’associé unique, représenté comme dit, décide de transférer le siège social de la société à L-2227 Luxembourg,
16, avenue de la Porte-Neuve.
9. Ensuite, Madame Céline Kham, prénommée, représentée comme dit, déclare démissionner avec effet immédiat de
ses fonctions de gérante de la société.
L’associé unique, représenté comme dit, déclare accepter cette démission et donner décharge pleine et entière à la
gérante démissionnaire.
L’associé unique décide de fixer le nombre des gérants à un et de nommer gérant unique de la société pour une durée
indéterminée Monsieur Saïd Benzahraa, prénommé, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la société, en tou-
tes circonstances, par sa seule signature.
10. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
11. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,
il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 27CS, fol. 66, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(022120/227/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
ACII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.793.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022121/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
GIV LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.261.
—
In the year two thousand and six, on the tenth day of February.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GIV LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg so-
ciété à responsabilité limitée with registered office at 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
not yet registered with the Luxembourg Companies’ Register, incorporated by notarial deed of the undersigned notary
on February 6, 2006, not yet published in the Mémorial C (the «Company»).
The meeting is presided by M
e
Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appoints as secretary M
e
Marie-Claude Frank, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer M
e
Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
E. Schlesser.
48053
The office of the meeting having thus been constituted, the president declares and requests the undersigned notary
to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to increase the capital of the Company by one thousand Pounds Sterling (GBP 1,000.-) so as to raise it
from its present amount of one hundred and twenty-five thousand one hundred Pounds Sterling (GBP 125,100.-) to one
hundred and twenty-six thousand one hundred Pounds Sterling (GBP 126,100.-) by the issue of ten (10) preference
shares, with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each and a share premium of two hundred and
forty-nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred Pounds Sterling (GBP 249,999,900.-) each, having
the rights and obligations attached to the P-Shares (as defined in the revised articles of association below).
Subscription by BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED of ten (10) new preference shares and payment by contri-
bution in kind of all its assets and all its liabilities.
2. Amendment of article 1 of the articles of association so as to read:
«Art. 1. Legal form
GIV LUXEMBOURG, S.à r.l., is a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which is gov-
erned by the laws pertaining to such an entity, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended («Law on Commercial Companies»), as well as by these articles of association.»
3. Amendment of article 3 of the articles of association so as to include a new section 3.1 (all other provisions being
numbered 3.2, but remaining unchanged) to read as follows:
«3.1 The formation of the company is effective as from February 6, 2006.
3.2 The company is formed for an unlimited period.»
4. Amendment of article 6 of the articles of association of the company, inter alia to reflect the above capital increase,
so as to read:
«Art. 6. Share capital - Shares
A) Share capital
6.1 The issued corporate capital is fixed at one hundred and twenty-six thousand one hundred Pounds Sterling (GBP
126,100.-), divided into:
(a) one thousand two hundred and fifty-one (1,251) ordinary shares («O-Shares») having a nominal value of one hun-
dred Pounds Sterling (GBP 100.-) each; and
(b) ten (10) preference shares («P-Shares») having a nominal value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.
6.2 In addition to the corporate capital, the O-Shares have been issued together with an issue premium of nine hun-
dred Pounds Sterling (GBP 900.-) per O-Share and the P-Shares with an issue premium («P-Shares Share Premium») of
two hundred and forty-nine million nine hundred and ninety-nine thousand and nine hundred Pounds Sterling (GBP
249,999,900.-) per P-Share.
6.3 All of the O-Shares and P-Shares including the issue premium have been fully paid up.
6.4 Unless the context indicates otherwise, the term’share’ as used in these articles of association shall refer to the
O-Shares and the P-Shares.
B) Shares
6.5 Each share gives right to one vote.
6.6 The O-Shares and P-Shares give right to the same rights, privileges, restrictions and conditions except that:
a) Each P-Share entitles its holder to receive a one-time interim dividend amounting to ten million three hundred
thirty-five thousand two Pounds Sterling twenty Pence (10,335,002.20 GBP) per share («Initial Dividend»). The Initial
Dividend is payable on March 1, 2006, in accordance with the provisions of article 17;
b) The holders of the P-Shares are entitled to receive, in accordance with the provisions of article 17, a fixed cumu-
lative preferential cash dividend at a rate of LIBOR plus one hundred (100) basis points per annum on the aggregate of
the nominal value of the P-Shares and the P-Shares Share Premium («Preferred Dividend»). The Preferred Dividend ac-
crues on a monthly basis as from the eleventh (11) month after March 1, 2006 and is payable on a monthly basis on the
first day of each subsequent month («Preferred Dividend Payment Date»). For the purposes hereof, (1) LIBOR means
the arithmetic mean of the offered quotations in the relevant currency for the required period which appear on the
relevant page of the Bloomberg screen which displays British Bankers Association Interest Settlement Rates for deposits
in the relevant currency (or, if no quotations are displayed, such other page or service which displays London Interbank
Offered Rates of Prime banks) as at 11.00 a.m. on the quotation date for such period and (2) a reference to a’month’
or’monthly’ is a reference to a period starting on one day in a calendar month and ending on the numerically corre-
sponding day in the next calendar month or the calendar month in which it is to end, except that: (i) if the numerically
corresponding day is not a business day, the period will end on the next business day in that month (if there is one) or
the preceding business day (if there is not) and (ii) if there is no numerically corresponding day in that month, that period
will end on the last business day in that month. If the Preferred Dividend is not paid in full on all of the P-Shares then,
such Preferred Dividend, or the unpaid part thereof, which for all purposes hereof shall until paid be considered to be
an accrued and unpaid Preferred Dividend, shall be paid on a subsequent monthly payment date or dates in accordance
with and subject to article 17.
c) The Initial Dividend and Preferred Dividend shall be declared and payable in priority to any dividend payments or
reimbursements (through redemption of the O-Shares, reduction of the share capital or otherwise) on the O-Shares.
d) The P-Shares are entitled to a preference payment over the O-Shares with respect to liquidation distributions in
the event of the dissolution and liquidation of the Company. Each holder of P-Shares shall be entitled to liquidation dis-
tributions amounting to the aggregate of the nominal value of the P-Shares and the P-Shares Share Premium and any
accrued and unpaid Preferred Dividend.
48054
e) The P-Shares are not entitled to share in any dividend or liquidation payments other than those defined under
articles 6.6 a) to d).
f) The P-Shares are not redeemable and may not be bought back by the company in any circumstances including share
capital reduction.
6.7 The O-Shares are entitled to the balance of the distributable sums after deduction of the dividend distributions
to the P-Shares pursuant to articles 6 a) and 6 b) and the liquidation distributions pursuant to article 6 d).»
5. Amendment of article 7 of the company’s articles of association so as to read:
«Art. 7. Preference Share Premium
7.1 The funds received as P-Shares Share Premium upon issuance of the P-Shares were allocated to a special reserve,
except for those allocated to the legal reserve. This reserve is at the disposal of the shareholders and board of managers,
as the case may be, for dividend and liquidation distributions exclusively to the holders of P-Shares.
7.2 The P-Shares Share Premium is convertible into newly issued preference shares (the «New P-Shares») for the
sole purposes of voting at an extraordinary general meeting of the shareholders which shall resolve upon the dissolution
and liquidation of the company and which shall deal with no other business.
7.3 The conversion of the P-Shares Share Premium into New P-Shares shall be subject to the following provisions:
a) Any shareholder is entitled to call the extraordinary general meeting of the shareholders, which shall have two (2)
items on the agenda: (i) the conversion of the P-Shares Share Premium into New P-Shares and (ii) the dissolution and
liquidation of the company.
b) The only business that may be transacted at that meeting is limited to the two (2) abovementioned items, which
must be both considered together at such meeting (rather than either one only). The meeting shall first resolve on the
conversion of the P-Shares Share Premium into New-P Shares pursuant to the quorum and majority provisions as set
forth under article 14.7 b). The same shareholders’ meeting subsequently. resolving on the dissolution and the liquida-
tion of the company shall take into consideration the New-P Shares issued pursuant to the first agenda item of that
shareholders’ meeting, the quorum and majority provisions being determined with reference to article 14.7 a).
c) The holder of each P-Share shall be entitled to receive one (1) New P-Share for each one hundred Pounds Sterling
(GBP 100.-) of the P-Shares Share Premium paid up in respect of such P-Share to be converted into New P-Shares.
d) The New P-Shares shall have the same rights, privileges, restrictions and conditions as those attached to the ex-
isting P-Shares except that as from the date of conversion of the P-Shares Share Premium into New P-Shares, any ref-
erence in article 6.6 to the «nominal value of the P-Shares plus the P-Shares Share Premium» shall be replaced by
«nominal value of the P-Shares».»
6. Amendment of article 14.6, fifth indent (all other provisions remaining unchanged) of the articles of association to
read as follows:
«(...) any change to the rights of the O-Shares and P-Shares.»
7. Amendment of article 14.7 of the articles of association as follows:
«14.7 A resolution shall be validly passed at an extraordinary shareholders’ meeting if it is unanimously approved by
all the shareholders save for an extraordinary shareholders’ meeting held in respect; of
a) the dissolution and liquidation of the company, including the dissolution and liquidation in accordance with article
7.3 and for the avoidance of doubt, the appointment of the liquidator(s), which shall be validly passed if a majority in
number of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital vote in favour of the resolu-
tion; and
b) the conversion of the P-Shares Share Premium into New P-Shares pursuant to article 7.3, which shall be validly
passed if a majority in number of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital vote in
favour of the conversion, it being understood that any vote against the conversion will automatically trigger the compa-
ny’s dissolution and liquidation.»
8. Creation of a new section 16.3 to article 16 (all other provisions remaining unchanged) of the articles of association
to read as follows:
«16.3 The holders of the P-Shares shall be entitled to receive, and the company shall provide to such holders, on any
Preferred Dividend Payment Date a tax voucher in a form satisfactory to the holders of the P-Shares.»
9. Amendment of the first sentence of article 17.1 of the articles of association of the company (all other provisions
remaining unchanged) so as to read:
«17.1 Subject to and in accordance with articles 6.6 and 16, the board of managers is authorised to proceed, as often
as it deems appropriate and at any moment in time during the financial year, to the payment of interim dividends to the
O-Shares and the P-Shares subject only to three (3) conditions: (...).»
10. Further amendment of article 17 of the company’s articles of association (all other provisions remaining un-
changed) so as to add two new sections numbered 17.3 and 17.4 to read as follows:
«17.3 Article 16.3 is applicable to interim dividend distributions.
17.4 For the purpose of this article, any Preferred Dividend paid is regarded as an interim dividend payment.»
11. Amendment of article 18 of the articles of association of the company so as to read:
«At the time of the winding up of the company, whether as a result of the adoption of shareholders’ resolutions to
this effect or as a result of automatic dissolution and liquidation pursuant to article 14.7 b), the liquidation will be carried
out by one (1) or more liquidators, who are appointed among a list of persons proposed by Barclays Bank PLC or any
of its affiliates by the shareholders, who will determine their number, their powers and their remuneration, in accord-
ance with article 14.7 a) above.»
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies
of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.
48055
The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed
to the present deed.
III) It appears from the attendance list that all the one thousand two hundred and fifty-one (1,251) shares representing
the entire capital of the Company of one hundred and twenty-five thousand one hundred Pounds Sterling (GBP
125,100.-) are represented at the present meeting.
IV) All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and received knowledge of
the agenda prior to this meeting. Accordingly, the meeting is validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting has decided to increase the capital of the Company by one thousand Pounds Sterling (GBP 1,000.-) so
as to raise it from its present amount of one hundred and twenty-five thousand one hundred Pounds Sterling (GBP
125,100.-) to one hundred and twenty-six thousand one hundred Pounds Sterling (GBP 126,100.-) by the issue of ten
(10) preference shares, with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each and a share premium of two
hundred and forty-nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred Pounds Sterling (GBP 249,999,900.-
) each, having the rights and obligations attached to the P-Shares (as defined in the revised articles of association below).
<i>Subscriptioni>
Thereupon, BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED, a limited liability company incorporated and validly existing
under the laws of England and Wales, with registered office at 1 Churchill Place, London E14 5HP, registered with The
Registrar of Companies for England and Wales under the registration number 5679205, here represented by M
e
Alain
Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 10, 2006, has declared to sub-
scribe for ten (10) new preference shares and to pay for them a total price of two billion and five hundred millions
Pounds Sterling (GBP 2,500,000,000.-) by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities, together constituting
its entire net equity, whose existence and value are documented by interim financial statements of BRAVEN INVEST-
MENTS No. 2 LIMITED as of February 10, 2006.
The assets and liabilities contributed by BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED comprise:
Assets:
- GBP 100,000,000.- loan receivable owed by BARCLAYS BANK PLC and GBP 1,398,000,000.- loan receivable owed
by BRAVEN INVESTMENTS No. 1 LIMITED;
- short-term commercial paper portfolio for a total amount of GBP 999,939,784.-;
- accrued interest on the above commercial paper and loan receivables for an aggregate amount of GBP 922,904.-;
cash for a total amount of GBP 1,420,417.-.
Liabilities:
- obligations in respect of UK tax liabilities under the BARCLAYS GROUP tax payment arrangements for an aggregate
amount of GBP 283,105.-;
and generally, without limitation, any and all assets which are the property of BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIM-
ITED and any and all liabilities which are incumbent upon BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED.
Out of the contribution made by BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED, the amount of twelve thousand six hun-
dred and ten Pounds Sterling (GBP 12,610.-) will be allocated to the legal reserve.
<i>Second resolutioni>
The meeting has decided to amend article 1 of the articles of association so as to read:
«Art. 1. Legal form
GIV LUXEMBOURG, S.à r.l., is a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which is gov-
erned by the laws pertaining to such an entity, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended («Law on Commercial Companies»), as well as by these articles of association.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting has decided to amend article 3 of the articles of association so as to include a new section 3.1
(all other provisions being numbered 3.2, but remaining unchanged) to read as follows:
«3.1 The formation of the company is effective as from February 6, 2006.
3.2 The company is formed for an unlimited period.»
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders’ meeting has decided to amend article 6 of the articles of association of the company, inter alia to
reflect the above capital increase, so as to read:
«Art. 6. Share capital - Shares
A) Share capital:
6.1 The issued corporate capital is fixed at one hundred and twenty-six thousand one hundred Pounds Sterling (GBP
126,100.-), divided into:
(a) one thousand two hundred and fifty-one (1,251) ordinary shares («O-Shares») having a nominal value of one hun-
dred Pounds Sterling (GBP 100.-) each; and
(b) ten (10) preference shares («P-Shares») having a nominal value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.
6.2 In addition to the corporate capital, the O-Shares have been issued together with an issue premium of nine hun-
dred Pounds Sterling (GBP 900.-) per O-Share and the P-Shares with an issue premium («P-Shares Share Premium») of
two hundred and forty-nine million nine hundred and ninety-nine thousand and nine hundred Pounds Sterling (GBP
249,999,900.-) per P-Share.
6.3 All of the O-Shares and P-Shares including the issue premium have been fully paid up.
48056
6.4 Unless the context indicates otherwise, the term’share’ as used in these articles of association shall refer to the
O-Shares and the P-Shares.
B) Shares:
6.5 Each share gives right to one (1) vote.
6.6 The O-Shares and P-Shares give right to the same rights, privileges, restrictions and conditions except that:
a) Each P-Share entitles its holder to receive a one-time interim dividend amounting to ten million three hundred
thirty-five thousand two Pounds Sterling twenty Pence (10,335,002.20 GBP) per share («Initial Dividend»). The Initial
Dividend is payable on March 1, 2006, in accordance with the provisions of article 17.
b) The holders of the P-Shares are entitled to receive, in accordance with the provisions of article 17, a fixed cumu-
lative preferential cash dividend at a rate of LIBOR plus one hundred (100) basis points per annum on the aggregate of
the nominal value of the P-Shares and the P-Shares Share Premium («Preferred Dividend»). The Preferred Dividend ac-
crues on a monthly basis as from the eleventh (11) month after March 1, 2006 and is payable on a monthly basis on the
first day of each subsequent month («Preferred Dividend Payment Date»). For the purposes hereof, (1) LIBOR means
the arithmetic mean of the offered quotations in the relevant currency for the required period which appear on the
relevant page of the Bloomberg screen which displays British Bankers Association Interest Settlement Rates for deposits
in the relevant currency (or, if no quotations are displayed, such other page or service which displays London Interbank
Offered Rates of Prime banks) as at 11.00 a.m. on the quotation date for such period and (2) a reference to a’month’
or’monthly’ is a reference to a period starting on one day in a calendar month and ending on the numerically corre-
sponding day in the next calendar month or the calendar month in which it is to end, except that: (i) if the numerically
corresponding day is not a business day, the period will end on the next business day in that month (if there is one) or
the preceding business day (if there is not) and (ii) if there is no numerically corresponding day in that month, that period
will end on the last business day in that month. If the Preferred Dividend is not paid in full on all of the P-Shares then,
such Preferred Dividend, or the unpaid part thereof, which for all purposes hereof shall until paid be considered to be
an accrued and unpaid Preferred Dividend, shall be paid on a subsequent monthly payment date or dates in accordance
with and subject to article 17.
c) The Initial Dividend and Preferred Dividend shall be declared and payable in priority to any dividend payments or
reimbursements (through redemption of the O-Shares, reduction of the share capital or otherwise) on the O-Shares.
d) The P-Shares are entitled to a preference payment over the O-Shares with respect to liquidation distributions in
the event of the dissolution and liquidation of the Company. Each holder of P-Shares shall be entitled to liquidation dis-
tributions amounting to the aggregate of the nominal value of the P-Shares and the P-Shares Share Premium and any
accrued and unpaid Preferred Dividend.
e) The P-Shares are not entitled to share in any dividend or liquidation payments other than those defined under
articles 6.6 a) to d).
f) The P-Shares are not redeemable and may not be bought back by the company in any circumstances including share
capital reduction.
6.7 The O-Shares are entitled to the balance of the distributable sums after deduction of the dividend distributions
to the P-Shares pursuant to articles 6 a) and 6 b) and the liquidation distributions pursuant to article 6 d).»
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders’ meeting has further decided to amend article 7 of the company’s articles of association so as to
read:
«Art. 7. Preference Share Premium
7.1 The funds received as P-Shares Share Premium upon issuance of the P-Shares were allocated to a special reserve,
except for those allocated to the legal reserve. This reserve is at the disposal of the shareholders and board of managers,
as the case may be, for dividend and liquidation distributions exclusively to the holders of P-Shares.
7.2 The P-Shares Share Premium is convertible into newly issued preference shares (the «New P-Shares») for the
sole purposes of voting at an extraordinary general meeting of the shareholders which shall resolve upon the dissolution
and liquidation of the company and which shall deal with no other business.
7.3 The conversion of the P-Shares Share Premium into New P-Shares shall be subject to the following provisions:
a) Any shareholder is entitled to call the extraordinary general meeting of the shareholders, which shall have two (2)
items on the agenda: (i) the conversion of the P-Shares Share Premium into New P-Shares and (ii) the dissolution and
liquidation of the company.
b) The only business that may be transacted at that meeting is limited to the two (2) abovementioned items, which
must be both considered together at such meeting, rather than either one only. The meeting shall first resolve on the
conversion of the P-Shares Share Premium into New-P Shares pursuant to the quorum and majority provisions as set
forth under article 14.7 b). The same shareholders’ meeting subsequently resolving on the dissolution and the liquidation
of the company shall take into consideration the New-P Shares issued pursuant to the first agenda item of that share-
holders’ meeting, the quorum and majority provisions being determined with reference to article 14.7 a).
c) The holder of each P-Share shall be entitled to receive one (1) New P-Share for each one hundred Pounds Sterling
(GBP 100.-) of the P-Shares Share Premium paid up in respect of such P-Share to be converted into New P-Shares.
d) The New P-Shares shall have the same rights, privileges, restrictions and conditions as those attached to the ex-
isting P-Shares except that as from the date of conversion of the P-Shares Share Premium into New P-Shares, any ref-
erence in article 6.6 to the «nominal value of the P-Shares plus the P-Shares Share Premium» shall be replaced by
«nominal value of the P-Shares».»
48057
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting has decided to amend article 14.6, fifth indent (all other provisions remaining unchanged) of the
articles of association to read as follows:
«(...) any change to the rights of the O-Shares and P-Shares.»
<i>Seventh resolutioni>
The meeting has decided to amend article 14.7 of the articles of association as follows:
«14.7 A resolution shall be validly passed at an extraordinary shareholders’ meeting if it is unanimously approved by
all the shareholders save for an extraordinary shareholders’ meeting held in respect of:
a. the dissolution and liquidation of the company, including the dissolution and liquidation in accordance with article
7.3 and for the avoidance of doubt, the appointment of the liquidator(s), which shall be validly passed if a majority in
number of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital vote in favour of the resolu-
tion, and
b. the conversion of the P-Shares Share Premium into New P-Shares pursuant to article 7.3, which shall be validly
passed if a majority in number of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital vote in
favour of the conversion, it being understood that any vote against the conversion will automatically trigger the compa-
ny’s dissolution and liquidation.»
<i>Eighth resolutioni>
The general shareholders’ meeting has decided to create a new section 16.3 to article 16 (all other provisions re-
maining unchanged) of the articles of association to read as follows:
«16.3 The holders of the P-Shares shall be entitled to receive, and the company shall provide to such holders, on any
Preferred Dividend Payment Date a tax voucher in a form satisfactory to the holders of the P-Shares.»
<i>Nineth resolutioni>
The meeting has also decided to amend the first sentence of article 17.1 of the articles of association of the company
(all other provisions remaining unchanged) so as to read:
«17.1 Subject to and in accordance with articles 6.6 and 16, the board of managers is authorised to proceed, as often
as it deems appropriate and at any moment in time during the financial year, to the payment of interim dividends to the
O-Shares and the P-Shares subject only to three (3) conditions: (...).»
<i>Tenth resolutioni>
The general meeting of shareholders has decided to amend article 17 of the company’s articles of association (all oth-
er provisions remaining unchanged) so as to add two new sections numbered 17.3 and 17.4 to read as follows:
«17.3 Article 16.3 is applicable to interim dividend distributions.
17.4 For the purpose of this article, any Preferred Dividend paid is regarded as an interim dividend payment.»
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting of shareholders finally decided to amend article 18 of the articles of association of the company
so as to read:
«At the time of the winding up of the company, whether as a result of the adoption of shareholders’ resolutions to
this effect or as a result of automatic dissolution and liquidation pursuant to article 14.7 b), the liquidation will be carried
out by one (1) or more liquidators, who are appointed among a list of persons proposed by BARCLAYS BANK PLC or
any of its affiliates by the shareholders, who will determine their number, their powers and their remuneration, in ac-
cordance with article 14.7 a) above.»
<i>Valuationi>
The contribution in kind consisting of the Total Assets and Liabilities of a company incorporated in the European
Union, the Company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.
The expression Total Assets and Liabilities includes the items listed above and more specifically the items listed in the
interim financial statements of BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED dated February 10, 2006 and any unknown as-
sets and liabilities as at the time the contribution is made by BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present capital increase and amendment of its articles of association, have been
estimated at about nine thousand Euro (EUR 9,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-
tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le dix février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
48058
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois GIV LUXEMBOURG, S.à r.l., dont l’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est
en cours, avec siège social au 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné le 6 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations C
(la «Société»).
La séance est ouverte sous la présidence de M
e
Jean Steffen, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M
e
Marie-Claude Frank, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur M
e
Alain Steichen, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter:
1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de mille livres sterling (GBP 1.000,-) pour le porter de
son montant actuel de cent vingt-cinq mille cent livres sterling (GBP 125.100,-) à cent vingt-six mille cent livres sterling
(126.100,-) par l’émission de dix (10) parts sociales préférentielles, ayant une valeur nominale de cent livres sterling (GBP
100,-) chacune avec une prime d’émission de deux cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf
cents livres sterling (GBP 249.999.900,-) chacune, assortis des droits et obligations rattachés aux parts sociales P (telles
que définies dans les statuts modifiés ci-après).
Souscription des dix (10) parts sociales préférentielles nouvelles par BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED et li-
bération de ces parts par un apport en nature de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.
2. Modification de l’article 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Forme juridique
GIV LUXEMBOURG, S.à r.l., est une société à responsabilité limitée privée soumise au lois relatives à ce type de
sociétés, notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts.»
3. Modification de l’article 3 des statuts de la Société par l’ajout d’une nouvelle section 3.1 (toutes les autres dispo-
sitions étant numérées 3.2, mais demeurent inchangées) ayant la teneur suivante:
«3.1 La constitution de la société est effective à partir du 6 février 2006.
3.2 La société est constituée pour une durée indéterminée.»
4. Modification de l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter entre autre l’augmentation de capital ci-dessus
et afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Capital social - Parts sociales
A) Capital social:
6.1 Le capital social émis est fixé à cent vingt-six mille cent livres sterling (GBP 126.100,-) divisé en:
(a) mille deux cent cinquante et une (1.251) parts sociales ordinaires («Parts O») ayant une valeur nominale de cent
livres sterling (GBP 100,-) chacune; et
(b) dix (10) parts sociales préférentielles («Parts P») ayant une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-)
chacune.
6.2 En plus du capital social, les Parts O ont été émises avec une prime d’émission de neuf cents livres sterling (GBP
900,-) par Part O et les Parts P avec une prime d’émission («Prime d’Emission des Parts P») de deux cents quarante-
neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents livres sterling (GBP 249.999.900,-) par Part P.
6.3 Toutes les Parts O et toutes les Parts P ainsi que la prime d’émission ont été intégralement libérées.
6.4 A moins que le contexte ne donne un sens contraire, le terme «part» utilisée dans les présents statuts se réfère
aux Parts O et aux Parts P.
B) Parts sociales:
6.5 Chaque part sociale donne droit à un vote.
6.6 Les Parts O et les Parts P donnent droit aux mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions, sauf que:
a) Chaque Part P autorise son détenteur à percevoir un dividende intérimaire unique s’élevant à dix millions trois
cent trente-cinq mille deux livres sterling vingt pences (10.335.002,20 GBP) par part («Dividende Initial»). Le Dividende
Initial est payable le 1
er
mars 2006, conformément aux dispositions de l’article 17.
b) Les détenteurs des Parts P sont autorisés à recevoir, conformément aux dispositions de l’article 17, un dividende
en espèces fixe cumulatif préférentiel au taux LIBOR plus (100) cent points de base par année sur le total de la valeur
nominale des Parts P et de la prime d’émission des Parts P («Dividende Préférentiel»). Le Dividende Préférentiel s’ac-
croît sur une base mensuelle à partir du (11) onzième mois après le 1
er
mars 2006 et est payable, sur une base mensuelle,
le premier jour de chaque mois subséquent («Date de Paiement du Dividende Préférentiel»). A cette fin, (1) LIBOR
équivaut à la moyenne arithmétique des cotations offertes dans la devise en question pour la période fixée, apparaissant
sur la page de l’écran Bloomberg affichant les taux de paiement d’intérêts de l’Association des Banquiers de Grande-
Bretagne pour des dépôts dans la devise en question (ou si aucune cotation n’est affichée, telle autre page ou service
qui affiche les London Interbank Offered Rates of Prime banks) à 11.00 heures du matin à la date de cotation pour telle
période et (2) une référence à un «mois» ou «mensuel» a trait à une période commençant un jour d’un mois de calen-
drier et se terminant le même jour du mois de calendrier suivant ou le mois de calendrier dans lequel elle doit s’achever,
à moins que:
(i) le même jour du mois de calendrier suivant n’est pas un jour ouvrable, auquel cas la période s’achèvera le jour
ouvrable suivant de ce mois (s’il y en a un) ou le jour ouvrable précédent (s’il n’y en a pas) et (ii) s’il n’y a pas un jour
correspondant dans ce mois, cette période s’achèvera le dernier jour ouvrable de ce mois. Si le Dividende Préférentiel
n’est pas payé intégralement sur toutes les Parts P, alors tel Dividende Préférentiel ou la partie restée impayée, qui, à
toutes fins sera, jusqu’à son paiement, considérée comme un Dividende Préférentiel accru et impayé, sera payé à une
date de paiement subséquente mensuelle ou à des dates conformément aux dispositions de l’article 17.
48059
c) Le Dividende Initial et le Dividende Préférentiel devront être déclarés et payés en priorité à tous les paiements de
dividendes ou remboursements (par rachat des Parts O, diminution de capital ou autrement) sur les Parts O.
d) Les Parts P ont droit à un paiement préférentiel sur les Parts O en ce qui concerne les distributions de liquidation
dans le cas de la dissolution et de la liquidation de la société.
Chaque détenteur des Parts P aura droit à des distributions de liquidation correspondant au total de la valeur nomi-
nale des Parts P et de la prime d’émission des Parts P et tout Dividende Préférentiel accru et impayé;
e) Les Parts P n’ont pas droit à une part des paiements de dividende ou de liquidation autres que ceux prévus aux
articles 6.6. a) à d).
f) Les Parts P ne sont pas rachetables et ne pourront en aucun cas être rachetées par la société même en cas d’une
diminution du capital.
6.7 Les Parts O ont droit à la différence entre les sommes distribuables après déduction des distributions de dividende
aux Parts P conformément aux articles 6 a) et 6 b) et les distributions de liquidation conformément à l’article 6 d).»
5. Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. Prime d’Emission Préférentielle
7.1 Les fonds reçus en tant que Prime d’Emission des Parts P lors de l’émission des Parts P ont été alloués à une
réserve spéciale, à l’exception de ceux alloués à la réserve légale. Cette réserve est à la disposition des associés et du
conseil de gérance, selon le cas, en vue de distributions de dividende et de liquidation exclusivement aux détenteurs des
Parts P.
7.2 La Prime d’Emission des Parts P est convertible en nouvelles parts préférentielles émises (les «Nouvelles Parts
P») seulement aux fins de vote à une assemblée générale extraordinaire des associés, qui aura comme seul point à l’or-
dre du jour de décider de la dissolution et de la liquidation de la société.
7.3 La conversion de la Prime d’Emission des Parts P en de nouvelles Parts P sera soumise aux dispositions suivantes:
a) Chaque associé à le droit de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des associés qui aura à l’ordre du jour
les deux points suivants: (i) la conversion de la Prime d’Emission des Parts P en de nouvelles Parts P et (ii) la dissolution
et la liquidation de la société.
b) Les seuls points qui peuvent être traités à cette assemblée sont les deux (2) points énumérés ci-avant, qui devront
être considérés ensemble à cette assemblée (plutôt que l’un d’entre eux seulement). L’assemblée devra d’abord décider
de la conversion de la Prime d’Emission des Parts P en nouvelles Parts P, en tenant compte des dispositions relatives au
quorum et à la majorité telles que prévues à l’article 14.7 b). La même assemblée des associés décidant de la dissolution
et de la liquidation de la société devra tenir compte des nouvelles Parts P émises conformément au premier point de
l’ordre du jour de cette assemblée, les dispositions de quorum et de majorité étant déterminées conformément à l’ar-
ticle 14.7 a).
c) Le détenteur de chaque Part P sera autorisé à recevoir une (1) nouvelle Part P pour chaque cent livres sterling
(GBP 100,-) de la Prime d’Emission des Parts P libérés en rapport avec chaque Part P qu’il y a lieu de convertir en de
Nouvelles Parts P.
d) Les Nouvelles Parts P devront avoir les mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions comme ceux attachés
aux Parts P existantes, sauf que, à partir de la date de conversion de la Prime d’Emission des Parts P en de Nouvelles
Parts P, toute référence à l’article 6.6 à «la valeur nominale des Parts P augmentée de la Prime d’Emission des Parts P»
sera remplacée par «la valeur nominale des Parts P».»
6. Modification de l’article 14.6, paragraphe 5 (toutes les autres dispositions demeurant inchangées) des statuts afin
de lui donner la teneur suivante:
«(...) toute modification aux droits des Parts O et des Parts P, (...).»
7. Modification de l’article 14.7 des statuts:
«14.7 Lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés, une résolution sera valablement prise si elle est
unanimement approuvée par tous les associés à l’exception d’une assemblée générale extraordinaire des associés ayant
à se prononcer sur:
a) la dissolution et la liquidation de la société, comprenant la dissolution et la liquidation en conformité de l’article
7.3 et, pour éviter tout doute, la nomination de liquidateur(s),qui sera valablement prise si la majorité en nombre des
associés représentant au moins trois quarts du capital social vote en faveur de la résolution; et
b) la conversion de la Prime d’Emission des Parts P en Parts P nouvelles conformément à l’article 7.3, qui sera vala-
blement prise dès lors qu’une majorité en nombre des associés représentant au moins trois quarts du capital social vote
en faveur de la conversion, étant entendu que tout vote contre la conversion déclenchera automatiquement la dissolu-
tion et la liquidation de la société.»
8. Création d’une nouvelle section 16.3 à l’article 16 (toutes les autres dispositions demeurant inchangées) des statuts
ayant la teneur suivante:
«16.3 Les détenteurs de Parts P seront autorisés à recevoir, et la société devra leur accorder, à chaque date de paie-
ment du Dividende Préférentiel, un reçu fiscal, sous une forme satisfaisante pour les détenteurs de Parts P.»
9. Modification de la première phrase de l’article 17.1 des statuts de la société (toutes les autres dispositions demeu-
rant inchangées) afin de lui donner la teneur suivante:
«17.1 Conformément aux articles 6.6. et 16, le conseil de gérance est autorisé à procéder, chaque fois qu’il le consi-
dère comme approprié et à tout moment pendant l’année sociale, au paiement de dividendes intérimaires aux Parts O
et Parts P. Ce paiement est uniquement soumis aux trois (3) conditions suivantes: (...).»
10. Modification ultérieure de l’article 17 des statuts de la société (toutes les autres dispositions demeurant inchan-
gées) afin d’ajouter deux nouvelles sections numérotées 17.3 et 17.4, ayant la teneur suivante:
«17.3 L’article 16.3 s’applique aux distributions de dividendes intérimaires.
48060
17.4 Pour les besoins de cet article, tout Dividende Préférentiel payé est considéré comme un paiement de dividende
intérimaire.»
11. Modification de l’article 18 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
«Au moment où la société cesse d’exister, soit du fait de résolutions des associés à cet effet soit du fait de la disso-
lution et de la liquidation automatique conformément aux dispositions de l’article 14.7 b), la liquidation sera faite par un
(1) ou plusieurs liquidateurs, nommés par les associés qui vont déterminer leur nombre, leurs pouvoirs et leur rému-
nération, en conformité de l’article 14.7 a) ci-dessus, parmi une liste de personnes proposées par BARCLAYS BANK
PLC, ou une de ses filiales.»
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents et les mandataires des associés représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante et un (1.251) parts sociales repré-
sentant l’intégralité du capital de la Société qui s’élève à cent vingt-cinq mille cent livres (GBP 125.100,-) sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que tous les associés présents ou représentés déclarent avoir été valablement et préalablement informés de tous
les points portés à l’ordre du jour. Par conséquent, l’assemblée est valablement constituée et peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre de jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille livres sterling (GBP 1.000,-)
pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille cent livres sterling (GBP 125.100,-) à cent vingt-six mille
cent livres sterling (126.100,-) par l’émission de dix (10) parts sociales préférentielles, ayant une valeur nominale de cent
livres sterling (GBP 100,-) chacune avec une prime d’émission de deux cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cents livres sterling (GBP 249.999.900,-) chacune, assortis des droits et obligations rattachés
aux parts sociales P (tells que définies dans les statuts modifiés ci-après).
<i>Souscriptioni>
Les dix (10) parts sociales préférentielles nouvelles ont été souscrites par BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED,
une société à responsabilité limitée, constituée et existant valablement sous le droit anglais, avec siège social au 1 Chur-
chill Place, Londres E14 5HP, enregistré avec le Registrar of Companies for England and Wales, sous le numéro 5679205,
ici représentée par M
e
Alain Steichen, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
le 10 février 2006, au prix de deux milliards cinq cent millions de livres sterling (GBP 2.500.000.000,-) et entièrement
libérées par un apport en nature de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société, constituant l’ensemble de ses
avoirs dont l’existence et la valeur sont documentés par les comptes intérimaires de BRAVEN INVESTMENTS No. 2
LIMITED établis à la date du 10 février 2006.
L’actif et le passif apportés par BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED comprend:
Actif:
- une créance provenant du contrat de prêt avec BARCLAYS BANK PLC pour la somme de GBP 100.000.000,- et
une créance provenant du contrat de prêt avec BRAVEN INVESTMENTS No. 1 LIMITED pour la somme de GBP
1.398.000.000,-,
- un porte-feuille à court terme de titres obligataires commerciaux pour un montant total de GBP 999.939.784,-,
- intérêts accrus sur le porte-feuille à court terme de titres obligataires commerciaux mentionné ci-dessus et les
créances provenant des contrats de prêts pour un montant total de GBP 922.904,-,
- espèces pour un montant total de GBP 1.420.417.-,
Passif:
- redevances fiscales en Grande-Bretagne découlant des arrangements de paiement fiscal interne au GROUPE BAR-
CLAYS pour la somme de GBP 283.105,-.
Et, en général, sans limitation, tous les actifs qui appartiennent à BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED et tous les
passifs dont est redevable BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED.
De l’apport de BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED, la somme de douze mille six cent dix livres sterling (GBP
12.610,-) sera attribuée à la reserve légale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 1
er
des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Forme juridique
GIV LUXEMBOURG, S.à r.l., est une société à responsabilité limitée privée soumise au lois relatives à ce type de
sociétés, notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 3 des statuts de la Société par l’ajout d’une nouvelle section 3.1 (toutes les
autres dispositions étant numérées 3.2, mais demeurent inchangées) ayant la teneur suivante:
«3.1 La constitution de la société est effective à partir du 6 février 2006.
3.2 La société est constituée pour une durée indéterminée.»
48061
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter entre autre l’augmentation de
capital ci-dessus et afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Capital social - Parts sociales
A) Capital social
6.1 Le capital social émis est fixé à cent vingt-six mille cent livres sterling (GBP 126.100,-) divisé en:
(a) mille deux cent cinquante et une (1.251) parts sociales ordinaires («Parts O») ayant une valeur nominale de cent
livres sterling (GBP 100,-) chacune; et
(b) dix (10) parts sociales préférentielles («Parts P») ayant une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-)
chacune.
6.2 En plus du capital social, les Parts O ont été émises avec une prime d’émission de neuf cents livres sterling (GBP
900,-) par Part O et les Parts P avec une prime d’émission («Prime d’Emission des Parts P») de deux cents quarante-
neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents livres sterling (GBP 249.999.900,-) par Part P.
6.3 Toutes les Parts O et toutes les Parts P ainsi que la prime d’émission ont été intégralement libérées.
6.4 A moins que le contexte ne donne un sens contraire, le terme «part» utilisée dans les présents statuts se réfère
aux Parts O et aux Parts P.
B) Parts sociales
6.5 Chaque part sociale donne droit à un vote.
6.6 Les Parts O et les Parts P donnent droit aux mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions, sauf que:
a) Chaque Part P autorise son détenteur à percevoir un dividende intérimaire unique s’élevant à dix millions trois
cent trente-cinq mille deux livres sterling vingt pences (10.335.002,20 GBP) par part («Dividende Initial»). Le Dividende
Initial est payable le 1
er
mars 2006, conformément aux dispositions de l’article 17;
b) Les détenteurs des Parts P sont autorisés à recevoir, conformément aux dispositions de l’article 17, un dividende
en espèces fixe cumulatif préférentiel au taux LIBOR plus (100) cent points de base par année sur le total de la valeur
nominale des Parts P et de la prime d’émission des Parts P («Dividende Préférentiel»). Le Dividende Préférentiel s’ac-
croît sur une base mensuelle à partir du (11) onzième mois après le 1
er
mars 2006 et est payable, sur une base mensuelle,
le premier jour de chaque mois subséquent («Date de Paiement du Dividende Préférentiel»). A cette fin, (1) LIBOR
équivaut à la moyenne arithmétique des cotations offertes dans la devise en question pour la période fixée, apparaissant
sur la page de l’écran Bloomberg affichant les taux de paiement d’intérêts de l’Association des Banquiers de Grande-
Bretagne pour des dépôts dans la devise en question (ou si aucune cotation n’est affichée, telle autre page ou service
qui affiche les London Interbank Offered Rates of Prime banks) à 11.00 heures du matin à la date de cotation pour telle
période et (2) une référence à un «mois» ou «mensuel» a trait à une période commençant un jour d’un mois de calen-
drier et se terminant le même jour du mois de calendrier suivant ou le mois de calendrier dans lequel elle doit s’achever,
à moins que:
(i) le même jour du mois de calendrier suivant n’est pas un jour ouvrable, auquel cas la période s’achèvera le jour
ouvrable suivant de ce mois (s’il y en a un) ou le jour ouvrable précédent (s’il n’y en a pas) et (ii) s’il n’y a pas un jour
correspondant dans ce mois, cette période s’achèvera le dernier jour ouvrable de ce mois. Si le Dividende Préférentiel
n’est pas payé intégralement sur toutes les Parts P, alors tel Dividende Préférentiel ou la partie restée impayée, qui, à
toutes fins sera, jusqu’à son paiement, considérée comme un Dividende Préférentiel accru et impayé, sera payé à une
date de paiement subséquente mensuelle ou à des dates conformément aux dispositions de l’article 17.
c) Le Dividende Initial et le Dividende Préférentiel devront être déclarés et payés en priorité à tous les paiements de
dividendes ou remboursements (par rachat des Parts O, diminution du capital social ou autrement) sur les Parts O.
d) Les Parts P ont droit à un paiement préférentiel sur les Parts O en ce qui concerne les distributions de liquidation
dans le cas de la dissolution et de la liquidation de la société.
Chaque détenteur des Parts P aura droit à des distributions de liquidation correspondant au total de la valeur nomi-
nale des Parts P et de la prime d’émission des Parts P et tout Dividende Préférentiel accru et impayé.
e) Les Parts P n’ont pas droit à une part des paiements de dividende ou de liquidation autres que ceux prévus aux
articles 6.6. a) à d).
f) Les Parts P ne sont pas rachetables et ne pourront en aucun cas être rachetées par la société même en cas d’une
diminution du capital.
6.7 Les Parts O ont droit à la différence entre les sommes distribuables après déduction des distributions de dividende
aux Parts P conformément aux articles 6 a) et 6 b) et les distributions de liquidation conformément à l’article 6 d).»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 7 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. Prime d’Emission Préférentielle
7.1 Les fonds reçus en tant que Prime d’Emission des Parts P lors de l’émission des Parts P ont été alloués à une
réserve spéciale, à l’exception de ceux alloués à la réserve légale. Cette réserve est à la disposition des associés et du
conseil de gérance, selon le cas, en vue de distributions de dividende et de liquidation exclusivement aux détenteurs des
Parts P.
7.2 La Prime d’Emission des Parts P est convertible en nouvelles parts préférentielles émises (les «Nouvelles Parts
P») seulement aux fins de vote à une assemblée générale extraordinaire des associés, qui aura comme seul point à l’or-
dre du jour de décider de la dissolution et de la liquidation de la société.
7.3 La conversion de la Prime d’Emission des Parts P en de nouvelles Parts P sera soumise aux dispositions suivantes:
48062
a) Chaque associé à le droit de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des associés qui aura à l’ordre du jour
les deux points suivants: (i) la conversion de la Prime d’Emission des Parts P en de nouvelles Parts P et (ii) la dissolution
et la liquidation de la société.
b) Les seuls points qui peuvent être traités à cette assemblée sont les deux (2) points énumérés ci-avant, qui devront
être considérés ensemble à cette assemblée, plutôt que l’un d’entre eux seulement. L’assemblée devra d’abord décider
de la conversion de la Prime d’Emission des Parts P en nouvelles Parts P, en tenant compte des dispositions relatives au
quorum et à la majorité telles que prévues à l’article 14.7 b). La même assemblée des associés décidant de la dissolution
et de la liquidation de la société devra tenir compte des nouvelles Parts P émises conformément au premier point de
l’ordre du jour de cette assemblée, les dispositions de quorum et de majorité étant déterminées conformément à l’ar-
ticle 14.7 a).
c) Le détenteur de chaque Part P sera autorisé à recevoir une (1) nouvelle Part P pour chaque cent livres sterling
(GBP 100,-) de la Prime d’Emission des Parts P libérés en rapport avec chaque Part P qu’il y a lieu de convertir en de
Nouvelles Parts P.
d) Les Nouvelles Parts P devront avoir les mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions comme ceux attachés
aux Parts P existantes, sauf que, à partir de la date de conversion de la Prime d’Emission des Parts P en de Nouvelles
Parts P, toute référence à l’article 6.6 à «la valeur nominale des Parts P augmentée de la Prime d’Emission des Parts P»
sera remplacée par «la valeur nominale des Parts P».»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 14.6, paragraphe 5 (toutes les autres dispositions demeurant inchangées)
des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«(...) toute modification aux droits des Parts O et des Parts P, (...).»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 14.7 des statuts:
«14.7 Lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés, une résolution sera valablement prise si elle est
unanimement approuvée par tous les associés à l’exception d’une assemblée générale extraordinaire des associés ayant
à se prononcer sur:
a) la dissolution et la liquidation de la société, comprenant la dissolution et la liquidation en conformité de l’article
7.3 et, pour éviter tout doute, la nomination de liquidateur(s), qui sera valablement prise si la majorité en nombre des
associés représentant au moins trois quarts du capital social vote en faveur de la résolution; et
b) la conversion de la Prime d’Emission des Parts P en Parts P nouvelles conformément à l’article 7.3, qui sera vala-
blement prise dès lors qu’une majorité en nombre des associés représentant au moins trois quarts du capital social vote
en faveur de la conversion, étant entendu que tout vote contre la conversion déclenchera automatiquement la dissolu-
tion et la liquidation de la société.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée a décidé de créer une nouvelle section 16.3 à l’article 16 (toutes les autres dispositions demeurant in-
changées) des statuts ayant la teneur suivante:
«16.3 Les détenteurs de Parts P seront autorisés à recevoir, et la société devra leur accorder, à chaque date de paie-
ment du Dividende Préférentiel, un reçu fiscal, sous une forme satisfaisante pour les détenteurs de Parts P.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier la première phrase de l’article 17.1 des statuts de la société (toutes les autres dis-
positions demeurant inchangées) afin de lui donner la teneur suivante:
«17.1 Conformément aux articles 6.6. et 16, le conseil de gérance est autorisé à procéder, chaque fois qu’il le consi-
dère comme approprié et à tout moment pendant l’année sociale, au paiement de dividendes intérimaires aux Parts O
et Parts P. Ce paiement est uniquement soumis aux trois (3) conditions suivantes: (...).»
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier ultérieurement l’article 17 des statuts de la société (toutes les autres dispositions
demeurant inchangées) afin d’ajouter deux nouvelles sections numérotées 17.3 et 17.4, ayant la teneur suivante:
«17.3 L’article 16.3 s’applique aux distributions de dividendes intérimaires.
17.4 Pour les besoins de cet article, tout Dividende Préférentiel payé est considéré comme un paiement de dividende
intérimaire.»
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 18 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
«Au moment où la société cesse d’exister, soit du fait de résolutions des associés à cet effet soit du fait de la disso-
lution et de la liquidation automatique conformément aux dispositions de l’article 14.7 b), la liquidation sera faite par un
(1) ou plusieurs liquidateurs, nommés par les associés qui vont déterminer leur nombre, leurs pouvoirs et leur rému-
nération, en conformité de l’article 14.7 a) ci-dessus, parmi une liste de personnes proposées par BARCLAYS BANK
PLC ou une de ses filiales.»
48063
<i>Evaluationi>
L’apport en nature composé de l’intégralité de l’actif et du passif d’une société constituée au sein de l’Union Euro-
péenne, la société se réfère à à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 relative à l’exonération fiscale du capital.
L’expression intégralité de l’actif et du passif comprend les articles énumérés ci-dessus et plus spécialement les articles
dans les comptes de BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED en date du 10 février 2006 et tout actif et passif inconnus
au moment où l’apport a été fait par BRAVEN INVESTMENTS No. 2 LIMITED.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ neuf mille euros (9.000,- EUR).
<i>Déclarationi>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Steffen, M.-C. Frank, A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, vol. 27CS, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022396/202/669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
GIV LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.261.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 mars 2006.
(022397/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
EUROLINE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.855.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 janvier 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04348. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018054/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
Senningerberg, le 24 février 2006.
P. Bettingen.
P. Bettingen
<i>Notairei>
MM. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
48064
EUGENIE PATRI SEBASTIEN («EPS»), Société Anonyme,
(anc. Société en Commandite par Actions).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 94.049.
—
RECTIFICATIF
<i>Acte rectificatif de la réquisition, enregistrée le 7 février 2006 sous la référence LSO-BN01749i>
<i>et déposée le 10 février 2006 sous le numéro B 94.049i>
En date du 23 janvier 2006, EUGENIE PATRI SEBASTIEN S.A. a procédé au rachat de 100.000 de ses actions propres
de classe D.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN06115. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020555//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.
ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.979.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 mars 2006.
(021786/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
APV (GEBOMSA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 111.269.
—
In the year two thousand six, the twenty-third day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of APV (GEBOMSA), S.à r.l., a Luxem-
bourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 9, rue Schiller in
L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register with number B 111.269 (the Com-
pany). The Company has been incorporated on 7 October 2005 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
There appeared:
1. 3i EUROPARTNERS IVa LP, a limited partnership incorporated under the laws of the United Kingdom, having its
registered office at 91 Waterloo Road, London, SE1 8XP, United Kingdom,
2. 3i EUROPARTNERS IVb LP, a limited partnership incorporated under the laws of the United Kingdom, having its
registered office at 91 Waterloo Road, London, SE1 8XP, United Kingdom,
3. 3i EUROPARTNERS IVc LP, a limited partnership incorporated under the laws of the United Kingdom, having its
registered office at 91 Waterloo Road, London, SE1 8XP, United Kingdom,
hereby represented by Mr Pieter Theunissen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London
on 20 January 2006.
The appearing parties above appear in their capacity as shareholders of the Company and are hereafter designated
as the Shareholders.
The proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the entirety
of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening formalities.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 34,000 (thirty-four thousand Euro) in order to
bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500
(five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 46,500 (forty-six thousand and
Luxembourg, le 28 février 2006.
Signature.
P. Bettingen
<i>Notairei>
48065
five hundred Euro), by way of the issue of 1,360 (one thousand three hundred sixty) new shares of the Company, having
a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
3. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 2. above.
4. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the company in order to reflect the increase
of the share capital adopted under item 2.
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company and CITCO (LUXEMBOURG) S.A. to proceed on behalf of the Company to the
registration of the newly issued shares in the share register of the Company.
6. Amendment to article 12 of the articles of association of the Company, by inserting an eight and ninth paragraph
in said article, in order to enable the managers to take decisions by way of telephone or video conference call or any
other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other, as
well as to allow the managers to resolve by way of circular resolutions.
7. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,
the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by EUR 34,000 (thirty-four thousand Euro) in
order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represent-
ed by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per share to EUR 46,500 (forty-
six thousand and five hundred Euro) by way of the creation and issue of 1,360 (one thousand three hundred sixty) new
shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Shareholders, represented as stated here above, declare to (i) subscribe to the share capital increase represented
by 1,360 (one thousand three hundred sixty) new shares of the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty-
five Euro) each, and an aggregate nominal value of EUR 34,000 (thirty-four thousand Euro), and to (ii) pay them up en-
tirely together with an issue premium thereon in the aggregate amount of EUR 1,420 (one thousand four hundred and
twenty Euro) to be allocated to the share premium reserve of the Company by way of:
(i) A contribution in kind, consisting of 12,509 (twelve thousand five hundred and nine) shares of YUGUREDA, S.L.,
a Spanish Sociedad Unipersonal, having its registered office at Móstoles (Madrid), calle Juan de la Cierva, 17, Spain
(YUGUREDA). Such contribution is made by 3i EUROPARTNERS IVa LP against the issue of 480 (four hundred and
eighty) shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each;
(ii) A contribution in kind, consisting of 11,484 (eleven thousand four hundred and eighty-four) shares of YUGURE-
DA. Such contribution is made by 3i EUROPARTNERS IVb LP against the issue of 441 (four hundred and forty-one)
shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each; and
(iii) A contribution in kind, consisting of 11,427 (eleven thousand four hundred and twenty-seven) shares of
YUGUREDA. Such contribution is made by 3i EUROPARTNERS IVc LP against the issue of 439 (four hundred and thir-
ty-nine) shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
Such contributions in kind in an aggregate amount of EUR 35,420 (thirty-five thousand four hundred and twenty Euro)
are to be allocated as follows:
(i) An amount of EUR 34,000 (thirty-four thousand Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of
the Company; and
(ii) The balance of EUR 1,420 (one thousand four hundred and twenty Euro) is to be allocated to the share premium
reserve of the Company.
I. With respect to the contribution by 3i EUROPARTNERS IVa LP
It results from a certificate issued by the management of 3i EUROPARTNERS IVa LP that:
«1. The Shares are part of those shown on the attached balance sheet of YUGUREDA dated 30 November 2005;
2. The Shares are in registered form;
3. The Shares are fully paid up;
4. 3i EUROPARTNERS IVa LP is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
5. The Shares are not encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exist no rights to
acquire any pledge or usufruct on the shares and the shares are not subject to any attachment;
6. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Shares be transferred to it;
7. According to Spanish law and the articles of association of YUGUREDA, the Shares are freely transferable;
8. All formalities required in Spain subsequent to the contribution in kind of the Shares at the occasion of the share
capital increase of the Company have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the relevant deed from
the officiating notary;
48066
9. The contribution of the Shares to the Company is governed by and subject to the terms and conditions of a trans-
fer, contribution and subscription agreement dated on or around 23 January 2006 by and between, inter alia, 3i EU-
ROPARTNERS IVa LP and the Company; and
10. Based on generally accepted accounting principles, the Shares to be contributed in exchange for the newly issued
shares of the Company are worth at least EUR 12,509 (twelve thousand five hundred and nine Euro) and since the bal-
ance sheet date of 30 November 2005 no material changes have occurred which would have depreciated the contribu-
tion made to the Company.»
It results furthermore from a certificate issued by the management of YUGUREDA that in accordance with the
records of Yugureda and without any further inquiries made by such management:
«1. The Shares are part of those shown on the attached balance sheet of YUGUREDA dated 30 November 2005;
2. The Shares are in registered form;
3. The Shares are fully paid up;
4. 3i EUROPARTNERS IVa LP is solely entitled to the Shares;
5. According to Spanish law and the articles of association of YUGUREDA, the Shares are freely transferable; and
6. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Shares be transferred to it.»
II. With respect to the contribution by 3i EUROPARTNERS IVb LP
It results from a certificate issued by the management of 3i EUROPARTNERS IVb LP that:
«1. The Shares are part of those shown on the attached balance sheet of YUGUREDA dated 30 November 2005;
2. The Shares are in registered form;
3. The Shares are fully paid up;
4. 3i EUROPARTNERS IVb LP is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
5. The Shares are not encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exist no rights to
acquire any pledge or usufruct on the shares and the shares are not subject to any attachment;
6. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Shares be transferred to it;
7. According to Spanish law and the articles of association of YUGUREDA, the Shares are freely transferable;
8. All formalities required in Spain subsequent to the contribution in kind of the Shares at the occasion of the share
capital increase of the Company have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the relevant deed from
the officiating notary;
9. The contribution of the Shares to the Company is governed by and subject to the terms and conditions of a trans-
fer, contribution and subscription agreement dated on or around 23 January 2006 by and between, inter alia, 3i EU-
ROPARTNERS IVb LP and the Company; and
10. Based on generally accepted accounting principles, the Shares to be contributed in exchange for the newly issued
shares of the Company are worth at least EUR 11,484 (eleven thousand four hundred and eighty-four Euro) and since
the balance sheet date of 30 November 2005 no material changes have occurred which would have depreciated the
contribution made to the Company.»
It results furthermore from a certificate issued by the management of YUGUREDA that in accordance with the
records of YUGUREDA and without any further inquiries made by such management:
«1. The Shares are part of those shown on the attached balance sheet of YUGUREDA dated 30 November 2005;
2. The Shares are in registered form;
3. The Shares are fully paid up;
4. 3i EUROPARTNERS IVb LP is solely entitled to the Shares;
5. According to Spanish law and the articles of association of YUGUREDA, the Shares are freely transferable; and
6. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Shares be transferred to it.»
III. With respect to the contribution by 3i EUROPARTNERS IVc LP
It results from a certificate issued by the management of 3i EUROPARTNERS IVc LP that:
«1. The Shares are part of those shown on the attached balance sheet of YUGUREDA dated 30 November 2005;
2. The Shares are in registered form;
3. The Shares are fully paid up;
4. 3i EUROPARTNERS IVc LP is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
5. The Shares are not encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exist no rights to
acquire any pledge or usufruct on the shares and the shares are not subject to any attachment;
6. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Shares be transferred to it;
7. According to Spanish law and the articles of association of YUGUREDA, the Shares are freely transferable;
8. All formalities required in Spain subsequent to the contribution in kind of the Shares at the occasion of the share
capital increase of the Company have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the relevant deed from
the officiating notary;
9. The contribution of the Shares to the Company is governed by and subject to the terms and conditions of a trans-
fer, contribution and subscription agreement dated on or around 23 January 2006 by and between, inter alia, 3i EU-
ROPARTNERS IVc LP and the Company; and
10. Based on generally accepted accounting principles, the Shares to be contributed in exchange for the newly issued
shares of the Company are worth at least EUR 11,427 (eleven thousand four hundred and twenty-seven Euro) and since
48067
the balance sheet date of 30 November 2005 no material changes have occurred which would have depreciated the
contribution made to the Company.»
It results furthermore from a certificate issued by the management of YUGUREDA that in accordance with the
records of YUGUREDA and without any further inquiries made by such management:
«1. The Shares are part of those shown on the attached balance sheet of YUGUREDA dated 30 November 2005;
2. The Shares are in registered form;
3. The Shares are fully paid up;
4. 3i EUROPARTNERS IVc LP is solely entitled to the Shares;
5. According to Spanish law and the articles of association of YUGUREDA, the Shares are freely transferable; and
6. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Shares be transferred to it.»
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-
pearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.
The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital, as
follows:
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the above
resolution so that it reads henceforth as follows:
«Art. 6. Capital. The capital is set at EUR 46,500 (forty-six thousand and five hundred Euro) divided into 1,860 (one
thousand eight hundred and sixty) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-
powers and authorizes any manager of the Company and CITCO (LUXEMBOURG) S.A. to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 12 of the articles of association of the Company by inserting an eighth and
ninth paragraph in said articles, which will read as follows:
«Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak
to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.»
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de APV (GEBOMSA), S.à r.l., une so-
ciété à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9, rue Schiller à L-2519 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.269 (la Société).
La Société a été constituée le 7 octobre 2005 en vertu d’un acte de Maître Henri Hellinckx, précité, non encore publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
Ont comparu:
1. 3i EUROPARTNERS IVa LP, une limited partnership de droit britannique ayant son siège social au 91 Waterloo
Road, London, SE1 8XP, Royaume-Uni,
2. 3i EUROPARTNERS IVb LP, une limited partnership de droit britannique ayant son siège social au 91 Waterloo
Road, London, SE1 8XP, Royaume-Uni,
Shareholder
Number of Shares
3i EUROPARTNERS IVa LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
3i EUROPARTNERS IVb LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
3i EUROPARTNERS IVc LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
48068
3. 3i EUROPARTNERS IVc LP, une limited partnership de droit britannique ayant son siège social au 91 Waterloo
Road, London, SE1 8XP, Royaume-Uni,
ici représentées par Maître Pieter Theunissen, Avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration don-
née à Londres, le 20 janvier 2006.
Les parties comparantes dénommées ci-dessus comparaissent en leur qualité d’associé de la Société et sont désignés
ci-après en tant qu’Associés.
Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Les Associés représenté comme décrit ci-dessus ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre de jour, reproduit ci-après;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 34.000 (trente-quatre mille euros) afin de porter
le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 46.500 (quarante-six mille cinq
cents euros) par voie d’émission de 1.360 (mille trois cent soixante) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune;
3. Souscriptions et paiement de l’augmentation du capital social mentionnée sous le point 2. ci-dessus;
4. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital décrite
sous le point 2. ci-dessus;
5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir
et autorité donnés à tout gérant de la Société et à CITCO (LUXEMBOURG) S.A. afin de procéder, au nom de la Société,
à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;
6. Modification de l’article 12 des statuts de la société via l’insertion d’un huitième et d’un neuvième alinéa dans ledit
article afin d’autoriser les gérants à prendre des décisions par téléphone ou par vidéoconférence ou par tout autre
moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’entendre
mutuellement, et afin d’autoriser les gérants à passer des résolutions par voie circulaire;
7. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’entièreté du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-
vocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de EUR
34.000 (trente-quatre mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille
cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune, à EUR 46.500 (quarante-six mille cinq cents euros) par voie d’émission de 1.360 (mille trois cent soixante)
nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions et paiements suivants de l’augmentation du capital
social mentionnée sous la seconde résolution ci-dessus comme suit:
<i>Souscription - Paiementi>
Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, déclarent (i) souscrire à l’augmentation de capital de la Société
représentée par 1.360 (mille trois cent soixante) nouvelles parts sociales de la Société, chacune ayant une valeur nomi-
nale de EUR 25 (vingt-cinq euros) et par une valeur nominale totale de EUR 34.000 (trente-quatre mille euros) et (ii)
payer ces nouvelles parts sociales ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 1.420 (mille quatre
cent vingt euros) devant être affecté au compte prime d’émission de la Société au moyen de:
(i) Un apport en nature consistant en 12.509 (douze mille cinq cent neuf) parts sociales de YUGUREDA, S.L., une
société unipersonnelle de droit espagnol ayant son siège social au 17, calle Juan de la Cierva Madrid, Espagne (YUGU-
REDA). Cet apport en nature est réalisé par 3i EUROPARTNERS IVa LP en contrepartie de 480 (quatre cent quatre-
vingts) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingts-cinq euros) chacune;
(ii) Un apport en nature consistant en 11.484 (onze mille quatre cent quatre-vingt-quatre) parts sociales de YUGU-
REDA. Cet apport en nature est réalisé par 3i EUROPARTNERS IVb LP en contrepartie de 441 (quatre cent quarante
et une) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune; et
(iii) Un apport en nature consistant en 11.427 (onze mille quatre cent vingt-sept) parts sociales de YUGUREDA. Cet
apport en nature est réalisé par 3i EUROPARTNERS IVc LP en contrepartie de 439 (quatre cent trente-neuf) parts so-
ciales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
Cet apport en nature d’un montant total de EUR 35.420 (trente-cinq mille quatre cent vingt euros) doit être affecté
comme suit:
(i) Un montant de EUR 34.000 (trente-quatre mille euros) au compte capital social de la Société; et
(ii) Un montant de EUR 1.420 (mille quatre cent vingt euros) au compte prime d’émission de la Société.
48069
I. Concernant l’apport par 3i EUROPARTNERS IVa LP:
Il résulte d’un certificat produit par la direction de 3i EUROPARTNERS IVa LP que:
« (1) Les Parts Sociales font partie de celles apparaissant sur le bilan annexé de YUGUREDA daté du 30 novembre
2005;
(2) Les Parts Sociales sont consignées dans un registre;
(3) Les Parts Sociales sont entièrement libérées;
(4) 3i EUROPARTNERS IVa LP est le seul ayant-droit des Parts Sociales avec le pouvoir d’en disposer;
(5) Aucune des Parts Sociales ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit de gage ou
de droit de jouissance sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne font l’objet d’aucune saisie;
(6) Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales;
(7) Conformément au droit espagnol et aux statuts de YUGUREDA, les Parts Sociales sont librement cessibles;
(8) Toutes les formalités requises en Espagne afférentes à l’apport en nature des Parts Sociales lors de l’augmentation
de capital de la Société ont été ou seront effectuées dès réception d’une copie certifiée conforme de l’acte notarié dé-
livrée par le notaire instrumentaire;
(9) L’apport des Parts Sociales à la Société est régi par et sujet aux conditions d’un contrat de cession, d’apport et
de souscription daté du 23 janvier 2006 conclu par et entre, entre autres, 3i EUROPARTNERS IVa LP et la Société; et
(10) Sur la base des principes comptables généralement acceptés, les Parts Sociales à apporter à la Société en con-
trepartie de parts sociales nouvellement émises de la Société ont une valeur d’au moins EUR 12.509 (douze mille cinq
cent neuf euros), et depuis le bilan daté du 30 novembre 2005 il n’y a eu aucun changement matériel susceptible de
déprécier l’apport fait à la Société.»
Il résulte en outre d’un certificat produit par la direction de YUGUREDA que, conformément aux dossiers de YU-
GUREDA et sans autres investigations faites par cette direction:
« (1) Les Parts Sociales font partie de celles apparaissant sur le bilan annexé de YUGUREDA daté du 30 novembre
2005;
(2) Les Parts Sociales sont consignées dans un registre;
(3) Les Parts Sociales sont entièrement libérées;
(4) 3i EUROPARTNERS IVa LP est le seul ayant-droit des Parts Sociales;
(5) Conformément au droit espagnol et aux statuts de YUGUREDA, les Parts Sociales sont librement cessibles; et
(6) Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales.»
II. Concernant l’apport par 3i EUROPARTNERS IVb LP:
Il résulte d’un certificat produit par la direction de 3i EUROPARTNERS IVb LP que:
« (1) Les Parts Sociales font partie de celles apparaissant sur le bilan annexé de YUGUREDA daté du 30 novembre
2005;
(2) Les Parts Sociales sont consignées dans un registre;
(3) Les Parts Sociales sont entièrement libérées;
(4) 3i EUROPARTNERS IVb LP est le seul ayant-droit des Parts Sociales avec le pouvoir d’en disposer;
(5) Aucune des Parts Sociales ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit de gage ou
de droit de jouissance sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne font l’objet d’aucune saisie;
(6) Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales;
(7) Conformément au droit espagnol et aux statuts de YUGUREDA, les Parts Sociales sont librement cessibles;
(8) Toutes les formalités requises en Espagne afférentes à l’apport en nature des Parts Sociales lors de l’augmentation
de capital de la Société ont été ou seront effectuées dès réception d’une copie certifiée conforme de l’acte notarié dé-
livrée par le notaire instrumentaire;
(9) L’apport des Parts Sociales à la Société est régi par et sujet aux conditions d’un contrat de cession, d’apport et
de souscription daté du 23 janvier 2006 conclu par et entre, entre autres, 3i EUROPARTNERS IVb LP et la Société; et
(10) Sur la base des principes comptables généralement acceptés, les Parts Sociales à apporter à la Société en con-
trepartie de parts sociales nouvellement émises de la Société ont une valeur d’au moins EUR 11.484 (onze mille quatre
cent quatre-vingt-quatre euros), et depuis le bilan daté du 30 novembre 2005 il n’y a eu aucun changement matériel
susceptible de déprécier l’apport fait à la Société.»
Il résulte en outre d’un certificat produit par la direction de YUGUREDA que, conformément aux dossiers de YU-
GUREDA et sans autres investigations faites par cette direction:
« (1) Les Parts Sociales font partie de celles apparaissant sur le bilan annexé de YUGUREDA daté du 30 novembre
2005;
(2) Les Parts Sociales sont consignées dans un registre;
(3) Les Parts Sociales sont entièrement libérées;
(4) 3i EUROPARTNERS IVb LP est le seul ayant-droit des Parts Sociales;
(5) Conformément au droit espagnol et aux statuts de YUGUREDA, les Parts Sociales sont librement cessibles; et
(6) Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales.»
III. Concernant l’apport par 3i EUROPARTNERS IVc LP:
48070
Il résulte d’un certificat produit par la direction de 3i EUROPARTNERS IVc LP que:
« (1) Les Parts Sociales font partie de celles apparaissant sur le bilan annexé de YUGUREDA daté du 30 novembre
2005;
(2) Les Parts Sociales sont consignées dans un registre;
(3) Les Parts Sociales sont entièrement libérées;
(4) 3i EUROPARTNERS IVc LP est le seul ayant-droit des Parts Sociales avec le pouvoir d’en disposer;
(5) Aucune des Parts Sociales ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit de gage ou
de droit de jouissance sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne font l’objet d’aucune saisie;
(6) Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales;
(7) Conformément au droit espagnol et aux statuts de YUGUREDA, les Parts Sociales sont librement cessibles;
(8) Toutes les formalités requises en Espagne afférentes à l’apport en nature des Parts Sociales lors de l’augmentation
de capital de la Société ont été ou seront effectuées dès réception d’une copie certifiée conforme de l’acte notarié dé-
livrée par le notaire instrumentaire;
(9) L’apport des Parts Sociales à la Société est régi par et sujet aux conditions d’un contrat de cession, d’apport et
de souscription daté du 23 janvier 2006 conclu par et entre, entre autres, 3i EUROPARTNERS IVc LP et la Société; et
(10) Sur la base des principes comptables généralement acceptés, les Parts Sociales à apporter à la Société en con-
trepartie de parts sociales nouvellement émises de la Société ont une valeur d’au moins EUR 11.427 (onze mille quatre
cent vingt-sept euros), et depuis le bilan daté du 30 novembre 2005 il n’y a eu aucun changement matériel susceptible
de déprécier l’apport fait à la Société.»
Il résulte en outre d’un certificat produit par la direction de YUGUREDA que, conformément aux dossiers de YU-
GUREDA et sans autres investigations faites par cette direction:
« (1) Les Parts Sociales font partie de celles apparaissant sur le bilan annexé de YUGUREDA daté du 30 novembre
2005;
(2) Les Parts Sociales sont consignées dans un registre;
(3) Les Parts Sociales sont entièrement libérées;
(4) 3i EUROPARTNERS IVc LP est le seul ayant-droit des Parts Sociales;
(5) Conformément au droit espagnol et aux statuts de YUGUREDA, les Parts Sociales sont librement cessibles; et
(6) Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales.»
Une copie des documents mentionnés ci-dessus après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le
compte des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.
L’Assemblée décide d’enregistrer que l’actionnariat de la Société est, suite à l’augmentation de capital ci-dessus, com-
posé comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus,
de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à EUR 46.500 (quarante-six mille cinq cents euros) représenté
par 1.860 (mille huit cent soixante) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements mention-
nés ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et à CITCO (LUXEMBOURG) S.A. à procéder, au
nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société via l’insertion d’un huitième et d’un neuvième
alinéa dans ledit article, qui aura désormais la teneur suivante:
«Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo
ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil
puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises
à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.000.
Associé
Nombre de parts sociales
3i EUROPARTNERS IVa LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
3i EUROPARTNERS IVb LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
3i EUROPARTNERS IVc LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
48071
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: P. Theunissen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 janvier 2006, vol. 435, fol. 22, case 11. – Reçu 354,20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023424/242/424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
TPE COACHING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3397 Roeser, 40, rue d’Alzingen.
R. C. Luxembourg B 114.756.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le premier mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Richard Jean Marck, gestionnaire de société, né à Thionville (F), le 9 octobre 1950, demeurant à L-3397
Roeser, 40, rue d’Alzingen;
2. Madame Monique Marck Niefer, sans profession, née à Amnéville (F), le 24 novembre 1949, demeurant à L-3397
Roeser, 40, rue d’Alzingen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entres les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de TPE COACHING, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Roeser.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet l’exécution pour compte de tiers de tous travaux administratifs incombant générale-
ment aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Très Petites Entreprises (TPE) y compris les services se rapportant
à l’exercice de la profession de comptable, y compris le développement et la commercialisation de logiciels informati-
ques.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement et indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.
Titre II. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Mersch, le 9 février 2006.
H. Hellinckx.
1. par Monsieur Marck Richard, préqualifié, quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2. par Madame Marck Monique, préqualifiée, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
48072
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédés entre vifs
à des non associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmi-
ses pour cause de mort à des non associés que moyennant le même agrément unanime. Dans ce dernier cas cependant,
le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit au conjoint survivant, soit à des descen-
dants.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et in-
ventaires de la société.
Titre III. Administration
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés, qui
fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l’assemblée des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, à
l’exception du premier exercice qui débute le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2006.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est
prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 21. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-
nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Marck Richard Jean, gestion-
naire de société, né à Thionville (F), le 9 octobre 1950, résident à L-3397 Roeser, 40, rue d’Alzingen.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature indi-
viduelle.
2) Le siège social est fixé à L-3397 Roeser, 40, rue d’Alzingen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Marck, M. Marck, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 52, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024330/220/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
Luxembourg, le 13 mars 2006.
G. Lecuit.
48073
AGENCE IMMOBILIERE WECKBECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 93.484.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00436, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(021842/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
CMC CAPITAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 114.738.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourteenth of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Derry Crowley, accountant, born in Cork, Ireland, on July 26, 1967, with professional address at 36 Strand
Road, Clonakilty, Co. Cork, Ireland.
2. Mr Donal McCarthy, accountant, born in Cork, Ireland, on October 17, 1967, with professional address at 36
Strand Road, Clonakilty, Co. Cork, Ireland.
All of them here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Lux-
embourg, by virtue of two proxies given on Februray 13, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the parties appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form
There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
The Company may at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding 40 Shareholders, either as
a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object
The purpose of the Company is the acquisition and administration of investment property in Germany. The Company
may also acquire ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatso-
ever and manage such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and ex-
change or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and
other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity
whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity
securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in
favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may carry out any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or in-
directly further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name
The Company will have the name of CMC CAPITAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Mandatairei>
48074
Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of
Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, shares
Art. 6. Subscribed capital
6.1. The capital of the Company is EUR 12,700 (twelve thousand seven hundred Euro) divided into 125 (one hundred
twenty-five) Ordinary Shares of EUR 100 each and 2 (two) A Ordinary Shares of EUR 100 each, all of which are fully
paid up.
6.2. Without prejudice to any special rights conferred on the holders of any existing shares or class of share, and in
compliance with the Luxembourg Law, any share may be issued with such rights or restriction as the Shareholders may
determine.
Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by a decision of the Shareholders’
meeting voting with the quorum and majority rules set out by these Articles, or, as the case may be, by the Law for any
amendment to these Articles.
Art. 8. Shares
Each share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders Ownership of a share carries im-
plicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting
of Shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
No shares may be transferred without the unanimous consent of all of the Shareholders.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a Shareholder
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the single Shareholder or of one of the Shareholders.
Chapter III. Board of Managers
Art. 10. Board of Managers
10.1. Board of Managers and Chairman
10.1.1. The Company will be managed by a Board of Managers, composed of a minimum of five and a maximum of
seven Managers, the majority of whom shall be resident in Luxembourg.
10.1.2. The Managers may be divided into two categories, to be respectively denominated «Category A Managers»
and «Category B Managers».
10.1.3. Each Manager will be elected by the Shareholders’ meeting, which will determine their number and the dura-
tion of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholders’
meeting holding a majority of votes. The holders of A Ordinary Shares may propose the appointment and removal of a
Manager.
10.2. Alternates
10.2.1. Each Manager shall be entitled to appoint an alternate to attend and vote at Board of Managers meetings in
his place.
10.2.2. The appointed alternate shall be entitled to receive notices of meetings of the Board of Managers and of all
committees of Managers of which his appointor is a member and shall be entitled to attend and vote and be counted in
a quorum at any such meeting which his appointor is not personally present and generally to perform all the functions
of his appointor in his absence.
10.3. Board Meetings
10.3.1. Board of Managers meetings shall be held at least four times a year in Luxembourg where all major decisions
regarding the business of the Company will be made. At least ten clear days’ written notice shall be given to each of the
Managers of all Board meetings (except if there are exceptional circumstances or the majority of the Managers agree to
shorter notice).
10.3.2. Each notice of meeting shall:
(i) specify a reasonably detailed agenda;
(ii) be accompanied by any relevant papers; and
(iii) be sent by courier or facsimile transmission or first class post.
10.3.3. The quorum at a Board meeting shall be three Managers present in person or duly represented, amongst
which at least one Manager of each Category if the case may be. If a quorum is not present, the Managers present shall
48075
adjourn the meeting to a specified place and time. Notice of the adjourned meeting shall be given by the Company to
all Managers.
10.3.4. Board of Managers meetings shall be chaired by the Chairman. If the Chairman is absent from any Board meet-
ing, the Managers present may appoint any one of their number to act as Chairman for the meeting.
10.3.5. At any Board meeting every Manager (or his alternate) present or represented shall have one vote.
10.3.6. All business arising at any Board of Managers meeting shall be determined by resolution passed by a majority
of the Managers present or represented, including at least the favourable vote of one Manager of each Category if the
case may be. In the case of an equality of votes, the Chairman shall not have a second or casting vote.
10.4. Committees of Managers
10.4.1. The Board of Managers, by unanimous resolution of all of the Managers of the Company may constitute com-
mittees of Managers.
10.4.2. The voting and quorum for Board committee meetings shall be the same as for Board of Managers meetings.
Art. 11. Powers of the Manager(s)
In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided
the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Board of Managers.
The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-
holders, selected from its members or not either Shareholders or not.
Art. 12. Day-to-day management
The Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several Manager(s) or
agent(s) and will determine the Manager’s/agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day management is
limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain the
prior approval from the Board of Managers.
Art. 13. Liability - Indemnification
The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.
Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is
a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for
hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any com-
pany or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affili-
ation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s)
Art. 15. General meeting of Shareholders
If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of Shareholders.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the Shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.
Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
48076
If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a Shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of
Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.
Art. 16. Powers of the meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object
of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 17. Procedure, Vote
Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject by virtue of these Ar-
ticles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles will be
taken by a majority of Shareholders representing at least three quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by Shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits
Art. 18. Financial Year
The Company’s accounting year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
Art. 19. Adoption of financial statements
At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of Shareholders for approval.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 20. Appropriation of profits
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to
be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the Shareholders.
The Shareholders may decide, at the majority vote, that the profit be either distributed, carried forward and allocated
to an extraordinary reserve.
Chapter VI. Dissolution, liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation
At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders
or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
In case the Company liquidates, the A Ordinary Shares are entitled to a preferred distribution on the liquidation pro-
ceeds, consisting of 20% of the growth achieved in excess of 10% compound annual results of the Company. The balance
of the liquidation proceeds will be distributed to the Ordinary Shares.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 23. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31, 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand seven hundred Euro (EUR 12,700.-)
is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand Euro.
1. Mr Derry Crowley, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Ordinary Shares + 1 A Ordinary Share
2. Mr Donal McCarthy, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Ordinary Shares + 1 A Ordinary Share
48077
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The Shareholders resolve to:
1. Appoint the following as Managers:
- Mr David De Marco, director of companies, Italian, born in Curepipe (Mauritius Island), on March 15, 1965, with
professional address at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Bruno Beernaerts, director of companies, born in Ixelles, Belgium, on November 4, 1963, with professional ad-
dress at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Alain Lam, director of companies, born in Rose Hill (Mauritius Island), on February 28, 1969, with professional
address at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Appoint Mr David De Marco, prenamed, as Chairman of the Board of Managers.
3. Fix the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. M. Derry Crowley, comptable, né à Cork, Irlande, le 26 juillet 1967, ayant son adresse professionnelle au 36 Strand
Road, Clonakilty, Co. Cork, Irlande.
2. M. Donal McCarthy, comptable, né à Cork, Irlande, le 17 octobre 1967, ayant son adresse professionnelle au 36
Strand Road, Clonakilty, Co. Cork, Irlande.
Représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg, en vertu de deux procurations données le 13 février 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d’une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme
Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la So-
ciété»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi»),
ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts).
La Société peut à tout moment être composée de plusieurs Associés, dans la limite de 40 Associés, par suite d’une
cession ou transmission, ou d’une émission de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet
La Société a pour objet l’acquisition et l’administration d’investissement immobilier en Allemagne. La Société peut
aussi acquérir des prises de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou entreprises
sous quelque forme que ce soit et gérer ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription,
achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances,
certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y
compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle
de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à
l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et
à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toute opération liée à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indi-
rectement se rapporte à cet objet.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
48078
Art. 4. Dénomination
La Société a comme dénomination CMC CAPITAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Chapitre II. Capital, parts sociales
Art. 6. Capital souscrit
6.1. Le capital de la Société est de EUR 12.700,- (douze mille sept cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)
Parts Ordinaires de EUR 100,- chacune et 2 (deux) Parts Ordinaires A de EUR 100,- chacune, toutes les parts étant
entièrement libérées.
6.2. Sans préjudice d’un quelconque droit spécifique conféré aux porteurs d’une quelconque part sociale ou classe de
part sociale existante, et conformément à la Loi Luxembourgeoise, toute part sociale peut être émise avec les droits ou
restrictions que les Associés détermineront.
Art. 7. Augmentation et diminution du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’Associé
unique ou des Associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par
la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire une voix à l’assemblée générale des Associés.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Associé
unique ou des Associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Aucune part sociale ne peut être cédée ou transmise sans l’accord unanime de tous les Associés.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un Associé
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite
de l’Associé unique ou d’un des Associés.
Chapitre III. Conseil de Gérance
Art. 10. Conseil de Gérance
10.1. Conseil de Gérance et Président
10.1.1. La Société est gérée par un Conseil de Gérance, composé au minimum de cinq et au maximum de sept Gé-
rants, la majorité d’entre eux devant être résidents luxembourgeois.
10.1.2. Les Gérants peuvent être divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de Catégorie A» et
«Gérants de Catégorie B».
10.1.3. Chaque Gérant sera nommé par les Associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils
pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par une décision des Associés représentant
une majorité des voix. Les porteurs de Parts Ordinaires A pourront proposer la nomination et la révocation d’un Gé-
rant.
10.2. Mandats
10.2.1. Chaque Gérant peut être autorisé à désigner un mandataire pour assister et voter à la réunion du Conseil de
Gérance à sa place.
10.2.2. Le mandataire désigné sera autorisé à recevoir les convocations aux réunions du Conseil de Gérance et de
tous les comités de Gérants dont son mandant est membre et sera autorisé à assister et voter et sera comptabilisé dans
le quorum d’une telle réunion quelconque à laquelle son mandant n’est pas personnellement présent et généralement
de remplir toutes les fonctions de son mandant en son absence.
10.3. Réunions du Conseil
10.3.1. Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au moins quatre fois par an au Luxembourg où toutes les
décisions importantes en relation avec les affaires de la Société seront prises. Au moins dix jours avant la tenue de toutes
les réunions du Conseil une convocation écrite sera donnée à chaque Gérant (sauf en cas de circonstances exception-
nelles ou si la majorité des Gérants accepte un délai de convocation plus court).
10.3.2. Chaque convocation devra:
(i) mentionner un agenda précis;
(ii) être accompagnée de toute documentation adéquate;
(iii) être envoyée par courrier ou facsimile ou courrier express.
48079
10.3.3. Le quorum d’une réunion du Conseil devra être de trois Gérants présents ou représentés, parmi lesquels au
moins un Gérant de chaque catégorie le cas échéant. Si le quorum n’est pas atteint, les Gérants présents ajourneront
la réunion à une date et place ultérieure. Une notification de la réunion ajournée sera donnée par la Société à tous les
Gérants.
10.3.4. Les réunions du Conseil de Gérance seront présidées par le Président. Si le Président ne peut être présent,
les Gérants présents désigneront l’un d’entre eux pour agir en tant que Président.
10.3.5. Lors de toute réunion du Conseil de Gérance, chaque Gérant (ou son mandataire) présent ou représenté
aura une voix.
10.3.6. Toute décision d’affaire lors d’une réunion du Conseil de Gérance sera déterminée par une résolution prise
à la majorité des Gérants présents ou représentés, incluant au moins le vote favorable d’un Gérant de chaque catégorie
le cas échéant. En cas d’égalité des votes, le Président n’aura pas de second vote ni de voix prépondérante.
10.4. Comités de Gérants
10.4.1. Le Conseil de Gérance, par une décision unanime de tous les Gérants de la Société, pourra constituer des
Comités de Gérants.
10.4.2. Le mode de vote et le quorum pour les réunions d’un Comité de Gérance seront les mêmes que pour les
réunions du Conseil de Gérance.
Art. 11. Pouvoirs des Gérants
Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes
les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que
les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-
nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient Associés ou non.
Art. 12. Gestion journalière.
Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Gérant(s) ou mandataire(s)
et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des Gérants/ mandataires, la durée de la période de
représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux
actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.
Art. 13. Responsabilité, indemnisation
Les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un Associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.
Art. 14. Conflit d’intérêt.
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront Gérant,
Associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la
Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, Associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre
société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le
motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou
d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des Associés.
Chapitre IV. Associé(s)
Art. 15. Assemblée générale des Associés
Si la Société comporte un Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée
générale des Associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions des Associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux Associés par lettre re-
48080
commandée. Dans ce dernier cas les Associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un Associé unique, les Associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des Associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux Associés en confor-
mité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les Associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout Associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, lequel peut ne pas être Associé.
Les assemblées générales des Associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des Associés régulièrement constituée représente l’ensemble des Associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-
ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.
Art. 17. Procédure - Vote
Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est soumise par les présents Sta-
tuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise par
une majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les Associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Chapitre V. Année sociale, Répartition
Art. 18. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 19. Approbation des comptes annuels
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare
un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’Associé unique ou, suivant le
cas, des Associés.
Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 20. Affectation des résultats
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est à la disposition des Associés.
Les Associés peuvent, à la majorité des voix, décider que le bénéfice sera soit distribué, soit reporté à nouveau, ou
transféré à une réserve spéciale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Dissolution, Liquidation
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou
non, nommés par les Associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
En cas de liquidation de la Société, les Parts Ordinaires A donneront droit à une distribution privilégiée des profits
de liquidation, correspondant à 20% de la croissance réalisée en excès de 10% des résultats annuels de la Société. Le
solde des profits de liquidation sera distribué aux Parts Ordinaires.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 22. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. M. Derry Crowley, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Parts Ordinaires + 1 Part Ordinaire A
2. M. Donal McCarthy, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Parts Ordinaires + 1 Part Ordinaire A
48081
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille sept cents euros (EUR 12.700,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.
<i>Décision des associési>
Les Associés décident de:
1. Nommer les personnes suivantes en tant que Gérants:
- M. David De Marco, directeur de sociétés, Italien, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, ayant son adresse
professionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Bruno Beernaerts, directeur de sociétés, né à Ixelles, Belgique, le 4 novembre 1963, ayant son adresse profes-
sionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Alain Lam, directeur de sociétés, né à Rose Hill (Ile Maurice), le 28 février 1969, ayant son adresse professionnelle
au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
La durée du mandat des Gérants est illimitée.
2. Nommer M. David De Marco, prénommé, en tant que Président du Conseil de Gérance.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, vol. 27CS, fol. 62, case 3. – Reçu 127 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024249/211/515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
FEROTRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.392.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07992, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(021727/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
FEROTRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.392.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07993, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(021728/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Luxembourg, le 23 février 2006.
J. Elvinger.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
48082
FEROTRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.392.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07995, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(021731/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
FEROTRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07997, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(021737/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
FEROTRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07999, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(021739/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
FEROTRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08001, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(021741/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
FEROTRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08002, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(021743/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
48083
KISLING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 110.029.
—
L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de KISLING INVESTMENT S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 110.029, constituée par acte du notaire instrumen-
taire, en date du 29 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1345 du 8 décembre
2005.
La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74,
rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente et une (31)
actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Echange des trente et une (31) actions avec une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) contre trois mille
cent (3.100) actions avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
2. Modification subséquente de l’article 3 alinéa 1
er
des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est procédé à la modification de la valeur nominale des actions qui passe de mille euros (EUR 1.000,-) à dix euros
(EUR 10,-) ainsi qu’à l’échange subséquent des trente et une (31) actions avec une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,-) contre trois mille cent (3.100) actions avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 3 alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. (alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent
(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à onze heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, vol. 27CS, fol. 80, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022392/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
KISLING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 110.029.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
242 du 21 février 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 9 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022393/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
48084
SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 29.256.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boule-
vard Roosevelt.
Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentale et l’a prié d’acter:
Que la société anonyme holding SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A. HOLDING, avec siège social à L-2450
Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de rési-
dence à Luxembourg, en date du 4 novembre 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
33 du 6 février 1989, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Thyes-Walch, en date du 21 décembre 1989, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 286 du 20 août 1990, inscrite au registre de commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 29.256.
Que le capital de ladite société est à ce jour de cent quarante-neuf mille euros (EUR 149.000,00), représenté par six
mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Que Mademoiselle Elisabeth Antona, prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de
ladite société SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A. HOLDING.
Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que Mademoiselle Elisabeth Antona, prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’elle a repris tout
l’actif, a réglé tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éven-
tuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.
Qu’en conséquence, la société SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A. HOLDING se trouve liquidée et a cessé
d’exister.
Que la comparante donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à
l’ancien siège de la société.
Et à l’instant-même, il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions de la société.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: E. Antona, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(022117/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
FARFISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.
R. C. Luxembourg B 70.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00538, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021847/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
FARFISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.
R. C. Luxembourg B 70.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00537, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021849/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Signature.
48085
DWS HEDGE, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 104.431.
—
<i>Beschluss des Verwaltungsratesi>
Der Unterzeichnende, als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, entscheidet gemäß Artikel 5 der Satzung der
Gesellschaft wie folgt:
1. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Oliver Behrens, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,
sowohl sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrats als auch das Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit
Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.
2. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Axel-Günter Benkner, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt
am Main, sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.
3. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Klaus-Michael Vogel, 2, boulevard Konrad Ade-
nauer, L-1115 Luxemburg, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in den
Verwaltungsrat aufgenommen wird. Er wird gleichzeitig zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt.
4. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Dr. Stephan Kunze, Mainzer Landstraße 178-190,
D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.
5. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Jochen Wiesbach, Mainzer Landstraße 178-190,
D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in
den Verwaltungsrat aufgenommen wird.
6. Es wird festgestellt, dass sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft demnach ab dem 1. Januar 2006 wie folgt zusam-
mensetzt:
Klaus-Michael Vogel (Vorsitzender),
Dr. Stephan Kunze,
Ernst Wilhelm Contzen,
Jochen Wiesbach.
Die oben genannten Beschlüsse wurden vom Verwaltungsrat zum 1. Januar 2006 unterzeichnet.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03321. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017969//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.
METROPARTECIPAZIONI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.923.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le quatre juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Marco Borello, indépendant, demeurant à Rome, Italie,
ici représenté par Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 20 juin 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire,
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivan-
tes:
- Le siège social statutaire et administratif de la société anonyme METROPARTECIPAZIONI S.A., avec siège social à
L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal a été transféré à Luxembourg, suivant procès-verbal d’assemblée générale ex-
traordinaire des associés, contenant une refonte complète des statuts, reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 773 du 22 mai 2002.
- La société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310)
actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
- La comparante déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, à savoir Monsieur
Marco Borello, prénommé.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société METROPARTECIPAZIONI S.A., prédésignée. Il
assume la fonction de liquidateur.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société METRO-
PARTECIPAZIONI S.A.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou
inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société METROPARTECIPAZIONI S.A., prédésignée.
E.W. Contzen.
48086
Les livres et documents comptables de la société METROPARTECIPAZIONI S.A., prédésignée, demeureront con-
servés pendant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-
meure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 14 juillet 2005, vol. 432, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): E. Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021983/242/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.594.
—
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg, le 5 avril 2005 et a adopté les résolutions sui-
vantes:
1. L’Assemblée a reconduit les mandats des administrateurs M. Frédéric Fasel, M. Pierre Etienne, M. Jerry Hilger et
Mme Michèle Berger.
2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05795. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020296/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.
GESTION PREMIER FUND, Société Anonyme.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 49.164.
—
Dear Unitholder,
We would like to inform you hereby of the changes made to PREMIER FUND, a collective investment fund (fonds
commun de placement) with multiple compartments (the «Fund») by the board of directors of GESTION PREMIER
FUND, acting in its capacity as management company of the Fund (the «Management Company») and which are the
following:
I. In line with the provisions of chapter 13 «Liquidation, dissolution and merger» of the latest prospectus in force of
the Fund (the «Prospectus»), the board of directors has decided to take all the necessary steps vis-à-vis the Commission
de Surveillance du Secteur Financier (the «Commission for the Supervision of the Financial Sector» or «CSSF») and the
unitholders of the Fund to put as of 17th May 2006 the following Sub-funds into liquidation:
PREMIER FUND - Portfolio 3
PREMIER FUND - Mixed Portfolio 8
PREMIER FUND - Mixed Portfolio 10
PREMIER FUND - Mixed Portfolio 11
PREMIER FUND - Mixed Portfolio 14
PREMIER FUND - Mixed Portfolio 19
PREMIER FUND - Mixed Portfolio 20
PREMIER FUND - Global International.
PREMIER FUND - Aim 7.
(together referred to as the «Sub-Funds»)
II. The assets not distributed to the unitholders of the Sub-Funds entitled thereto after the close of the liquidation
will be kept under custody by CACEIS BL for a period of six months. After the expiration of this period, assets shall be
deposited in scrow at the Caisse de Consignations.
III. The board of directors has resolved to proceed to the liquidation of the Sub-Funds as a consequence of the strat-
egy foreseen in the coming months by POPULAR BANCA PRIVADA S.A., in its capacity as promoter of the Fund.
Luxembourg, on 17th May 2006.
(02655/755/31)
Mersch, le 24 octobre 2005.
H. Hellinckx.
<i>Pour FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures
48087
SOBIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 46.394.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
5. Divers.
I (02379/655/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYRVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.266.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du mardi <i>13 juin 2006i> à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
I (02467/783/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PEMBROOKE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.375.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2006i> à 17.30 heures, à l’adresse du siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2005.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge au commissaire aux comptes et administrateurs.
Tous les documents sont à disposition des actionnaires au siège social de la société.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
I (02589/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
UBAM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.412.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui aura lieu le mercredi <i>7 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration.
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Lecture et approbation du rapport annuel au 31 décembre 2005.
48088
4. Affectation des résultats.
5. Décharge aux administrateurs pour l’année écoulée.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Les décisions concernant les points à l’ordre du jour ne requièrent pas de quorum. Les décisions seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout ac-
tionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav. Afin de parti-
ciper à l’Assemblée, les actionnaires au porteur sont priés de déposer leurs actions pour le 31 mai 2006 au plus tard au
siège de la Sicav ou à l’adresse suivante: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., 18, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg.
I (02529/1670/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EVENTS COMPANY TRADING S.A., Société Anonyme.
Capital social: 250.000 EUR.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.595.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2006i> à 14.00 heures, à l’adresse du siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2005.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge au commissaire aux comptes et administrateurs.
Tous les documents sont à disposition des actionnaires au siège social de la société.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
I (02590/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SAM COMPANY S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.295.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2006i> à 16.00 heures, à l’adresse du siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2005.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge au commissaire aux comptes et administrateurs.
Tous les documents sont à disposition des actionnaires au siège social de la société.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
I (02591/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FFTW FUNDS SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.079.
—
As the Extraordinary General Meeting of FFTW Funds Selection (the «Corporation») held on 16 May 2006 could not
validly deliberate for lack of quorum, shareholders are hereby invited to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(the «Meeting») which will be held at the registered office of the Corporation in Luxembourg, on <i>22 June 2006i> at 11.00
a.m. (Luxembourg time) to approve the proposed amendment to the Articles of Incorporation of the Corporation as
set out below under the Extraordinary Resolution.
48089
<i>Extraordinary resolution:i>
Amendment of the Articles of Incorporation by adding or changing the provisions outlined below:
1. Amendment of the last paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation to provide for an investment limit
of 10% of the net assets of any class in units of undertakings for collective investments as defined in article 41 (1)
e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment.
2. Amendment of article 21 of the Articles of Incorporation by adding the following wording as seventh paragraph:
«If the requests for redemption and/or conversion received for any class of shares for any specific Valuation Day
exceed a certain amount or percentage of the net asset value of such class, such amount or percentage being fixed
by the board of directors from time to time and disclosed in the offering documents, the board of directors may
defer such redemption and/or conversion requests to be carried forward for realisation on the next following ap-
plicable Valuation Day.»
3. Amendment of article 23 of the Articles of Incorporation by replacing the word «nominal» by «market» in item
A.(5).
<i>Quorum requirementsi>
No quorum is required and the passing of this Extraordinary Resolution requires the consent of two-thirds of the
votes expressed at the Meeting.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Any proxy which was sent for the Extraordinary General Meeting held on 16 May 2006 will remain valid unless spe-
cifically revoked by a new one.
Proxy forms, a draft of the restated Articles of Incorporation as well as a draft of the Prospectus are available upon
request at the registered office of the Corporation.
I (02654/755/33)
<i>The Board of Directorsi>.
INTERPORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.902.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(l’«Assemblée») de INTERPORTFOLIO (la «Société»), Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siè-
ge social de la Société, le jeudi <i> 15 juin 2006i> à 12 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 mars 2006.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2006.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice clos au 31 mars 2006.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont
priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège de la Société, où des formules de procuration
sont disponibles.
I (02656/755/24)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
SOCOFIGEST INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.043.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (02289/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48090
IFONAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.023.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mardi, <i>6 juin 2006i> à 8.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2005.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (00278/502/18)
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
(«AGM») and an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(«EGM») of the shareholders of MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. («MILLICOM») is convened to be held
at the Château de Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund, Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, on Tues-
day <i>May 30, 2006i> at 4.00 p.m. Central European time, to consider and vote on the following resolutions:
<i>Agenda:i>
AGM
1. To receive the Directors’ Report (Rapport de Gestion) and the Report of the Independent Auditors on the con-
solidated and parent company accounts at December 31, 2005.
2. To approve the consolidated accounts and the parent company accounts for the year ended December 31, 2005.
3. To allocate the result (losses) of the year ended December 31, 2005.
4. To discharge the Board of Directors for the year ended December 31, 2005.
5. To re-elect Vigo Carlund, Donna Cordner, Ernest Cravatte, Lars-Johan Jarnheimer, Daniel Johannesson, Tope
Lawani, Michel Massart and Cristina Stenbeck as Directors for a term ending at the 2007 AGM.
6. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as external auditor of MILLICOM for a term ending at the 2007
AGM.
7. To approve the Directors’ fees.
8. To approve (i) certain changes to the terms of the stock options previously granted to the Directors, and (ii) the
entry between each Director and MILLICOM into an agreement whereby, if MILLICOM is subject to a change of
control, the Directors’ stock options and restricted shares will vest immediately.
9. Miscellaneous.
EGM
Allocation of Result (Loss) for the Year (Item 3)
On a parent company basis MILLICOM incurred a loss in the year 2005, which loss is proposed to be set off in its
entirety against the share premium account.
Appointment of the Members of the Board of Directors (Item 5)
The Nominations Committee proposes that, until the end of the AGM to be held in 2007, Daniel Johannesson, Donna
Cordner, Cristina Stenbeck, Michel Massart, Ernest Cravatte, Vigo Carlund, Lars-Johan Jarnheimer and Tope Lawani be
re-elected directors of MILLICOM. Raymond Kirsch will not stand for re-election.
Appointment of the External Auditor (Item 6)
The Board of Directors proposes that PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, be re-appointed as external
auditor for a term ending at the AGM to be held in 2007.
Directors’ Fees (Item 7)
10. To (a) approve the grant of (i) restricted shares to the directors in relation to 2005, (ii) additional 2005 stock
options to senior management that had not been approved by the May 31, 2005 AGM, and (iii) restricted per-
formance shares to senior management and employees in relation to 2005; and (b) acknowledge that the grants
under this Item 10 will be made within the current authorised share capital of MILLICOM.
11. To pass a resolution in accordance with the requirements of article 100 of the Luxembourg law of August 10,
1915 on commercial companies, as amended (the «Luxembourg Company Law»).
12. Miscellaneous.
48091
The Nominations Committee proposes to the Meeting that the fees for the members of the Board of Directors for
the period until the end of the AGM to be held in 2007 be a total of USD 490,000.-.
Approval of Changes to the terms of the Directors’ Stock Options; and the entry into change of control Agreements
(Item 8)
It is proposed that the AGM approve several changes to the terms of the stock options granted to the directors to
date, including in particular (i) the term of the stock option agreements, meaning that the options will no longer auto-
matically expire if a Director ceases to be a member of the MILLICOM Board or the Board of a sister company, and (ii)
the vesting term, which was previously staggered over three years in the same manner as the vesting of employee stock
options, will occur on the first anniversary of the stock option grant so as to correspond to the directors’ one-year
term of office.
It is also proposed that the AGM ratify the entry by each director and MILLICOM into an agreement whereby, if
MILLICOM is subject to a change of control, the directors’ stock options will vest immediately and their restricted
shares will become unrestricted upon the change of control.
Grant of restricted Shares to Directors in relation to 2005, Additional Stock Options to Senior Management for 2005,
and performance Shares to employees in relation to 2005 (Item 10)
It is proposed that the grant of restricted shares to Directors in relation to 2005 be approved. The Board of Direc-
tors proposes to replace the grant of stock options going forward by the grant of restricted shares of MILLICOM com-
mon stock. The restricted shares will be subject to a one-year holding period. The total number of restricted shares to
be granted to each Director in relation to 2005 is proposed to be a number equal to USD 50,000.- divided by the closing
price of the MILLICOM stock on the NASDAQ National Market on May 30, 2006.
Prior to the Chief Financial Officer joining MILLICOM on September 1, 2005, the Compensation Committee had
approved the grant to the CFO of a total of 100,000 stock options. The total amount of unallocated stock options
approved by the 2005 AGM was insufficient to cover the entirety of the grant of 100,000 stock options. Approval is
therefore requested for the grant of the remaining 20,240 stock options for the CFO for 2005 with terms identical to
those of the stock options approved by the 2005 AGM (USD 20.562 per share).
Starting on May 30, 2006, the grant of stock options to employees is being replaced by the grant of performance
shares under MILLICOM’s new Long-Term Incentive Plan (LTIP) covering 2006-2008. The directors will not be included
in the LTIP and therefore, going forward, grants of employee performance shares under the LTIP will not be subject to
the AGM’s approval. In keeping with previous practice, and because year 2005 is not included in the LTIP, it is proposed
that the AGM approve the grant of up to 62,749 performance shares to employees in relation to 2005. The final number
of 2005 performance shares to be issued to employees will be determined by the Board of directors according to a
formula based on the employees’ salaries and the closing price of MILLICOM’s common stock on the NASDAQ
National Market on May 30, 2006.
Resolution required by Article 100 of the Luxembourg Company (Item 11)
Luxembourg Company Law requires that, if a company’s accumulated losses are equal to at least half of its issued
share capital, the company’s shareholders must take a vote on whether to wind-up the company or continue its business.
At December 31, 2005, MILLICOM, on a parent company basis, had accumulated losses higher than half of its issued
share capital and the shareholders are therefore required to take such a vote at an EGM to be held at the same time as
this AGM (unless the quorum is insufficient, in which case the EGM will be reconvened). The parent company has his-
torically incurred such losses and the MILLICOM shareholders have for a number of years been called upon to take such
a vote.
Other information
There is no quorum of presence requirement for the AGM/EGM, except that a quorum of presence of half of the
issued and outstanding share capital is required for purposes of Item 11 of the Agenda (EGM). The AGM agenda items
and item 10 of the EGM agenda are adopted by a simple majority of the shares present or represented at the AGM/EGM.
The MILLICOM consolidated financial statements for the year ended December 31, 2005 are available on MILLI-
COM’s website (www.millicom.com). The statutory parent company financial statements will be available from May 15,
2006 upon request by e-mail to: information&commat;millicom.com.
Participation in the AGM is reserved to shareholders who give notice of their intention to attend the AGM/EGM by
mail or return a duly completed proxy form at the following address: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.,
75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Luxembourg, attention: Ms. Véronique Mathieu, telephone: + 352 27 759 287,
fax: + 352 27 759 359, so that it shall be received no later than Friday May 26, 2006, 5:00 p.m. Central European time.
Proxy forms are available upon request at MILLICOM’s registered office, at the above address and contact numbers.
Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend the meeting or to be represented at the AGM/EGM by
proxy have to request a power of attorney from Fischer Partners Fondkommission AB, P.O. Box 16027, SE-103-21
Stockholm, Sweden, telephone: + 46 8 463 85 00, and send it duly completed to MILLICOM’s address indicated above,
so that it shall be received no later than Friday May 26, 2006, 5:00 p.m. Central European time. Holders of Swedish
Depository Receipts having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily
register the Swedish Depository Receipts in their own name in the records maintained by VPC AB in order to exercise
their shareholders’ rights at the AGM/EGM. Such registration must be completed no later than Monday May 22, 2006.
May 12, 2006.
II (02278/5499/106)
<i>The Board of Directorsi>.
48092
BALZAC, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.240.
—
Les Actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises Agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises Agréé.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-
bles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 2 juin 2006
au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (02119/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARTIMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 110.033.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02290/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
G&P SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 70.712.
—
Die Aktionäre der G&P SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>31. Mai 2006i> um 15.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2005 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2005 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl bzw. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der G&P SICAV (DZ BANK
INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903
4009 angefordert werden.
Luxemburg, im Mai 2006.
II (02385/755/28)
<i>Der Verwaltungsrati>.
48093
TRANSCOM WorldWide S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.528.
—
Convening notice is given to the shareholders of the Company that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company will be held on <i>30 May 2006i> at 3.00 p.m. at Château de Septfontaines, 330, rue de
Rollingergrund, L-2441 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the Meeting) with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the external auditor of the Company on (i) the annual
accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2005 and (ii) the consolidated annual accounts
for the financial year ended 31 December 2005.
2. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2005.
3. Allocation of the results as of 31 December 2005 and approval of the Extraordinary Final Dividend of 35 Euro per
share for the year ended 2005 (the first 2% of any dividend being paid to the B shareholders and the balance being
split equally per share between the A and B shares), as proposed by the Board and approved by the Audit Com-
mittee at the Audit Committee meeting of 24 April 2006.
4. Discharge of the liability of the members of the Board of Directors and the external auditor of the Company for,
and in connection with, the financial year ended 31 December 2005.
5. Appointment of the members of the Board of Directors.
6. Appointment of the external auditor of the Company.
7. Determination of the Directors’ fees.
8. Approval of the procedure of the Nomination Committee for the election of members of the Board of Directors
at the Annual General Meeting to be held in 2007.
9. Miscellaneous.
Appointment of the Members of the Board of Directors (item 5)
The Nomination Committee proposes that, until the end of the Annual General Meeting to be held in 2007: Mr Wil-
liam Walker, Ms Cristina Stenbeck, Ms Susan Hooper, Mr. Björn Rosengren and Mr Jim Beers be re-elected as directors
of the Company, and that Ms Mia Brunell be appointed as a director of the Company. The Board of Directors proposes
that the meeting shall appoint William Walker as the Chairman of the Board of Directors, and that the Board of Direc-
tors appoint a Remuneration Committee and Audit Committee at a Board Meeting following the Annual General Meet-
ing.
Appointment of the External Auditor of the Company (item 6)
As recommended by the Audit Committee, the Nomination Committee proposes that ERNST & YOUNG S.A.,
Luxembourg be re-appointed as external auditor for a term ending at the Annual General Meeting of the shareholders
to be held in 2007. The remuneration of the auditor shall be paid in accordance with an approved bill which specifies
time, persons who worked and tasks performed.
Directors’ Fees (item 7)
The Nomination Committee proposes that the Meeting resolves that the fees for the members of the Board of
Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting to be held in 2007 be a total of EUR 260,000.
Approval of the procedure for the nomination of Board of Directors for the annual general meeting to be held in
2007 (item 8)
The Nomination Committee proposes that the Meeting approves the following procedure for preparing a proposal
for the election of members of the Board of Directors for the Annual General Meeting of 2007. The work shall be
executed by a Nomination Committee which will consist of at least 3 members representing major shareholders in
TRANSCOM WorldWide S.A. The Committee will be formed in September 2006 in consultation with the largest share-
holders in the Company, by number of voting shares held, at that time. The Nomination Committee will be elected for
a term of one year. The majority of the members of the Committee may not be members of the Board of Directors of
TRANSCOM WorldWide S.A. nor be employed by the Company. If a member of the Committee resigns before the
work is concluded, a replacement member is to be appointed in accordance with the foregoing criteria. Cristina Sten-
beck will be a member of the Committee and will also act as its convenor. The members of the Committee will appoint
the Chairman at their first meeting from amongst themselves. The composition of the Committee will be communicated
in the financial report for the third quarter of 2006.
The above proposal is supported by shareholders representing more than 50 per cent of the votes in the company
including among others EMESCO AB, INVESTMENT AB KINNEVIK, FJÄRDE AP-FONDEN, SEB FONDER and SEB
TRYGG LIV.
Other information
In respect of items 1 to 9 of the above agenda, no specific quorum is required for the valid deliberation or
acknowledgement of the Meeting and the resolutions are taken by a simple majority of the Class A shares represented
and voting at the Meeting.
Participation in the Meeting of shareholders is reserved for shareholders who file their intention to attend the
Meeting by mail and/or return a duly completed proxy form to the following address: TRANSCOM WORLDWIDE S.A.,
c/o Modern Treuhand, 11, boulevard Royal, B.P. 2599, L-1025 Luxembourg, Tel: + 352 - 27 751 350, Fax: + 352 - 27
48094
751 312, so that it shall be received not later than Friday, 26 May 2006, 3:00 p.m. Proxy forms for the Meeting are avail-
able at the same address.
Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend the Meeting or be represented at the Meeting via proxy
must request a power of attorney from FISCHER PARTNERS FONDKOMMISSION AB, P.O. Box 16027, SE-103-21
Stockholm, Sweden, Tel: +46 - 8 463 85 00 and send it duly completed to the following address: TRANSCOM World-
Wide S.A., c/o Modern Treuhand, 11, boulevard Royal, B.P. 2599, L-1025 Luxembourg, Tel: + 352 - 27 751 350, Fax: +
352 - 27 751 312, so that it shall be received not later than Friday, 26 May 2006, 3.00 p.m. Those holders of Swedish
Depository Receipts having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily
register the Swedish Depository Receipts in their own name in the records maintained by VPC AB in order to exercise
their shareholders’ rights at the Meeting. Such registration must be completed not later than Monday, 22 May 2006.
Luxembourg, 12 May 2006.
II (02336/5499/76)
<i>The Board of Directorsi>.
METRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.790.
—
Convening notice is given to the shareholders of the Company that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders will be held on<i> 30 May 2006i> at 5.30 p.m. at Château de Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund
in L-2441 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) followed by an Extraordinary General Meeting of the sharehold-
ers (referred to, together with the Annual General Meeting, as the Meeting) with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the external auditor of the Company on (i) the
annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2005 and (ii) the consolidated annual
accounts for the financial year ended 31 December 2005.
2. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2005.
3. Allocation of the results as of 31 December 2005.
4. Discharge of the liability of the members of the Board of Directors and the external auditor of the Company for,
and in connection with, the financial year ended 31 December 2005.
5. Appointment of the members of the Board of Directors.
6. Appointment of the external auditor of the Company.
7. Determination of the Directors’ fees.
8. Approval of a long term incentive plan.
9. Approval of the procedure of the Nomination Committee for the election of members of the Board of Directors
at the Annual General Meeting to be held in 2007.
10. Miscellaneous.
11. Resolution in accordance with the requirements of article 100 of the law of 10 August 1915 on commercial com-
panies as amended.
Appointment of the Members of the Board of Directors (item 5)
The Nomination Group proposes that, until the end of the Annual General Meeting to be held in 2007, Mr Josh
Berger, Mr Paddy Byng, Mr Henry Guy, Mr Dennis Malamatinas and Ms Cristina Stenbeck shall be re-elected Directors
of the Company, and that Ms Mia Brunell, Mr Peter Castenfelt and Ms Christine Ockrent shall be appointed as Directors
of the Company. The Nomination Group proposes that Mr Peter Castenfelt be appointed as the Chairman of the Board
of Directors and that the Board of Directors appoint a Remuneration Committee and an Audit Committee at a Board
Meeting following the Annual General Meeting.
Appointment of the external auditor of the company (item 6)
As recommended by the Audit Committee, the Nomination Group proposes that KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxem-
bourg be re-appointed as external auditor for a term ending at the Annual General Meeting of the shareholders to be
held in 2007. The remuneration of the auditor shall be paid in accordance with an approved bill which specifies time,
persons who worked and tasks performed.
Directors’s fees (item 7)
The Nomination Group proposes that the Meeting resolve that the fees for the members of the Board of Directors
for the period until the end of the next Annual General Meeting to be held in 2007 be a total of USD 405,000.
Approval of long term incentive plan (item 8)
As recommended by the Remuneration Committee, the Board of Directors propose to approve a three year long
term incentive plan, the details of which are as follows: a maximum of 550,667 restricted shares and 550,667 share
options (the strike price thereof being the average share price over a period 10 days preceding the relevant Annual
General Meeting plus a premium of 10 per cent.) are to be granted annually to leading executives of the Company upon
achievement of predetermined goals, vesting over three years in equal amounts.
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
48095
Approval of the procedure for the nomination of Board of Directors for the annual general meeting to be held in
2007 (item 9)
The Nomination Group proposes that the Meeting approve the following procedure for preparing a proposal for the
election of members of the Board of Directors for the Annual General Meeting of 2007. The work shall be executed
by a Nomination Committee which will consist of at least 3 members representing major shareholders in the Company.
The Nomination Committee will be formed in September 2006 in consultation with the largest shareholders in the
Company, by number of voting shares held, at that time. The Nomination Committee will be elected for a term of one
year. The majority of the members of the Nomination Committee may not be members of the Board of Directors of
the Company, nor be employed by the Company. If a member of the Nomination Committee resigns before the work
is concluded, a replacement member is to be appointed in accordance with the foregoing criteria. Ms Cristina Stenbeck
will be a member of the Nomination Committee and will also act as its convenor. The members of the Nomination
Committee will appoint the Chairman at their first meeting from amongst themselves. The composition of the Nomi-
nation Committee will be communicated in the financial report for the third quarter of 2006.
The above proposals made by the Board of Directors and the Nomination Group in respect of items 5, 6, 7, 8 and 9
are supported by shareholders representing more than 50 per cent of the votes in the Company including among others
EMESCO AB, INVESTMENT AB KINNEVIK and MODERN TIMES GROUP MTG AB.
Other information
In respect of items 1 to 10 of the above agenda, no specific quorum is required for the valid deliberation or
acknowledgement of the Meeting and the resolutions are taken by a simple majority of the Class A shares represented
and voting at the Meeting, it being reminded that the Class B shares are non voting shares.
In respect of item 11 of the agenda, a quorum of 50 per cent of all issued and outstanding shares of the Company is
required for the valid deliberation of the Meeting and the resolution must be taken by a two third majority of all the
shares present or represented.
Participation in the Meeting is reserved for shareholders who file their intention to attend the Meeting by mail and/
or return a duly completed proxy form to the following address: METRO INTERNATIONAL S.A., 11, boulevard Royal,
B.P. 2599, L-1025 Luxembourg, Tel: +352 - 27 751 350, Fax: + 352 - 27 751 312 so that it shall be received not later
than Friday, 26 May 2006, 3.00 p.m. Proxy forms for the Meeting are available at the same address.
Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend the Meeting or to be represented at the Meeting via proxy
must request a power of attorney from FISCHER PARTNERS FONDKOMMISSION AB, P.O. Box 16027, SE-103-21
Stockholm, Sweden, Tel: +46 - 8 463 85 00 and send it duly completed to the following address: METRO INTERNA-
TIONAL S.A., 11, boulevard Royal, B.P. 2599, L-1025 Luxembourg, Tel: + 352 - 27 751 350, Fax: + 352 - 27 751 312,
so that it shall be received not later than Friday, 26 May 2006, 3.00 p.m. Those holders of Swedish Depository Receipts
having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily register the Swedish
Depository Receipts in their own name in the records maintained by VPC AB, in order to exercise their shareholders’
rights at the Meeting. Such registration must be completed not later than Monday, 22 May 2006.
Luxembourg, 12 May 2006.
II (02367/5499/86)
<i>The Board of Directorsi>.
ARKAS SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.543.
—
Shareholders are kindly convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on June 1, 2006 at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2005.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year
ended December 31, 2005.
5. Election and Remuneration of the Board Members.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.
<i>Notesi>
The resolutions on the agenda of the Meeting do not require any quorum and are passed by majority of the votes
expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a certificate of deposit issued by the CUSTODIAN BANK, UBS (Luxem-
bourg) S.A., which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be de-
posited with UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on 29 May 2006.
48096
- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against deposit of said share certifi-
cates. The proxies must be sent to UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. and have to be in the possession of
ARKAS SELECTION c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on 29 May 2006.
Share certificates so deposited will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof will have
been concluded.
II (02384/755/31)
<i>The Board of Directorsi>.
TOYFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.174.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>31 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation du Commissaire aux Comptes;
2. Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
3. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (02387/755/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KB LUX KEY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.616.
—
Les Actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2006i> à 15 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-
bles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 5 juin 2006
au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (02657/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BAILIFF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.
R. C. Luxembourg B 102.872.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00433, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(021845/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Manestan S.A.
DWS Investment S.A.
Adlux S.A.
W Industries Finances S.A.
Kanaka Holding S.A.
ACII, S.à r.l.
ACII, S.à r.l.
GIV Luxembourg, S.à r.l.
GIV Luxembourg, S.à r.l.
Euroline Finance S.A.
Eugénie Patri Sébastien ('EPS')
Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.
APV (Gebomsa), S.à r.l.
TPE Coaching, S.à r.l.
Agence Immobilière Weckbecker S.A.
CMC Capital Luxembourg, S.à r.l.
Ferotron S.A.
Ferotron S.A.
Ferotron S.A.
Ferotron S.A.
Ferotron S.A.
Ferotron S.A.
Ferotron S.A.
Kisling Investment S.A.
Kisling Investment S.A.
Société Financière Grandvaux S.A. Holding
Farfisa S.A.
Farfisa S.A.
DWS Hedge, Sicav
Metropartecipazioni S.A.
Funds Management Company S.A.
Gestion Premier Fund
Sobim S.A.
Syrval S.A.
Pembrooke S.A.
UBAM
Events Company Trading S.A.
Sam Company S.A.
FFTW Funds Selection
Interportfolio
Socofigest Investment
Ifonas Holding S.A.
Millicom International Cellular S.A.
Balzac
Artimon S.A.
G&P Sicav
Transcom WorldWide S.A.
Metro International S.A.
Arkas Selection
Toyfin S.A.
KB Lux Key Fund
Bailiff S.A.