logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

45985

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 959

16 mai 2006

S O M M A I R E

A&G Europe Invest, S.à r.l., Perlé  . . . . . . . . . . . . . .

46026

Jean Gilson, S.à r.l., Mertzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46027

A&G Europe Invest, S.à r.l., Perlé  . . . . . . . . . . . . . .

46026

Kobelco Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

46015

A&G Europe Invest, S.à r.l., Perlé  . . . . . . . . . . . . . .

46026

Looking For, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

46015

A&G Europe Invest, S.à r.l., Perlé  . . . . . . . . . . . . . .

46026

LR Industrie Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . 

46027

A&G Europe Invest, S.à r.l., Perlé  . . . . . . . . . . . . . .

46026

LR Industrie Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . 

46027

Also Enervit International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

46005

Mansion Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

46008

Anker Telecommunications Services S.A., Luxem- 

Marul Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

46003

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46032

Marul Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

46003

Apsida Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

46016

Marul Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

46004

Aran International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

46017

Marul Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

46004

Bateman Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

46013

Marul Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

46004

Benelux Import Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .

46008

Marul Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

46004

Blue Sky Financial S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

46016

Neffa International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46030

Café Passage Beim Jimmy, S.à r.l., Derenbach . . . .

46025

NN Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

45986

Café Passage Beim Jimmy, S.à r.l., Derenbach . . . .

46025

Nouvelle Espaces Verts Luxembourgeois,  S.à r.l., 

Café Passage Beim Jimmy, S.à r.l., Derenbach . . . .

46025

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46013

Cardigan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46024

P.R. Coiffure, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46026

Club Hiversport,  Section Danse et Formation sur 

Parati Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

46009

Glace, A.s.b.l, Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . . .

46014

Parcolog, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

46015

Commerzbank International S.A., Luxemburg  . . .

46008

Piklift S.A., Crendal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46024

Dalmatian Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46005

Placolux S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46025

Dibilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46016

Planalto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46006

Dogi’ Investment Strategy S.A., Luxembourg  . . . .

46027

Planalto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46006

Etablissements Schultz, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

46007

Properties Management, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . 

46013

Eurange, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

46014

Properties Management, S.à r.l., Luxembourg . . . 

46013

Euro Labo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46017

Ramill International Holdings S.A., Luxembourg . 

46024

European Retail S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

46012

Rhocarts Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

46024

Express Services S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

46007

Roncadin Participations S.C.A., Luxembourg . . . . 

45987

Fitzwilliam  International Resource Services Limi- 

S.L. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

46012

ted, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46017

Travel Retail, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45986

Gesab Benelux S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . .

46014

Vafage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46009

Glacier Luxembourg Two, S.à r.l., Luxembourg. . .

46025

Viatris  Holding  (Luxembourg),   S.à r.l.,  Munsbach

46006

HR Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

46009

Viria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

46007

I.C.C.I. Inc. S.A., Inter Continental and Capital In- 

W.A., S.à r.l., Aspelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46030

vestments Incorporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46006

Wallenstein Finanz S.A. Holding, Luxembourg  . . 

46007

Intabex Worldwide S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

46012

wwholding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

45986

Interjam Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

46015

Yapi Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

46005

IST International Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .

46005

45986

NN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.824. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé ad-

ministrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs et
du Commissaire aux comptes à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02783. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017892//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

wwholding, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 107.941. 

Il résulte de la résolution tenue au siège social en date du 8 février de la société wwholding, S.à r.l. que l’associé unique

a pris la décision suivante:

1. Démission des Gérants suivants:
Cees-Jan Quirijns à la date du 8 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018240/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

TRAVEL RETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.853. 

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société prises en date du 15 février 2006

En date du 15 février 2006, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Michael Thomas, gérant de sociétés, de son mandat en tant que gérant de la

Société avec effet immédiat;

- de nommer Madame Myriam Deltenre, comptable, née le 16 février 1963 à Arlon en Belgique, demeurant au 48, Le

Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique en tant que nouvelle gérante de la Société avec effet immédiat pour une durée
indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Madame Janet Hennessy, Gérante;
- Monsieur Desmond Mitchell, Gérant;
- Madame Myriam Deltenre, Gérante.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04460. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018290/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour extrait sincère et conforme
NN INVEST HOLDING S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur 

wwholding, S.à r.l.
Ch. Hultman
<i>Gérant «A»

TRAVEL RETAIL, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

45987

RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.115. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twentieth day of December.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, a Delaware limited partnership having its registered address

at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States,
registered with the Delaware Secretary of State under number 3725285,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles on 14 December 2005;
2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, a Delaware limited partnership having its registered address

at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States,
registered with the Delaware Secretary of State under number 3794755,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles on 14 December 2005;
3) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, a Delaware limited partnership having its registered address at Corpora-

tion Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States, registered
with the Delaware Secretary of State under number 3982314,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles on 14 December 2005.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société anonyme, which they declare organised among themselves as follows:

Chapter I. Name, Registered office, Duration, Object

Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a com-

pany in the form of a société en commandite par actions under the name of RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A.
(hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within the same

municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager. Branches, subsidi-
aries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Man-
ager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have occurred or are immi-

nent, which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Com-
pany which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited term.

Art. 4. Purpose
The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, and any other form of investment, including the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of any such participations and the administration, voting and con-
trol of any such participations.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist any entity in which it holds a direct or indirect

participation, or which forms part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 5. Shareholders’ Liability
The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company.

The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the Manager), being the holder(s) of Ordinary Shares
shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as
shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

45988

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 6. Corporate Capital
6.1. Subscribed Capital
The Company has a subscribed capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by fully paid up shares,

consisting of:

(a) twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twen-

ty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»).

All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders

of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.

6.2. The Class A Ordinary Shares
(a) All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A Ordinary Shares shall share ratably in the

payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate
basis to such Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company
may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders
held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class A Ordinary Shares will be reduced
accordingly.

(b) Voting Rights. Each Class A Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

6.3. The Class B Ordinary Shares
(a) All Class B Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class B Ordinary Shares shall share ratably in the

payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate
basis to such Class B Ordinary Shares. All Class B Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company
may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders
held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class B Ordinary Shares will be reduced
accordingly.

(b) Voting Rights. Each Class B Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

6.4. Redemption, Convertibility
(a) Redeemable Shares. The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 498

of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to receive
dividends and have the same voting rights as non-redeemable Ordinary Shares, if any. Subscribed and fully paid-in re-
deemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by each holder upon
request of the Company (i) in accordance with the provisions of article 498 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended, and (ii) as may be provided for in a written agreement which may be entered into among the
Company and the relevant shareholders of the Company. The redemption of the redeemable shares can only be made
by using sums available for distribution in accordance with article 721 of the law of 10 August 1915 on commercial com-
panies (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company
as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed shares bear
no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed shares may be cancelled
upon request of the Manager by a positive vote of the general meeting of shareholders held in accordance with.

(b) Special Reserve. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of

all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the
event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed
share capital by capitalization of reserves.

(c) Redemption Price. Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be

entered into among the Company and the relevant shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall
be determined by the Manager, or by such person appointed by the Manager, and shall be approved by holders of a
majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the shareholders convened in accordance with. In the ab-
sence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the Manager that is
approved by a majority of the shareholders of the Company shall be conclusive and binding on the Company and on its
present, past and future shareholders.

(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among

the Company and the relevant Shareholders at least 20 days prior to the redemption date, written notice shall be sent
by  registered  mail  (and  if  the  Manager  so  elects  by  internationally recognized overnight courier) to each registered
shareholder of the Ordinary Shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of
the Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the
redemption price, the procedures necessary to submit the Ordinary Shares to the Company for redemption and the
projected date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Ordinary Shares and the valuation
of the redemption price, as provided for in Articles and (...). Each holder of Ordinary Shares to be redeemed shall sur-
render the certificate or certificates, if any, issued in relation to such Ordinary Shares to the Company. The redemption
price of such Ordinary Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as
the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(e) Convertibility. The Class A Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares shall not be convertible into any other

class of shares.

45989

6.5. Distributions to Shareholders
If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by

the Manager (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive dis-
tributions, when, as, and if approved and declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Manager out
of funds legally available therefor, in accordance with applicable law, in the following manner:

(a) the Class A Shareholders shall be entitled to receive all distributions made by the Company which are attributable

to Class A Proceeds, and such distributions shall be made pro rata among the Class A Shareholders based on the number
of Class A Ordinary Shares held by each Class A Shareholder; and

(b) the Class B Shareholders shall be entitled to receive all distributions made by the Company which are attributable

to Class B Proceeds, and such distributions shall be made pro rata among the Class B Shareholders based on the number
of Class B Ordinary Shares held by each Class B Shareholder.

6.6. Liquidation Rights
In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Com-

pany will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article above. Neither a merger nor consolidation
of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or entities
into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or
any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article, unless such
merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of complete
liquidation, dissolution or winding up of the Company.

6.7. Authorized Capital
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at two hundred million

Euro (EUR 200,000,000.-) represented by: 

(a) one hundred twenty-three million six hundred eighteen thousand five hundred forty-four (123,618,544) Class A

Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share; and

(b) thirty-six million three hundred eighty-one thousand four hundred fifty-six (36,381,456) Class B Ordinary Shares

having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-

thorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is
authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the
new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be sub-
scribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine
to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.
Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager
is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The
Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized per-
son, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such in-
creased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the
Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

6.8. Amendment of the subscribed and of the authorized capital
The subscribed and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.

Art. 7. Shares, Shareholders Register, and Share Transfers
7.1. Shareholders Register
The shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders’ register which may be examined by

any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each sharehold-
er and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the
transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address
and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates of
these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.

7.2. Share Ownership
Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register. The Company rec-

ognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is dis-
puted, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s)
towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such
shares until such representative is appointed, at which time any suspended distributions with respect to such shares shall
be paid to such representative.

7.3. Share Transfer
(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer registered into the

shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers
of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the
Luxembourg Civil code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders’ register any transfer
referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

45990

(b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth anniversary of the Date of Issuance, or during such shorter period as

may be consistent with applicable law, the Secondary Investors may not validly transfer the shares issued by the Com-
pany without the prior written approval of the Manager or unless otherwise permitted pursuant to this Article.

(c) Permitted Transfers. Any Secondary Investor may Transfer any and all Securities held by any such Persons (where

such Person is a natural person) to each such Person’s spouse and/or descendants (whether natural or adopted) or to
any trust solely for the benefit of such Person and/or such Person’s spouse and/or descendants (a «Permitted Transfer-
ee»), pursuant to the applicable laws of descent and distribution or otherwise (a «Permitted Transfer»).

(d) Drag-Along Sale
(i) Procedures. In the event of a contemplated Transfer by the Primary Investors of the Company to any Third Party

Purchaser, the Primary Investors or the Manager may, prior to but in contemplation of such Transfer, elect to deem
such Transfer a «Drag-Along Sale», and in such case any Secondary Investors shall take all actions reasonably requested
by the Primary Investors and/or the Manager in connection with such Drag-Along Sale as set forth in this Article. In the
event of a Drag-Along Sale, the Manager may compel any Secondary Investors to participate on a pro rata basis (deter-
mined on an As-Converted basis) in such Drag-Along Sale. The Manager shall provide notice of a Drag-Along Sale (the
«Drag-Along Sale Notice») to such Secondary Investors. Such Drag-Along Sale Notice shall disclose in reasonable detail
the proposed type and number (or percentage) of Ordinary Shares, CPECs and PECs held by the Secondary Investors
to be subject to the Drag-Along Sale (the «Drag-Along Securities»), the proposed price, the other proposed terms and
conditions of the proposed Drag-Along Sale, and the identity of the prospective purchaser, if known.

(ii) Cooperation. With respect to any Drag-Along Sale, any Secondary Investor shall effect such transactions as are

necessary or advisable, as determined by the Manager in the light of any business, taxation or marketability concerns
and agrees to use his or her best efforts to effect such Drag-Along Sale as expeditiously as practicable, including deliv-
ering all documents and entering into any instrument, undertaking or obligation necessary or reasonably requested by
the Manager or the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale necessary or reasonably requested in
connection with such Drag-Along Sale (as specified in the applicable Drag-Along Sale Notice) and hereby consents to
the taking of any step by the Company and the Manager which is necessary or desirable as determined by the Manager
to effect any legal formalities in connection with the Transfer of the Securities subject to such Drag-Along Sale. In addi-
tion, the Secondary Investors shall (i) pay their pro rata share (based on the aggregate proceeds) of the reasonable ex-
penses (if any) incurred by the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale and (ii) join severally on a
pro rata basis (based on the inverse amount each Person concerned would be entitled to receive on a complete liqui-
dation of the Company) in any indemnification or other obligations that are specified in the Drag-Along Sale Notice.

(iii) Consideration. In the event of a Drag-Along Sale, each Secondary Investor shall Transfer such Securities held by

that Secondary Investor as are provided in the Drag-Along Sale Notice. The form and value of the consideration offered
in respect of any security in a Drag-Along Sale shall be the same for all Securities of the same type or class subject to
such Drag-Along Sale as set forth in the Drag-Along Sale Notice.

(e) Transfer. For the purposes of these Articles, «Transfer» or «transfer» shall mean any transaction, whether vol-

untary or involuntary or by operation of law, resulting in a transfer of the ownership, «nuepropriété», «usufruit» or any
rights of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend rights) to any person other than the
Company itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means whatsoever (including, without limitation,
gifts, partial contributions of assets («apports partiels d’actifs»), mergers, splits («scissions»), sales, assignments, pledges
or any other form of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial interest in the shares, as well as any
combination of such methods of transfer of ownership. The shares are and shall remain in registered form.

(f) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any pro-

vision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor record
such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any
purpose. 

Chapter III. Management

Art. 8. Manager
The Company shall be managed by RONCADIN HOLDINGS GP S.A., a société anonyme organized under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole Manager (associé commandité) and manager of the Company
(referred to herein as the «Manager»). The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the man-
agement of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Man-
ager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided
the Supervisory Board, as provided for in hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order
that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall
convene within 15 days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager,
in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment,
the Company shall be dissolved and liquidated.

Art. 9. Powers of the Manager
9.1. General Powers
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Com-

pany’s stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of sharehold-
ers or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager. 

9.2. Enforcement of Rights
The Manager shall act, in its reasonable good faith judgment, in the best interests of the Company and its sharehold-

ers, shall use reasonable efforts to enforce any rights granted to the Company under the articles of association of any

45991

company in which it holds participations or under any securityholders agreement or other agreement which may be
entered into among the Company and any of its securityholders from time to time.

9.3. Termination of the Manager by the holders of Ordinary Shares
In the event that, in the reasonable opinion of the holders of Ordinary Shares, the Manager shall have failed to fulfill

its obligations to the Company and the shareholders under Article, then the shareholders may, acting pursuant to an
affirmative vote taken at a duly convened meeting of the shareholders in accordance with the quorum and majority con-
ditions required for the amendment of these Articles, revoke the appointment of the Manager and replace the Manager
with a new manager whose appointment shall be approved by an affirmative vote taken under the same quorum and
majority requirements as above mentioned. The Manager may not participate in any vote concerning the revocation of
its appointment as manager of the Company.

Art. 10. Third Parties
The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager, or by the signature(s) of any

other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion.

Chapter IV. Supervision

Art. 11. Supervisory Board
11.1. Supervisory Board Members
The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a

Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members, who need not be shareholders.
For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as
provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The
Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize
any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these Articles, exceed the powers
of the Manager. The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders
for a period of one (1) year and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory
Board are reeligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by
the general meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman. 

11.2. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board

must be convened if any of its members so requests.

11.3. Notices
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior

to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall
be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda there-
of. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of commu-
nication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.

11.4. Chairman
The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory

Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.

11.5. Resolutions
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the members are present or repre-

sented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

11.6. Minutes
Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Cop-

ies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chair-
man of the meeting or any two members.

11.7. Written Resolutions Conference Call
Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as

resolutions voted at a meeting of the Supervisory Board; each member shall approve such resolution in writing as evi-
denced by his, her or its signature, a copy thereof being sufficient. All such documents shall together form the document
which proves that such resolution has been taken. Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting
of the Supervisory Board by conferencecall or by other similar means of communication allowing all the Persons taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting.

11.8. Liability
No member of the Supervisory Board assumes, by reason of his membership thereof, any personal liability in relation

to commitments regularly made by the members of the Supervisory Board in the name of the Company. They are au-
thorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

11.9. Indemnity
(a) Indemnity. The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory

Board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the

45992

Supervisory Board of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to mat-
ters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of
duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

(b) Expenses. The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection

with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding
undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not
entitled to indemnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction,
or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did
not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash
payment to such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an ob-
ligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably
require.

11.10. Conflicts
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise
engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from consid-
ering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Chapter V. General meeting of the shareholders

Art. 12. Shareholder Meetings
(a) Powers. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest

powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.
The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory
Board.

(b) Location, Time. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on 31 March. If such day
is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day
in Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective
convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent
by the Manager by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Com-
pany at the address indicated in the share register.

(c) Voting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing

another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.
The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Company,
unless otherwise provided herein. The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by sharehold-
ers for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meet-
ing of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice or publication.

Chapter VI. Accounting year balance sheet

Art. 13. Accounting Year
The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of the same year.

Art. 14. Reserve
From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten percent (10%) of
the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall deter-
mine how the remainder of the annual net profit will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing
the terms and conditions provided for by law.

Chapter VII. Liquidation amendment of the articles

Art. 15. Amendment
These Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at least two-thirds of the

votes of the shareholders of the Company at a general meeting of the shareholders at which at least 50% of the capital
of the Company is represented in person or by proxy. In the event that the foregoing quorum requirement is not sat-
isfied, these Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at least two-thirds of the
votes of the shareholders of the Company at a second general meeting of the shareholders with respect to which no
quorum requirement shall apply.

Art. 16. Dissolution
In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities), shall carry out the liq-

uidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall de-
termine their powers and compensation.

45993

Chapter VIII. Final dispositions

Art. 17. Miscellaneous
For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg Law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended.

Art. 18. Definitions
For the purpose of these Articles:
«Affiliate» or «Affiliates» means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls,

is Controlled by, or is under common Control with such first Person or any other Person who holds directly or indi-
rectly more than a fifty percent (50%) economic interest in such first Person or in whom such first Person holds directly
or indirectly or has a contractual right to acquire more than a fifty percent (50%) economic interest.

«Articles» means the articles of association of the Company as amended from time to time.
«As-Converted Basis» with respect to the outstanding securities of the Company, shall mean as if all such securities

convertible into or exercisable or exchangeable for Ordinary Shares outstanding were converted, exercised or ex-
changed into or for Ordinary Shares pursuant to the terms of such convertible, exercisable or exchangeable securities
(i.e., the number of Ordinary Shares outstanding, plus the additional number of Ordinary Shares that would be outstand-
ing assuming such conversion, exercise or exchange).

«Class A Proceeds» means any shareholder distributions, redemption amounts or other proceeds paid by RONCA-

DIN HOLDINGS S.C.A. to the Company by virtue of the Company’s status as a holder of Class A1 Ordinary Shares,
Class A2 Ordinary Shares, Series 1 PECs or Series 1 CPECs issued by RONCADIN HOLDINGS S.C.A. (as each such
term is defined in the articles of association of RONCADIN HOLDINGS S.C.A., as amended from time to time).

«Class B Proceeds» means any shareholder distributions, redemption amounts or other proceeds paid by RONCA-

DIN HOLDINGS S.C.A. to the Company by virtue of the Company’s status as a holder of Class B Ordinary Shares or
Series 2 CPECs issued by RONCADIN HOLDINGS S.C.A. (as each such term is defined in the articles of association
of RONCADIN HOLDINGS S.C.A., as amended from time to time).

«Class A Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Class A Shareholders» means the holders of Class A Ordinary Shares of the Company.
«Class B Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Class B Shareholders» means the holders of Class B Ordinary Shares of the Company.
«Company» has the meaning provided in.
«Control» means in respect of a Person, the power to manage or govern such Person, or to appoint the managing

and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through
the ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership shall be deemed to
be Controlled by its Manager).

«CPECs» means the Series 1 CPECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any

additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to
time.

«Drag-Along Sale» shall have the meaning set forth in Article.
«Drag-Along Sale Notice» shall have the meaning set forth in Article.
«Drag-Along Securities» shall have the meaning set forth in Article.
«Manager» has the meaning provided in.
«Group» means the Company and its Subsidiaries and Group Company means any of them.
«Issuance» shall have the meaning set forth in Article 6.13.
«Managed Entity» means any entity Controlled by the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company or

in which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company has management or operating responsibilities or
of which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company is a partner or shareholder.

«Ordinary Shares» means the Class A Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares issued by the Company.
«PECs» means the Series 1 PECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any ad-

ditional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to time.

«Permitted Transfer» shall have the meaning set forth in Article hereto.
«Permitted Transferee» shall have the meaning set forth in Article hereto.
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock

company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.

«Primary Investors» means OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC or any Affiliate thereof which holds Ordinary

Shares or Securities of the Company or the Manager.

«Secondary Investors» means all holders of Ordinary Shares or Securities of the Company other than the Primary

Investors.

«Securities» means any duly authorized securities of the Company including, but not limited to, PECs and CPECs.
«Series 1 CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Series 1 PECs» means the Series 1 preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Subsidiary» or «Subsidiaries» means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of

the total voting power of shares or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any contingency)
to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly or indi-
rectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof. For purposes hereof, a Person
or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership, association

45994

or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability company, partnership,
association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.

«Supervisory Board» has the meaning provided in Article.
«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-

cember 2005.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, pre-named,
paid ten thousand three hundred thirty-three Euro and seventy-five cents (EUR 10,333.75) in subscription for eight

thousand two hundred sixty-seven (8,267) shares;

2) OCM PRINICPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, pre-named,
paid ten thousand three hundred thirty-two Euro and fifty cents (EUR 10,332.50) in subscription for eight thousand

two hundred sixty-six (8,266) shares;

3) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, pre-named,
paid ten thousand three hundred thirty-two Euro and fifty cents (EUR 10,332.50) in subscription for eight thousand

two hundred sixty-six (8,266) shares;

4) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., pre-named,
paid one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) in subscription for one (1) share;
Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) paid for twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro and (EUR 31,000.-) is as of

now available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been ful-
filled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately four thousand four hundred (4,400.-) Euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of managers is fixed at one and the number of members of the board of auditors at 3.
2. RONCADIN HOLDINGS GP S.A., prenamed, is appointed sole manager of the company with immediate effect.
The following persons are appointed members of the board of auditors of the company:
a) Jacques Peffer, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
b) Jean-Jacques Soisson, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
c) Christophe Deschamps, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg.

4. The address of the company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
5. The term of office of the members of the board of auditors shall end at the general meeting called to approve the

accounts of the accounting year 2006 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen
Delaware Secretary of State unter der Nummer 3725285,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles, am 14. Dezember 2005;

45995

2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen
Delaware Secretary of State unter der Nummer 3794755,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles, am 14. Dezember 2005;
3) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen Delaware Se-
cretary of State unter der Nummer 3982314,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles, am 14. Dezember 2005;
4) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., eine Gesellschaft Luxemburg Rechts mit Geschäftsadresse in L-1882 Luxem-

bourg, 5, rue Guillaume Kroll,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in London und Luxemburg, am 14. Dezember 2005.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die sie

hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. Name, Sitz, Dauer, Zweck

Art. 1. Name
Hiermit wird von den Zeichnern und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer «société en

commandite par actions» unter dem Namen RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A. (nachstehend die «Gesellschaft»)
gegründet.

Art. 2. Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb dieses Verwaltungsbe-

zirks kann der Sitz der Gesellschaft kraft eines Geschäftsführerbeschlusses verlegt werden. Filialen, Tochtergesellschaf-
ten oder andere Niederlassungen können mit Kraft eines Geschäftsführerbeschlusses entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden.

Kommt die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse, die die

üblichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz bzw. die Kommunikation zwischen diesem Gesellschaftssitz
und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder einzutreten drohen, so kann der Sitz vorüber-
gehend ins Ausland verlegt werden, bis die betreffenden außergewöhnlichen Ereignisse vollumfänglich überwunden sind;
eine solche provisorische Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet solcher
zeitlich befristeten Maßnahmen eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. 

Art. 3. Dauer
Die Gesellschaft wird für unbefristete Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung in jedweder Art an luxemburgischen und ausländischen Un-

ternehmen sowie in jeder weiteren Form der Investition, einschließlich des käuflichen Erwerbs, der Zeichnung oder in
anderer Weise und der Übertragung entsprechender Beteiligungen mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig sowie der
Verwaltung, Stimmbeteiligung an und Leitung von Beteiligungen.

Der Gesellschaftszweck umfasst ferner die Abgabe von Bürgschaften, Gewährung von Darlehen sowie jede andere

Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist oder die der gleichen Un-
ternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann jeder wirtschaftlichen, industriellen oder finanziellen Beschäftigung nachgehen, die sie für die

Erreichung ihres Zwecks für nützlich hält.

Art. 5. Haftung der Aktionäre
Die Geschäftsführerin haftet gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten, die mit dem Vermögen der Gesellschaft

nicht bestritten werden können. Die anderen Aktionäre (der Klarheit halber: unter Ausschluss der Geschäftsführerin)
haben als Stammaktionäre davon Abstand zu nehmen, die Gesellschaft in einer Form oder Funktion, die über ihre Rechte
als Aktionäre - wie sie beispielsweise anlässlich von Hauptversammlungen wahrgenommen werden können - hinausgeht,
zu vertreten, und haften lediglich im Umfang ihrer Einlagen in die Gesellschaft.

Kapitel II. Aktienkapital, Aktien

Art. 6. Grundkapital
6.1. Gezeichnetes Kapital
Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), durch

vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:

(a) Vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem

Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A);

Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-

rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.

45996

6.2. Stammaktien der Klasse A
(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse A sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse A nehmen an-

teilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttungen
teil, die auf die Stammaktien der Klasse A auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich oder
anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse A können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zustimmung
einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass die Anzahl
ausgegebener Stammaktien der Klasse A entsprechend zu reduzieren ist.

(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse A berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter den

Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.

6.3. Stammaktien der Klasse B
(c) Sämtliche Stammaktien der Klasse B sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse B nehmen an-

teilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttungen
teil, die auf die Stammaktien der Klasse B auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich oder
anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse B können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zustimmung
einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass die Anzahl
ausgegebener Stammaktien der Klasse B entsprechend zu reduzieren ist.

(d) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse B berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter den

Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.

6.4. Einziehung; Austauschbarkeit
(a) Einziehbare Aktien. Bei den Stammaktien handelt es sich um einziehbare Aktien im Sinne der jeweils geltenden

Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften. Einziehbare Aktien haben
die gleichen Dividenden- und Stimmrechte wie ggf. auch nicht einziehbare Stammaktien. Gezeichnete und vollständig
eingezahlte einziehbare Aktien können auf Wunsch der Gesellschaft anteilig - d.h. auf Basis der von dem jeweiligen Ak-
tionär gehaltenen einziehbaren Aktien jeder Anteilsklasse, eingezogen werden (i) unter Beachtung der jeweils geltenden
Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und (ii) nach Maßgabe ei-
nes ggf. zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrags. Die Ein-
ziehung der einziehbaren Aktien kann nur unter Verwendung von Mitteln erfolgen, die gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes
vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften zur Ausschüttung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Mittel ein-
schließlich der außerordentlichen Rücklagen, die mit Hilfe der von der Gesellschaft als Agio vereinnahmten Erlöse ein-
gerichtet wurden) oder aus einer neuen, mit dem Ziel einer entsprechenden Einziehung vorgenommenen Emission
gewonnen wurden. Eingezogene Aktien bieten weder Stimm- noch Dividendenrechte und berechtigen nicht zu Liquida-
tionserlösen. Sie können auf Wunsch der Geschäftsführerin mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abge-
haltenen Hauptversammlung gekündigt werden.

(b) Besondere Rücklagen. Ein Betrag in Höhe des Nennwerts bzw. (falls dieser nicht ermittelt werden kann) der bi-

lanzierte Stückwert sämtlicher eingelöster Aktien ist in Rücklagen zu hinterlegen, die lediglich im Falle einer Kapitalher-
absetzung des gezeichneten Aktienkapitals an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf; ansonsten sind diese Rücklagen
ausschließlich zur Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Wege der Umwandlung der Rücklagen einzusetzen.

i. Rücknahmepreis. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen (i) in diesen Artikeln oder (ii) im Rahmen einer

schriftlichen Vereinbarung, wie sie unter Umständen zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären abge-
schlossen wird, ist der Rücknahmepreis der einziehbaren Aktien seitens der Geschäftsführerin oder einer von dieser
ernannten Person zu bestimmen und von den Inhabern einer Mehrheit ausstehender Stammaktien anlässlich einer im
Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Aktionärsversammlung zu genehmigen. Abgesehen von Arglist, grober Fahrlässig-
keit oder offensichtlichem Irrtum ist jede seitens der Geschäftsführerin vorgenommene Berechnung des Rücknahme-
preises, die von einer Mehrheit der Aktionäre der Gesellschaft genehmigt wurde, für die Gesellschaft sowie ihre
gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Aktionäre endgültig und verbindlich.

ii. Rücknahmeverfahren. Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen, wie sie zwischen der Gesell-

schaft und den betreffenden Aktionären mindestens 20 Tage vor dem Einzugstermin getroffen werden können, ist jeder
eingetragene Inhaber der einzuziehende Stammaktien unter seiner im Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft zuletzt ver-
merkten Anschrift per Einschreiben (oder auf Verlangen der Geschäftsführerin unter Verwendung eines angesehenen
internationalen Übernacht-Kuriers) schriftlich unter Angabe von Einzugstermin und -preis, der Verfahren, die beim Ein-
zug der Stammaktien an die Gesellschaft zu Einzugzwecken Anwendung finden, des voraussichtlichen Termins der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung zum Thema des Einzugs von Stammaktien sowie der Bewertung des
Rücknahmepreises gemäß Artikels 6.4(a) und 6.4(c) davon in Kenntnis zu setzen, wie viele Aktien auf diese Weise ein-
gezogen werden. Jeder Inhaber einzuziehender Stammaktien hat dabei die jeweiligen Aktienscheine abzuliefern, wie sie
ggf. in Bezug auf entsprechende Stammaktien der Gesellschaft ausgestellt wurden. Der Einzugspreis solcher Stammaktien
ist an die Person zahlbar, deren Name im Aktionärsverzeichnis als Inhaber der Stammaktien geführt ist, unter Verwen-
dung des seitens des betreffenden Aktionärs vor dem Einzugstermin gegenüber der Gesellschaft bezeichneten Kontos.

iii. Austauschbarkeit. Die Stammaktien der Klasse A und der Klasse B können nicht in Aktien anderer Anteilsklassen

umgewandelt werden.

6.5. Ausschüttungen an Aktionäre
Kommt die Aktionärsversammlung der Gesellschaft und/oder die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass an die Ak-

tionäre eine Ausschüttung zu erfolgen hat (mittels Abschlagsdividende, Einzug oder anderweitig), so haben die Aktionäre
nach Maßgabe der von der Aktionärsversammlung und/oder der Geschäftsführerin beschlossenen Konditionen und vor-
behaltlich anwendbaren Rechts in folgendem Umfang Anspruch auf Ausschüttungen unter Verwendung der rechtmäßig
zu diesem Zweck zur Verfügung stehenden Mittel:

45997

(a) Die Aktionäre der Klasse A haben Anspruch auf alle von der Gesellschaft im Hinblick auf Stammaktien der Klasse

A vorgenommenen Ausschüttungen, wobei solche Ausschüttungen anteilig, also auf der Grundlage der Anzahl von
Stammaktien der Klasse A im Besitz der einzelnen Aktionäre der Klasse A, auszuschütten sind;

(b) Die Aktionäre der Klasse B haben Anspruch auf alle von der Gesellschaft im Hinblick auf Stammaktien der Klasse

B vorgenommenen Ausschüttungen, die anteilig, also auf der Grundlage der Anzahl von Stammaktien der Klasse B im
Besitz der einzelnen Aktionäre der Klasse B, auszuschütten sind.

6.6. Liquidationsansprüche
Im Falle einer Liquidation werden die verbleibenden Vermögenswerte der Gesellschaft nach Zahlung sämtlicher

Schulden und Verbindlichkeiten unter den Aktionären in der unter Artikel 6.5 oben beschriebenen Weise aufgeteilt.
Weder eine Fusion oder ein Zusammenschluss der Gesellschaft zu oder mit (einem) weiteren Unternehmen, noch eine
Fusion oder ein Zusammenschluss dritter Unternehmen zu oder mit der Gesellschaft, noch die Veräußerung, Abtretung,
Vermietung oder der Tausch (gegen Barmittel, Wertpapiere oder andere Werte) eines beliebigen Teils des Gesell-
schaftsvermögens gilt als eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 6.6, es sei denn, Fusionen, Zusammenschlüsse, Ver-
äußerungen, Abtretungen, Miet- oder Tauschgeschäfte dieser Art stehen im Zusammenhang mit oder beinhalten ein
Vorhaben zur Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.

6.7. Genehmigtes Kapital
Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes Kapital, das auf zweihundert Mil-

lionen Euro (EUR 200.000.000,-) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:

(a) Einhundertdreiundzwanzig Millionen sechshundertachtzehntausendfünfhundertvierundvierzig (123.618.544)

Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Anteil; 

(b) Sechsunddreissig Millionen dreihunderteinundachtzigtausendvierhundertsechsundfünfzig (36.381.456) Stammakti-

en der Klasse B mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Anteil. 

Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-

versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.

6.8. Änderung des gezeichneten und des genehmigten Kapitals
Das gezeichnete und das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann aufgrund einer Entscheidung der Hauptversamm-

lung mit der selben Mehrheit, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt
werden.

Art. 7. Aktien, Aktionärsverzeichnis, Aktienübertragung
7.1. Aktionärsverzeichnis
Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien. Am Sitz ist ein Aktionärsverzeichnis zu führen, das von jedem

Aktionär eingesehen werden kann. Das Verzeichnis enthält die exakte Bezeichnung jedes Aktionärs sowie Angaben zur
Anzahl seiner Aktien, den darauf geleisteten Zahlungen und der Übertragung von Aktien einschließlich des Zeitpunkts.
Die Aktionäre haben die Gesellschaft per Einschreiben von ihren Anschriften und etwaigen Adressänderungen in Kennt-
nis zu setzen. Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, sich auf die zuletzt gemeldete Anschrift zu verlassen. Abschriften
dieser Angaben werden auf Wunsch eines Aktionärs in beglaubigter Form ausgestellt und von der Geschäftsführerin
unterzeichnet.

7.2. Aktienbesitz
Der Besitz eingetragener Aktien ergibt sich aus den Aufzeichnungen im Aktionärsverzeichnis. Die Gesellschaft er-

kennt lediglich einen Inhaben pro Aktie an. Befinden sich eine oder mehrere Aktien im Besitz mehrerer Inhaber oder
steht der Aktienbesitz in Streit, so haben alle Anspruchssteller eine einzigen Vertreter zu bestimmen, der die betreffen-
de(n) Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft vertritt. Wird die Ernennung eines solchen Vertreters versäumt, so werden
sämtliche mit den betreffenden Aktien verbundenen Rechte so lange ausgesetzt, bis ein Vertreter berufen ist. Ausge-
setzte Ausschüttungen auf die betreffenden Aktien werden dann umgehend an diesen Vertreter zur Auszahlung ge-
bracht.

7.3. Aktienübertragung
(a) Abtretungserklärung. Die Übertragung von Aktien erfolgt auf dem Wege einer Abtretungserklärung, die im Ak-

tionärsverzeichnis einzutragen und seitens des Abtretenden und des Abtretungsempfängers bzw. ihrer Vertreter zu da-
tieren und zu unterzeichnen ist. Eine Übertragung von Aktien kann auch im Einklang mit den Regeln zur Übertragung
von Ansprüchen gemäß Artikel 1690 des Luxemburger Civil Code stattfinden. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt,
Übertragungen anzunehmen und in das Aktionärsverzeichnis einzutragen, auf die in Korrespondenzen oder anderen das

45998

Einverständnis zwischen dem Abtretendem und dem Abtretungsempfänger nachweisenden Unterlagen Bezug genom-
men wird. 

(b) Abtretungsbeschränkungen. Vor Ablauf des zehnten Jahrestages des Ausgabetermins bzw. vor Ablauf kürzerer

Fristen nach anwendbarem Recht können die Secondary Investors die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile vor-
behaltlich anderslautender Bestimmungen dieses Artikels 7.3 ohne das vorherige schriftliche Einverständnis der Ge-
schäftsführerin nicht wirksam übertragen.

(c) Zulässige Abtretungen. Secondary Investors dürfen sämtliche im Besitz solcher (natürlicher) Personen befindli-

chen Wertpapiere auf ihren Ehepartner oder Nachkommen (einschließlich Adoptivkinder) sowie auf beliebige, aus-
schließlich zugunsten solcher Personen bzw. ihrer Ehepartner und/oder Nachkommen (jeweils ein «zulässiger
Abtretungsempfänger») eingerichtete Treuhandvermögen übertragen, sofern dem keine Rechtsnachfolge- oder Vertei-
lungsregeln oder weitere anwendbaren Gesetze entgegenstehen (eine «zulässige Abtretung»).

(d) Drag-Along Sale
(i) Verfahren. Im Falle einer angedachten Übertragung seitens der Primary Investors der Gesellschaft an einen Dritt-

käufer sind die Primary Investors bzw. die Geschäftsführerin berechtigt, vor - aber in Bezug auf - eine entsprechende
Übertragung diese als einen Drag-Along Sale zu betrachten, woraufhin sämtliche Secondary Investors im zumutbaren
Umfang alle in Verbindung mit einem solchen Drag-Along Sale gemäß diesem Artikel 7.3(d) vorgebrachten Wünsche der
Primary Investors bzw. der Geschäftsführerin nach Kräften zu erfüllen haben. Im Falle eines Drag-Along Sale kann die
Geschäftsführerin jeden beliebigen Secondary Investor zwingen, sich an diesem auf anteiliger Basis (wie sie auf der
Grundlage der Besitzverhältnisse zum Zeitpunkt der Umwandlung - «as-converted basis» - zu ermitteln ist) zu beteiligen.
Die Geschäftsführerin hat den betreffenden Secondary Investors von einem Drag-Along Sale unter hinreichend detail-
lierter Angabe der vorgesehenen Anteilsklasse und Anzahl (bzw. des Prozentsatzes) der Stammaktien sowie des vorge-
sehenen Preises, weiterer anvisierter Bedingungen und Konditionen des vorgesehenen Drag-Along Sale und ggf. der
Identität des vorgesehenen Käufers schriftlich Mitteilung zu machen (die «Ankündigung des Drag-Along Sale»); dem
Drag-Along Sale unterliegen dabei Stammaktien, CPECs and PECs, die sich im Besitz der Secondary Investors befinden
(die «Wertpapiere des Drag-Along Sale»).

(ii) Zusammenarbeit. Im Hinblick auf einen Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor alle notwendigen oder rat-

samen Transaktionen vorzunehmen, wie sie seitens der Geschäftsführerin unter Berücksichtigung von Geschäft-, Steu-
er- und Marktfähigkeitsgesichtspunkten festgelegt werden. Ferner verpflichtet sich jeder Secondary Investor, einen
entsprechenden Drag-Along Sale so rasch wie möglich abzuwickeln und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass alle seitens
der Geschäftsführerin bzw. der Primary Investors in Verbindung mit einem Drag-Along Sale nachvollziehbar angeforder-
ten und notwendigen Unterlagen, Urkunden, Vereinbarungen oder Verpflichtungen (auch unter Berücksichtigung der
Ankündigung des Drag-Along Sale) überbracht, unterzeichnet bzw. eingegangen werden. Die Secondary Investors erklä-
ren bereits hiermit ihr Einverständnis mit beliebigen, seitens der Gesellschaft und der Geschäftsführerin unternomme-
nen Schritten, wie sie nach Einschätzung der Geschäftsführerin zur Erledigung rechtlicher Formalitäten in Verbindung
mit der Übertragung der dem Drag-Along Sale zugrundeliegenden Wertpapiere notwendig oder ratsam sein mögen. Zu-
dem haben die Secondary Investors (i) einen (abhängig von den Gesamterlösen) entsprechenden Teil (pro rata) des zu-
mutbaren, seitens der Primary Investors im Zusammenhang mit dem betreffenden Drag-Along Sale entstandenen
angemessenen Aufwands zu entrichten und (ii) sich jeweils anteilig (auf der Basis des invertierten Betrags, wie er allen
Beteiligten im Falle einer vollumfänglichen Liquidation der Gesellschaft zustünde) an etwaigen, in der Ankündigung des
Drag-Along Sale konkretisierten Entschädigungen oder Verpflichtungen zu beteiligen.

(iii) Gegenleistung. Im Falle eines Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor von seinen Wertpapieren all diejeni-

gen zu übertragen, die in der Ankündigung des Drag-Along Sale aufgeführt sind. Form und Umfang der Gegenleistung
für Wertpapiere, wie sie im Rahmen eines Drag-Along Sale übertragen werden, ist, wie in der Ankündigung des Drag-
Along Sale ausgewiesen, für alle Wertpapiere der gleichen Art oder Anteilsklasse identisch.

(e) Abtretung. Für Zwecke dieser Artikel bezeichnet «Übertragung» oder «Abtretung» eine freiwillige oder unfrei-

willige (auch gesetzlich erzwungene) Transaktion, die zu einer Übertragung des Eigentums - «nue-propriété», «usufruit»
- bzw. der Rechte an den von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien (einschließlich von Stimm- und Dividendenrechten)
auf eine beliebige Person mit Ausnahme der Gesellschaft - z.B. eines Aktionärs der Gesellschaft - auf beliebigem Wege
(einschließlich von Schenkungen, teilumfänglichen Übertragungen von Vermögenswerten («apports partiels d’actifs»),
Fusionen, Splits («scissions»), Veräußerungen, Abtretungen, Verpfändungen oder anderen Formen der Übertragung, Ab-
tretung oder Verfügung von bzw. über Eigentums- oder Nießbrauchsrechten an den Aktien sowie jeder beliebigen Kom-
bination entsprechender Methoden der Besitzübertragung führt. Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien.

(f) Diesen Artikeln zuwiderhandelnde Abtretungen. Übertragungen von Wertpapieren (einschließlich möglicher

Übertragungsversuche), die den Bestimmungen dieser Artikel zuwiderhandeln, sind nichtig und wirkungslos und sind sei-
tens der Gesellschaft weder anzuerkennen noch in den Büchern der Gesellschaft zu dokumentieren. Ebensowenig wird
ein angeblicher Abtretungsempfänger unter diesen Umständen als Inhaber der betreffenden Wertpapiere anerkannt.

Kapitel III. Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführerin
Die Gesellschaft wird von RONCADIN HOLDINGS GP S.A., einer gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxem-

burg gegründeten «société anonyme», als ausschließliche Geschäftsführerin («associé commandité») und Manager der
Gesellschaft (nachstehend als «Geschäftsführerin» bezeichnet) verwaltet. Die anderen Aktionäre sind an der Geschäfts-
führung der Gesellschaft weder beteiligt, noch können sie in diese eingreifen. Im Falle der rechtlichen Geschäftsunfähig-
keit oder Liquidation der Gesellschaft bzw. bei einer anderweitigen ständigen Beeinträchtigung der Geschäftsführung
durch die Geschäftsführerin ist diese nicht umgehend aufzulösen und zu liquidieren. Dies setzt allerdings voraus, dass
der Aufsichtsrat gemäß Artikel 11 dieses Vertrags einen Verwalter bestellt (bei dem es sich nicht um einen Aktionär
handeln muss), der sich bis zur Abhaltung einer Hauptversammlung, die er innerhalb von 15 Tagen nach seiner Bestellung

45999

anzuberaumen hat, dringenden Verwaltungsaufgaben widmet. Anlässlich der Versammlung können die Aktionäre unter
Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten einen
Nachfolger berufen. Kommt eine solche Berufung nicht zustande, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.

Art. 9. Vollmachten der Geschäftsführerin
9.1. Allgemeine Vollmachten
Die Geschäftsführerin verfügt zur Wahrnehmung ihrer administrativen Aufgaben im Sinne des Gesellschaftszwecks

über weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt, die eine Einschränkung nur insofern erfah-
ren, als sie nach anwendbarem Recht und diesen Artikeln der Hauptversammlung bzw. dem Aufsichtsrat vorbehalten
sind.

9.2. Durchsetzung von Rechten
Die Geschäftsführerin hat auf der Grundlage ihres besten Wissens und Gewissens den Interessen der Gesellschaft

und ihrer Aktionäre zu dienen und nach Kräften sämtlichen Rechten zur Durchsetzung zu verhelfen, die der Gesellschaft
im Rahmen von Gesellschaftsverträgen von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie gemäß Wertpa-
pierinhaber- oder weiteren Verträgen zugestanden wurden, die zwischen der Gesellschaft und beliebiger ihrer Anteils-
eigner von Zeit zu Zeit abgeschlossen werden können.

9.3. Entlassung der Geschäftsführerin durch Stammaktionäre 
Falls die Geschäftsführerin gemäß der nachvollziehbaren Einschätzung der Stammaktionäre die Erfüllung ihrer Pflich-

ten gegenüber der Gesellschaft und den Aktionären im Sinne von Artikel vernachlässigt, sind die Aktionäre aufgrund
einer im Rahmen einer ordnungsgemäß anberaumten Aktionärsversammlung und unter Einhaltung des Gebots der Be-
schlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Ab-
stimmung berechtigt, die Bestellung der Geschäftsführerin rückgängig zu machen und diese durch eine neue
Geschäftsführerin zu ersetzen, deren Bestellung ebenfalls einer unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und
der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Abstimmung bedarf. Der
Geschäftsführerin ist die Beteiligung an einer Abstimmung zur Frage der Widerrufung ihrer Bestellung als Geschäftsfüh-
rerin der Gesellschaft nicht gestattet.

Art. 10. Dritte
Die Gesellschaft ist wirksam gegenüber Dritten durch die Unterschrift der Geschäftsführerin bzw. die Unterschriften

weiterer Personen gebunden, deren Vollmacht diesen von der Geschäftsführerin nach eigenem Ermessen übertragen
wurde.

Kapitel IV. Aufsicht

Art. 11. Aufsichtsrat
11.1. Mitglieder des Aufsichtsrates
Das Geschäft der Gesellschaft und ihre finanzielle Lage - insbesondere im Hinblick auf ihre Bücher und Konten - un-

terliegen der Aufsicht eines mindestens aus drei Mitgliedern (bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss) be-
stehenden Aufsichtsrates («Conseil de Surveillance»). Zur Ausübung seiner Aufsichtsfunktion verfügt dieses Gremium
über die Vollmacht eines Prüfungsbeauftragen der Geschäftsführung gemäß Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August
1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung. Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführerin zu
beliebigen Fragen konsultiert werden und ist zur Genehmigung von Maßnahmen der Geschäftsführerin berechtigt, die
nach anwendbarem Recht oder diesen Artikeln die Befugnisse der Geschäftsführerin unter Umständen überschreiten.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von jeweils
einem (1) Jahr zu bestellen und bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können
wiedergewählt, aber auch jederzeit ohne Angabe von Gründen kraft eines Beschlusses der Hauptversammlung der Ak-
tionäre abgewählt werden. Der Aufsichtsrat kann eines seiner Mitglieder zum Sprecher wählen.

11.2. Versammlungen des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat wird von seinem Sprecher bzw. von der Geschäftsführerin einberufen und tritt auch auf Wunsch

eines seiner Mitglieder zusammen.

11.3. Mitteilungen
Von Versammlungen des Aufsichtsrates ist sämtlichen Mitglieder mindestens drei (3) Tage vor dem für die Versamm-

lung anberaumten Termin schriftlich Mitteilung zu machen. In dringenden Fällen ist diese Frist nicht verbindlich - aller-
dings ist in entsprechenden Einladungen die Dringlichkeit detailliert zu erläutern. Mitteilungen erfolgen unter Angabe
des Versammlungsorts und der Tagesordnung. Auf die Mitteilungsfrist kann schriftlich, per Telegramm, Telex, Fax oder
unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden verzichtet werden. Zu diesem Zweck genügt auch eine Ab-
schrift. Im Falle von Versammlungen, deren Zeitpunkt und Ort von dem Aufsichtsrat bereits in einen Terminkalender
eingetragen wurden, bedarf es keiner gesonderten Mitteilungen.

11.4. Vorsitzender
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates sitzt allen Versammlungen des Rates vor und ist im Falle seiner Abwesenheit

durch ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrates zu ersetzen, das mit der Mehrheit der vertretenen Stimmen zum vor-
übergehenden Vorsitzenden bestellt wird. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per Telegramm, Te-
lex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck genügt auch eine
Abschrift. Dabei ist es zulässig, dass ein Mitglied mehrere seiner Kollegen vertritt.

11.5. Beschlüsse
Der Aufsichtsrat ist zu wirksamen Beschlüssen nur dann fähig, wenn zumindest eine einfache Mehrheit seiner Mitglie-

der anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse bedürfen zu ihrer Fassung einer Mehrheit der anwesenden oder vertrete-
nen Stimmen.

46000

11.6. Protokolle
Beschlüsse des Aufsichtsrates sind in Versammlungsprotokollen festzuhalten und von dem Vorsitzenden der betref-

fenden Versammlung zu unterzeichen. Abschriften der Auszüge solcher Protokolle, wie sie etwa anlässlich von Gerichts-
verfahren sowie bei anderen Anlässen vorzulegen sind, sind von dem Vorsitzenden der Versammlung oder zwei
beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

11.7. Schriftlich gefasste Beschlüsse, Konferenzgespräch
Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Aufsichtsrates unterzeichnet wurden, stehen auf dem

Wege der Abstimmung anlässlich von Aufsichtsratsversammlungen gefassten Beschlüssen gleich. Dabei sind schriftlich
gefasste Beschlüsse von allen Mitgliedern schriftlich durch ihre Unterschrift zu bestätigen. Zu diesem Zweck genügt auch
eine Abschrift. Alle Unterlagen bilden gemeinsam die Urkunde, die als Nachweis der jeweiligen Beschlussfassung dient.
Jedem Mitglied des Aufsichtsrates steht es frei, an Versammlungen des Gremiums über eine Konferenzschaltung oder
weitere Kommunikationsmethoden teilzunehmen, die allen Versammlungsteilnehmern erlaubt, einander zu hören. Eine
derartige Teilnahme an einer Versammlung steht einer persönlichen Teilnahme in keiner Hinsicht nach.

11.8. Haftung
Keines der Mitglieder des Aufsichtsrates übernimmt mit seinem Aufsichtsratsmandat eine wie auch immer geartete

Haftung im Bezug auf die von den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Namen der Gesellschaft regelmäßig eingegangenen
Verpflichtungen. Bei ihnen handelt es sich lediglich um Bevollmächtigte, die ausschließlich für die Erfüllung ihres Mandats
eine Verantwortung tragen.

11.9. Freistellung
(a) Freistellung. Die Gesellschaft stellt alle Mitglieder des Aufsichtsrates sowie deren Rechtsnachfolger, Testaments-

vollstrecker und Nachlassverwalter im gesetzlich zulässigen Umfang von allen Ausgaben frei, die diesen nachvollziehbar
im Rahmen von Klagen oder Verfahren entstehen, denen sie infolge ihres Aufsichtsratsmandats bei der Gesellschaft als
Partei ausgesetzt sind und von denen sie nicht freigestellt werden müssen. Dies gilt nicht im Bezug auf Klagen oder Ver-
fahren, im Rahmen derer sie letztendlich der Fahrlässigkeit oder schwerwiegenden Fehlverhaltens als schuldig erachtet
werden; im Falle eines Vergleichs wird eine Freistellung nur in Verbindung mit den durch den Vergleich abgegoltenen
Handlungen gewährt, für die nach Einschätzung der Rechtsvertreter der Gesellschaft seitens der freizustellenden Person
keine Pflichtverletzung vorliegt. Der vorstehende Freistellungsanspruch schließt andere Rechte, auf die diese Personen
ggf. Anspruch haben, nicht aus.

(b) Ausgaben. Die Gesellschaft kommt für sämtliche Ausgaben auf, die einer im Rahmen dieser Artikel freizustellen-

den Person entstehen, vor endgültiger Entscheidung auf. Dies setzt allerdings voraus, dass der Gesellschaft eine schrift-
liche und rechtlich verbindliche Verpflichtungserklärung der betreffenden Person zugeht, in der sich diese im Falle der
abschließenden Feststellung, dass sie über keinen Freistellungsanspruch verfügt, zur Einziehung des vollständigen Betrags
bereit erklärt. Die Beendigung von Klagen und Verfahren über Urteile, Verfügungen, Vergleiche, Verurteilungen oder
Schuldgeständnisse oder vergleichbare Abschlüsse bergen an sich keinen Hinweis darauf, dass die freizustellende Person
die an ihren im Rahmen dieses Vertrags bestehenden Freistellungsanspruch geknüpften Verhaltensvorgaben nicht erfüllt
hat. Nach Erhalt einer Mitteilung einer freizustellenden Person, in der diese unter Erfüllung zumutbarer Vorgaben der
Gesellschaft deren Freistellungsverpflichtung nachweist, ist die Gesellschaft umgehend zu einer Barzahlung an die betref-
fende Person in Höhe des vollen Freistellungsbetrags verpflichtet.

11.10 Konflikte
Sollte die Geschäftsführerin bzw. einer oder mehrere ihrer Direktoren oder Vorstände an einem weiteren Unter-

nehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt sein oder einem solchen als
Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehören, so nehmen die betreffenden Verträge oder Geschäftsbeziehungen dar-
an keinen Schaden. Ebenso bleibt es keinem Direktor oder Vorstand der Geschäftsführerin, der an einem weiteren Un-
ternehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt ist oder einem solchen
als Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehört, verwehrt, aufgrund seines Verhältnisses zu dem betreffenden Unter-
nehmen an der Besprechung oder Abstimmung zu Angelegenheiten teilzunehmen, die entsprechende Verträge oder Ge-
schäftsbeziehungen berühren.

Kapitel V. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 12. Aktionärsversammlungen
(a) Vollmachten. Die Hauptversammlung der Aktionäre vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft und verfügt zur

Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Vorgängen betreffend den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft über
weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt. Diese ist lediglich dadurch eingeschränkt, dass
Beschlüsse zu ihrer wirksamen Fassung vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in diesen Artikeln der Zustimmung
der Geschäftsführerin bedürfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft tritt immer dann zusammen,
wenn die Geschäftsführerin oder der Aufsichtsrat eine Versammlung einberaumt. 

(b) Ort, Zeit. Die in jährlichen Abständen stattfindende Hauptversammlung wird in Luxemburg am Sitz der Gesell-

schaft bzw. an einem weiteren, in der Einladung genannten Ort in Luxemburg jeweils am 31. März abgehalten. Handelt
es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf
folgenden Geschäftstag in Luxemburg statt. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre werden an den Orten und zu
den Zeitpunkten abgehalten, wie sie in den jeweiligen Einladungen angegeben sind. Die Hauptversammlungen der Ak-
tionäre werden in Form einer Einladung anberaumt, aus der die Tagesordnung hervorgeht und die von der Geschäfts-
führerin mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär der Gesellschaft unter der im
Aktionärsverzeichnis angegebenen Anschrift verschickt wird. 

(c) Abstimmung. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per

Telegramm, Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck ge-
nügt auch eine Abschrift. Die Versammlungen der Aktionäre unterliegen vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen

46001

dieses Vertrags den gesetzlichen Bestimmungen zu Beschlussfähigkeit und erforderlichen Mehrheiten. Alle weiteren Be-
dingungen, die seitens der Aktionäre im Sinne ihrer Teilnahme an Aktionärsversammlungen zu erfüllen sind, bestimmt
die Geschäftsführerin. Falls alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Tagesordnung der Ver-
sammlung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, so kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

Kapitel VI. Geschäftsjahr, Bilanz

Art. 13. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 14. Rücklagen
Von dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen

zuzuführen. Diese Zuweisungspflicht entfällt, sobald die gesetzlichen Rücklagen zehn Prozent (10%) des gezeichneten
Aktienkapitals erreicht haben. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat auf Empfehlung der Geschäftsführerin zu be-
stimmen, wie über den verbleibende Teil des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Vorbehaltlich der einschlägigen
gesetzlichen Bedingungen können Abschlagsdividenden ausgeschüttet werden.

Kapitel VII. Liquidation, Änderung der Artikel

Art. 15. Änderung
Diese Artikel können vorbehaltlich der Zustimmung der Geschäftsführerin von einer Mehrheit von zwei Dritteln der

Stimmen der Gesellschaftsaktionäre anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre, bei dem wenigstens fünfzig Pro-
zent (50%) des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist, abgeändert werden. In dem Fall, dass die vorstehende
Voraussetzung der Beschlussfähigkeit nicht erfüllt ist, bedarf es zur Abänderung dieser Artikel vorbehaltlich der Zustim-
mung der Geschäftsführerin anlässlich einer zweiten Hauptversammlung der Aktionäre ebenfalls einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen der Gesellschaftsaktionäre; diese zweite Hauptversammlung unterliegt allerdings hinsichtlich
ihrer Beschlussfähigkeit keiner Voraussetzung mehr.

Art. 16. Auflösung
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren Liquidatoren (natürliche oder juristi-

sche Personen) durchgeführt. Liquidatoren werden von der Hauptversammlung bestellt, die auch die Auflösung be-
schloss und darüber hinaus den Umfang der Vollmachten und die Entschädigung der Liquidatoren festlegt.

Kapitel VIII. Abschliessende Verfügungen

Art. 17. Allgemeines
Im Hinblick auf alle nicht im Rahmen dieser Artikel geregelten Angelegenheiten haben sich die Vertragsparteien an

dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung zu orien-
tieren.

Art. 18. Definitionen
Für Zwecke dieser Artikel:
bezeichnen «Verbundene Unternehmen» sämtliche Personen, die von einer weiteren Person direkt oder indirekt be-

herrscht werden, diese selbst beherrschen oder mit dieser oder anderen Personen, die an jenen mit über fünfzig Prozent
(50%) wirtschaftlich beteiligt sind oder ihrerseits eine Beteiligung jener Personen in eben diesem Umfang aufweisen, ge-
meinsam von einer dritten Person beherrscht werden;

bezeichnen «Artikel» die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft, wie er von Zeit zu Zeit abgeän-

dert werden mag;

beschreibt «As-converted Basis» im Hinblick auf die ausstehenden Wertpapiere der Gesellschaft das Szenario, dass

alle in Stammaktien umwandelbare bzw. als solche ausüb- oder umtauschbare Wertpapiere im Einklang mit den Bedin-
gungen dieser umgewandelt, ausgeübt oder umgetauscht werden (d.h., die Anzahl der ausstehenden Stammaktien zu-
züglich der zusätzlichen Anzahl von Stammaktien, die unter der Voraussetzung einer entsprechenden Verwertung
ausstehen würden);

bezeichnen «Erlöse der Klasse A» sämtliche Ausschüttungen an Aktionäre, Einziehungsbeträge oder andere von

RONCADIN HOLDINGS S.C.A. an die Gesellschaft aufgrund ihres Besitzes von seitens RONCADIN HOLDINGS
S.C.A. ausgegebener Stammaktien der Klasse A1, Stammaktien der Klasse A2, PECs der Serie 1 oder CPECs der Serie
1 (gemäß der Definition dieser Begriffe in dem Gesellschaftsvertrag von RONCADIN HOLDINGS S.C.A. in seiner je-
weils geltenden Fassung);

bezeichnen «Erlöse der Klasse B» sämtliche Ausschüttungen an Aktionäre, Einziehungsbeträge oder andere von

RONCADIN HOLDINGS S.C.A. an die Gesellschaft aufgrund ihres Besitzes von seitens RONCADIN HOLDINGS
S.C.A. ausgegebener Stammaktien der Klasse B oder CPECs der Serie 2 (gemäß der Definition dieser Begriffe in dem
Gesellschaftsvertrag von RONCADIN HOLDINGS S.C.A. in seiner jeweils geltenden Fassung);

haben «Stammaktien der Klasse A» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung;
bezeichnen «Aktionäre der Klasse A» die Inhaber von Stammaktien der Klasse A der Gesellschaft;
haben «Stammaktien der Klasse B» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung;
bezeichnen «Aktionäre der Klasse B» die Inhaber von Stammaktien der Klasse B der Gesellschaft;
hat «Gesellschaft» die in Artikel 1 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Beherrschung» im Hinblick auf eine Person die Fähigkeit zur Verwaltung oder Kontrolle dieser Person

oder zur Bestellung ihrer Verwaltungsgremien bzw. einer Mehrheit der Mitglieder solcher Gremien im Falle einer ge-
meinschaftlichen Entscheidung auf der Grundlage des Besitzes stimmberechtigter Wertpapiere, der Vertragsgewalt oder
anderweitig (in dieser Hinsicht gilt eine Kommanditgesellschaft als von ihrem Geschäftsführer beherrscht);

46002

bezeichnen «CPECs» CPECs der Serie 1, wie sie von der Gesellschaft von Zeit ausgegeben werden können, sowie

ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft eben-
falls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können;

hat «Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
hat «Ankündigung des Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
haben «Drag-Along Securities» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung;
hat «Geschäftsführer(in)» die in Artikel 8 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Gruppe» die Gesellschaft sowie deren Tochtergesellschaften, bei denen es sich jeweils um Gruppenun-

ternehmen handelt;

hat «Ausgabe» die in Artikel 6.13 dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Verwaltete juristische Person» eine juristische Person, die von der Geschäftsführerin, der Gesellschaft

oder einer ihrer Tochtergesellschaften beherrscht oder aber verwaltet oder betrieben wird oder der die Geschäftsfüh-
rerin, die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften als Partner oder Aktionär angehört;

bezeichnen «Stammaktien» von der Gesellschaft ausgegebene Stammaktien der Klasse A und Stammaktien der Klasse

B;

bezeichnen «PECs» PECs der Serie 1, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können, sowie

ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft eben-
falls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können;

hat «Zulässige Abtretung» die in Artikel 7.3(c) dieses Vertrags dargelegte Bedeutung;
hat «Zulässiger Abtretungsempfänger» die in Artikel 7.3(c) dieses Vertrags dargelegte Bedeutung;
bezeichnet «Person» ein Individuum, eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, einen Verband, eine Aktien-

gesellschaft, einen Trust, ein Gemeinschaftsunternehmen, eine nicht eingetragene Organisation oder eine Regierungs-
stelle (-amt, -ministerium usw.);

bezeichnen «Primary Investors» OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC oder ein mit dieser Gesellschaft verbun-

denes Unternehmen, das als Stammaktionär bzw. Anteilseigner an der Gesellschaft oder der Geschäftsführerin beteiligt
ist;

bezeichnen «Secondary Investors» alle Inhaber von Stammaktien oder anderen Anteilen an der Gesellschaft mit Aus-

nahme der Primary Investors;

bezeichnen «Wertpapiere» alle ordnungsgemäß genehmigten Wertpapiere der Gesellschaft, so z.B. der PECs und

CPECs;

bezeichnen «CPECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen umtauschbaren Vorzugsaktien der Serie

1;

bezeichnen «PECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen Vorzugsaktien der Serie 1;
bezeichnet «Tochtergesellschaft» im Hinblick auf eine Person alle weiteren Personen, deren Stimmrechte oder wei-

teren stimmberechtigten Anteile - auch im Sinne der Bestellung von Direktoren, Geschäftsführern oder Treuhände -
jene bzw. eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften in beliebiger Konstellation (ungeachtet des Eintritts möglicher
Ausnahmefälle) zum Zeitpunkt des Besitzes oder der Beherrschung direkt oder indirekt mehrheitlich besitzen oder be-
herrschen. Für Zwecke dieses Vertrags gelten Personen als Mehrheitsaktionäre von, GmbHs, Personengesellschaften,
Verbänden oder weiterer gewerblich tätiger Organisation, wenn die betreffenden Personen solche, GmbHs, Personen-
gesellschaften, Verbände oder weiteren gewerblich tätigen Organisationen beherrschen oder deren Gewinne bzw. Ver-
luste überwiegend absorbieren;

hat «Aufsichtsrat» die in Artikel 11.1 dargelegte Bedeutung;
haben «Übertragung» und «übertragen» (bzw. «Abtretung» und «abtreten») die in Artikel 7.3(e) dargelegte Bedeu-

tung.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner habe die auszugebenen Aktien wie folgt gezeichnet:
1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, vorgenannt,
hat zehntausenddreihundertdreiunddreissig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 10.333,75) eingezahlt und

vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (8.267) Aktien gezeichnet;

2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, vorgennant,
hat zehntausenddreihundertzweiunddreissig Euro und fünfzig Cent (EUR 10.332,50) eingezahlt und achttausendzwei-

hundertsechsundsechzig (8.266) Aktien gezeichnet;

3) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, vorgennant,
hat zehntausenddreihundertzweiunddreissig Euro und fünfzig Cent (EUR 10.332,50) eingezahlt und achttausendzwei-

hundertsechsundsechzig (8.266) Aktien gezeichnet;

4) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., vorgenannt,
hat ein Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) eingezahlt und einen (1) Aktie gezeichnet;
Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingezahlt für vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Ak-

tien.

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

46003

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr viertausendvierhundert (4.400,-) Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
2. RONCADIN HOLDINGS GP S.A. wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung.
3. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
- Jacques Peffer, mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;
- Jean-Jacques Soisson mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;
- Christophe Deschamps, mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
5. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten für das

Rechnungsjahr 2006 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Vollmachtnehmers

der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher
Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maß-
gebend. 

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmers der Erschienenen, hat derselben

mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 55, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021292/230/1055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

MARUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.702. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 mars 1995, acte publié au

Mémorial C numéro 326 du 18 juillet 1995. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé le 13 dé-
cembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 788 du 24 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04384, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018404/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

MARUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.702. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 mars 1995, acte publié au

Mémorial C numéro 326 du 18 juillet 1995. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé le 13 dé-
cembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 788 du 24 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04387, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018351/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

<i>Pour MARUL HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour MARUL HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

46004

MARUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.702. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 mars 1995, acte publié au

Mémorial C numéro 326 du 18 juillet 1995. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé le 13 dé-
cembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 788 du 24 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04388, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018408/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

MARUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.702. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 mars 1995, acte publié au

Mémorial C numéro 326 du 18 juillet 1995. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé le 13
décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 788 du 24 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04389, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018350/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

MARUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.702. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 mars 1995, acte publié au

Mémorial C numéro 326 du 18 juillet 1995. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé le 13
décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 788 du 24 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04390, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018409/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

MARUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.702. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 mars 1995, acte publié au

Mémorial C numéro 326 du 18 juillet 1995. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé le 13
décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 788 du 24 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04391, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018352/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

<i>Pour MARUL HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour MARUL HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour MARUL HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour MARUL HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

46005

IST INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 107.943. 

Il résulte de la résolution tenue au siège social en date du 8 février de la société IST INTERNATIONAL HOLDING,

S.à r.l., que l’associé unique a pris la décision suivante:

1. Démission des Gérants suivants:
Cees-Jan Quirijns à la date du 8 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04286. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018244/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

DALMATIAN FUND, Fonds Commun de Placement.

Le Règlement de Gestion coordonné au 30 janvier 2006 et le contrat modificatif du Règlement de Gestion du 30

janvier 2006, enregistrés à Luxembourg le 1

er

 février 2006 sous la référence LSO-BN00407 ont été déposés au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2006.

(018282//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

ALSO ENERVIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.130. 

Société constituée le 14 août 1995 par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémo-

rial C n

°

 564 du 4 novembre 1995. 

Monsieur Angelo de Bernardi et Madame Marie Fiore Ries-Bonani administrateurs, ainsi que Monsieur Adrien Schaus

commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société ALSO ENERVIT INTERNATIONAL S.A., établi au 17, rue de Beaumont, L-1219 Luxem-

bourg, a été dénoncé le 10 février 2006.

Luxembourg, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018287//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

YAPI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.704. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, (agissant en remplacement de son col-

lègue empêché Maître Jean Seckler), en date du 11 février 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 362 du 20 mai 1999,

modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 mai 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 629 du 20 août 1999, en date du 24 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 873 du 7 juin

2002, et en date du 19 décembre 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 231 du 26 février 2004.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04385, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018349/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

IST INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l.
Ch. Hultman
<i>Gérant «A»

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

<i>Pour YAPI INVEST S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

46006

VIATRIS HOLDING (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 1.856.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.533. 

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société prise en date du 13 février 2006

En date du 13 février 2006, l’associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Wilhelm Plumpe, Diplom-

Kauffmann, né le 15 septembre 1952 à Marl, Allemagne, demeurant au 8A, Schöne Aussicht, D-61348 Bad Homburg,
Allemagne, en tant que nouveau liquidateur de la Société en remplacement de AIM SERVICES, S.à r.l. et ce avec date
d’effet rétroactif au 1

er

 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018289/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

I.C.C.I. INC. S.A., INTER CONTINENTAL AND CAPITAL INVESTMENTS INCORPORATION, 

Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.215. 

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 novembre 2002.

Le siège social de la société jusqu’alors fixé au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, a été dénoncé avec

effet au 31 décembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018341//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

PLANALTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.431. 

Constituée par-devant M

e

 Alex Weber, notaire alors de résidence à Niederkerschen, maintenant à Bascharage, en date

du 17 novembre 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 99 du 10 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en

date du 20 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 178 du 19 avril 1995.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04342, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018417/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

PLANALTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.431. 

Constituée par-devant M

e

 Alex Weber, notaire alors de résidence à Niederkerschen, maintenant à Bascharage, en date

du 17 novembre 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 99 du 10 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en

date du 20 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 178 du 19 avril 1995.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04346, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018421/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

VIATRIS HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 31 décembre 2005.

Ch. Kaufhold.

<i>Pour PLANALTO S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour PLANALTO S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

46007

VIRIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 59.319. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 7 mai 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 459 du 25 août 1997, modifiée par-devant le même notaire en date

du 28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1395 du 26 septembre 2002, et en date du 9 août 2002, acte publié

au Mémorial C n

°

 1532 du 24 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04380, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018410/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

WALLENSTEIN FINANZ S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 69.962. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 15 septembre 2005

<i>Décision

1. Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 14, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg au

14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018043/4181/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

ETABLISSEMENTS SCHULTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 5, rue Cyprien Merjai.

R. C. Luxembourg B 18.559. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2005

Les associés de la société SCHULTZ, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 30 dé-

cembre 2005, ont décidé, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante:

Le siège social est transféré, à compter du 1

er

 janvier 2006, à: L-2145 Luxembourg, 5, rue Cyprien Merjai.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03357. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018061/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

EXPRESS SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 310, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 4.516. 

AUSZUG

Es erhellt aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung sowie der Verwaltungsratsitzung unter Privats-

chrift vom 20. Mai 2005, einregistriert in Luxembourg-Sociétés, am 14. Februar 2006, référence LSO-BN03196, dass
KPMG AUDIT, mit Geschäftssitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, wird als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2005 bestätigt.

Für Auszug zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. Februar 2006.

(018064/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

<i>Pour VIRIA HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Signature.

Pour extrait conforme
G. Schultz / R. Schultz

A. Schwachtgen
<i>Notaire

46008

BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.360. 

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la société BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., établie et ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 11, bd du Prince Henri, et la société ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à
r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, a été dénoncé avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018256//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2540 Luxemburg, 25, rue Edward Steichen.

H. R. Luxemburg B 8.495. 

Die Gesellschaft teilt folgende personelle Veränderungen in Bezug auf die Besetzung des Verwaltungsrats mit:
Herr Dr. Sebastian Klein hat sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats zum 31. Dezember 2005 niedergelegt. Der

Verwaltungsrat hat Herrn René Kaselitz mit Wirkung zum 1. Januar 2006 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats ge-
wählt.

Der Verwaltungsrat der COMMERZBANK INTERNATIONAL setzt sich demnach aktuell wie folgt zusammen:
- Herr Klaus-Peter Müller (Vorsitzender);
- Herr Jacques Loesch;
- Herr Ulrich H. Leistner;
- Herr Dr. Eric Strutz;
- Herr René Kaselitz;
- Herr Bernd Holzenthal;
- Herr Cornelius Obert.
Erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Februar 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01817. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018258//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

MANSION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.563. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 janvier 2006 

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la société avec effet

rétroactif au 7 septembre 2005.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme Madame Géraldine Schmit, domiciliée professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, au poste d’administrateur vacant de la société avec effet rétroactif au 7 septembre 2005. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04674. – Reçu 14 euros.

(018633/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Signature
<i>L’agent domiciliataire

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
Dr. B. Weber / S. Schwickerath

Pour extrait
<i>Pour la société
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

46009

VAFAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 59.318. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 7 mai 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 459 du 25 août 1997, modifiée par-devant le même notaire en date

du 28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1395 du 26 septembre 2002 et en date du 9 août 2002, acte publié

au Mémorial C n

°

 1532 du 24 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04371, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018413/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

PARATI INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 100.572. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique de la société en date du 6 février 2006

- La nomination de Madame Susanne Heger, 105/2/11 Mariahilfer Strasse, A-1060 Vienne, Autriche, en tant que gérant

supplémentaire de la société avec effet au 6 février 2006 pour une période indéterminée a été acceptée, confirmée et
ratifiée.

Luxembourg, le 20 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018505/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

HR REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 114.448. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quatorze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Rani Harb, responsable commercial, né à Suresnes (France), le 21 février 1978, demeurant à F-75020

Paris, 28, rue Piat (France);

2.- Monsieur Ghassan Harb, manutentionnaire, né à Suresnes (France), le 14 septembre 1983, demeurant à F-95280

Jouy Le Moutier, 25, rue de la Montgolfière (France);

3.- Madame Emma Harb, étudiante, née à Suresnes (France), le 13 février 1987, demeurant à F-95280 Jouy Le Moutier,

25, rue de la Montgolfière (France).

Les comparants sub 2.- et 3.- sont ici représentés par Monsieur Rani Harb, préqualifié, en vertu de deux procurations

sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de HR REAL ESTATE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

<i>Pour VAFAGE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

46010

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion de biens immobiliers, ainsi que la prise de participations

dans d’autres sociétés ayant un objet similaire ou analogue.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois

46011

être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions generales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve

dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Rani Harb, responsable commercial, né à Suresnes (France), le 21 février 1978, demeurant à F-75020

Paris, 28, rue Piat (France);

b) Monsieur Ghassan Harb, manutentionnaire, né à Suresnes (France), le 14 septembre 1983, demeurant à F-95280

Jouy Le Moutier, 25, rue de la Montgolfière (France);

c) Mademoiselle Katia Roti, employée privée, née à Thionville (France), le 3 juin 1978, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société: 
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née 2011.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Rani Harb, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Harb, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2006, vol. 535, fol. 78, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020452/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

1.- Monsieur Rani Harb, préqualifié, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2.- Monsieur Ghassan Harb, préqualifié, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3.- Madame Emma Harb, préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 1

er

 mars 2006.

J. Seckler.

46012

INTABEX WORLDWIDE, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.069. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 février 2006

Les actionnaires:
-mettent fin au mandat d’administrateur de Donald Crane, résidant professionnellement au 149 Zwarteweg, VL-

Aalsmeer NL-1431, Pays-Bas, avec effet à la date de ladite assemblée;

-et nomment à la fonction d’administrateur Wim Lapere, résidant professionnellement au 149 Zwarteweg, VL-

Aalsmeer NL-1431, Pays-Bas, avec effet à la date de ladite assemblée.

Luxembourg, le 15 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018506/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

S.L. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.009. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 16 février 2006 à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus et Monsieur

Koen Lozie et COSAFIN S.A. au poste d’Administrateurs ainsi que le mandat de Monsieur Noël Didier comme Com-
missaire aux Comptes.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés

au 30 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018561/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

EUROPEAN RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.627. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 février 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04575. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018653/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MM. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

46013

PROPERTIES MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

R. C. Luxembourg B 85.627. 

Il résulte d’un courrier adressé à la société PROPERTIES MANAGEMENT, S.à r.l. que la société WOOD, APPLE-

TON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., en sa qualité d’agent domiciliataire, a dénoncé le siège social avec effet
au 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018565//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

PROPERTIES MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.627. 

Il résulte d’un courrier adressé à la société PROPERTIES MANAGEMENT, S.à r.l. que M. Alain Heinz a démissionné

de son mandat d’administrateur de la société en date du 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018567//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

BATEMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.189. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 juin 2005

L’Assemblée accepte la démission de WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. avec siège social

au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société avec
effet au 1

er

 janvier 2004.

L’Assemblée décide de nommer KPMG, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au poste de Com-

missaire aux Comptes de la société avec effet au 1

er

 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018570/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

NOUVELLE ESPACES VERTS LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8089 Bertrange, 15, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 46.478. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2005

Le siège social de la société NOUVELLE ESPACES VERTS LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l. est transféré avec effet im-

médiat au 15, rue des Prés, L-8089 Bertrange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018592//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Signature
<i>Le domiciliataire

A la demande des intéressés
Signature

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour NOUVELLE ESPACES VERTS LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

46014

EURANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 108.085. 

La société EURANGE, S.à r.l. informe des modifications non statutaires suivantes la concernant:
1) L’adresse privée ou professionnelle de l’associé unique M. Mogenier Lionel, Jean-Charles est désormais rue du

Grand Bureau, n

°

 9 - 1227 Genève Acacias - Suisse»;

2) L’adresse privée ou professionnelle du gérant M. Mogenier Lionel, Jean-Charles est désormais rue du Grand Bu-

reau, n

°

 9 - 1227 Genève Acacias - Suisse».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018572//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

GESAB BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 75.528. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 14 février 2006

Il résulte dudit procès-verbal que la société AUDICO INTERNATIONAL S.A. a été révoquée de son poste d’admi-

nistrateur de la société avec effet immédiat. La société PROGRESS INVEST S.A. dont le siège social est au 28, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg a été nommée en remplacement.

La société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l. a été révoquée de son poste de commissaire aux comptes avec effet im-

médiat. La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg a été nommée
en remplacement.

Luxembourg, le 14 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018576//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

CLUB HIVERSPORT, SECTION DANSE ET FORMATION SUR GLACE, A.s.b.l, 

Association sans but lucratif,

(anc. CLUB HIVERSPORT, SECTION DANSE SUR GLACE ET SPORT LOISIR, A.s.b.l.). 

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 42, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg. 

Statuts de fondation du Club publiés au Mémorial C n

°

 134, le 25 avril 1990, Page 6392.

Une Assemblée Générale extraordinaire a décidé de modifier:
1) le nom du Club;
2) l’adresse du Siège social.
Ancienne dénomination: CLUB HIVERSPORT, SECTION DANSE SUR GLACE ET SPORT LOISIR, A.s.b.l.
Nouvelle dénomination: CLUB HIVERSPORT, SECTION DANSE ET FORMATION SUR GLACE, A.s.b.l.
Ancien Siège social: L-7237 Walferdange, 20, rue Jean Mercatoris.
Nouveau Siège social: Patinoire, 42, rte de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer.
Modification du paragraphe 2 de l’Article 14 des Statuts:
Tous les membres actifs doivent être convoqués par écrit quinze jours avant la date de l’assemblée générale. 
La convocation doit contenir l’ordre du jour.

Fait à Luxembourg, le 20 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04880. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018692//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

EURANGE, S.à r.l.
L. Mogenier
<i>Le Gérant

<i>Pour PROGRESS INVEST S.A.
P. Vansant
<i>Administrateur-délégué

J.-M. Nilles / A. Chlecq
<i>Secrétaire / <i>Présidente

46015

KOBELCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.528. 

EXTRAIT

Par décision de la majorité des actionnaires, Monsieur Bruno Vermeiren, demeurant professionnellement au 23, rue

Aldringen, L-1118 Luxembourg a été nommé administrateur-délégué de la société pour une durée de six ans.

Par décision de la majorité des actionnaires, Monsieur Paul Crepain, demeurant Mertensstraat 88, B-2950 Kapellen

a été révoqué de son poste d’administrateur-délégué de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018582//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

LOOKING FOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.956. 

Monsieur Jean-Pierre Blavet a démissionné de son poste de gérant de la société à responsabilité limitée LOOKING

FOR, S.à r.l. en date du 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04526. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018627/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

INTERJAM COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 72.096. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Luc Biebuyck, demeurant 8, avenue Van Sever à B-1970 Wezembeek-

Oppem, de ses fonctions d’administrateur-délégué. Il n’est pas prévu de le remplacer.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018634/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

PARCOLOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.756. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

2 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 363 du 17 mai 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04972, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018750/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

B. Vermeiren
<i>Administrateur-délégué

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

PARCOLOG, S.à r.l.
Signature
<i>Authorised Person

46016

BLUE SKY FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.835. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 9 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, actuellement en
vigueur, a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de MONTBRUN REVISION, S.à
r.l., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018646/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

APSIDA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.360. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société, le 17 février 2006

Conformément à l’article 10 des statuts, Monsieur Ioannis Sotiropoulos est révoqué de sa fonction d’Administrateur

avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05004. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018649//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

DIBILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.156. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 20 février 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018655/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

<i>Pour BLUE SKY FINANCIAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
APSIDA CORPORATION S.A.
Signature
<i>Un mandataire

MM. Olivier Marc Geinoz, administrateur de sociétés, demeurant à I-Milan, président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

46017

ARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.174. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 9 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 février 2006, le mandat de commissaire aux comp-

tes de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018652/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

EURO LABO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 82.780. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2006 que:
- La démission de Madame L. Zenners de son poste d’administrateur de la société est acceptée et est élue comme

nouvel administrateur FIDIGA S.A., avec siège social au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, son mandat
expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006.

- Le commissaire aux comptes a changé sa dénomination sociale en EWA REVISION S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018659//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

FITZWILLIAM INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES LIMITED, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Registered office: Dublin, Ireland.

Principal place of management: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 114.487. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Was held an Extraordinary General Meeting of members of FITZWILLIAM INTERNATIONAL RESOURCE

SERVICES LIMITED (the «Company»), a company organised under the laws of Ireland, having its registered office in
Dublin, Republic of Ireland, and validly registered at the Office of Register of Companies of Ireland, under the number
315308.

The meeting is presided by Mr Ricardo Sanchez, Director at L-2017 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Lux-

embourg.

The chairman declared and requested the notary to record:
I. Te present extraordinary general meeting was duly convened.
The sole member FIRSL RESOURCES LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic of Ireland

whose registered office is at Dublin, Republic of Ireland declares to have had full knowledge prior to the meeting of the
agenda of such meeting and to waive to the extent necessary all notice periods.

II. The member is here represented by Mr Ricardo Sanchez by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy form of the represented member, after having been initialled ne varietur by the above persons, will also

remain annexed to the present deed. 

III. All the 120,000 (one hundred and twenty thousand) shares in issue, are represented at the extraordinary general

meeting so that the present meeting may validly deliberate on all items on the agenda.

IV. The following documents were submitted to the meeting:
(a) A certified copy of the current articles of association of FITZWILLIAM INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES

LIMITED;

<i>Pour ARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signature.

46018

(b) A certified copy of the certificate of incorporation of the Company;
(c) A recent balance sheet.
All the above mentioned documents initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

V. That, with a view to strengthening the Company’s ability to carry out its ongoing activities in an efficient manner,

the meeting pursues to transfer the principal place of management and business and centre of main interests of the Com-
pany FITZWILLIAM INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES LIMITED from Dublin to Luxembourg. For such a pur-
pose, the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

(1) To take note of the transfer of the principal place of management and business and the centre of main interests

of the Company from Dublin, Ireland, to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(2) To approve and confirm the Luxembourg law form of Company of a société à responsabilité limitée.
(3) To adopt new articles of association.
(4) To confirm the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and to approve the report

by the board of directors of the Company relating to its assets.

(5) To fix the Luxembourg address of the company at L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

(6) To acknowledge the following persons as managers of the Company:

<i>Type A managers:

- FIRSL RESOURCES LIMITED, a company residing in Dublin, Republic of Ireland;

<i>Type B managers:

- Mr Jürgen Fischer, Director, residing at Luxembourg;
- Mr Ricardo Sanchez, Director, residing at Luxembourg.
VI. That this transfer of principal establishment to another country, without prior liquidation of the Company, is au-

thorised and accepted under Irish law.

The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting approves and confirms as far as is necessary the decision to transfer the principal place of management

and business and the centre of main interests of the Company from Dublin, Ireland, to Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting decides to adopt the Luxembourg form of a Company of a société à responsabilité limitée.
This resolution does not amend or change the Memorandum of Association or the Articles of Association as cur-

rently filed with the Irish authorities.

<i>Third resolution

For Luxembourg law purposes and the best functioning of the place of business, the meeting resolves to amend and

to restate the articles of association which will henceforth on read as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915 on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Ar-
ticles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The company may carry out any industrial and/or commercial activity, in particular (but not limited to) ren-

dering professional services to companies, including consulting services, outsourced functions, introduction of business
or facilitating qualified employees to work under the supervision of its clients. In general, it may take any controlling and
supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting directly or through an agent, in its own name or for

account of a third party, alone or in cooperation with other, and may carry out any operation which promotes its cor-
porate purpose or the purpose of the companies or partnerships in which it holds interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in other way.

The company has also as purpose the acquisition, management, development by renting out or by any other means,

and if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests

in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participat-
ing interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

46019

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes how-
ever without taking advantage of the act of July 31, 1929 on Holding Companies.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name FITZWILLIAM INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES LIMITED, S.à r.l.

Art. 5.The Company has its registered office in Dublin, Republic of Ireland.
The Company has its principal place of management and business and the centre of its main interests in Luxembourg

- Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of

managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 120,000.- (one hundred and twenty thousand Euro) repre-

sented by 100,000 (one hundred thousand) shares of EUR 1.20 (one Euro, twenty cents) each, all fully paid-up and sub-
scribed.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, divided into two different categories, named Type A managers and Type B managers.
Type B managers must be Luxembourg residents. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be
revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, provided that such majority includes at least one Type A manager and one Type B
manager.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year ends every 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

46020

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members;

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Fourth resolution

The meeting records and confirms the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and

approves the report by the board of directors of the Company relating to its assets.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to fix the Luxembourg address of the Company at L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon

1

er

, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The meeting acknowledged the following persons as managers of the Company: 

<i>Type A managers:

- FIRSL RESOURCES LIMITED, a company residing in Dublin, Republic of Ireland;

<i>Type B managers:

- Mr Jürgen Fischer, Director, residing at Luxembourg;
- Mr Ricardo Sanchez, Director, residing at Luxembourg.

<i>Subscriptions

The meeting notes that all the shares of the Company are owned by FIRSL RESOURCES LIMITED, a company incor-

porated under the laws of the Republic of Ireland with registered number 371709, whose registered office is at Dublin,
Republic of Ireland.

<i>Expenses

Costs and expenses due to the present changes and supported by the Company are valued at approximately three

thousand Euro.

For the purpose of registration, it is stated that this transfer of the place of effective management of the company to

Luxembourg is exempt from contribution duty (droit d’apport) according to article 3, paragraph 2 of the law of 29th
December 1971 «concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales
et portant revision de certaines dispositions legislatives régissant la perception des droits d’enregistrement» as amend-
ed. 

Whereupon the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de FITZWILLIAM INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES LIMI-

TED (la «Société»), une société de droit irlandais, ayant son siège social à Dublin, République d’Irlande, valablement en-
registrée au Register of Companies of Ireland sous le numéro 315308.

L’assemblée est présidée par Monsieur Ricardo Sanchez, administrateur de sociétés à L-2017 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste

à L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. La présente assemblée extraordinaire a été dûment convoquée.
Le seul associé, FIRSL RESOURCES LIMITED, société irlandaise établie à Dublin, République d’Irlande, déclare ayant

eu pleine connaissance préalable à l’assemblée de l’ordre du jour de l’assemblée et renonce dans la mesure nécessaire
aux périodes d’envoi des convocations.

II. L’associé est ici représenté par Monsieur Ricardo Sanchez, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.

46021

La procuration de l’associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les personnes prémentionnées res-

tera également annexée au présent acte.

III. Toutes les 120.000 (cent vingt mille) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale de

sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV. Les documents suivants ont été soumis à l’assemblée:
a) Une copie certifiée conforme des statuts actuels de FITZWILLIAM INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES LI-

MITED;

b) Une copie certifiée conforme du certificat de constitution de la Société;
c) Un bilan récent de la Société.
Les documents prémentionnés après avoir été paraphés ne varietur par les personnes désignées ci-dessus et le no-

taire instrumentant resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

V. L’ordre du jour de la société est le suivant:

<i>Ordre du jour:

(1) De prendre acte du transfert du principal établissement et du centre des intérêts principaux de la Société de Du-

blin (Irlande), à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(2) D’approuver et de confirmer la forme luxembourgeoise de la Société comme celle de la société à responsabilité

limitée.

(3) D’adopter de nouveaux statuts.
(4) De confirmer la description et la consistance des avoirs de la Société et d’approuver le rapport du conseil de

gérance de la Société se prononçant sur les avoirs de la Société.

(5) De fixer l’adresse de la Société à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

(6) De confirmer les personnes suivantes comme gérants de la Société:

<i>Gérant de type A: 

- FIRSL RESOURCES LIMITED, une société établie à Dublin, République d’Irlande;

<i>Gérants de type B: 

- Monsieur Jürgen Fischer, administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Ricardo Sanchez, administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg.
VI. Ce transfert du principal établissement vers un autre pays, sans liquidation préalable de la Société, est autorisé et

accepté par le droit anglais.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve et confirme dans la mesure où cela est nécessaire la décision de transférer le principal établis-

sement et le centre des intérêts principaux de la Société de Dublin, Irlande, vers la commune de Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide d’adopter la forme luxembourgeoise d’une société à responsabilité limitée.
Cette résolution n’apporte aucune modification au «Memorandum of Association» ni aux «Articles of Association»

tels qu’ils sont enregistrés auprès des autorités irlandaises.

<i>Troisième résolution

Pour des besoins légaux luxembourgeois et le bon fonctionnement de l’établissement à Luxembourg, l’assemblée dé-

cide de modifier et de reformuler les statuts de la Société qui prennent dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut mener toute activité industrielle et/ou commerciale, en particulier (mais sans l’y limiter) la

prestation de services professionnels à des sociétés, y compris des services de consultance, des fonctions de sous-
traitance, l’introduction d’affaires ou la mise à disposition d’employés qualifiés pouvant travailler sous la supervision des
ses clients. En général, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de supervision et réaliser toute opération de na-
ture à favoriser l’accomplissement et le développement de son objet.

Elle peut réaliser son objet soit directement soit indirectement, en agissant directement ou par l’intermédiaire

d’agents, en son nom propre ou pour compte de tiers, seul ou en coopération avec d’autres et peut mener à bien toute
opération pouvant promouvoir son objet social ou l’objet de sociétés ou de partenariats dans lesquels elle détient des
intérêts.

La Société peut participer à l’organisation et au développement de toute société industrielle ou de commerce et peut

octroyer son assistance à ces sociétés sous la forme de prêts, avances, garanties ou d’autres manières.

La Société a également pour objet l’acquisition, la gestion, le développement par location ou de toute autre manière

et, si possible, la vente de biens immobiliers de toute nature, au Grand-Duché de Luxembourg et ailleurs.

La Société peut mener à bien toutes transactions relatives aux actifs mobiliers ou aux biens immeubles ou ceux de

nature financière, industrielle, commerciale ou civile, liés directement ou non à son objet.

La Société peut opérer toutes transactions touchant directement ou non l’acquisition de participations dans toutes

entreprises ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces intérêts.

46022

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour l’établissement, la gestion, le développement et la disposition

d’un portefeuille compose de titres, brevets et licences de toutes origines, et participer à la création, le développement
et le contrôle de toute entreprise, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière de tous titres, brevets et licences, et
les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement, les développer, et octroyer à d’autres sociétés ou en-
treprises tout soutien, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, toutesd transaction

portant sur des meubles ou des immeubles que la société estimera utile à l’accomplissement de son objet, sans vouloir
toutefois bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: FITZWILLIAM INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES LIMITED, S.à r.l.

Art. 5. Le siège statutaire est établi à Dublin, République d’Irlande.
La Société a son principal établissement et le centre de ses intérêts principaux à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 120.000,- (cent vingt mille euros) représenté par 100.000 (cent mille) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 1,20 (un euro et vingt centimes) chacune, toutes souscrites et entièrement libé-
rées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, Le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance, divisé en deux catégories: gérants de Type A et gérants de

Type B. Les gérants de type B doivent nécessairement être résidants luxembourgeois.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants dont obligatoirement celle d’un gérant de Type A. 
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s’il en est) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, pourvu que

cette majorité comprenne au moins la voix d’un Gérant de Type A et celle d’un Gérant de Type B.

Art. 13. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale se termine chaque 31 décembre.

46023

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes;

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée note et confirme la description et la consistance des avoirs de la Société et approuve le rapport du con-

seil de gérance de la Société se prononçant sur les avoirs de la Société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse luxembourgeoise de la Société à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon

1

er

, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’assemblée confirme les personnes suivantes comme gérants de la Société.

<i>Gérant de type A: 

- FIRSL RESOURCES LIMITED, une société établie à Dublin, République d’Irlande;

<i>Gérants de type B: 

- Monsieur Jürgen Fischer, administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Ricardo Sanchez, administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg.

<i>Souscription

L’assemblée note que toutes les parts de la Société sont détenues par un seul associé: FIRSL RESOURCES LIMITED,

société irlandaise établie à Dublin, République d’Irlande, inscrite sous le numéro 371709.

<i>Dépenses

Les frais et dépenses payables en raison des présentes et incombant à la Société sont évaluées à trois mille euros.
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le transfert du principal établissement de la société à Luxem-

bourg est exempt du droit d’apport conformément à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1971, concernant l’im-
pôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines
disposition législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, telle qu’elle a été modifiée.

Fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur noms, prénoms usuels états et demeures, les com-

parants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute. Le notaire soussigné, qui comprend et parle
anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en an-
glais, suivis d’une traduction française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: R. Sanchez, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 43, case 4. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020741/211/391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

J. Elvinger.

46024

RHOCARTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.136. 

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2005

1. La liquidation de la société RHOCARTS INVESTMENTS S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018660/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

RAMILL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.224. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 décembre 2005

- En conformité avec l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et avec l’article 3 des statuts de la société,

le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 2.624 actions au prix net de EUR 4.683.603,84 (quatre
millions six cent quatre-vingt-trois mille six cent trois euros et quatre-vingt-quatre cents) soit EUR 1.784,91 (mille sept
cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-onze cents) par action.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018663//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

PIKLIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Luxembourg B 102.014. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2005, réf. DSO-BL00560, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916290//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2006.

CARDIGAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 90.945. 

Société constituée le 24 décembre 2002 par-devant Maître J. Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au 

Mémorial C n

°

 223 du 5 mars 2003

Messieurs Angelo de Bernardi, Federico Innocenti et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, administrateurs, ainsi que

Monsieur Alexis de Bernardi, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société CARDIGAN S.A., établi au 17, rue de Beaumont, L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 17

février 2006.

Luxembourg, le 17 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04767. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018707//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur 
Signatures

Certifié sincère et conforme
RAMILL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Wincrange, le 15 février 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

46025

CAFE PASSAGE BEIM JIMMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, 5, route de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 98.431. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03247, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916432//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

CAFE PASSAGE BEIM JIMMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, 5, route de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 98.431. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03246, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916434//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

CAFE PASSAGE BEIM JIMMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, 5, route de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 98.431. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03244, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916436//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

PLACOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 109.042. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2005, réf. DSO-BL00562, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916291//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2006.

GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 101.086. 

<i>Extrait de la résolution prise par voie circulaire par le conseil de gérance

Il résulte de la décision prise par le conseil de gérance que le siège social de la Société est transféré au:
18-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018686/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Insenborn, le 15 février 2006.

Signature.

Insenborn, le 15 février 2006.

Signature.

Insenborn, le 15 février 2006.

Signature.

Le 15 février 2006.

Signature.

<i>Pour GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l.
MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
Signature

46026

A &amp; G EUROPE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8826 Perlé, 3, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 106.816. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 16 février 2006, réf. DSO-BN00114, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916870//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

A &amp; G EUROPE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8826 Perlé, 3, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 106.816. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 16 février 2006, réf. DSO-BN00115, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916869//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

A &amp; G EUROPE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8826 Perlé, 3, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 106.816. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 16 février 2006, réf. DSO-BN00116, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916868//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

A &amp; G EUROPE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8826 Perlé, 3, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 106.816. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 16 février 2006, réf. DSO-BN00117, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916867//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

A &amp; G EUROPE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8826 Perlé, 3, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 106.816. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 16 février 2006, réf. DSO-BN00118, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916865//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

P.R. COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2723 Howald, 2, rue E. Welter.

R. C. Luxembourg B 50.825. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 février 2006, réf. DSO-BN00183, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(917398//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 février 2006.

Diekirch, le 16 février 2006.

Signature.

Diekirch, le 16 février 2006.

Signature.

Diekirch, le 16 février 2006.

Signature.

Diekirch, le 16 février 2006.

Signature.

Diekirch, le 16 février 2006.

Signature.

Diekirch, le 20 février 2006.

Signature.

46027

JEAN GILSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9167 Mertzig, 23, Wechen.

R. C. Luxembourg B 100.553. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 10 février 2006, réf. DSO-BN00067, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916518/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

LR INDUSTRIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 96.197. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 février 2006, réf. DSO-BN00043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916918/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2006.

LR INDUSTRIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 96.197. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 février 2006, réf. DSO-BN00044, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(916928/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 février 2006.

DOGI’ INVESTMENT STRATEGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 114.591. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-sept février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Palmira Mirella Bottalini, conseil économique, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 11,

rue Beaumont;

2.- Monsieur Carlo Pecchinotti, courtier en assurances, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 11,

rue Beaumont;

3.- Monsieur Marco Pecchinotti, courtier en assurances, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 11,

rue Beaumont.

Les trois comparants sont ici représentés par Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant professionnel-

lement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DOGI’ INVESTMENT STRATEGY S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le courtage en assurances par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.
Elle pourra aussi vendre ou placer, auprès d’une clientèle privée ou institutionnelle, des polices d’assurances conte-

nant des parts de fonds communs de placement ou tout autre instrument d’investissement provenant d’un émetteur

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Wiltz, le 15 février 2006.

Signature.

Wiltz, le 15 février 2006.

Signature.

46028

autorisé, et prester tous services de conseil, d’assistance, de collaboration et d’administration généralement quelcon-
ques pour compte de tiers relativement à ces instruments.

Elle pourra encore prester tout service de conseil en stratégie industrielle, mobilière, immobilière, patrimoniale et

financière en structuration de dettes et créances en reprise ou alliance de société et présenter des relations d’affaires
à des établissements financières et autres.

Son objet inclut la participation sociétaire, l’acquisition et la vente, la location et l’administration de tous biens mobi-

liers et immobiliers au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, l’activité de marketing et de communication, l’or-
ganisation de réseaux commerciaux pour compte de tiers, l’organisation de cours de formation, de séminaires, de
conférences, de présentations et d’activités de communication en général, la mise en place de services informatiques et
de communication destinés à sa clientèle ou à des tiers.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée pour toutes les activités autres que le courtage d’assurances, par la signature

individuelle de l’administrateur A. En matière de courtage d’assurances et la gestion journalière s’y rattachant, vis-à-vis
des tiers, la société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur A avec un administrateur B.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de mai à neuf heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

46029

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:

<i>Administrateur de catégorie A:

Madame Palmira Mirella Bottalini, conseil économique, née à Naples (Italie), le 17 octobre 1942, demeurant profes-

sionnellement à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont;

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Carlo Pecchinotti, courtier en assurances, né à Rome (Italie), le 16 avril 1972, demeurant professionnel-

lement à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont;

- Monsieur Marco Pecchinotti, courtier en assurances, né à Rome (Italie), le 31 janvier 1974, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2009.

<i>Cinquième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Déclaration

Les comparants déclarent être parfaitement au courant de ce que la société ne pourra exercer ses diverses activités

prévues dans l’objet social qu’après avoir obtenu les agréments nécessaires à cet effet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Arno’, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 février 2006, vol. 535, fol. 84, case 1. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022096/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

1.- Madame Palmira Mirella Bottalini, préqualifiée, trois cent dix-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
2.- Monsieur Carlo Pecchinotti, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Marco Pecchinotti, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Junglinster, le 7 mars 2006.

J. Seckler.

46030

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.715. 

Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que la société NEFFA INTERNATIONAL S.A. ayant été liquidée en date du 22

décembre 2005, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 3 janvier 2001 entre la société NEFFA INTERNA-
TIONAL S.A. et nous-mêmes est devenu sans objet.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos

salutations très distinguées.

Le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018676//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

W.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5730 Aspelt, 1, Op der Gare.

R. C. Luxembourg B 114.470. 

STATUTS

L’an deux mille six, le deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Antoniella Chiarello, commerçante, demeurant à L-2112 Howald, 2B, rue du 9 Mai 1944, née à Luxembourg,

le 10 mars 1970,

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
En outre, la société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: W.A., S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Aspelt.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libé-
rées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Sous-Directeur / <i>Directeur

46031

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

46032

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, Madame Antoniella Chiarello, prénommée, a déclaré que toutes les parts sociales ont été en-

tièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de 12.400,- EUR est à la disposition de la Société,
ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (1.400,-
EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Madame Antoniella Chiarello, commerçante, demeurant à L-2112 Howald, 2B, rue du 9 mai 1944, née à Luxem-

bourg, le 10 mars 1970,

- Monsieur Michèle Frino, restaurateur, demeurant à B-1300 Wavre, 3/1, Chaussée de Bruxelles.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-5730 Aspelt, 1, Op der Gare.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Chiarello, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 25, case 6. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(020628/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.

ANKER TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 82.649. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 janvier 2006 que:
1) Le siège social de la société est transféré au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
2) Le mandat des administrateurs, Monsieur Bruno Beernaerts, résidant professionnellement au 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, Monsieur Hugues Baudenet D’Annoux et Madame Cristina Baudenet D’Annoux, résidant tous
deux au 4, avenue de Krieg, CH-1208 Genève, est renouvelé pour une durée d’un an;

3) Monsieur Olivier Dorier, résidant professionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, est réélu com-

missaire pour une durée d’un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018802/727/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Luxembourg, le 14 février 2006.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

NN Invest Holding S.A.

wwholding, S.à r.l.

Travel Retail, S.à r.l.

Roncadin Participations SCA

Marul Holding S.A.

Marul Holding S.A.

Marul Holding S.A.

Marul Holding S.A.

Marul Holding S.A.

Marul Holding S.A.

IST International Holding, S.à r.l.

Dalmatian Fund

Also Enervit International S.A.

Yapi Invest S.A.

Viatris Holding (Luxembourg)

I.C.C.I. Inc. S.A., Inter Continental and Capital Investments Incorporation

Planalto S.A.

Planalto S.A.

Viria Holding S.A.

Wallenstein Finanz S.A. Holding

Etablissements Schultz, S.à r.l.

Express Services S.A.

Benelux Import Management S.A.

Commerzbank International S.A.

Mansion Investments S.A.

Vafage S.A.

Parati Investments, S.à r.l.

HR Real Estate S.A.

Intabex Worldwide

S.L. Investments S.A.

European Retail S.A.

Properties Management, S.à r.l.

Properties Management, S.à r.l.

Bateman Luxembourg S.A.

Nouvelle Espaces Verts Luxembourgeois, S.à r.l.

Eurange, S.à r.l.

Gesab Benelux S.A.

Club Hiversport, Section Danse et Formation sur Glace, A.s.b.l

Kobelco Luxembourg S.A.

Looking For, S.à r.l.

Interjam Company S.A.

Parcolog, S.à r.l.

Blue Sky Financial S.A.

Apsida Corporation S.A.

Dibilux S.A.

Aran International S.A.

Euro Labo S.A.

Fitzwilliam International Resource Services Limited, S.à r.l.

Rhocarts Investments S.A.

Ramill International Holdings S.A.

Piklift S.A.

Cardigan S.A.

Café Passage Beim Jimmy, S.à r.l.

Café Passage Beim Jimmy, S.à r.l.

Café Passage Beim Jimmy, S.à r.l.

Placolux S.A.

Glacier Luxembourg Two, S.à r.l.

A&amp;G Europe Invest, S.à r.l.

A&amp;G Europe Invest, S.à r.l.

A&amp;G Europe Invest, S.à r.l.

A&amp;G Europe Invest, S.à r.l.

A&amp;G Europe Invest, S.à r.l.

P.R. Coiffure, S.à r.l.

Jean Gilson, S.à r.l.

LR Industrie Holding S.A.

LR Industrie Holding S.A.

Dogi’ Investment Strategy S.A.

Neffa International S.A.

W.A., S.à r.l.

Anker Telecommunications Services S.A.