This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
31153
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 650
30 mars 2006
S O M M A I R E
Aberdeen Investment Services S.A., Luxembourg .
31179
NET s IT e.lu, S.à r.l., Hovelange . . . . . . . . . . . . . .
31193
Arcadia, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31199
NET s IT e.lu, S.à r.l., Hovelange . . . . . . . . . . . . . .
31193
Avante Colombia, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
31180
Nordliicht, S.à r.l., Moestroff . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31173
Avenida Moda, S.à r.l., Ingeldorf. . . . . . . . . . . . . . . .
31200
Nordmazout S.A., Oberfeulen . . . . . . . . . . . . . . . .
31154
BLN, GmbH, Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31191
Nouveau Garage Agra-Nord, S.à r.l., Clervaux . . .
31190
BLN, GmbH, Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31191
Nouveau Garage Agra-Nord, S.à r.l., Clervaux . . .
31190
Brever M, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . .
31196
Nouvelle Société du Magasin Klein-Angelsberg
Capi, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31193
Ettelbruck, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . .
31200
Chantraine Commerciale, S.à r.l., Derenbach . . . .
31154
Op der Lay, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . .
31180
Clearway, S.à r.l., Eselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31200
P & W CNC Umformtechnik, S.à r.l., Grevenma-
Climmolux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31173
cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31195
Climmolux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31179
P & W CNC Umformtechnik, S.à r.l., Grevenma-
De Jonge, S.à r.l., Alscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31197
cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31196
DGG, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31199
(D’)Pettener Schlësserei, S.à r.l., Pettingen . . . . .
31154
Dometic Holding, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . .
31194
Protec MBV, S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . .
31197
Dometic, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31194
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüf-
Edens S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31197
tung, Haustechnik, Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31192
EMCK, S.à r.l., Eselborn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31191
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüf-
EMCK, S.à r.l., Eselborn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31191
tung, Haustechnik, Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31192
Euro Pro Services, S.à r.l., Warken . . . . . . . . . . . . .
31197
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüf-
Euroflam, S.à r.l., Wilwerdange . . . . . . . . . . . . . . . .
31193
tung, Haustechnik, Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31192
Garage Scheuren, S.à r.l., Kehmen. . . . . . . . . . . . . .
31173
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüf-
Hilger S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31172
tung, Haustechnik, Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31192
Hilger S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31172
Ramoge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31190
Hilger S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31172
Rentco S.A., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31171
Hobo AG, Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31194
Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l., Fischbach. . . . .
31180
Hopla, S.à r.l., Walsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31200
Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l., Fischbach. . . . .
31180
Hôtel Koener, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . .
31172
Roncadin Holdings SCA, Luxembourg . . . . . . . . . .
31154
Illuminare, GmbH, Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . .
31197
S-Team S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31193
ING PFCE Poland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
31188
Screen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31198
ING PFCE Poland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
31189
Taxi des Trois Frontières, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
31188
Indusol, S.à r.l., Michelau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31190
Taxi des Trois Frontières, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
31188
InterKoener S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31172
Telluride S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31194
LCA Luxembourg II, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . .
31172
Thewes, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31173
Lux Stahl AG, Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31196
Topsolar, S.à r.l., Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31190
Maurach A.G., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31195
Traditionell Bauen, S.à r.l., Platen . . . . . . . . . . . . .
31194
Maurach A.G., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31195
Zephyr Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
31192
Millesima 99, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
31191
31154
NORDMAZOUT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9180 Oberfeulen, 6, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.418.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 18 novembre 2005, réf. DSO-BK00132, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903879.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
D’PETTENER SCHLESSEREI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7463 Pettingen, 3, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 104.796.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le `18 novembre 2005, réf. DSO-BK00133, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903880.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
CHANTRAINE COMMERCIALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 58.
R. C. Luxembourg B 105.196.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 7 décembre 2005, réf. DSO-BL00068, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903881.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
RONCADIN HOLDINGS SCA, Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 113.113.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twentieth day of December.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, not yet recorded
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register,
duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London and Luxembourg on 14 December 2005.
2) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-
istered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London and Luxembourg on 14 December 2005.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain at-
tached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of association
of a société en commandite par actions, which they declare organised among themselves as follows:
Chapter I. Name, Registered office, Duration, Object
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in
the future, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of RONCADIN HOLDINGS
S.C.A. (hereinafter the «Company»).
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of
the Manager. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by resolution of the Manager.
P. Binsfeld
<i>L’administrateuri>
T. Prickaerts
<i>Le géranti>
Diekirch, le 13 décembre 2005.
Signature.
31155
In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have occurred or are immi-
nent, which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Com-
pany which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited term.
Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxem-
bourg and foreign companies, and any other form of investment, including the acquisition by purchase, subscription or
in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of any such participations and the adminis-
tration, voting and control of any such participations.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist any entity in which it holds a direct or indirect
participation, or which forms part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 5. Shareholders liability. The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out
of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the Manager), being
the holder(s) of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other
than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contri-
butions to the Company.
Chapter II. Share capital, Shares
Art. 6. Corporate capital
6.1. Subscribed capital
The Company has a subscribed capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by fully paid up shares,
consisting of:
(a) twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A1 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A1 Ordinary Shares»);
All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.
6.2. The Class A1 Ordinary Shares
(a) All Class A1 Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A1 Ordinary Shares shall share ratably in
the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an ag-
gregate basis to such Class A1 Ordinary Shares. All Class A1 Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the
Company may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the
shareholders held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class A1 Ordinary Shares
will be reduced accordingly.
(b) Voting Rights. Each Class A1 Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
shareholders have the right to vote.
6.3. The Class A2 Ordinary Shares
(a) All Class A2 Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A2 Ordinary Shares shall share ratably in
the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an ag-
gregate basis to such Class A2 Ordinary Shares. All Class A2 Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the
Company may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the
shareholders held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class A2 Ordinary Shares
will be reduced accordingly
(b) Voting Rights. Each Class A2 Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
shareholders have the right to vote.
6.4. The Class B Ordinary Shares.
(a) All Class B Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class B Ordinary Shares shall share ratably in the
payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate
basis to such Class B Ordinary Shares. All Class B Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company
may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders
held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class B Ordinary Shares will be reduced
accordingly
(b) Voting Rights. Each Class B Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
shareholders have the right to vote.
6.5. Redemption; Convertibility
(a) Redeemable Shares. The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 498
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to receive
dividends and have the same voting rights as non-redeemable Ordinary Shares, if any. Subscribed and fully paid-in re-
deemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by each holder upon
request of the Company (i) in accordance with the provisions of article 498 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended, and (ii) as may be provided for in a written agreement which may be entered into among the
Company and the relevant shareholders of the Company. The redemption of the redeemable shares can only be made
31156
by using sums available for distribution in accordance with article 721 of the law of 10 August 1915 on commercial com-
panies (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company
as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed shares bear
no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed shares may be cancelled
upon request of the Manager by a positive vote of the general meeting of shareholders held in accordance with.
(b) Special Reserve. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of
all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the
event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed
share capital by capitalization of reserves.
(c) Redemption Price. Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be
entered into among the Company and the relevant shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall
be determined by the Manager, or by such person appointed by the Manager, and shall be approved by holders of a
majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the shareholders convened in accordance with. In the ab-
sence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the Manager that is
approved by a majority of the shareholders of the Company shall be conclusive and binding on the Company and on its
present, past and future shareholders.
(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among
the Company and the relevant Shareholders at least 20 days prior to the redemption date, written notice shall be sent
by registered mail (and if the Manager so elects by internationally recognized overnight courier) to each registered
shareholder of the Ordinary Shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of
the Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the
redemption price, the procedures necessary to submit the Ordinary Shares to the Company for redemption and the
projected date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Ordinary Shares and the valuation
of the redemption price, as provided for in Articles and. Each holder of Ordinary Shares to be redeemed shall surrender
the certificate or certificates, if any, issued in relation to such Ordinary Shares to the Company. The redemption price
of such Ordinary Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the
owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.
(e) Convertibility. The Class A1 Ordinary Shares, Class A2 Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares shall not
be convertible into any other class of shares.
6.6. Distributions to shareholders
If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by
the Manager (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive dis-
tributions, when, as, and if approved and declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Manager out
of funds legally available therefor, in accordance with applicable law, in the following manner and priority:
(a) First, the Class A Shareholders shall be entitled to receive all distributions made by the Company with respect to
its Ordinary Shares, and such distributions shall be made pro rata among the Class A Shareholders based on the number
of Class A Interests held by each Class A Shareholder until such time as the Class A Shareholders and the holders of
Series 1 CPECs, collectively, shall have received aggregate distributions equal to the Tranche I Amount; and
(b) Second, the Class A Shareholders and the Class B Shareholders shall be entitled to receive all distributions made
by the Company with respect to its Ordinary Shares on a pari passu basis, and such distributions shall be declared and
allocated pro rata regardless of a holder’s relevant Percentage Vested among the Class A Shareholders and Class B
Shareholders based on the Class A Interests and Class B Interests held by each such holder (the «Tranche II Distribu-
tions»); provided, that all declared and allocated distributions pursuant to this Article shall be paid (i) fully to each Class
A Shareholder, and (ii) to each Class B Shareholder in an amount equal to the Tranche II Distributions declared and
allocated to such holder multiplied by the holder’s relevant Percentage Vested applicable on such payment date. Any
amount of such declared and allocated distributions not paid to such Class B Shareholder shall be recorded as a liability
of the Company payable to such holder, and cash in respect of such liability shall be segregated into a separate account
owed to the same holder otherwise entitled to receive such distribution (each, a «Tranche II Unvested Distribution
Amount»). Each Class B Shareholder’s Tranche II Unvested Distribution Amount shall be paid ratably, quarterly on 31
March, 30 June, 30 September, and 31 December or, in each case, the next Business Day throughout the period through
which such holder’s Class B Interests would have become 100% Percentage Vested (and the Company’s associated lia-
bility shall be reduced accordingly).
6.7. Liquidation rights
In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Com-
pany will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article above. Neither a merger nor consolidation
of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or entities
into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or
any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article, unless such
merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of complete
liquidation, dissolution or winding up of the Company.
6.8. Authorized capital
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at two hundred million
Euro (EUR 200,000,000) represented by:
(a) one hundred fifty-three million one hundred seventy-three thousand four hundred and eight (153,173,408) Class
A1 Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
31157
(b) one million four hundred twenty thousand four hundred fourty-eight (1,420,448) Class A2 Ordinary Shares having
a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share; and
(c) five million four hundred six thousand one hundred forty-four (5,406,144) Class B Ordinary Shares having a nom-
inal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.
During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-
thorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is
authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the
new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be sub-
scribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine
to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.
Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager
is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The
Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized per-
son, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such in-
creased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the
Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.
6.9. Amendment of the subscribed and of the authorized capital
The subscribed and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.
Art. 7. Shares, Shareholders register and share transfers
7.1. Shareholders register
The shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders’ register which may be examined by
any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each sharehold-
er and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the
transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address
and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates of
these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.
7.2. Share Ownership
Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register. The Company rec-
ognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is dis-
puted, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s)
towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such
shares until such representative is appointed, at which time any suspended distributions with respect to such shares shall
be paid to such representative.
7.3. Share transfer.
(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer registered into the
shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers
of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the
Luxembourg Civil code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders’ register any transfer
referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.
(b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth anniversary of the Date of Issuance, or during such shorter period as
may be consistent with applicable law, the Secondary Investors may not validly transfer the shares issued by the Com-
pany without the prior written approval of the Manager or unless otherwise permitted pursuant to this Article.
(c) Permitted Transfers. Any»
Secondary Investor may Transfer any and all Securities held by any such Persons (where such Person is a natural per-
son) to each such Person’s spouse and/or descendants (whether natural or adopted) or to any trust solely for the benefit
of such Person and/or such Person’s spouse and/or descendants (a «Permitted Transferee»), pursuant to the applicable
laws of descent and distribution or otherwise (a «Permitted Transfer»).
(d) Drag Along Sale»
(i) Procedures. In the event of a contemplated Transfer by the Primary Investors of the Company to any Third Party
Purchaser, the Primary Investors or the Manager may, prior to but in contemplation of such Transfer, elect to deem
such Transfer a «Drag-Along Sale», and in such case any Secondary Investors shall take all actions reasonably requested
by the Primary Investors and/or the Manager in connection with such Drag-Along Sale as set forth in this Article. In the
event of a Drag-Along Sale, the Manager may compel any Secondary Investors to participate on a pro rata basis (deter-
mined on an As-Converted basis) in such Drag-Along Sale. The Manager shall provide notice of a Drag-Along Sale (the
«Drag-Along Sale Notice») to such Secondary Investors. Such Drag-Along Sale Notice shall disclose in reasonable detail
the proposed type and number (or percentage) of Ordinary Shares, CPECs and PECs held by the Secondary Investors
to be subject to the Drag-Along Sale (the «Drag-Along Securities»), the proposed price, the other proposed terms and
conditions of the proposed Drag-Along Sale, and the identity of the prospective purchaser, if known.
(ii) Cooperation. With respect to any Drag-Along Sale, any Secondary Investor shall effect such transactions as are
necessary or advisable, as determined by the Manager in the light of any business, taxation or marketability concerns
and agrees to use his or her best efforts to effect such Drag-Along Sale as expeditiously as practicable, including deliv-
ering all documents and entering into any instrument, undertaking or obligation necessary or reasonably requested by
31158
the Manager or the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale necessary or reasonably requested in
connection with such Drag-Along Sale (as specified in the applicable Drag-Along Sale Notice) and hereby consents to
the taking of any step by the Company and the Manager which is necessary or desirable as determined by the Manager
to effect any legal formalities in connection with the Transfer of the Securities subject to such Drag-Along Sale. In addi-
tion, the Secondary Investors shall (i) pay their pro rata share (based on the aggregate proceeds) of the reasonable ex-
penses (if any) incurred by the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale and (ii) join severally on a
pro rata basis (based on the inverse amount each Person concerned would be entitled to receive on a complete liqui-
dation of the Company) in any indemnification or other obligations that are specified in the Drag-Along Sale Notice.
(iii) Consideration. In the event of a Drag-Along Sale, each Secondary Investor shall Transfer such Securities held by
that Secondary Investor as are provided in the Drag-Along Sale Notice. The form and value of the consideration offered
in respect of any security in a Drag-Along Sale shall be the same for all Securities of the same type or class subject to
such Drag-Along Sale as set forth in the Drag-Along Sale Notice.
(e) Transfer. For the purposes of these Articles, «Transfer» or «transfer» shall mean any transaction, whether vol-
untary or involuntary or by operation of law, resulting in a transfer of the ownership, «nuepropriété», «usufruit» or any
rights of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend rights) to any person other than the
Company itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means whatsoever (including, without limitation,
gifts, partial contributions of assets («apports partiels d’actifs»), mergers, splits («scissions»), sales, assignments, pledges
or any other form of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial interest in the shares, as well as any
combination of such methods of transfer of ownership. The shares are and shall remain in registered form.
(f) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any pro-
vision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor record
such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any
purpose.
Chapter III. Management
Art. 8. Manager. The Company shall be managed by RONCADIN HOLDINGS GP S.A., a société anonyme organ-
ized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole Manager (associé commandité) and man-
ager of the Company (referred to herein as the «Manager»). The other shareholders shall neither participate in nor
interfere with the management of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation
preventing the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and
liquidated, provided the Supervisory Board, as provided for in hereof, appoints an administrator, who need not be a
shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such
administrator shall convene within 15 days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint
a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles. Fail-
ing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.
Art. 9. Powers of the Manager
9.1. General powers
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Com-
pany’s stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of sharehold-
ers or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.
9.2. Enforcement of Rights.
The Manager shall act, in its reasonable good faith judgment, in the best interests of the Company and its sharehold-
ers, shall use reasonable efforts to enforce any rights granted to the Company under the articles of association of any
company in which it holds participations or under any securityholders agreement or other agreement which may be
entered into among the Company and any of its securityholders from time to time.
9.3. Termination of the Manager by the holders of Ordinary Shares
In the event that, in the reasonable opinion of the holders of Ordinary Shares, the Manager shall have failed to fulfill
its obligations to the Company and the shareholders under Article, then the shareholders may, acting pursuant to an
affirmative vote taken at a duly convened meeting of the shareholders in accordance with the quorum and majority con-
ditions required for the amendment of these Articles, revoke the appointment of the Manager and replace the Manager
with a new manager whose appointment shall be approved by an affirmative vote taken under the same quorum and
majority requirements as above mentioned. The Manager may not participate in any vote concerning the revocation of
its appointment as manager of the Company.
Art. 10. Third parties. The Company is validly bound visàvis third parties by the signature of the Manager, or by
the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion.
Chapter IV. Supervision
Art. 11. Supervisory Board
11.1. Supervisory Board Members
The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a
Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members, who need not be shareholders.
For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as
provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The
Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize
any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these Articles, exceed the powers
of the Manager. The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders
31159
for a period of one (1) year and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory
Board are reeligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by
the general meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.
11.2. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board
must be convened if any of its members so requests.
11.3. Notices
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior
to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall
be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda there-
of. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of commu-
nication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.
11.4. Chairman
The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory
Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.
11.5. Resolutions
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the members are present or repre-
sented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
11.6. Minutes
Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Cop-
ies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chair-
man of the meeting or any two members.
11.7. Written resolutions Conference Call.
Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as
resolutions voted at a meeting of the Supervisory Board; each member shall approve such resolution in writing as evi-
denced by his, her or its signature, a copy thereof being sufficient. All such documents shall together form the document
which proves that such resolution has been taken. Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting
of the Supervisory Board by conferencecall or by other similar means of communication allowing all the Persons taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting.
11.8. Liability
No member of the Supervisory Board assumes, by reason of his membership thereof, any personal liability in relation
to commitments regularly made by the members of the Supervisory Board in the name of the Company. They are au-
thorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
11.9. Indemnity
(a) Indemnity. The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory
Board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the
Supervisory Board of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to mat-
ters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of
duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
(b) Expenses. The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection
with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding
undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not
entitled to indemnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction,
or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did
not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash
payment to such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an ob-
ligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably
require.
11.10. Conflicts
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise
engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from consid-
ering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
31160
Chapter V. General meeting of the shareholders
Art. 12. Shareholder meetings
(a) Powers. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest
powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.
The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory
Board.
(b) Location, Time. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on 31 March. If such day
is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day
in Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective
convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent
by the Manager by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Com-
pany at the address indicated in the share register.
(c) Voting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.
The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Company,
unless otherwise provided herein. The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by sharehold-
ers for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meet-
ing of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice or publication.
Chapter VI. Accounting year balance sheet
Art. 13. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on
31 December of the same year.
Art. 14. Reserve. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve
required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached
ten percent (10%) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the
Manager, shall determine how the remainder of the annual net profit will be disposed of. Interim dividends may be dis-
tributed by observing the terms and conditions provided for by law.
Chapter VII. Liquidation, Amendment of the articles
Art. 15. Amendment. These Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of
at least two-thirds of the votes of the shareholders of the Company at a general meeting of the shareholders at which
at least 50% of the capital of the Company is represented in person or by proxy. In the event that the foregoing quorum
requirement is not satisfied, these Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at
least two-thirds of the votes of the shareholders of the Company at a second general meeting of the shareholders with
respect to which no quorum requirement shall apply.
Art. 16. Dissolution. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities)
shall carry out the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution
and which shall determine their powers and compensation.
Chapter VIII. Final dispositions
Art. 17. Miscellaneous. For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg
Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 18. Definitions. For the purpose of these Articles:
«Affiliate» or «Affiliates» means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls,
is Controlled by, or is under common Control with such first Person or any other Person who holds directly or indi-
rectly more than a fifty percent (50%) economic interest in such first Person or in whom such first Person holds directly
or indirectly or has a contractual right to acquire more than a fifty percent (50%) economic interest.
«Articles» means the articles of association of the Company as amended from time to time.
«As-Converted Basis» with respect to the outstanding securities of the Company, shall mean as if all such securities
convertible into or exercisable or exchangeable for Ordinary Shares outstanding were converted, exercised or ex-
changed into or for Ordinary Shares pursuant to the terms of such convertible, exercisable or exchangeable securities
(i.e., the number of Ordinary Shares outstanding, plus the additional number of Ordinary Shares that would be outstand-
ing assuming such conversion, exercise or exchange).
«Class A Interests» means, as of any date of determination (i) with respect to any holder of Class A1 Ordinary Shares
the aggregate number of Class A1 Ordinary Shares held by such holder; and (ii) with respect to any holder of Class A2
Ordinary Shares the aggregate number of Class A2 Ordinary Shares held by such holder, multiplied by (B) forty.
«Class A Shareholders» means the holders of Class A1 Ordinary Shares of the Company and the holders of Class A2
Ordinary Shares of the Company.
«Class A1 Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Class A2 Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Class B Interests» means, as of any date of determination with respect to any holder of Class B Ordinary Shares, (i)
the aggregate number of Class B Ordinary Shares held by such holder, multiplied by (ii) forty.
«Class B Shareholders» means the holders of Class B Ordinary Shares of the Company.
31161
«Class B Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Company» has the meaning provided in.
«Control» means in respect of a Person, the power to manage or govern such Person, or to appoint the managing
and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through
the ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership shall be deemed to
be Controlled by its Manager).
«CPECs» means the Series 1 CPECs and Series 2 CPECs which may be issued by the Company from time to time
and, if applicable, any additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and issued by the
Company from time to time.
«Drag-Along Sale» shall have the meaning set forth in Article.
«Drag-Along Sale Notice» shall have the meaning set forth in Article.
«Drag-Along Securities» shall have the meaning set forth in Article.
«Manager» has the meaning provided in.
«Group» means the Company and its Subsidiaries and Group Company means any of them.
«Issuance» shall have the meaning set forth in Article 6.13.
«Managed Entity» means any entity Controlled by the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company or
in which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company has management or operating responsibilities or
of which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company is a partner or shareholder.
«Ordinary Shares» means the Class A1 Ordinary Shares, Class A2 Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares.
«PECs» means the Series 1 PECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any ad-
ditional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to time.
«Percentage Vested» means, as of any date of determination and with respect to any holder of Class B Ordinary
Shares which are subject to vesting, the «Vesting Percentage» applicable to such Person on such date of determination
pursuant to any written agreement between the Company and such Person.
«Percentage Unvested» means, as of any date of determination and with respect to any holder of Class B Ordinary
Shares which are subject to vesting, one minus the applicable Percentage Vested.
«Permitted Transfer» shall have the meaning set forth in Article hereto.
«Permitted Transferee» shall have the meaning set forth in Article hereto.
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock
company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.
«Primary Investors» means OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC or any Affiliate thereof which holds Ordinary
Shares or Securities of the Company or the Manager.
«Secondary Investors» means all holders of Ordinary Shares or Securities of the Company other than the Primary
Investors.
«Securities» means any duly authorized securities of the Company including, but not limited to, PECs and CPECs.
«Series 1 CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Series 2 CPECs» means the Series 2 convertible preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Series 1 PECs» means the Series 1 preferred equity certificates issued by the Company, if any.
«Subsidiary» or «Subsidiaries» means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of
the total voting power of shares or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any contingency)
to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly or indi-
rectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof. For purposes hereof, a Person
or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership, association
or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability company, partnership,
association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.
«Supervisory Board» has the meaning provided in Article.
«Tranche I Amount» means an amount of aggregate distributions made by the Company pursuant to Article equal to
the sum of (i) the product of (A) ten Euro (EUR 10), multiplied by (B) the maximum number of Class A1 Ordinary Shares
and Series 1 CPECs issued and outstanding at any time during the life of the Company, plus (ii) the product of (C) four
hundred Euro (EUR 400), multiplied by (D) the maximum number of Class A2 Ordinary Shares issued and outstanding
at any time during the life of the Company; provided, that in the event any Series 1 CPECs are converted into Class A1
Ordinary Shares at any time, such Series 1 CPECs and Class A1 Ordinary Shares shall not be counted twice for purposes
of the foregoing determination of the Tranche I Amount.
«Tranche II Distributions» has the meaning provided in Article.
«Tranche II Unvested Distribution Amount» has the meaning provided in Article.
«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-
cember 2005.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., prenamed, paid thirty thousand nine hundred ninety-eight Euro and sev-
enty-five cents (EUR 30,998.75) in subscription for twenty-four thousand four hundred ninety-nine (24,799) shares;
31162
4) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., prenamed, paid one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) in subscription for
one (1) share;
Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31.000) paid for twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro and (EUR 31.000) is as of
now available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been ful-
filled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately four thousand seven hundred (4,700.00) Euro.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of managers is fixed at one and the number of members of the board of auditors at 3.
2. RONCADIN HOLDINGS GP S.A., prenamed, is appointed sole manager of the company with immediate effect.
The following persons are appointed members of the board of auditors of the company:
a) Jacques Peffer, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
b) Jean-Jacques Soisson, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
c) Christophe Deschamps, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg.
4. The address of the company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
5. The term of office of the members of the board of auditors shall end at the general meeting called to approve the
accounts of the accounting year 2006 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,
the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendundfünf, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., eine Gesellschaft Luxemburg Rechts mit Geschäftsadresse in 5, rue Guil-
laume Kroll, L-1882 Luxemburg,
vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in London und Luxemburg, am 14. Dezember 2005.
2) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., eine Gesellschaft Luxemburg Rechts mit Geschäftsadresse in L-1882 Luxem-
bourg, 5, rue Guillaume Kroll,
vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in London und Luxemburg, am 14. Dezember 2005.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die sie
hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I. Name, Sitz, Dauer, Zweck
Art. 1. Name. Hiermit wird von den Zeichnern und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form
einer «société en commandite par actions» unter dem Namen RONCADIN HOLDINGS S.C.A (nachstehend die «Ge-
sellschaft») gegründet.
Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb dieses
Verwaltungsbezirks kann der Sitz der Gesellschaft kraft eines Geschäftsführerbeschlusses verlegt werden. Filialen, Toch-
tergesellschaften oder andere Niederlassungen können Kraft eines Geschäftsführerbeschlusses entweder im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden.
Kommt die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse, die die
üblichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz bzw. die Kommunikation zwischen diesem Gesellschaftssitz
und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder einzutreten drohen, so kann der Sitz vorüber-
gehend ins Ausland verlegt werden, bis die betreffenden außergewöhnlichen Ereignisse vollumfänglich überwunden sind;
31163
eine solche provisorische Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet solcher
zeitlich befristeten Maßnahmen eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird für unbefristete Zeit gegründet.
Art. 4. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung in jedweder Art an luxemburgischen und
ausländischen Unternehmen sowie in jeder weiteren Form der Investition, einschließlich des käuflichen Erwerbs, der
Zeichnung oder in anderer Weise und der Übertragung entsprechender Beteiligungen mittels Verkauf, Tausch oder an-
derweitig sowie der Verwaltung, Stimmbeteiligung an und Leitung von Beteiligungen.
Der Gesellschaftszweck umfasst ferner die Abgabe von Bürgschaften, Gewährung von Darlehen sowie jede andere
Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist oder die der gleichen Un-
ternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft.
Die Gesellschaft kann, jeder wirtschaftlichen, industriellen oder finanziellen Beschäftigung nachgehen, die sie für dei
Erreichung ihres Zwecks für nützlich hält.
Art. 5. Haftung der Aktionäre. Die Geschäftsführerin haftet gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten, die
mit dem Vermögen der Gesellschaft nicht bestritten werden können. Die anderen Aktionäre (der Klarheit halber: unter
Ausschluss der Geschäftsführerin) haben als Stammaktionäre davon Abstand zu nehmen, die Gesellschaft in einer Form
oder Funktion, die über ihre Rechte als Aktionäre - wie sie beispielsweise anlässlich von Hauptversammlungen wahrge-
nommen werden können - hinausgeht, zu vertreten, und haften lediglich im Umfang ihrer Einlagen in die Gesellschaft.
Kapitel II. Aktienkapital, Aktien
Art. 6. Grundkapital
6.1. Gezeichnetes Kapital
Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,00),
durch vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:
(a) vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Stammaktien der Klasse A1 mit einem Nennwert von jeweils einem
Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A1);
Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-
rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.
6.2. Stammaktien der Klasse A1
(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse A1 sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse A1 nehmen
anteilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttun-
gen teil, die auf die Stammaktien der Klasse A1 auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich
oder anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse A1 können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zu-
stimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass
die Anzahl ausgegebener Stammaktien der Klasse A1 entsprechend zu reduzieren ist.
(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse A1 berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter
den Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.
6.3. Stammaktien der Klasse A2
(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse A2 sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse A2 nehmen
anteilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttun-
gen teil, die auf die Stammaktien der Klasse A2 auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich
oder anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse A2 können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zu-
stimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass
die Anzahl ausgegebener Stammaktien der Klasse A2 entsprechend zu reduzieren ist.
(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse A2 berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter
den Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.
6.4. Stammaktien der Klasse B
(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse B sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse B nehmen an-
teilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttungen
teil, die auf die Stammaktien der Klasse B auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich oder
anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse B können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zustimmung
einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass die Anzahl
ausgegebener Stammaktien der Klasse B entsprechend zu reduzieren ist.
(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse B berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter den
Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.
6.5. Einziehung; Austauschbarkeit
(a) Einziehbare Aktien. Bei den Stammaktien handelt es sich um einziehbare Aktien im Sinne der jeweils geltenden
Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften. Einziehbare Aktien haben
die gleichen Dividenden- und Stimmrechte wie ggf. auch nicht einziehbare Stammaktien. Gezeichnete und vollständig
eingezahlte einziehbare Aktien können auf Wunsch der Gesellschaft anteilig - d.h. auf Basis der von dem jeweiligen Ak-
tionär gehaltenen einziehbaren Aktien jeder Anteilsklasse, eingezogen werden (i) unter Beachtung der jeweils geltenden
Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und (ii) nach Maßgabe ei-
nes ggf. zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrags. Die Ein-
31164
ziehung der einziehbaren Aktien kann nur unter Verwendung von Mitteln erfolgen, die gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes
vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften zur Ausschüttung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Mittel ein-
schließlich der außerordentlichen Rücklagen, die mit Hilfe der von der Gesellschaft als Agio vereinnahmten Erlöse ein-
gerichteten wurden) oder aus einer neuen, mit dem Ziel einer entsprechenden Einziehung vorgenommenen Emission
gewonnen wurden. Eingezogene Aktien bieten weder Stimm- noch Dividendenrechte und berechtigen nicht zu Liquida-
tionserlösen. Sie können auf Wunsch der Geschäftsführerin mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abge-
haltenen Hauptversammlung gekündigt werden.
(b) Besondere Rücklagen. Ein Betrag in Höhe des Nennwerts bzw. (falls dieser nicht ermittelt werden kann) der bi-
lanzierte Stückwert sämtlicher eingelöster Aktien ist in Rücklagen zu hinterlegen, die lediglich im Falle einer Kapitalher-
absetzung des gezeichneten Aktienkapitals an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf; ansonsten sind diese Rücklagen
ausschließlich zur Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Wege der Umwandlung der Rücklagen einzusetzen.
(c) Rücknahmepreis. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen (i) in diesen Artikeln oder (ii) im Rahmen einer
schriftlichen Vereinbarung, wie sie unter Umständen zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären abge-
schlossen wird, ist der Rücknahmepreis der einziehbaren Aktien seitens der Geschäftsführerin oder einer von dieser
ernannten Person zu bestimmen und von den Inhabern einer Mehrheit ausstehender Stammaktien anlässlich einer im
Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Aktionärsversammlung zu genehmigen. Abgesehen von Arglist, grober Fahrlässig-
keit oder offensichtlichem Irrtum ist jede seitens der Geschäftsführerin vorgenommene Berechnung des Rücknahme-
preises, die von einer Mehrheit der Aktionäre der Gesellschaft genehmigt wurde, für die Gesellschaft sowie ihre
gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Aktionäre endgültig und verbindlich.
(d) Rücknahmeverfahren. Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen, wie sie zwischen der Gesell-
schaft und den betreffenden Aktionären mindestens 20 Tage vor dem Einzugstermin getroffen werden können, ist jeder
eingetragene Inhaber der einzuziehenden Stammaktien unter seiner im Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft zuletzt
vermerkten Anschrift per Einschreiben (oder auf Verlangen der Geschäftsführerin unter Verwendung eines angesehe-
nen internationalen Übernacht-Kuriers) schriftlich unter Angabe von Einzugstermin und -preis, der Verfahren, die beim
Einzug der Stammaktien an die Gesellschaft zu Einzugszwecken Anwendung finden, des voraussichtlichen Termins der
Beschlussfassung der Hauptversammlung zum Thema des Einzugs von Stammaktien sowie der Bewertung des Rücknah-
mepreises gemäß Artikels 6.5(a) und 6.5(c) davon in Kenntnis zu setzen, wie viele Aktien auf diese Weise eingezogen
werden. Jeder Inhaber einzuziehender Stammaktien hat dabei die jeweiligen Aktienscheine abzuliefern, wie sie ggf. in
Bezug auf entsprechende Stammaktien der Gesellschaft ausgestellt wurden. Der Einzugspreis solcher Stammaktien ist
an die Person zahlbar, deren Name im Aktionärsverzeichnis als Inhaber der Stammaktien geführt ist, unter Verwendung
des seitens des betreffenden Aktionärs vor dem Einzugstermin gegenüber der Gesellschaft bezeichneten Kontos.
(e) Austauschbarkeit. Die Stammaktien der Klasse A1, der Klasse A2 und der Klasse B können nicht in Aktien anderer
Anteilsklassen umgewandelt werden.
6.6. Ausschüttungen an Aktionäre
Kommt die Aktionärsversammlung der Gesellschaft und/oder die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass an die Ak-
tionäre eine Ausschüttung zu erfolgen hat (mittels Abschlagsdividende, Einzug oder anderweitig), so haben die Aktionäre
nach Maßgabe der von der Aktionärsversammlung und/oder der Geschäftsführerin beschlossenen Konditionen und vor-
behaltlich anwendbaren Rechts in folgendem Umfang Anspruch auf Ausschüttungen unter Verwendung der rechtmäßig
zu diesem Zweck zur Verfügung stehenden Mittel:
(a) Erstens haben die Aktionäre der Klasse A Anspruch auf alle von der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Stammaktien
vorgenommenen Ausschüttungen, wobei solche Ausschüttungen anteilig - also auf der Grundlage der Anzahl von An-
teilen der Klasse A im Besitz der einzelnen Aktionäre der Klasse A - ausgeschüttet werden, bis die Aktionäre der Klasse
A und Inhaber der CPECs der Serie 1 gemeinsam Ausschüttungen im Umfang des Betrags der Tranche I vereinnahmt
haben;
(b) Zweitens haben die Aktionäre der Klasse A sowie die Aktionäre der Klasse B auf pari passu Basis Anspruch auf
alle von der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Stammaktien vorgenommenen Ausschüttungen, die unabhängig von der
jeweiligen prozentualen Beteiligung eines Aktionärs anteilig (pro rata) zu erklären und unter den Aktionären der Klasse
A sowie den Aktionären der Klasse B auf der Grundlage der Anzahl von Anteilen der Klasse A sowie von Anteilen der
Klasse B im Besitz der einzelnen Aktionäre zuzuweisen sind (die «Ausschüttungen der Tranche II»); dies allerdings unter
der Maßgabe, dass alle erklärten und zugewiesenen Ausschüttungen gemäß diesem Artikel 6.6(b) (i) an jeden Aktionär
der Klasse A vollumfänglich und (ii) an jeden Aktionär der Klasse B in einem Umfang auszuzahlen sind, der den mit der
prozentualen Beteiligung des betreffenden Inhabers zum jeweiligen Zahlungstermin multiplizierten, diesem Inhaber er-
klärten und zugewiesenen Ausschüttungen der Tranche II entspricht,. Nicht an Aktionäre der Klasse B zur Auszahlung
gebrachte Beträge der entsprechend erklärten und zugewiesenen Ausschüttungen sind als Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft festzuhalten, die an den betreffenden Inhaber auszuzahlen, wobei alle zu solchen Verbindlichkeiten in Bezug ste-
henden Barmittel in einem getrennten Konto zugunsten des gleichen, ansonsten zur Vereinnahmung berechtigten
Inhabers zu verwahren sind (jeweils ein «nicht übertragener Ausschüttungsbetrag der Tranche II»). Jeder nicht übertra-
gene Ausschüttungsbetrag de Tranche B, wie er einem Aktionär der Klasse B zuzuordnen ist, wird anteilig in vierteljähr-
lichen Abständen jeweils zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember bzw. zu dem jeweils folgenden
Geschäftstag zur Auszahlung gebracht, bis die Anteile der Klasse B des betreffenden Inhabers zu 100% übertragen (und
die damit verbundene Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechend reduziert) sind.
6.7. Liquidationsansprüche
Im Falle einer Liquidation werden die verbleibenden Vermögenswerte der Gesellschaft nach Zahlung sämtlicher
Schulden und Verbindlichkeiten unter den Aktionären in der unter Artikel 6.6 oben beschriebenen Weise aufgeteilt.
Weder eine Fusion oder ein Zusammenschluss der Gesellschaft zu oder mit (einem) weiteren Unternehmen, noch eine
Fusion oder ein Zusammenschluss dritter Unternehmen zu oder mit der Gesellschaft, noch die Veräußerung, Abtretung,
31165
Vermietung oder der Tausch (gegen Barmittel, Wertpapiere oder andere Werte) eines beliebigen Teils des Gesell-
schaftsvermögens gilt als eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 6.7, es sei denn, Fusionen, Zusammenschlüsse, Ver-
äußerungen, Abtretungen, Miet- oder Tauschgeschäfte dieser Art stehen im Zusammenhang mit oder beinhalten ein
Vorhaben zur Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.
6.8. Genehmigtes Kapital
Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes Kapital, das auf zwei hundert Mil-
lionen Euro (EUR 200.000.000) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:
(a) Einhundertdreiundfünfzig Millionen einhundertdreiundsiebzigtausendvierhundertacht (153.173.408) Stammaktien
der Klasse A1 mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) pro Anteil;
(b) Eine Million vierhundertzwanzigtausendvierhundertachtundvierzig (1.420.448) Stammaktien der Klasse A2 mit ei-
nem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) pro Anteil;
(c) Fünf Millionen vierhundertsechstausendeinhundertvierundvierzig (5.406.144) Stammaktien der Klasse B mit einem
Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) pro Anteil.
Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-
versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.
6.9. Änderung des gezeichneten und des genehmigten Kapitals
Das gezeichnete und das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann aufgrund einer Entscheidung der Hauptversamm-
lung mit der selben Mehrheit, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrags erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt
werden. Dies setzt allerdings eine Beschlussfähigkeit in dem zur Abänderung der vorliegenden Artikels notwendigen
Umfang voraus.
Art. 7. Aktien, Aktionärsverzeichnis, Aktienübertragung
7.1. Aktionärsverzeichnis
Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien. Am Sitz ist ein Aktionärsverzeichnis zu führen, das von jedem
Aktionär eingesehen werden kann. Das Verzeichnis enthält die exakte Bezeichnung jedes Aktionärs sowie Angaben zur
Anzahl seiner Aktien, den darauf geleisteten Zahlungen und der Übertragung von Aktien einschließlich des Zeitpunkts.
Die Aktionäre haben die Gesellschaft per Einschreiben von ihren Anschriften und etwaigen Adressänderungen in Kennt-
nis zu setzen. Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, sich auf die zuletzt gemeldete Anschrift zu verlassen. Abschriften
dieser Angaben werden auf Wunsch eines Aktionärs in beglaubigter Form ausgestellt und von der Geschäftsführerin
unterzeichnet.
7.2. Aktienbesitz
Der Besitz eingetragener Aktien ergibt sich aus den Aufzeichnungen im Aktionärsverzeichnis. Die Gesellschaft er-
kennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Befinden sich eine oder mehrere Aktien im Besitz mehrerer Inhaber oder
steht der Aktienbesitz in Streit, so haben alle Anspruchssteller eine einzigen Vertreter zu bestimmen, der die betreffen-
de(n) Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft vertritt. Wird die Ernennung eines solchen Vertreters versäumt, so werden
sämtliche mit den betreffenden Aktien verbundenen Rechte so lange ausgesetzt, bis ein Vertreter berufen ist. Ausge-
setzte Ausschüttungen auf die betreffenden Aktien werden dann umgehend an diesen Vertreter zur Auszahlung ge-
bracht.
7.3. Aktienübertragung
(a) Abtretungserklärung. Die Übertragung von Aktien erfolgt auf dem Wege einer Abtretungserklärung, die im Ak-
tionärsverzeichnis einzutragen und seitens des Abtretenden und des Abtretungsempfängers bzw. ihrer Vertreter zu da-
tieren und zu unterzeichnen ist. Eine Übertragung von Aktien kann auch im Einklang mit den Regeln zur Übertragung
von Ansprüchen gemäß Artikel 1690 des Luxemburger Civil Code stattfinden. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt,
Übertragungen anzunehmen und in das Aktionärsverzeichnis einzutragen, auf die in Korrespondenzen oder anderen das
Einverständnis zwischen dem Abtretendem und dem Abtretungsempfänger nachweisenden Unterlagen Bezug genom-
men wird.
(b) Abtretungsbeschränkungen. Vor Ablauf des zehnten Jahrestages des Ausgabetermins bzw. vor Ablauf kürzerer
Fristen nach anwendbarem Recht können die Secondary Investors die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile vor-
behaltlich anderslautender Bestimmungen dieses Artikels 7.3 ohne das vorherige schriftliche Einverständnis der Ge-
schäftsführerin nicht wirksam übertragen.
31166
(c) Zulässige Abtretungen. Secondary Investors dürfen sämtliche im Besitz solcher (natürlicher) Personen befindli-
chen Wertpapiere auf ihren Ehepartner oder Nachkommen (einschließlich Adoptivkinder) sowie auf beliebige, aus-
schließlich zugunsten solcher Personen bzw. ihrer Ehepartner und/oder Nachkommen (jeweils ein «Zulässiger
Abtretungsempfänger») eingerichtete Treuhandvermögen übertragen, sofern dem keine Rechtsnachfolge- oder Vertei-
lungsregeln oder weitere anwendbaren Gesetze entgegenstehen (eine «Zulässige Abtretung»).
(d) Drag-Along Sale
(i) Verfahren. Im Falle einer angedachten Übertragung seitens der Primary Investors der Gesellschaft an einen Dritt-
käufer sind die Primary Investors bzw. die Geschäftsführerin berechtigt, vor - aber in Bezug auf - eine entsprechende
Übertragung diese als einen Drag-Along Sale zu betrachten, woraufhin sämtliche Secondary Investors im zumutbaren
Umfang alle in Verbindung mit einem solchen Drag-Along Sale gemäß diesem Artikel 7.3(d) vorgebrachten Wünsche der
Primary Investors bzw. der Geschäftsführerin nach Kräften zu erfüllen haben. Im Falle eines Drag-Along Sale kann die
Geschäftsführerin jeden beliebigen Secondary Investor zwingen, sich an diesem auf anteiliger Basis (wie sie auf der
Grundlage der Besitzverhältnisse zum Zeitpunkt der Umwandlung - «as-converted basis» - zu ermitteln ist) zu beteiligen.
Die Geschäftsführerin hat den betreffenden Secondary Investors von einem Drag-Along Sale unter hinreichend detail-
lierter Angabe der vorgesehenen Anteilsklasse und Anzahl (bzw. des Prozentsatzes) der Stammaktien sowie des vorge-
sehenen Preises, weiterer anvisierter Bedingungen und Konditionen des vorgesehenen Drag-Along Sale und ggf. der
Identität des vorgesehenen Käufers schriftlich Mitteilung zu machen (die «Ankündigung des Drag-Along Sale»); dem
Drag-Along Sale unterliegen dabei Stammaktien, CPECs and PECs, die sich im Besitz der Secondary Investors befinden
(die «Wertpapiere des Drag-Along Sale»).
(ii) Zusammenarbeit. Im Hinblick auf einen Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor alle notwendigen oder rat-
samen Transaktionen vorzunehmen, wie sie seitens der Geschäftsführerin unter Berücksichtigung von Geschäft-, Steu-
er- und Marktfähigkeitsgesichtspunkten festgelegt werden. Ferner verpflichtet sich jeder Secondary Investor, einen
entsprechenden Drag-Along Sale so rasch wie möglich abzuwickeln und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass alle seitens
der Geschäftsführerin bzw. der Primary Investors in Verbindung mit einem Drag-Along Sale nachvollziehbar angeforder-
ten und notwendigen Unterlagen, Urkunden, Vereinbarungen oder Verpflichtungen (auch unter Berücksichtigung der
Ankündigung des Drag-Along Sale) überbracht, unterzeichnet bzw. eingegangen werden. Die Secondary Investors erklä-
ren bereits hiermit ihr Einverständnis mit beliebigen, seitens der Gesellschaft und der Geschäftsführerin unternomme-
nen Schritten, wie sie nach Einschätzung der Geschäftsführerin zur Erledigung rechtlicher Formalitäten in Verbindung
mit der Übertragung der dem Drag-Along Sale zugrundeliegenden Wertpapiere notwendig oder ratsam sein mögen. Zu-
dem haben die Secondary Investors (i) einen (abhängig von den Gesamterlösen) entsprechenden Teil (pro rata) des zu-
mutbaren, seitens der Primary Investors im Zusammenhang mit dem betreffenden Drag-Along Sale entstandenen
angemessenen Aufwands zu entrichten und (ii) sich jeweils anteilig (auf der Basis des invertierten Betrags, wie er allen
Beteiligten im Falle einer vollumfänglichen Liquidation der Gesellschaft zustünde) an etwaigen, in der Ankündigung des
Drag-Along Sale konkretisierten Entschädigungen oder Verpflichtungen zu beteiligen.
(iii) Gegenleistung. Im Falle eines Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor von seinen Wertpapieren all diejeni-
gen zu übertragen, die in der Ankündigung des Drag-Along Sale aufgeführt sind. Form und Umfang der Gegenleistung
für Wertpapiere, wie sie im Rahmen eines Drag-Along Sale übertragen werden, ist wie in der der Ankündigung des
Drag-Along Sale ausgewiesen, für alle Wertpapiere der gleichen Art oder Anteilsklasse identisch.
(e) Abtretung. Für Zwecke dieser Artikel bezeichnet «Übertragung» oder «Abtretung» eine freiwillige oder unfrei-
willige (auch gesetzlich erzwungene) Transaktion, die zu einer Übertragung des Eigentums - «nuepropriété», «usufruit»
- bzw. der Rechte an den von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien (einschließlich von Stimm- und Dividendenrechten)
auf eine beliebige Person mit Ausnahme der Gesellschaft - z.B. eines Aktionärs der Gesellschaft - auf beliebigem Wege
(einschließlich von Schenkungen, teilumfänglichen Übertragungen von Vermögenswerten («apports partiels d’actifs»),
Fusionen, Splits («scissions»), Veräußerungen, Abtretungen, Verpfändungen oder anderen Formen der Übertragung, Ab-
tretung oder Verfügung von bzw. über Eigentums- oder Nießbrauchsrechten an den Aktien sowie jeder beliebigen Kom-
bination entsprechender Methoden der Besitzübertragung führt. Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien.
(f) Diesen Artikeln zuwiderhandelnde Abtretungen. Übertragungen von Wertpapieren (einschließlich möglicher
Übertragungsversuche), die den Bestimmungen dieser Artikel zuwiderhandeln, sind nichtig und wirkungslos und sind sei-
tens der Gesellschaft weder anzuerkennen noch in den Büchern der Gesellschaft zu dokumentieren. Ebensowenig wird
ein angeblicher Abtretungsempfänger unter diesen Umständen als Inhaber der betreffenden Wertpapiere anerkannt.
Kapitel III. Geschäftsführung
Art. 8. Geschäftsführerin. Die Gesellschaft wird von RONCADIN HOLDINGS GP S.A., einer gemäß dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg gegründeten «société anonyme», als ausschließliche Geschäftsführerin («associé com-
mandité») und Manager der Gesellschaft (nachstehend als «Geschäftsführerin» bezeichnet) verwaltet. Die anderen Ak-
tionäre sind an der Geschäftsführung der Gesellschaft weder beteiligt, noch können sie in diese eingreifen. Im Falle der
rechtlichen Geschäftsunfähigkeit oder Liquidation der Gesellschaft bzw. bei einer anderweitigen ständigen Beeinträch-
tigung der Geschäftsführung durch die Geschäftsführerin ist diese nicht umgehend aufzulösen und zu liquidieren. Dies
setzt allerdings voraus, dass der Aufsichtsrat gemäß Artikel 11 dieses Vertrags einen Verwalter bestellt (bei dem es sich
nicht um einen Aktionär handeln muss), der sich bis zur Abhaltung einer Hauptversammlung, die er innerhalb von 15
Tagen nach seiner Bestellung anzuberaumen hat, dringenden Verwaltungsaufgaben widmet. Anlässlich der Versammlung
können die Aktionäre unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel not-
wendigen Mehrheiten einen Nachfolger berufen. Kommt eine solche Berufung nicht zustande, wird die Gesellschaft auf-
gelöst und liquidiert.
31167
Art. 9. Vollmachten der Geschäftsführerin
9.1. Allgemeine Vollmachten
Die Geschäftsführerin verfügt zur Wahrnehmung ihrer administrativen Aufgaben im Sinne des Gesellschaftszwecks
über weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt, die eine Einschränkung nur insofern erfah-
ren, als sie nach anwendbarem Recht und diesen Artikeln der Hauptversammlung bzw. dem Aufsichtsrat vorbehalten
sind.
9.2. Durchsetzung von Rechten
Die Geschäftsführerin hat auf der Grundlage ihres besten Wissens und Gewissens den Interessen der Gesellschaft
und ihrer Aktionäre zu dienen und nach Kräften sämtlichen Rechten zur Durchsetzung zu verhelfen, die der Gesellschaft
im Rahmen von Gesellschaftsverträgen von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie gemäß Wertpa-
pierinhaber- oder weiteren Verträgen zugestanden wurden, die zwischen der Gesellschaft und beliebiger ihrer Anteils-
eigner von Zeit zu Zeit abgeschlossen werden können.
9.3. Entlassung der Geschäftsführerin durch Stammaktionäre
Falls die Geschäftsführerin gemäß der nachvollziehbaren Einschätzung der Stammaktionäre die Erfüllung ihrer Pflich-
ten gegenüber der Gesellschaft und den Aktionären im Sinne von Artikel vernachlässigt, sind die Aktionäre aufgrund
einer im Rahmen einer ordnungsgemäß anberaumten Aktionärsversammlung und unter Einhaltung des Gebots der Be-
schlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Ab-
stimmung berechtigt, die Bestellung der Geschäftsführerin rückgängig zu machen und diese durch eine neue
Geschäftsführerin zu ersetzen, deren Bestellung ebenfalls einer unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und
der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Abstimmung bedarf. Der
Geschäftsführerin ist die Beteiligung an einer Abstimmung zur Frage der Widerrufung ihrer Bestellung als Geschäftsfüh-
rerin der Gesellschaft nicht gestattet.
Art. 10. Dritte. Die Gesellschaft ist wirksam gegenüber Dritten durch die Unterschrift der Geschäftsführerin bzw.
die Unterschriften weiterer Personen gebunden, deren Vollmacht diesen von der Geschäftsführerin nach eigenem Er-
messen übertragen wurde.
Kapitel IV. Aufsicht
Art. 11. Aufsichtsrat
11.1. Mitglieder des Aufsichtsrates
Das Geschäft der Gesellschaft und ihre finanzielle Lage - insbesondere im Hinblick auf ihre Bücher und Konten - un-
terliegen der Aufsicht eines mindestens aus drei Mitgliedern (bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss) be-
stehenden Aufsichtsrates («Conseil de Surveillance»). Zur Ausübung seiner Aufsichtsfunktion verfügt dieses Gremium
über die Vollmacht eines Prüfungsbeauftragten der Geschäftsführung gemäß Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August
1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung. Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführerin zu
beliebigen Fragen konsultiert werden und ist zur Genehmigung von Maßnahmen der Geschäftsführerin berechtigt, die
nach anwendbarem Recht oder diesen Artikeln die Befugnisse der Geschäftsführerin unter Umständen überschreiten.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von jeweils
einem (1) Jahr zu bestellen und bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können
wiedergewählt, aber auch jederzeit ohne Angabe von Gründen kraft eines Beschlusses der Hauptversammlung der Ak-
tionäre abgewählt werden. Der Aufsichtsrat kann eines seiner Mitglieder zum Sprecher wählen.
11.2. Versammlungen des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat wird von seinem Sprecher bzw. von der Geschäftsführerin einberufen und tritt auch auf Wunsch
eines seiner Mitglieder zusammen.
11.3. Mitteilungen
Von Versammlungen des Aufsichtsrates ist sämtlichen Mitglieder mindestens drei (3) Tage vor dem für die Versamm-
lung anberaumten Termin schriftlich Mitteilung zu machen. In dringenden Fällen ist diese Frist nicht verbindlich - aller-
dings ist in entsprechenden Einladungen die Dringlichkeit detailliert zu erläutern. Mitteilungen erfolgen unter Angabe
des Versammlungsorts und der Tagesordnung. Auf die Mitteilungsfrist kann schriftlich, per Telegramm, Telex, Fax oder
unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden verzichtet werden. Zu diesem Zweck genügt auch eine Ab-
schrift. Im Falle von Versammlungen, deren Zeitpunkt und Ort von dem Aufsichtsrat bereits in einen Terminkalender
eingetragen wurden, bedarf es keiner gesonderten Mitteilungen.
11.4. Vorsitzender
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates sitzt allen Versammlungen des Rates vor und ist im Falle seiner Abwesenheit
durch ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrates zu ersetzen, das mit der Mehrheit der vertretenen Stimmen zum vor-
übergehenden Vorsitzender bestellt wird. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per Telegramm, Te-
lex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck genügt auch eine
Abschrift. Dabei ist es zulässig, dass ein Mitglied mehrere seiner Kollegen vertritt.
11.5. Beschlüsse
Der Aufsichtsrat ist zu wirksamen Beschlüssen nur dann fähig, wenn zumindest eine einfache Mehrheit seiner Mitglie-
der anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse bedürfen zu ihrer Fassung einer Mehrheit der anwesenden oder vertrete-
nen Stimmen.
11.6. Protokolle
Beschlüsse des Aufsichtsrates sind in Versammlungsprotokollen festzuhalten und von dem Vorsitzenden der betref-
fenden Versammlung zu unterzeichen. Abschriften der Auszüge solcher Protokolle, wie sie etwa anlässlich von Gerichts-
31168
verfahren sowie bei anderen Anlässen vorzulegen sind, sind von dem Vorsitzenden der Versammlung oder zwei
beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen.
11.7. Schriftlich gefasste Beschlüsse Konferenzgespräch
Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Aufsichtsrates unterzeichnet wurden, stehen auf dem
Wege der Abstimmung anlässlich von Aufsichtsratsversammlungen gefassten Beschlüssen gleich. Dabei sind schriftlich
gefasste Beschlüsse von allen Mitgliedern schriftlich durch ihre Unterschrift zu bestätigen. Zu diesem Zweck genügt auch
eine Abschrift. Alle Unterlagen bilden gemeinsam die Urkunde, die als Nachweis der jeweiligen Beschlussfassung dient.
Jedem Mitglied des Aufsichtsrates steht es frei, an Versammlungen des Gremiums über eine Konferenzschaltung oder
weitere Kommunikationsmethoden teilzunehmen, die allen Versammlungsteilnehmern erlaubt, einander zu hören. Eine
derartige Teilnahme an einer Versammlung steht einer persönlichen Teilnahme in keiner Hinsicht nach.
11.8. Haftung
Keines der Mitglieder des Aufsichtsrates übernimmt mit seinem Aufsichtsratsmandat eine wie auch immer geartete
Haftung im Bezug auf die von den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Namen der Gesellschaft regelmäßig eingegangenen
Verpflichtungen. Bei ihnen handelt es sich lediglich um Bevollmächtigte, die ausschließlich für die Erfüllung ihres Mandats
eine Verantwortung tragen.
11.9. Freistellung
(a) Freistellung. Die Gesellschaft stellt alle Mitglieder des Aufsichtsrates sowie deren Rechtsnachfolger, Testaments-
vollstrecker und Nachlassverwalter im gesetzlich zulässigen Umfang von allen Ausgaben frei, die diesen nachvollziehbar
im Rahmen von Klagen oder Verfahren entstehen, denen sie infolge ihres Aufsichtsratsmandats bei der Gesellschaft als
Partei ausgesetzt sind und von denen sie nicht freigestellt werden müssen. Dies gilt nicht im Bezug auf Klagen oder Ver-
fahren, im Rahmen derer sie letztendlich der Fahrlässigkeit oder schwerwiegenden Fehlverhaltens als schuldig erachtet
werden; im Falle eines Vergleichs wird eine Freistellung nur in Verbindung mit den durch den Vergleich abgegoltenen
Handlungen gewährt, für die nach Einschätzung der Rechtsvertreter der Gesellschaft seitens der freizustellenden Person
keine Pflichtverletzung vorliegt. Der vorstehende Freistellungsanspruch schließt andere Rechte, auf die diese Personen
ggf. Anspruch haben, nicht aus.
(b) Ausgaben. Die Gesellschaft kommt für sämtliche Ausgaben auf, die einer im Rahmen dieser Artikel freizustellen-
den Person entstehen, vor endgültiger Entscheidung auf. Dies setzt allerdings voraus, dass der Gesellschaft eine schrift-
liche und rechtlich verbindliche Verpflichtungserklärung der betreffenden Person zugeht, in der sich diese im Falle der
abschließenden Feststellung, dass sie über keinen Freistellungsanspruch verfügt, zur Einziehung des vollständigen Betrags
bereit erklärt. Die Beendigung von Klagen und Verfahren über Urteile, Verfügungen, Vergleiche, Verurteilungen oder
Schuldgeständnisse oder vergleichbare Abschlüsse bergen an sich keinen Hinweis darauf, dass die freizustellende Person
die an ihren im Rahmen dieses Vertrags bestehenden Freistellungsanspruch geknüpften Verhaltensvorgaben nicht erfüllt
hat. Nach Erhalt einer Mitteilung einer freizustellenden Person, in der diese unter Erfüllung zumutbarer Vorgaben der
Gesellschaft deren Freistellungsverpflichtung nachweist, ist die Gesellschaft umgehend zu einer Barzahlung an die betref-
fende Person in Höhe des vollen Freistellungsbetrags verpflichtet.
11.10. Konflikte
Sollte die Geschäftsführerin bzw. einer oder mehrere ihrer Direktoren oder Vorstände an einem weiteren Unter-
nehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt sein oder einem solchen als
Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehören, so nehmen die betreffenden Verträge oder Geschäftsbeziehungen dar-
an keinen Schaden. Ebenso bleibt es keinem Direktor oder Vorstand der Geschäftsführerin, der an einem weiteren Un-
ternehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt ist oder einem solchen
als Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehört, verwehrt, aufgrund seines Verhältnisses zu dem betreffenden Unter-
nehmen an der Besprechung oder Abstimmung zu Angelegenheiten teilzunehmen, die entsprechende Verträge oder Ge-
schäftsbeziehungen berühren.
Kapitel V. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 12. Aktionärsversammlungen
(a) Vollmachten. Die Hauptversammlung der Aktionäre vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft und verfügt zur
Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Vorgängen betreffend den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft über
weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt. Diese ist lediglich dadurch eingeschränkt, dass
Beschlüsse zu ihrer wirksamen Fassung vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in diesen Artikeln der Zustimmung
der Geschäftsführerin bedürfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft tritt immer dann zusammen,
wenn die Geschäftsführerin oder der Aufsichtsrat eine Versammlung einberaumt.
(b) Ort, Zeit. Die in jährlichen Abständen stattfindende Hauptversammlung wird in Luxemburg am Sitz der Gesell-
schaft bzw. an einem weiteren, in der Einladung genannten Ort in Luxemburg jeweils am 31. März abgehalten. Handelt
es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf
folgenden Geschäftstag in Luxemburg statt. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre werden an den Orten und zu
den Zeitpunkten abgehalten, wie sie in den jeweiligen Einladungen angegeben sind. Die Hauptversammlungen der Ak-
tionäre werden in Form einer Einladung anberaumt, aus der die Tagesordnung hervorgeht und die von der Geschäfts-
führerin mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär der Gesellschaft unter der im
Aktionärsverzeichnis angegebenen Anschrift verschickt wird.
(c) Abstimmung. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per
Telegramm, Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck ge-
nügt auch eine Abschrift. Die Versammlungen der Aktionäre unterliegen vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieses Vertrags den gesetzlichen Bestimmungen zu Beschlussfähigkeit und erforderlichen Mehrheiten. Alle weiteren Be-
31169
dingungen, die seitens der Aktionäre im Sinne ihrer Teilnahme an Aktionärsversammlungen zu erfüllen sind, bestimmt
die Geschäftsführerin. Falls alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Tagesordnung der Ver-
sammlung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, so kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.
Kapitel VI. Geschäftsjahr, Bilanz
Art. 13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des-
selben Jahres.
Art. 14. Rücklagen. Von dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) den gesetzlich vor-
geschriebenen Rücklagen zuzuführen. Diese Zuweisungspflicht entfällt, sobald die gesetzlichen Rücklagen zehn Prozent
(10%) des gezeichneten Aktienkapitals erreicht haben. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat auf Empfehlung der
Geschäftsführerin zu bestimmen, wie über den verbleibende Teil des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Vorbe-
haltlich der einschlägigen gesetzlichen Bedingungen können Abschlagsdividenden ausgeschüttet werden.
Kapitel VII. Liquidation, Änderung der Art
Art. 15. Änderung. Diese Artikel können vorbehaltlich der Zustimmung der Geschäftsführerin von einer Mehrheit
von zwei Dritteln der Stimmen der Gesellschaftsaktionäre anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre, bei dem
wenigstens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist, abgeändert werden. In dem Fall,
dass die vorstehende Voraussetzung der Beschlussfähigkeit nicht erfüllt ist, bedarf es zur Abänderung dieser Artikel vor-
behaltlich der Zustimmung der Geschäftsführerin anlässlich einer zweiten Hauptversammlung der Aktionäre ebenfalls
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Gesellschaftsaktionäre; diese zweite Hauptversammlung unterliegt
allerdings hinsichtlich ihrer Beschlussfähigkeit keiner Voraussetzung mehr.
Art. 16. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren Liquidatoren
(natürliche oder juristische Personen) durchgeführt. Liquidatoren werden von der Hauptversammlung bestellt, die auch
die Auflösung beschloss und darüber hinaus den Umfang der Vollmachten und die Entschädigung der Liquidatoren fest-
legt.
Kapitel VIII. Abschliessende Verfügungen
Art. 17. Allgemeines. Im Hinblick auf alle nicht im Rahmen dieser Artikel geregelten Angelegenheiten haben sich
die Vertragsparteien an dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils gel-
tenden Fassung zu orientieren.
Art. 18. Definitionen. Für Zwecke dieser Artikel:
bezeichnen «Verbundene Unternehmen» sämtliche Personen, die von einer weiteren Person direkt oder indirekt be-
herrscht werden, diese selbst beherrschen oder mit dieser oder anderen Personen, die an jenen mit über fünfzig Prozent
(50%) wirtschaftlich beteiligt sind oder ihrerseits eine Beteiligung jener Personen in eben diesem Umfang aufweisen, ge-
meinsam von einer dritten Person beherrscht werden.
bezeichnen «Artikel» die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft, wie er von Zeit zu Zeit abgeän-
dert werden mag.
beschreibt «As-converted Basis» im Hinblick auf die ausstehenden Wertpapiere der Gesellschaft das Szenario, dass
alle in Stammaktien umwandelbare bzw. als solche ausüb- oder umtauschbare Wertpapiere im Einklang mit den Bedin-
gungen dieser umgewandelt, ausgeübt oder umgetauscht werden (d.h., die Anzahl der ausstehenden Stammaktien zu-
züglich der zusätzlichen Anzahl von Stammaktien, die unter der Voraussetzung einer entsprechenden Verwertung
ausstehen würden).
bezeichnen «Anteile der Klasse A» zum Zeitpunkt einer Feststellung (i) bezüglich der Inhaber von Stammaktien der
Klasse A1 die Gesamtanzahl der im Besitz des betreffenden Inhabers befindlichen Stammaktien der Klasse A1 und (ii)
bezüglich der Inhaber von Stammaktien der Klasse A2 die Gesamtanzahl der im Besitz des betreffenden Inhabers be-
findlichen Stammaktien der Klasse A2, multipliziert mit (B) vierzig.
bezeichnen «Aktionäre der Klasse A» die Inhaber der Stammaktien der Klasse A1 der Gesellschaft sowie die Inhaber
der Stammaktien der Klasse A2 der Gesellschaft.
haben «Stammaktien der Klasse A1» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung.
haben «Stammaktien der Klasse A2» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung
bezeichnen «Anteile der Klasse B» zum Zeitpunkt einer Feststellung (i) bezüglich der Inhaber von Stammaktien der
Klasse B die Gesamtanzahl der im Besitz des betreffenden Inhabers befindlichen Stammaktien der Klasse B, multipliziert
mit (ii) vierzig.
bezeichnen «Aktionäre der Klasse B» die Inhaber der Stammaktien der Klasse B der Gesellschaft.
haben «Stammaktien der Klasse B» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung.
hat «Gesellschaft» die in Artikel 1 dargelegte Bedeutung.
bezeichnet «Beherrschung» im Hinblick auf eine Person die Fähigkeit zur Verwaltung oder Kontrolle dieser Person
oder zur Bestellung ihrer Verwaltungsgremien bzw. einer Mehrheit der Mitglieder solcher Gremien im Falle einer ge-
meinschaftlichen Entscheidung auf der Grundlage des Besitzes stimmberechtigter Wertpapiere, der Vertragsgewalt oder
anderweitig (in dieser Hinsicht gilt eine Kommanditgesellschaft als von ihrem Geschäftsführer beherrscht).
bezeichnen «CPECs» CPECs der Serien 1 oder 2, wie sie von der Gesellschaft von Zeit ausgegeben werden können,
sowie ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft
ebenfalls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können.
hat «Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung.
hat «Ankündigung des Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung.
haben «Drag-Along Securities» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung.
hat «Geschäftsführer(in)» die in Artikel 8 dargelegte Bedeutung.
31170
bezeichnet «Gruppe» die Gesellschaft sowie deren Tochtergesellschaften, bei denen es sich jeweils um Gruppenun-
ternehmen handelt.
hat «Ausgabe» die in Artikel 6.13 dargelegte Bedeutung.
bezeichnet «Verwaltete juristische Person» eine juristische Person, die von der Geschäftsführerin, der Gesellschaft
oder einer ihrer Tochtergesellschaften beherrscht oder aber verwaltet oder betrieben wird oder der die Geschäftsfüh-
rerin, die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften als Partner oder Aktionär angehört.
bezeichnen «Stammaktien» Stammaktien der Klasse A1, Stammaktien der Klasse A2 und Stammaktien der Klasse B.
bezeichnen «PECs» PECs der Serie 1, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können, sowie
ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft eben-
falls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können.
bezeichnet «Prozentuale Übertragung» den zu einem gegebenen Zeitpunkt bezüglich eines Inhabers von zu übertra-
genden Stammaktien der Klasse B vollzogenen Umfang der Übertragung in Prozent, wie er auf den betreffenden Inhaber
zu dem gegebenen Zeitpunkt aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Inhaber und Gesellschaft zutrifft.
bezeichnet «Prozentuale nicht vollzogene Übertragung» den zu einem gegebenen Zeitpunkt bezüglich eines Inhabers
von zu übertragenden Stammaktien der Klasse B als 1 abzüglich der vollzogenen Übertragung ausgedrückten nicht voll-
zogenen Umfang der Übertragung.
hat «Zulässige Abtretung» die in Artikel 7.3(c) dieses Vertrags dargelegte Bedeutung.
hat «Zulässiger Abtretungsempfänger» die in Artikel 7.3(c) dieses Vertrags dargelegte Bedeutung.
bezeichnet «Person» ein Individuum, eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, einen Verband, eine Aktien-
gesellschaft, einen Trust, ein Gemeinschaftsunternehmen, eine nicht eingetragene Organisation oder eine Regierungs-
stelle (-amt, -ministerium usw.).
bezeichnen «Primary Investors» OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC oder ein mit dieser Gesellschaft verbun-
denes Unternehmen, das als Stammaktionär bzw. Anteilseigner an der Gesellschaft oder der Geschäftsführerin beteiligt
ist.
bezeichnen «Secondary Investors» alle Inhaber von Stammaktien oder anderen Anteilen an der Gesellschaft mit Aus-
nahme der Primary Investors.
bezeichnen «Wertpapiere» alle ordnungsgemäß genehmigten Wertpapiere der Gesellschaft, so z.B. der PECs und
CPECs.
bezeichnen «CPECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen umtauschbaren Vorzugsaktien der Serie
1.
bezeichnen «CPECs der Serie 2» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen umtauschbaren Vorzugsaktien der Serie
2.
bezeichnen «PECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen Vorzugsaktien der Serie 1.
bezeichnet «Tochtergesellschaft» im Hinblick auf eine Person alle weiteren Personen, deren Stimmrechte oder wei-
teren stimmberechtigten Anteile - auch im Sinne der Bestellung von Direktoren, Geschäftsführern oder Treuhände -
jene bzw. eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften in beliebiger Konstellation (ungeachtet des Eintritts möglicher
Ausnahmefälle) zum Zeitpunkt des Besitzes oder der Beherrschung direkt oder indirekt mehrheitlich besitzen oder be-
herrschen. Für Zwecke dieses Vertrags gelten Personen als Mehrheitsaktionäre von, GmbHs, Personengesellschaften,
Verbänden oder weiterer gewerblich tätiger Organisation, wenn die betreffenden Personen solche, GmbHs, Personen-
gesellschaften, Verbände oder weiteren gewerblich tätigen Organisationen beherrschen oder deren Gewinne bzw. Ver-
luste überwiegend absorbieren.
hat «Aufsichtsrat» die in Artikel 11.1 dargelegte Bedeutung.
bezeichnet der «Betrag der Tranche I» die Gesamtsumme von Ausschüttungen, wie sie seitens der Gesellschaft im
Einklang mit Artikel 6.6(a) in Höhe der Summe von (i) dem Produkt von (A) zehn Euro (EUR 10), multipliziert mit (B)
der Maximalzahl von Stammaktien der Klasse A1, und CPECs der Serie 1, die zu irgendeiner Zeit des Bestehens der
Gesellschaft ausgegeben wurden und noch bestehen, plus (ii) dem Produkt von (C) vier hundert Euro (EUR 400), mul-
tipliziert mit (D) der Maximalzahl von Stammaktien der Klasse A2, die zu irgendeiner Zeit des Bestehens der Gesell-
schaft ausgegeben wurden und noch bestehen, gemacht werden. Für den Fall, dass zu irgendeiner Zeit CPECs der Serie
1 in Stammaktien der Klasse A1 umgetauscht werden, werden solche CPECs der Serie 1 und Stammaktien der Klasse
A1 für die weitere Bestimmung des Betrages der Tranche I nicht doppelt gezählt.
haben «Ausschüttungen der Tranche II» die in Artikel 6.6(b) dargelegte Bedeutung.
hat der «Nicht übertragene Ausschüttungsbetrag der Tranche II» die in Artikel 6.6(b) dargelegte Bedeutung.
haben «Übertragung» und «übertragen» [bzw. «Abtretung» und «abtreten»] die in Artikel 7.3(e) dargelegte Bedeu-
tung.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember 2005.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Die Zeichner habe die auszugebenen Aktien wie folgt gezeichnet:
1) RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., vorgenannt, hat dreissigtausendneunhundertachtundneunzig Euro und
fünfundsiebzig Cent (EUR 30,998.75) eingezahlt und vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (24.799) Ak-
tien gezeichnet
31171
2) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., vorgenannt, hat ein Euro (EUR 1,25) fünfundzwanzig Cents eingezahlt und ei-
nen (1) Aktie gezeichnet
Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) eingezahlt für vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Akti-
en
Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr viertausendsiebenhundert (4.700,00) Euro.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-
lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
2. RONCADIN HOLDINGS GP S.A. wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung.
3. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
- Jacques Peffer, mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;
- Jean-Jacques Soisson mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg;
- Christophe Deschamps, mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg;
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
5. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten für das
Rechnungsjahr 2006 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Vollmachtnehmers
der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher
Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maß-
gebend.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmers der Erschienenen, hat derselben
mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 55, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003780.3/230/1087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
RENTCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5540 Remich, 26, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 64.361.
—
Suite à la nomination de la société REAL PROPERTIES CAPITAL S.A. en remplacement de la société ESPADA S.A.,
démissionnaire, par décision du Conseil d’Administration en date du 15 décembre 2005, nous vous prions de procéder
à l’enregistrement de cette nomination:
A Inscrire:
Démission de ESPADA S.A. en qualité d’administrateur.
Nomination en remplacement de REAL PROPERTIES CAPITAL S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01148. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001326.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Luxembourg, le 2 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
31172
LCA LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 97.039.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 7 décembre 2005, réf. DSO-BL00070, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903882.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
HOTEL KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 94.755.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00085, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903883.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
InterKoener S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 96.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00084, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903885.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
HILGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 31, rue de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 106.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00159, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903922.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
HILGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 31, rue de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 106.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00160, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903921.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
HILGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 31, rue de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 106.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00161, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903920.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
31173
GARAGE SCHEUREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9163 Kehmen, 8, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 107.965.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00081, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903886.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
NORDLIICHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9381 Moestroff, 22, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 101.777.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 5 décembre 2005, réf. DSO-BL00013, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903887.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
THEWES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 106.226.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00083, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903888.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
CLIMMOLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.225.
—
L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLIMMOLUX, ayant son
siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 49.225, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 novembre 1994,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 60 du 7 février 1995 et dont les statuts ont été mo-
difiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 482 du 27 juin 2001.
L’Assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Salle, employé privé, demeurant à
Woluwé-Saint-Pierre (B),
qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Refonte complète des statuts.
2. Démission et nomination. Décharge à donner aux administrateurs sortants.
3. Transfert du siège social à Strassen.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Diekirch, le 13 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
Signature.
31174
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide une refonte complète des statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:
Titre I
er
. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée
«Art. 1
er
. Forme - Dénomination. La société est une société anonyme.
Elle a pour dénomination CLIMMOLUX.
Art. 2. Siège. Le siège social est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut, par simple décision du conseil d’administration, être transféré en tout autre endroit au Luxembourg.
Tout changement du siège social est publié aux annexes du Mémorial par les soins des administrateurs.
La société peut établir, par décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales, agences et
comptoirs au Luxembourg et à l’étranger.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront ou
paraîtront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation com-
plète des circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Objet. La société a pour objet:
La recherche, l’étude et la réalisation, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, soit seule, soit conjointement avec d’autres
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour son compte ou pour le compte de tiers publics ou privés,
de toutes opérations quelconques portant sur des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis.
Par projets immobiliers il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se rapportant à
un bien immeuble, qu’il s’agisse:
- d’achat, vente, échange d’immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers,
- de construction, rénovation, transformation ou démolition d’un bien immobilier,
- de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens immeubles ainsi
qu’à des droits réels.
La société peut par ailleurs faire toutes soumissions, participer à toutes adjudications, répondre à tous appels d’offres,
conclure tous contrats de gré à gré ou ensuite d’adjudications, soumissions ou appels d’offre en matière d’entreprises
de travaux publics ou privés, sous toutes leurs formes et quel qu’en soit l’objet et exécuter de tels contrats, soit par ses
propres moyens, soit par le recours à toutes autres entreprises sous la forme de sous-traitance, de cession de marché,
d’association ou plus généralement sous quelque forme que ce soit.
Elle peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, administratives, financières, mobilières ou im-
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement ou de nature à en faciliter ou
développer la réalisation, tant pour elle-même que pour ses filiales.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention finan-
cière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou de nature à favoriser la
réalisation de son objet.
Elle peut accomplir son objet social soit pour elle-même, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment affermer
ou donner à bail tout ou partie de ses exploitations et installations, ou les donner à gérer à des tiers.
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale délibérant dans les formes requises par la loi.
Titre II. Capital - Actions
Art. 5. Capital. Le capital social, fixé à six cent dix-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 618.750,-), est repré-
senté par vingt-quatre mille sept cent cinquante (24.750) actions sans désignation de valeur nominale. Il est entièrement
libéré.
Art. 6. Forme des actions. Les actions sont et restent nominatives.
Art. 7. Emission des obligations. Le conseil d’administration pourra décider la création et l’émission de bons ou
d’obligations. Il détermine le type et le taux de l’intérêt des bons ou obligations à émettre, le prix, le mode et l’époque
de leur remboursement ou amortissement, ainsi que le prix et les conditions auxquelles ils seront émis ou vendus.
L’obligation au porteur est signée par deux administrateurs; une de ces signatures peut être apposée au moyen d’une
griffe.
Art. 8. Responsabilité. Tout actionnaire n’est responsable des engagements de la société que jusqu’à concurrence
du montant de sa souscription.
Art. 9. Registre des actions nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout
actionnaire pourra prendre connaissance; ce registre contient:
- la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions ou coupures;
- l’indication des versements effectués;
- les transferts avec leur date.
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par l’alinéa précédent.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.
Art. 10. Transfert des actions. Aucun transfert d’une action nominative, non entièrement libérée, ne peut avoir
lieu, si ce n’est en vertu d’une décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d’administration et au profit d’un ces-
sionnaire agréé par lui.
31175
La cession de l’action nominative s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actions nomina-
tives, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies
par l’article 1690 du Code civil.
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu’il passe.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l’assemblée gé-
nérale.
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer
l’apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d’opposition,
demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s’immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux comptes annuels et aux décisions de l’assemblée générale.
Art. 11. Augmentation du capital - Réduction du capital. Le capital peut être augmenté ou réduit, en une ou
plusieurs fois, par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux
statuts.
Le conseil d’administration règle l’exécution de l’augmentation de capital. Il a, dans tous les cas, la faculté de passer
aux clauses et conditions qu’il avisera, avec tous tiers quelconques, des conventions destinées à assurer la souscription
de tout ou partie des titres à émettre.
Art. 12. Droit de préférence. En cas d’augmentation du capital contre espèces, les actionnaires ont droit de pré-
férence à la souscription du capital nouveau. Ils l’exercent au prorata du nombre de titres de la société alors en leur
possession.
L’assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, peut limiter ou sup-
primer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d’administration à le faire.
Art. 13. Actions non libérées - Obligation de libération. Les versements à effectuer sur les actions non entiè-
rement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le conseil d’administration détermine.
L’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à tout
appel de fonds sur les actions, doit bonifier de plein droit à la société les intérêts calculés au taux d’intérêt légal.
Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, le conseil
détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.
Art. 14. Indivisibilité des actions. La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action, en ce qui concerne
l’exercice des droits accordés aux actionnaires.
La société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux actions faisant l’objet d’une copropriété, d’un usufruit
ou d’un gage, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme bénéficiant à l’égard de la société, de ces droits.
Titre III. Administration - Représentation - Contrôle
Art. 15. Nomination - Démission - Vacance. La société est administrée par un conseil d’administration composé
de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus, par l’assemblée générale des ac-
tionnaires et en tout temps révocables par elle.
Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire. Les ad-
ministrateurs sortants sont toujours rééligibles.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale peut conférer aux anciens administrateurs le titre
de président, de vice-président ou d’administrateur à titre honoraire de la société. Quand il le juge utile, le président
peut inviter les administrateurs honoraires à assister aux séances du conseil d’administration, mais avec voix consultative
seulement.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les membres restants du conseil d’administration peuvent y pourvoir
provisoirement; en ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procédera à l’élection définitive.
Art. 16. Rémunération - Compensation. L’assemblée générale peut octroyer aux administrateurs en cette qua-
lité, à charge du compte de résultats, des émoluments consistant en une somme fixe. Le conseil d’administration décide,
selon les règles qu’il édicte, de la répartition entre ses membres de ces émoluments.
Les administrateurs sont remboursés des frais notamment de déplacement que peut nécessiter l’exercice de leur
mandat, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration.
Art. 17. Présidence. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et éventuellement un vice-
président. En cas d’empêchement du président et du vice-président, un administrateur désigné par le conseil peut assu-
mer la présidence.
Art. 18. Assemblée. Le conseil d’administration se réunit, sur la convocation du président, aussi souvent que l’in-
térêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions du conseil ont lieu au siège de la société. Elles pourront avoir lieu, par exception, à tout autre endroit
qui sera fixé dans les avis de convocation.
Art. 19. Processus décisionnel - Représentation. Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, troubles ou
autres calamités publiques, le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié de ses
membres est présente ou représentée.
L’administrateur empêché d’assister à une réunion du conseil d’administration a la faculté de donner à un de ses col-
lègues, par lettre, par télégramme, télex, télécopie ou mail électronique, pouvoir de voter en son nom sur les proposi-
tions à l’ordre du jour; aucun administrateur ne peut représenter plus d’un collègue absent.
31176
Les lettres, télégrammes, télex, télécopies ou mails électroniques donnant le mandat de vote seront annexés au pro-
cès-verbal de la séance du conseil à laquelle ils ont été produits.
Les résolutions sont votées à la majorité des membres présents ou représentés, sauf dans le cas où des administra-
teurs doivent s’abstenir de prendre part à la délibération, en vertu de la loi; dans ce cas, les résolutions sont votées à la
majorité des autres membres présents ou représentés du conseil.
Si les voix sont partagées également, celle du membre qui préside la réunion est prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par résolutions circulaires. Une décision écrite signée
par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d’adminis-
tration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits
ayant le même contenu.
Art. 20. Procès - verbaux. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le pré-
sident et les membres du conseil qui ont pris part à la délibération et consignées dans un registre spécial, tenu au siège
de la société.
Les copies ou extraits à produire en justice et à des tiers sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 21. Compétences. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social de la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents
statuts est de sa compétence.
Art. 22. Comité de direction - Gestion journalière - Pouvoirs spéciaux. Le conseil d’administration peut
constituer un comité de direction dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein, et dont il détermine les
pouvoirs.
Il peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à une
ou plusieurs personnes, agissant, dans ce dernier cas, conjointement deux à deux, et confier la direction de l’ensemble,
de telle partie ou de telle branche spéciale des affaires à une ou plusieurs personnes et conférer des pouvoirs spéciaux
à tous mandataires.
Le conseil d’administration détermine les pouvoirs, les appointements ou indemnités des personnes mentionnées à
l’alinéa qui précède.
Il peut révoquer en tout temps la décision qu’il a prise à cet égard.
Les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spé-
ciaux déterminés à tous mandataires.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale, et impose au conseil d’administration de rendre annuellement compte à l’assemblée générale des traitements,
émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
Art. 23. Représentation. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonction-
naire public ou un officier ministériel et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion s’il n’y en a qu’un seul et par deux dé-
légués agissant conjointement s’ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par les mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Art. 24. Contrôle. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la
loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés pour six ans au plus, par l’assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
La fonction des commissaires sortants cesse immédiatement après l’assemblée générale annuelle. Les commissaires
sortants sont toujours rééligibles.
Le nombre des commissaires et leurs émoluments sont déterminés par l’assemblée générale. Ces émoluments con-
sistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des par-
ties.
Titre IV. Assemblée générale
Art. 25. Compétences. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
L’assemblée générale est composée de tous les actionnaires qui y sont présents ou représentés, après avoir rempli les
formalités prescrites par la loi ou les présents statuts.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents, incapables ou dissidents.
Elle a les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi et les présents statuts.
Art. 26. Assemblée. L’assemblée générale ordinaire et annuelle se réunit le premier vendredi ouvrable de mai, à
quatorze heures, au siège social ou en tout autre endroit qu’indiqueraient les convocations. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.
L’assemblée générale entend le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du ou des commissaires
sur leur mission.
Elle statue ensuite sur les comptes annuels et la répartition des bénéfices, ainsi que sur tous autres objets à l’ordre
du jour.
Elle procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs et des commissaires sortants.
Après approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et des commissaires.
31177
Art. 27. Assemblée générale extraordinaire. L’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement
par le conseil d’administration ou par le(s) commissaire(s).
Elle est convoquée extraordinairement sur la demande écrite, indiquant l’ordre du jour, des actionnaires représentant
le cinquième du capital social.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans les avis de convocation.
Art. 28. Prorogation. Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée générale or-
dinaire et annuelle, ainsi que l’assemblée générale extraordinaire appelée à modifier les statuts, à quatre semaines. Il doit
le faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation annule
toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans les cas de modification
de statuts les conditions de présence soient remplies.
Si l’assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu’une as-
semblée générale appelée à modifier les statuts et que cette dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la pre-
mière assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu’il soit possible de convoquer les deux
assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines.
Art. 29. Convocation - Agenda. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux
articles 67 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Les convocations pour toute assemblée contiennent l’ordre du jour et sont faites par des lettres recommandées
adressées, huit jours avant l’assemblée, aux actionnaires en nom.
Art. 30. Admission - Représentation - Liste de présence. Pour assister à l’assemblée générale ou pour s’y faire
représenter par un mandataire, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans le registre des actions
nominatives à la société, cinq jours ouvrables au moins avant l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non. Les mandataires doivent avoir reçu
pouvoir dans les formes déterminées par l’organe qui convoque l’assemblée; ces pouvoirs doivent avoir été déposés au
lieu et dans les délais fixés par ledit organe.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nue-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent respectivement
se faire représenter par une seule et même personne.
Une liste de présence indiquant l’identité des actionnaires et le nombre de titres qu’ils possèdent doit être signée par
chacun d’eux ou par leur mandataire, avant d’entrer en assemblée.
Le registre des actions nominatives est clos pendant les cinq jours qui précèdent et les huit jours qui suivent l’assem-
blée générale.
Art. 31. Droit de vote. Chaque action donne droit à une voix.
L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
Art. 32. Processus décisionnel.
Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le conseil d’administration ou par
le(s) commissaire(s), pourvu que l’ordre du jour et les convocations en aient fait mention.
Une proposition faite par les actionnaires n’est mise en délibération que si elle est signée par des actionnaires repré-
sentant le dixième du capital et si elle a été communiquée en temps utile pour être portée à l’ordre du jour et mention-
née dans les convocations.
Sauf les cas prévus ci-dessous, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions réunies à l’assemblée géné-
rale, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les votes se font à main levée ou par appel
nominal, à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement, à la majorité absolue des voix.
En cas de nomination d’administrateurs et/ou de commissaires, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est
procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité du nombre de
suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.
Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire délibérant d’une modification des statuts, une augmentation ou une réduction
du capital, une fusion de la société avec d’autres sociétés, la dissolution/liquidation de la société ou l’émission d’obliga-
tions convertibles ou avec droit de souscription, ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est repré-
sentée et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui
touchent à l’objet ou à la forme de la société.
Si la première des conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée, dans les formes statutaires.
Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde
assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Néanmoins le changement de la nationalité et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être dé-
cidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires.
31178
Délibération par correspondance
Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi par le conseil
d’administration reprenant leur identité complète, le nombre de parts pour lesquels ils prennent part au vote, l’ordre
du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être signé et daté et renvoyé par lettre re-
commandée ou télécopie trois jours au moins avant l’assemblée, au lieu indiqué dans les convocations. A la liste des
présences demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.
Art. 33. Bureau. Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son dé-
faut, par le vice-président ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues.
Le président désigne un secrétaire et l’assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.
Les membres présents du conseil d’administration et le commissaire complètent le bureau.
Art. 34. Procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par le président, par le secrétaire, par les deux scruta-
teurs et par les actionnaires qui le demandent et consignés dans un registre spécial.
Les copies à délivrer au tiers sont certifiées conformes à l’original dans le cas où les délibérations ont été constatées
par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par le président ou par deux membres du conseil
d’administration.
Titre V. Comptes annuels - Répartition du bénéfice
Art. 35. Exercice social - Inventaire - Comptes annuels. L’exercice social commence le premier janvier et finit
le trente et un décembre.
Au trente et un décembre de chaque année, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes
annuels, conformément aux articles 72 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Le conseil d’administration détermine, sous sa responsabilité, l’évaluation des créances et des autres valeurs mobiliè-
res et immobilières composant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la
bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la société.
Le conseil d’administration remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant
l’assemblée générale ordinaire aux commissaires qui font un rapport contenant leurs propositions.
Art. 36. Communication. Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance
au siège social:
- du bilan et du compte des profits et pertes;
- de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille;
- de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de
leur domicile;
- du rapport des commissaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes, de même que le rapport des commissaires, sont adressées aux actionnaires
en nom, en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir, sur la production de son titre, quinze jours avant l’assemblée générale, un exem-
plaire des pièces mentionnées à l’alinéa qui précède.
Art. 37. Publication. Dans le mois après leur approbation par l’assemblée, les comptes annuels sont publiés par les
soins des administrateurs, dans les conditions prescrites l’article 75 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
Art. 38. Répartition du bénéfice. Sur les bénéfices nets, il est prélevé annuellement un vingtième au moins affecté
à la constitution d’une réserve prescrite par la loi; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ce fonds de réserve
a atteint le dixième du capital social, mais reprend lorsque ce dixième est entamé.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée peut toujours affecter tout ou partie du surplus soit à la do-
tation de fonds de réserve, soit à un report à nouveau. La décision qui sera prise à cet égard pourra l’être à la simple
majorité des voix.
Sans préjudice du pouvoir du conseil d’administration de décider de l’octroi d’acomptes sur dividendes, le solde des
bénéfices nets est réparti par l’assemblée générale dans le respect de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
Art. 39. Dividendes. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d’ad-
ministration. Celui-ci peut décider le paiement d’acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions de l’article
72-2 et suivantes de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Titre VI. Liquidation
Art. 40. Liquidation. En cas de liquidation de la société, pour quelque cause que ce soit, l’actif net social, après
extinction de tout le passif, sera réparti uniformément entre toutes les actions, sous déduction des versements restant
éventuellement à effectuer sur ces actions.
La liquidation sera faite par une ou plusieurs personnes choisies par l’assemblée générale, qui fixera leur rémunéra-
tion.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs spécifiés par les articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales. L’assemblée générale pourra étendre ou restreindre ces pouvoirs et, avec son assentiment,
le ou les liquidateurs pourront céder ou apporter l’actif contre des espèces ou des titres.
31179
Titre VII. Dispositions générales
Art. 41. Election de domicile. Pour l’exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissai-
re et liquidateur, élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peu-
vent être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition des
destinataires.
Les actionnaires attribuent de plein droit juridiction aux tribunaux compétents de Luxembourg pour tout ce qui re-
garde leurs rapports avec la société.
Art. 42. Les actionnaires entendent se conformer entièrement à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales et les lois ultérieures qui l’ont modifié et, en conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il n’est pas
licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites et les clauses, qui seraient contraires aux dispositions
impératives de ces lois, sont censées non écrites.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels et leur donne décharge pour l’exécution de
leur mandat avec effet au 30 novembre 2005.
L’assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Fabien De Jonge, employé privé, né le 2 janvier 1972 à Huy, demeurant à B-1160 Bruxelles, 35, rue Jean
Colin;
- Monsieur Patrick Luchie, employé privé, né le 8 juin 1958 à Veurne, demeurant à B-1030 Bruxelles, 51, avenue Prin-
cesse Elisabeth;
- Monsieur Patrick Van Craen, directeur, né le 7 janvier 1953 à Mechelen, demeurant à B-1170 Watermael-Boitsfort,
1, Chemin du Silex.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Salle, M. Muller, S. Schenk, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 48, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(004103.3/200/376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
CLIMMOLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.225.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004105.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
ABERDEEN INVESTMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 54.225.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2005i>
Les mandats de MM. Andrew Laing, Hugh Young, Iain Taylor, en tant qu’administrateurs de la Société, ont été renou-
velés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice social prenant fin au 30
septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04381. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001124.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
F. Baden.
F. Baden.
Luxembourg, le 16 août 2005.
Signature.
31180
OP DER LAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 19, rue d’Eschdorf.
R. C. Luxembourg B 102.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00119, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903889.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
RESTAURANT-AUBERGE REIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9749 Fischbach, Maison 10.
R. C. Luxembourg B 100.502.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00115, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903893.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
RESTAURANT-AUBERGE REIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9749 Fischbach, Maison 10.
R. C. Luxembourg B 100.502.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00116, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903892.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
AVANTE COLOMBIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 113.128.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the thirteenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AVANTE PETROLEUM S.A., a public limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Company register under number B 99.983,
hereby represented by Mr Dirk Groen, CFO, with his professional address at 6, Cours de Rive in 1204 Geneva in
Switzerland, by virtue of a power of attorney given in Geneva, on 6 December 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.
Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name
of AVANTE COLOMBIA, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present
articles of association (the Articles).
The Company is formed for an unlimited duration.
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
31181
Art. 2. Corporate object
The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm
or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those share-
holdings;
- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire
securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company
any assistance, loan, advance or guarantee;
- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real
estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;
- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private
issue of bonds and debentures; and
- make investments or hold interests either directly or indirectly in oil and gas concessions or other licenses relating
to those concessions and carry out any operation required to manage such interests.
Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the managers of the Com-
pany and within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its
shareholder(s).
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
Chapter II.- Corporate capital
Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by
125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) per share.
Art. 5. Profit sharing
Each share entitles to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares
in existence.
Art. 6. Transfer of shares
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholder(s) who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such
authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-
ters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares
The Company shall have the power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The
quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles shall apply.
Chapter III.- Management
Art. 8. Management - Board of Managers
8.1 The Company is administered by one or more managers, appointed by the general meeting of the shareholder(s)
which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case
of plurality of managers, they constitute a board of managers (the Board of Managers), appointed by the general meeting
of the shareholder(s). The managers need not be shareholders. The general meeting of the shareholder(s) may at any
time and without cause revoke and replace any of the managers.
8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,
either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.
The Chairman, if any, will preside at all meetings of the shareholder(s) and of the Board of Managers. In his absence,
the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as
chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.
8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by any member of the Board of Managers.
The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency
which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board of Managers’ meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented at the meeting.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a
rule, in Luxembourg.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the
Board of Managers.
31182
8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram
or telex another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his co-managers at a meeting of the Board of Managers.
8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such
meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
8.7 Resolutions in writing signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of a resolution in writing will be
deemed to be held in Luxembourg.
8.8 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in
all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company’s objects and further
provided the terms of this Article 8 shall be complied with.
8.9 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within
the scope of the competence of the Board of Managers. The Company shall be bound by the individual signature of any
member of the Board of Managers up to an amount of EUR 50,000 and for matters involving an amount greater than
EUR 50,000 only provided the shareholder(s) shall have approved the matter or the expense.
The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration
of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
8.10 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and to
be signed by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman or by the Secretary.
8.11 The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint
proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.
8.12 The effective place of management shall be the city of Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be
carried out in or from the city of Luxembourg.
Art. 9. Liability of managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
Chapter IV.- Secretary
Art. 10. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the Board of Managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. He shall
have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks
so delegated.
The Secretary shall have the power and the authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to
be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V.- General meetings of shareholders
Art. 11. Annual and extraordinary general meetings of the shareholders
The annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of the Company’s registered office as may be specified in the notice of meeting, on the
first Monday of June at 11.00 a.m.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting of the shareholder(s) shall be held on the next following busi-
ness day. The annual general meeting of the shareholder(s) may be held abroad if, in the absolute and final judgement of
the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
Art. 12. Shareholders’ voting rights
Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irrespective of the number of shares which
he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any
general meeting of the shareholder(s).
31183
Art. 13. Quorum - Majority
Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far as they are adopted by a ma-
jority of shareholders’ owning more than half of the Company’s share capital.
However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried
out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
Resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at a general meeting of the shareholder(s), be passed in
writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be
passed, and shall vote in writing.
Chapter VI.- Accounting year - Financial statement - Profit sharing
Art. 14. Accounting year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.
Art. 15. Financial statements
Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 16. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-
fice.
Art. 17. Appropriation of profits - Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-
utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company.
The general meeting of the shareholder(s) shall have the power to make payable one or more interim dividends.
Chapter VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of
the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles, to the
dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 19. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-
er shareholders or not, appointed by a general meeting of the shareholder(s) which will determine their powers and
remuneration.
Chapter VIII.- Audit
Art. 20. Statutory auditor - External auditor
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more
than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.
Chapter IX.- Governing law
Art. 21. Reference to legal provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been established, the appearing party hereby declares that it
subscribes to the 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each,
representing the total share capital of the Company of an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro)
as follows:
All these shares have been fully paid up by the appearing party by means of a payment in cash so that the amount of
EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been
given to the undersigned notary by a blocking certificate issued by Credit Suisse - St Leonardstrasse 3 - 9001 St. Gallen
in Switzerland, and the notary expressly acknowledges such payment.
<i>Transitory provisionsi>
By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company’s current accounting year is to run from 13 December
2005 to 31 December 2006.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800 (one thousand and eight hundred Euro).
Shareholders
Shares
Payments
AVANTE PETROLEUM S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
EUR 12,500
31184
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company has adopted the following res-
olutions:
1. The shareholder of the Company resolves to set the number of managers at two managers who shall constitute a
Board of Managers.
2. The shareholder of the Company resolves to appoint the following two managers for an unlimited period:
a) Mark Rollins, Director, born in Nantwich (UK), on 13 May 1964, with residence at 2, route Suisse - 1296 Coppet
(Switzerland);
b) Dirk Groen, Director, born in Velsen (NL), on 13 April 1945, with residence at Villa la Géronde - 1663 Pringy
(Switzerland).
3. The shareholder of the Company resolves to set the registered office of the Company at 11B, boulevard Joseph II
in L-1840 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AVANTE PETROLEUM S.A., une société anonyme de droit Luxembourg ayant son siège social au 66, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 99.983,
ici représentée par M. Dirk Groen, CFO, avec adresse professionnelle au 6, Cours de Rive à CH-1204 Genève, en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 6 décembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:
Chapitre I
er
.- Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et Durée
Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination AVANTE COLOMBIA,
S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet social
La Société peut:
- accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quel-
que forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations;
- créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine; elle
peut également acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets, les réa-
liser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre; et elle peut également accorder des aides financières sous la
forme de prêts, avances ou garanties à des filiales ou à leur profit et/ou à des entreprises liées de la Société;
- prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales,
financières, mobilières et immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de
son objet social;
- emprunter sous toutes formes à partir de filiales et/ou d’entreprises liées et/ou de toute autre personne ou entité
de toute forme et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature; et
- faire des investissements et détenir des participations soit directement soit indirectement dans des concessions pé-
trolière ou gazières ou autres licences en relation avec ces concessions et faire toutes les opérations nécessaire afin de
gérer ces intérêts.
Art. 3. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du pays par résolution prise en assemblée générale extraordinaire par
l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) dans tous
autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
31185
Chapitre II.- Capital social
Art. 4. Capital
Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent
vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Art. 5. Partage des bénéfices
Chaque part sociale donne droit à son titulaire à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes, de
l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.
Art. 6. Cession des parts sociales
En cas de pluralité d’associés, la cession des parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être approuvée
par une résolution des associés lors d’une assemblée générale représentant au moins trois quarts du capital social de la
Société. Une telle approbation préalable n’est pas requise pour la cession de parts sociales entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des associés
représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat des parts sociales
La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital pour autant que la Société possède des réserves
distribuables suffisantes à cet effet.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.
Chapitre III.- Gestion
Art. 8. Gestion - Conseil de Gérance
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’assemblée générale des associés qui déter-
minera la rémunération et les modalités de nomination de chaque gérant. En cas de pluralité de gérants, ils constituent
un conseil de gérance (le Conseil de Gérance), nommé par l’assemblée générale des associés. Les gérants n’ont pas be-
soin d’être associés. L’Assemblée générale des associés peut à tout moment et sans motif révoquer et remplacer les
gérants.
8.2 Le Conseil de Gérance peut nommer un Président parmi ses membres. Il peut en outre nommer un Secrétaire,
qu’il soit gérant ou non, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
Le Président, s’il est nommé, présidera toutes les réunions des associés et du Conseil de Gérance. En son absence,
l’assemblée générale des associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant que pré-
sident pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.
8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil
de Gérance.
Les gérants recevront chacun une convocation préalable pour chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les
cas d’urgence qui seront décrits dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite
devra parvenir aux gérants au moins deux jours avant les réunions du Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants
sont présents ou valablement représentés.
Les réunions sont tenues au lieu, à la date et l’heure spécifiés dans la convocation. Les réunions du Conseil de Gérance
sont normalement tenues à Luxembourg.
Il peut être renoncé à l’obligation d’envoyer une convocation par l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax,
télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spéci-
fiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.
8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou
télex un autre gérant comme son mandataire.
Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’entendre
mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant
localisé au Luxembourg sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi ré-
putée avoir été tenue à Luxembourg.
8.6 Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres sont pré-
sents ou représentés.
8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-
lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises par voie circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.
8.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société, sous réserve du res-
pect des dispositions du présent Article 8.
8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés sont de
la compétence du Conseil de Gérance. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique de tout membre
du Conseil de Gérance de la Société pour toute transaction représentant un montant inférieur ou égal à EUR 50.000
31186
(cinquante mille euros) et pour toute transaction supérieure à ce montant, les actionnaires devront donner leur accord
préalable.
Le Conseil de Gérance peut désigner, pour des tâches spécifiques, un ou plusieurs mandataires ad hoc qui peuvent
ou non être membres du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (le cas échéant),
la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.
8.10 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spéci-
fique et signé par le Président ou par le Secrétaire. Toutes les procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou autre sont signés par le Président ou par le
Secrétaire.
8.11 Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.
8.12 La Société sera gérée à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront posés à ou à partir de Luxem-
bourg.
Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-
blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispo-
sitions applicables de la Loi.
Chapitre IV.- Secrétaire
Art. 10. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en cas de
pluralité d’associés) de la Société (le Secrétaire).
Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-
nions du Conseil de Gérance et, dans la mesure nécessaire, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des as-
sociés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et des réunions de l’associé unique (ou
de l’assemblée des associés) et de toutes leurs transactions. Il exercera des fonctions similaires pour tous les comités
du Conseil de Gérance si nécessaire. Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes pour autant qu’il
conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité, qui lui seront conférés uniquement par le Conseil de Gérance, d’émettre
des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice ou, de manière plus
générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.
Chapitre V.- Assemblée générale des associés
Art. 11. Assemblées générales annuelles des associés
Une assemblée générale annuelle des Associés sera tenue au siège social de la Société ou en tout autre lieu à Luxem-
bourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, le premier lundi du mois de juin à 11 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle des associés sera tenue le jour ouvrable suivant. L’assemblée
générale annuelle des associés peut être tenue à l’étranger si, d’après l’avis final et unanime du Conseil de Gérance, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.
Les autres assemblées générales des associés peuvent être tenues au lieu et à l’heure tels que spécifiés dans leurs
convocations respectives à la réunion.
Art. 12. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales des associés indépendamment du nombre de parts qu’il
détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui ne doit pas forcément être un associé pour le
représenter et pour voter en son nom aux assemblées des associés.
Art. 13. Quorum - Majorité
Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement prises uniquement si elles sont adoptées par
une majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Cependant, les résolutions modifiant les Statuts et les résolutions visant à dissoudre, liquider ou fusionner la Société
ne seront valablement prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital so-
cial de la Société.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans ce cas, la/les résolutions à prendre devra/devront être envoyée(s) à chaque associé,
et chaque associé pourra voter par écrit.
Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 14. Année sociale
L’année sociale de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 15. Comptes sociaux
Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le Conseil de Gérance établit le bilan et le compte de
pertes et profits.
Art. 16. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.
31187
Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement d’une réserve
légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.
Le solde peut être distribué à l’associé unique (ou aux associés) en proportion des parts qu’il(s) détient (détiennent)
dans la Société.
L’assemblée générale des associés a le pouvoir d’autoriser le payement d’un ou plusieurs dividendes intérimaires.
Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associés n’entraînera pas la dis-
solution de la Société. Les associés doivent donner leur accord, conformément aux dispositions de l’article 13 paragra-
phe 2 des présents Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.
Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associés ou non,
nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Chapitre VIII.- Vérification des comptes
Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, les comptes de la Société doivent être vérifiés par un commissaire unique-
ment si la Société a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles
256 et 215 de la Loi n’est pas applicable.
Chapitre IX.- Loi applicable
Art. 21. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispo-
sitions de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, la partie comparante, représentée comme décrit ci-avant, déclare sous-
crire les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, représentant
l’intégralité du capital social souscrit de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros).
Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par la partie comparante via un paiement en espèces, de sorte
que le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire par la voie d’un certificat de blocage émis par Crédit Suisse - St Leonardstrasse 3 - 9001
St. Gallen en Suisse et le notaire en prend expressément acte.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article 14 des présents Statuts, le premier exercice social de la Société débute le 13 décembre 2005
et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent à approximativement EUR 1.800 (mille huit cents euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. L’associé unique de la Société a décidé de fixer le nombre de gérants à deux (2), constituant ainsi un Conseil de
Gérance.
2. L’associé unique de la Société a décidé de nommer les 2 gérants suivants pour une durée illimitée:
- Mark Rollins, Administrateur, né à Nantwich (GB), le 13 mai 1964, de résidence au 2, route Suisse - 1296 Coppet
(Suisse);
- Dirk Groen, Administrateur, né à Velsen (PB), le 13 avril 1945, de résidence Villa la Géronde - 1663 Pringy (Suisse).
3. Le siège social de la Société est établi au 11B, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: D. Groen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 54, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003971.3/242/454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Associés
Parts Sociales
Payments
AVANTE PETROLEUM S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
EUR 12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
EUR 12.500
Mersch, le 3 janvier 2006.
H. Hellinckx.
31188
TAXI DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 103.309.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00113, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903895.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
TAXI DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 103.309.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00114, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903894.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
ING PFCE POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.701.
—
In the year two thousand and five, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ING PFCE HOLDCO, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under
the number B 95.702, hereby duly represented by its manager Mr Steve Van den Broek, employee, with professional
address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
The appearing party, acting in his capacity as the only partner, has requested the undersigned notary to enact the
following:
The appearing party ING PFCE HOLDCO, S.à r.l. is the only partner of ING PFCE POLAND II, S.à r.l., an unipersonal
limited liability corporation with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed
of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on September 12th, 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1058 of October 11th, 2003, modified by a deed of the notary Alphonse Lentz,
before residing in Remich on June 18th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
897 of September 7th, 2004.
The capital of the company is fixed at twenty-one thousand Euro (21,000.- EUR) represented by twenty-one (21)
parts, with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, entirely paid in.
The appearing party takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The only partner resolves to increase the corporate capital by an amount of one thousand Euro (1,000.- EUR), so as
to raise it from its present amount of twenty-one thousand Euro (21,000.- EUR) to twenty-two thousand Euro (22,000.-
EUR), by issuing one (1) new part with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR), having the same rights and
obligations as the existing parts.
<i>Subscription and liberationi>
The appearing sole partner declares to subscribe the one (1) new part and to pay its up, fully in cash, at its par value
of one thousand Euro (1,000.- EUR), so that the amount of one thousand Euro (1,000.- EUR) is at the free disposal of
the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The appearing sole partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase
of capital, which shall henceforth have the following wording:
«Art. 6. The capital is set at twenty-two thousand Euro (22,000.- EUR) represented by twenty-two (22) parts of a
par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
31189
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française:
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ING PFCE HOLDCO, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue
Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 95.702, ici dûment représentée
par son gérant Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,
5, rue Eugène Ruppert.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce
qui suit:
La société comparante ING PFCE HOLDCO, S.à r.l. est la seule associée de la société à responsabilité limitée uni-
personnelle ING PFCE POLAND II, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée
suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 12 septembre 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1058 du 11 octobre 2003, dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich en date du 18 juin 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 897 du 7 septembre 2004.
Le capital social de la société est fixé à vingt et un mille euros (21.000,- EUR) représenté par vingt et une (21) parts
sociales d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
L’associée unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de mille euros (1.000,- EUR) afin de
le porter de son montant actuel de vingt et un mille euros (21.000,- EUR) à vingt-deux mille euros (22.000,- EUR), par
l’émission d’une (1) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR), ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Et à l’instant, une (1) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) a été souscrite par
l’associée unique et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de mille euros (1.000,- EUR) se trouve dès
maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l’article 6 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-deux mille euros (22.000,- EUR) représenté par vingt-deux (22) parts sociales
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. Van den Broek, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003526.3/5770/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
ING PFCE POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.701.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003527.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Remich, le 9 janvier 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 4 janvier 2006.
M. Schaeffer.
31190
INDUSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9172 Michelau, 10, Fléiberstrooss.
R. C. Luxembourg B 96.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00112, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903896.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
TOPSOLAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8838 Wahl, 5, Kinnékshall.
R. C. Luxembourg B 103.244.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00111, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903897.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
NOUVEAU GARAGE AGRA-NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9709 Clervaux, 20, rue de Marnach.
R. C. Luxembourg B 97.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00110, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903898.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
NOUVEAU GARAGE AGRA-NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9709 Clervaux, 20, rue de Marnach.
R. C. Luxembourg B 97.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00109, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903899.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
RAMOGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.091.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00017, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001320.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
Luxembourg, le 28 décembre 2005.
Signature.
31191
EMCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9748 Eselborn, 2, rue Knupp.
R. C. Luxembourg B 97.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00107, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903901.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
EMCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9748 Eselborn, 2, rue Knupp.
R. C. Luxembourg B 97.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00108, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903900.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
BLN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 43C.
R. C. Luxembourg B 103.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00103, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903905.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
BLN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 43C.
R. C. Luxembourg B 103.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00104, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 décembre 2005.
(903904.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.
MILLESIMA 99, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 102.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00562, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2006.
(001401.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
BÜRODIF
Signature
GH TRUST
Signature
31192
R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6834 Biwer, 6, Buergaass.
R. C. Luxembourg B 101.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07537, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903912.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6834 Biwer, 6, Buergaass.
R. C. Luxembourg B 101.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07539, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903913.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6834 Biwer, 6, Buergaass.
R. C. Luxembourg B 101.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07541, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903914.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6834 Biwer, 6, Buergaass.
R. C. Luxembourg B 101.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07542, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903915.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
ZEPHYR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 97.847.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 décembre 2005i>
1. Les administrateurs confirment que le capital social souscrit de la société de EUR 31.000,- est depuis le 10 août
2005 entièrement libéré.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00039. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001441.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
31193
NET s IT e.l.u., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8538 Hovelange, 59, am Kiem.
R. C. Luxembourg B 96.966.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06689, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2005.
(903927.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
NET s IT e.l.u., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8538 Hovelange, 59, am Kiem.
R. C. Luxembourg B 96.966.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK02033, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(903926.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
CAPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.616.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00076, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903908.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
EUROFLAM, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 63.
R. C. Luxembourg B 104.046.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00157, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903923.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
S-TEAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.967.
—
A l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 21 décembre 2001 le capital social de la société est fixé, avec
effet au 1
er
janvier 2002, à 31.250,- EUR, résultant d’une conversion de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR puis d’une
augmentation de 263,31 EUR, libérée par prélèvement sur les réserves et sans création d’actions nouvelles.
Luxembourg, le 3 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001459.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Wiltz, le 13 décembre 2005.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
31194
HOBO AG, Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
R. C. Luxembourg B 99.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00158, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903924.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
TRADITIONELL BAUEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8611 Platen, 4, rue des Carrières.
R. C. Luxembourg B 109.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06708, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(903928.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
DOMETIC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9809 Hosingen.
R. C. Luxembourg B 94.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 2 décembre 2005, réf. DSO-BL00009, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903930.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
DOMETIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9809 Hosingen.
R. C. Luxembourg B 91.535.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 2 décembre 2005, réf. DSO-BL00008, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903931.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
TELLURIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.337.
—
Il résulte d’un courrier adressé à la société en date du 10 novembre que Monsieur Marco Theodoli a donné sa dé-
mission en tant qu’Administrateur de la société avec effet immédiat.
Il résulte de deux courriers séparés adressés à la société en date 30 novembre 2005, que Madame Mireille Gehlen et
Monsieur Thierry Jacob ont respectivement donnés leurs démission en tant qu’Administrateur de la société avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00021. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001533.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
DOMETIC HOLDING, S.à r.l.
J. Craig
DOMETIC, S.à r.l.
A. Roux
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
Signature.
31195
MAURACH A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 95.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00196, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903943.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
MAURACH A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 95.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00199, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903942.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
P & W CNC UMFORMTECHNIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 78.920.
—
Im Jahre zweitausendzwei, den elften November.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Capellen, die ausserordentliche Gene-
ralversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P & W CNC UMFORMTECHNIK, S.à r.l., mit Sitz in L-6793
Grevenmacher, 15, route de Trèves, zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet am 3. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C Seite 19421 von 2001, die
Satzung wurde abgeändert gemäss einer ausserordentlichen Generalversammlung, vom 17. August 2001, beide Urkun-
den durch den amtierenden Notar mit damaligem Amtssitz in Redingen.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 78.920.
Erschienen sind:
1. Herr Friedhelm Wollenhaupt, Kaufmann, wohnhaft in D-55767 Schwollen, 9, am Schwimmbad;
2. Frau Sabine Elisabeth Buchberger, geborene Brieger, Kauffrau, wohnhaft in D-60439 Frankfurt, Antoniusstrasse
117.
Somit sind alle einhundert ausgegebenen Gesellschaftsanteile vertreten und diese Versammlung ist rechtsgültig zu-
sammengesetzt und beschlussfähig.
Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, daß Herr Friedhelm Wollenhaupt alle seine ein hundert Gesellschaftsanteile
an Frau Sabine Elisabeth Buchberger abgetreten hat.
Die Gesellschaftssatzung bleibt unverändert.
Herr Friedhelm Wollenhaupt bleibt als Geschäftsführer im Amt.
Die in der Gründungsurkunde enthaltene Rubrik «Zeichnung und Einzahlung» wird wie folgt geändert:
«Alle Gesellschaftsanteile werden von Frau Sabine Elisabeth Buchberger, Kauffrau, wohnhaft in D-60439 Frankfurt,
Antoniusstrasse 117 gehalten.»
Der zweite Absatz dieser Rubrik bleibt unverändert.
Es wird ausdrücklich bestätigt, daß der Gesellschaftssitz inzwischen in L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves ist,
und nicht mehr wie in der Gründungsurkunde erwähnt, auf Nr. 19, route de Trèves.
<i>Kosteni>
Die Kosten dieser Urkunde sind solidarisch zu Lasten der Gesellschaft und des neuen Gesellschafters.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die Erschienenen, welche dem Notar mit Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt sind mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Wollenhaupt, S. Buchberger, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 15 novembre 2002, vol. 426, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Für gleichlautende Abschrift, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094704.3/225/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Diekirch, le 15 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 15 décembre 2005.
Signature.
Capellen, den 25. Oktober 2005.
C. Mines.
31196
LUX STAHL AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves.
R. C. Luxembourg B 78.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00193, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903946.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
BREVER M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, route de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 92.160.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02809, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903932.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
P & W CNC UMFORMTECHNIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 78.920.
—
Im Jahre zweitausendfunf, den zehnten März.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Capellen, die ausserordentliche Gene-
ralversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P & W CNC UMFORMTECHNIK, S.à r.l., mit Sitz in L-6793
Grevenmacher, 15, route de Trèves, zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet am 3. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C Seite 19421 von 2001, die
Satzung wurde abgeändert gemäss einer ausserordentlichen Generalversammlung, vom 17. August 2001, beide Urkun-
den durch den amtierenden Notar mit damaligem Amtssitz in Redingen.
Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss einer ausserordentlichen Generalversammlung, vom 11. November
2002, aufgenommen durch den amtierenden Notar.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 78.920.
Erschienen sind:
1. Frau Sabine Elisabeth Brieger, Kauffrau, wohnhaft in D-60439 Frankfurt, in der Römerstadt, 179.
Somit sind alle einhundert ausgegebenen Gesellschaftsanteile vertreten und diese Versammlung ist rechtsgültig zu-
sammengesetzt und beschlussfähig.
2. Herr Heinrich Günter Wollenhaupt, Dipl. Betriebswirt, wohnhaft in D-59557 Lippstadt, Akazienstrasse, 11.
Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, daß Frau Sabine Elisabeth Brieger, Kauffrau, wohnhaft in D-60439 Frankfurt,
Antoniusstrasse 117 alle ihre ein hundert Gesellschaftsanteile an Herrn Heinrich Günter Wollenhaupt, vorbenannt, ab-
getreten hat.
Die Gesellschaftssatzung bleibt unverändert.
Herr Friedhelm Wollenhaupt bleibt als Geschäftsführer im Amt.
Die in der Gründungsurkunde enthaltene Rubrik «Zeichnung und Einzahlung» wird wie folgt geändert:
«Alle Gesellschaftsanteile werden von Herrn Heinrich Günter Wollenhaupt, wohnhaft in Lippstadt gehalten.»
Der zweite Absatz dieser Rubrik bleibt unverändert.
<i>Kosteni>
Die Kosten dieser Urkunde sind solidarisch zu Lasten der Gesellschaft und des neuen Gesellschafters.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die Erschienenen, welche dem Notar mit Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt sind mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Brieger, H. Wollenhaupt, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 11 mars 2005, vol. 431, fol. 73, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Für gleichlautende Abschrift, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094705.3/225/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Diekirch, le 15 décembre 2005.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Capellen, den 16. März 2005.
C. Mines.
31197
ILLUMINARE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 11, rue de Drinklange.
R. C. Luxembourg B 92.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02805, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903933.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
PROTEC MBV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 93.754.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02802, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903934.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
EURO PRO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9030 Warken, 42, Cité Warkdall.
R. C. Luxembourg B 93.723.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07559, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, en décembre 2005.
(903954.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
DE JONGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9632 Alscheid, 20, Um Bëchel.
R. C. Luxembourg B 100.318.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07560, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, en décembre 2005.
(903955.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
EDENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8075 Strassen, 28, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 43.791.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01132, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001356.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>EURO PRO SERVICES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>DE JONGE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
Signature.
31198
SCREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.894.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
The company SHATHO BEHEER B.V., with registered office at 142, Sevillaweg, NL-3047 AL Rotterdam, Netherlands,
hereby represented by Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a power of attorney issued under private seal in Rotterdam on December
15th 2005.
Which power of attorney after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to enact that:
- It result of a units purchase agreement under private seal signed on January 31, 2005, duly registered by extract on
December 13, 2005, which extract has been put on the Trade and Companies Register of Luxembourg on December
16, 2005, that it is the sole member of the company SCREEN, S.à r.l., having its registered office at L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (hereinafter «the Company»), registered to the Luxembourg Trade and
Companies Register under section B and number 104.894, incorporated by a deed of the undersigned notary, on De-
cember 10, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 244, dated March 18, 2005;
- The Company’s capital is established at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one
hundred and twenty-five) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully subscribed
and entirely paid up.
- In its capacity as sole member of the Company, it has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dis-
solution of the Company and to put it into liquidation;
- The sole member declares that it is perfectly aware of the financial situation and the Company’s articles of associ-
ation;
- The sole member gives discharge to the Manager for the execution of their mandate until the present day.
- The sole member acting as liquidator, declares having settled all the Company’s liabilities and will be personally an-
swerable for all the Company’s debts and undertakings, even currently unknown;
- The sole member is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of
the terminated Company, even currently unknown;
- Following the above-resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- There should be proceeded to the cancellation of the corporate units register;
- The books and Company’s documents will be kept at the Company’s registered office for five years.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meet-
ing, is estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appear-
ing person, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof, the present deed was drawn-up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
A comparu:
La société SHATHO BEHEER B.V., avec siège social au 142, Sevillaweg, NL-3047AL Rotterdam, Pays-Bas, ici repré-
sentée par Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Rotterdam le 15 décembre 2005.
Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes.
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a demandé au notaire d’acter que:
- Il résulte d’un acte de cession de parts sociales sous seing privé signé le 31 janvier 2005, dûment enregistré par
extrait le 13 décembre 2005, lequel extrait a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 16
décembre 2005, qu’elle est l’associée unique de la société à responsabilité limitée SCREEN, S.à r.l., ayant son siège social
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (ci-après «la Société»), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 104.894, constituée suivant acte reçu par le
31199
notaire instrumentant, le 10 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 244
du 18 mars 2005;
- Le capital social de la Société s’élève à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-
cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées;
- En sa qualité d’associée unique de la Société, elle a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la
Société et de la mettre en liquidation;
- L’associée unique déclare qu’elle a toute connaissance de la situation financière et des statuts de la Société;
- L’associée unique donne décharge pleine et entière au gérant de la Société pour l’exécution de son mandat jusqu’à
ce jour;
- L’associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société déclare avoir réglé tout le passif de la Société, et qu’elle
sera personnellement responsable de toutes les dettes et de tous les engagements de la Société, même actuellement
inconnus;
- L’associée unique est donc investie de tout l’actif de la Société et s’engage à régler tout et n’importe quel passif
éventuel de la Société dissoute, même actuellement inconnu;
- Suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- Il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des parts sociales;
- Les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l’ancien siège de
la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée, est
estimé à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la requête de la personne comparante, dûment re-
présentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et, à la requête de la même personne, en
cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête de ce document.
Et lecture faite à la mandataire, ès qualités qu’elle agit, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Lyon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 151S, fol. 68, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(004153.3/222/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
ARCADIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 107, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 93.551.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07429, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, en décembre 2005.
(903956.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
DGG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 102.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00557, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2006.
(001472.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 9 janvier 2006.
T. Metzler.
<i>Pouri> <i>ARCADIA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
GH TRUST
Signature
31200
CLEARWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9748 Eselborn, 10, Cité Schleed.
R. C. Luxembourg B 101.530.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07420, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, en décembre 2005.
(903957.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
HOPLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Walsdorf.
R. C. Luxembourg B 93.019.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03416, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, en décembre 2005.
(903958.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
NOUVELLE SOCIETE DU MAGASIN KLEIN-ANGELSBERG ETTELBRUCK, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9161 Ingeldorf, 20, Clos du Berger.
R. C. Luxembourg B 99.469.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03410, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, en décembre 2005.
(903959.3/568/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
AVENIDA MODA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9161 Ingeldorf, 20, Clos du Berger.
R. C. Luxembourg B 107.150.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03402, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, en décembre 2005.
(903960.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
<i>Pouri> <i>CLEARWAY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>HOPLA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>NOUVELLE SOCIETE DU MAGASIN KLEIN-ANGELSBERG ETTELBRUCK, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>AVENIDA MODA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Nordmazout S.A.
D’Pettener Schlësserei, S.à r.l.
Chantraine Commerciale, S.à r.l.
Roncadin Holdings SCA
Rentco S.A.
LCA Luxembourg II, S.à r.l.
Hôtel Koener, S.à r.l.
InterKoener S.A.
Hilger S.A.
Hilger S.A.
Hilger S.A.
Garage Scheuren, S.à r.l.
Nordliicht, S.à r.l.
Thewes, S.à r.l.
Climmolux
Climmolux
Aberdeen Investment Services S.A.
Op der Lay, S.à r.l.
Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l.
Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l.
Avante Colombia, S.à r.l.
Taxi des Trois Frontières, S.à r.l.
Taxi des Trois Frontières, S.à r.l.
ING PFCE Poland II, S.à r.l.
ING PFCE Poland II, S.à r.l.
Indusol, S.à r.l.
Topsolar, S.à r.l.
Nouveau Garage Agra-Nord, S.à r.l.
Nouveau Garage Agra-Nord, S.à r.l.
Ramoge S.A.
EMCK, S.à r.l.
EMCK, S.à r.l.
BLN, GmbH
BLN, GmbH
Millesima 99, S.à r.l.
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüftung, Haustechnik
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüftung, Haustechnik
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüftung, Haustechnik
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüftung, Haustechnik
Zephyr Investments S.A.
NET s IT e.lu, S.à r.l.
NET s IT e.lu, S.à r.l.
Capi, S.à r.l.
Euroflam
S-Team S.A.
HOBO S.A.
Traditionell Bauen, S.à r.l.
Dometic Holding, S.à r.l.
Dometic, S.à r.l.
Telluride S.A.
Maurach A.G.
Maurach A.G.
P & W CNC Umformtechnik, S.à r.l.
Lux Stahl A.G.
Brever M, S.à r.l.
P & W CNC Umformtechnik, S.à r.l.
Illuminare, GmbH
Protec MBV, S.à r.l.
Euro Pro Services, S.à r.l.
De Jonge, S.à r.l.
Edens S.A.
Screen, S.à r.l.
Arcadia, S.à r.l.
DGG, S.à r.l.
Clearway, S.à r.l.
Hopla, S.à r.l.
Nouvelle Société du Magasin Klein-Angelsberg Ettelbruck, S.à r.l.
Avenida Moda, S.à r.l.