This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
5473
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 115
17 janvier 2006
S O M M A I R E
WIND RIVER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 105.903.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 septembre 2005 de la société WIND RIVER
(LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg que l’élection de M. Troy
William Thacker ayant comme adresse professionnelle Fox Paine and Company, LLC, 950 tower Lane, Suite 1150, Fos-
ter City, CA. 94404, USA, en tant que Gérant est acceptée. Il est élu pour une durée indéteminée.
Luxembourg, le 7 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02878. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081763.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
1. SICAV, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5519
Indian Investment Company, Sicav, Luxembourg
5519
Anne Wéry Editions et Ressources, S.à r.l., Lu-
King’s Cross Asset Funding N° 6, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5512
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5512
(The) Asian Technology Fund, Sicav, Luxembourg
5520
Lamar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5494
Bella Marta, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
5501
Monte Cervino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5513
Brookbylux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5505
Motwit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5519
Brookbylux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5512
Nell US Acquisition, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
5503
COVALBA S.A., Comptoir de Valeurs de Banque,
Nell US Acquisition, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
5505
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5517
Neomed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5502
Conventum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5518
Ofilux Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5518
Corelia S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5493
PLD Germany VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
5517
Delta Lloyd Real Estate Management Company,
ProLogis Netherlands XI, S.à r.l., Luxembourg. . .
5520
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5487
Quilvest Managers Sicar S.A., Luxembourg . . . . .
5475
Financière de Beaufort S.A., Luxembourg . . . . . . .
5518
Sharpwell Technology, OEM S.A., Mondorf-les-
HSBC Partners Group Global Private Equity,
Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5512
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5474
Wind River (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .
5473
I.G.C., International Group Company S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5518
Pour extrait conforme
B. Zech
5474
HSBC PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 105.942.
—
In the year two thousand five, on the fifteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
Was held:
An extraordinary general meeting of shareholders of HSBC PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY (here-
after referred to as the «Company»), a société d’investissement à capital variable, having its registered office in L-2163
Luxembourg, 40, avenue Monterey, registered in the trade register of Luxembourg under number B 105.942. The arti-
cles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») were published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 18 February 2005.
The meeting was opened at 11 o’clock with Mrs Céline Labarsouque, bank employee, residing in Rémeling (France)
in the chair
who appointed as secretary Mrs Debra Adams, bank employee, residing in Hombourg-Budange (France).
The meeting elected as scrutineer Mrs Géraldine Astgen, bank employee, residing in Arlon (Belgium).
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
Approval of a proposal to amend the 3rd paragraph of article 21 of the Articles of Incorporation so as to read as
follows:
«Following the aforementioned twenty-four months period, net redemptions from any shareholder will be limited
per calendar quarter to 5% of the number of shares held by the relevant shareholder at the end of the preceding quarter
provided that the directors may waive such restriction partly (by determining a higher percentage) or totally, based on
the investment adviser’s analysis of available liquidity, by giving prior notice to that effect to all shareholders at least one
month before the beginning of the relevant calendar quarter»
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders, the board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders initialled «ne varietur» by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III.- As appears from the said attendance list, out of 463,988 outstanding shares, 455,711 shares are present or rep-
resented at the present Extraordinary General Meeting.
IV.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by reg-
istered mail to the shareholders on November 15, 2005.
V.- As a result of the foregoing, the present extraordinary general meeting (the «Meeting») is regularly constituted
and may validly deliberate on the items on the agenda.
After deliberation, the Meeting takes the following resolution:
The Meeting by 455,711 votes in favour decides to amend the 3rd paragraph of article 21 (2nd sentence of the 2nd
paragraph of article 21 of the French translation) of the Articles of Incorporation. This paragraph will now read as fol-
lows:
«Following the aforementioned twenty-four months period, net redemptions from any shareholder will be limited
per calendar quarter to 5% of the number of shares held by the relevant shareholder at the end of the preceding quarter
provided that the directors may waive such restriction partly (by determining a higher percentage) or totally, based on
the investment adviser’s analysis of available liquidity, by giving prior notice to that effect to all shareholders at least one
month before the beginning of the relevant calendar quarter»
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the registered offices of the Company, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting signed together with Us,
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie:
l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de HSBC PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY,
(ci-après la «Société»), une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40,
5475
avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.942. Les sta-
tuts de la Société (ci-après les «Statuts») ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémo-
rial») du 18 février 2005.
L’assemblée fut ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Céline Labarsouque, employée de banque,
résidant à Rémeling (France),
qui désigne comme secrétaire Madame Debra Adams, employée de banque, résidant à Hombourg-Budange (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Géraldine Astgen, employée de banque, résidant à Arlon (Belgium).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jouri>
Approbation d’une proposition de modifier le 3e paragraphe de l’article 21 des Statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«A la fin de la période de vingt-quatre mois précitée, les rachats nets de chaque actionnaire seront limités par trimes-
tre à 5% des actions détenues par l’actionnaire concerné à la fin du trimestre précédant étant entendu que les adminis-
trateurs peuvent renoncer partiellement (en déterminant un autre pourcentage) ou totalement à une telle restriction
en fonction des analyses du conseiller en investissement concernant la liquidité disponible, en donnant un préavis à cet
effet d’au moins un mois à tout actionnaire avant le début du trimestre concerné.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Qu’il apparaît de ladite liste de présence que sur les 463.988 actions en circulation, 455.711 actions sont présentes
ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée générale a été convoquée par lettre recommandée contenant l’ordre du jour envoyée
le 15 novembre 2005.
V.- En conséquence, la présente Assemblée Générale Extraordinaire (l’«Assemblée») est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend la résolution suivante:
L’Assemblée par 455.711 votes en faveur décide de modifier le texte de la 2
e
phrase du 2
e
paragraphe de l’article 21
(3
e
alinéa de l’article 21 dans la version anglaise) des Statuts. Ce paragraphe aura la teneur suivante:
«A la fin de la période de vingt-quatre mois précitée, les rachats nets de chaque actionnaire seront limités par trimes-
tre à 5% des actions détenues par l’actionnaire concerné à la fin du trimestre précédant étant entendu que les adminis-
trateurs peuvent renoncer partiellement (en déterminant un autre pourcentage) ou totalement à une telle restriction
en fonction des analyses du conseiller en investissement concernant la liquidité disponible, en donnant un préavis à cet
effet d’au moins un mois à tout actionnaire avant le début du trimestre concerné.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est dès lors close.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des com-
parants les présents statuts ont été rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des mêmes
comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec le notaire le pré-
sent acte.
Signé: C. Labarsouque, D. Adams, G. Astgen et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2005, vol. 434, fol. 48, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112839.2/242/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
QUILVEST MANAGERS SICAR S.A., Société d’Investissement en Capital à Risque.
Registered office: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 113.121.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) QUILVEST SERVICES LIMITED, a corporation incorporated under the laws of the British Virgin Islands with its
registered office at Craigmur Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Island, represented by Mr
Xavier Le Sourne, maître en droit, residing in Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, pursuant
to a proxy dated 28th December 2005.
Mersch, le 19 décembre 2005.
H. Hellinckx.
5476
2) QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, Société Anonyme, a corporation incorporated under the laws of
Luxembourg with its registered office at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, represented by Mr Xavier Le Sourne, pre-
named, pursuant to a proxy dated 28th December 2005.
The proxies signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
a société anonyme which they form between themselves:
Art. 1. Form, name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of
the shares hereafter issued a corporation in the form of a société anonyme, under the name of QUILVEST MANAGERS
SICAR S.A. (the «Corporation»).
Art. 2. Duration. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at
any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the articles of incorpo-
ration of the Corporation (the «Articles») as prescribed in Article 23 hereof.
Art. 3. Object. The exclusive object of the Corporation is to invest its assets in securities and other assets repre-
senting risk capital within the meaning of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital (the «Sicar
Law») in order to provide its investors with the benefit of the result of the management of its assets in consideration
of the risk which they incur.
The Corporation may hold on an ancillary basis liquid assets such as, but not limited to, cash or bank deposits or
money market instruments with a maturity of less than twelve months and may further take any measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent per-
mitted by the SICAR Law.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. The regis-
tered office may be transferred within Luxembourg-City by decision of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. Capital - Shares
(a) The subscribed share capital of the Corporation is set at Euro thirty-one thousand (EUR 31,000.-) divided into
three thousand one hundred (3,100), shares entirely subscribed and paid-in, with a par value of Euro ten (EUR 10.-) per
share.
(b) The authorized capital of the Corporation is set at Euro thirty million (EUR 30,000,000.-) divided into three million
(3,000,000) shares with a par value of Euro ten (EUR 10.-) per share.
The board of directors may delegate under its responsibility and supervision to any duly authorized officer of the
Corporation or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving
payment for shares to be issued.
(c) Within the limits of the authorized share capital and until the fifth anniversary of the publication of the Articles in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») the board of directors is authorized to issue shares
for a total subscription price of Euro thirty million (EUR 30,000,000.-). The duration of this power may be extended by
the general meeting of shareholders from time to time.
The Corporation shall issue two Classes of shares (the «Classes»), the proceeds of the issue of each Class being in-
vested pursuant to Article 3 hereof:
(i) Class A Shares will be issued exclusively to companies within the Quilvest group; and
(ii) Class B Shares will be issued to well-informed members of the team of managers employed by the Quilvest group
that advises the Board of Directors with respect to the Corporation’s investments. Consequently, Class B Shares will
be designated in as many different numerical sequences as there will be different team members.
Transactions shall be funded either by way of direct investment of the Corporation into the portfolio companies or
alternatively and upon discretionary decision of the board of directors, by way of indirect funding of the portfolio com-
panies through investment entities incorporated ad hoc.
The Board may decide to issue partly paid Shares, a minimum of 5% of which must be paid in. The Board may further
decide to issue Shares with a share premium or any other acceptance fee to be accounted for in the share premium
account of the Corporation.
(d) Investors will commit to make investments in shares and fund the transactions. Subscriptions by eligible investors,
as defined under section (f) of this article, will be accepted by the board until the end of the first Closing. Confirmation
of accepted subscriptions will be sent to investors. The board may subsequently decide to offer to existing shareholders,
as well as to other eligible persons, the opportunity to subscribe for additional shares at any subsequent Closing, as the
board of directors may find appropriate. The subscription price for each share is payable on a date determined by the
board of directors. The board of directors acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the pro-
cedures relating to closings, payments of subscribed shares and related share premium or acceptance fees and exercise
of the subscription rights attached to the shares and will more fully disclose those in the sales documents of the Cor-
5477
poration and the agreement which may be entered into by a shareholder determining among other things its subscrip-
tion commitment.
(e) Each time the board of directors shall elect to render effective in all or in part the increase of capital as authorized
by the foregoing provisions, this Article five of these Articles shall be amended so as to reflect the result of such action
and the board of directors shall take or authorize any necessary step for the purpose of obtaining execution and publi-
cation of such amendment in accordance with law.
(f) Shares may only be subscribed by well-informed investors within the meaning of article 2 of the Sicar Law, i.e. (i)
by any institutional investor, professional investor or (ii) any other investor who confirms in writing that he adheres to
the status of well-informed investor and who (a) invests or commits to invest a minimum of 125,000.- EUR in the Cor-
poration or (b) has obtained an assessment by a credit institution or another professional of the financial sector certi-
fying his expertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment in risk capital.
Shares will be in registered form only.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are validly registered in the register of share-
holders as the full owner of such shares.
Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder.
Art. 6. Increase of capital. The authorized capital of the Corporation as described under article 5 (b) may be in-
creased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Arti-
cles, as prescribed in Article 23 hereof.
Art. 7. Transfer, pledge and assignment of shares. Any transfer, pledge or assignment of shares in the Corpo-
ration, whether free of charge or in return for a consideration, shall require the prior written consent of the board of
directors.
Where the board of directors has agreed to a transfer, pledge or assignment in relation to shares, then the purchaser,
pledgee or assignee thereof shall comply with the provisions set forth under Article 5 here above and accept to take
over any outstanding commitments and other liabilities of the transferor towards the Corporation.
The board of directors shall have twenty (20) business days from the date upon which notification of any intended
transfer, pledge or assignment is dispatched to it to take its decision, which shall not require any justification.
Art. 8. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corpora-
tion shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order,
carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in
accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting on the last Thursday of the month of June, each year at 3 p.m.
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of
directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 10. Board of directors. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three mem-
bers at least who need not be shareholders of the Corporation. A majority of the board of directors shall at all times
comprise persons not resident for tax purposes in the United Kingdom.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and
shall hold office until their successors are elected.
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-
ers.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 11. Procedures of meeting of the board of directors. The board of directors may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and
of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of
meeting.
5478
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-
holders or the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex
another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman shall have a casting vote.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
A director may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of directors by means of a
telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the
meeting can hear each other and speak to each other.
The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate in-
struments in writing or by telex, cable, telegram or facsimile transmission confirmed in writing which shall together con-
stitute appropriate minutes evidencing such decision.
Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors. The minutes of any meeting of the board of directors
shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two directors.
Art. 13. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the
present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate under its own responsibility and supervision its powers to conduct the daily
management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs,
with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board who may constitute
committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special man-
dates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emolu-
ments.
Art. 14. Binding signatures. The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Cor-
poration or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been
delegated by the board of directors.
Art. 15. Independent Auditor. The operations of the Corporation and its financial situation including particularly
its books shall be supervised by an independent auditor («réviseur d’entreprises agréé») who shall satisfy the require-
ments of Luxembourg law as to honorableness and professional experience and who shall carry out the duties pre-
scribed by the SICAR Law. The independent auditor shall be elected by the general meeting of shareholders.
The first independent auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the in-
corporation of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.
The independent auditor in office may only be removed by the shareholders on serious grounds.
Art. 16. Redemption of Shares. Shares of the Corporation are redeemable by the Corporation upon determina-
tion by the board of directors only. No redemption may be requested by the holders of shares.
The Corporation may at the entire discretion of the board of directors redeem shares up to the amount and under
the conditions specified by the board of directors in a notice served to shareholders. Upon receipt of such a notice,
shareholders may ask for redemption of whole or part of their shares. Applications for redemption received in excess
of the amount to be redeemed will automatically be rejected.
Notwithstanding the foregoing, redemptions of shares shall normally be effected pro rata the respective number of
shares held by each shareholder.
In this case, the Corporation shall also serve a notice upon the person appearing in the register of shareholders as
the owner of shares, specifying the number of shares to be redeemed, the Valuation Date as defined hereafter and the
date on which such redemption will be effective (the «Redemption Date»).
Immediately after the close of business on the Redemption Date specified in the redemption notice (and whether or
not such holder(s) of shares shall have provided the bank account information required below) such holder(s) of shares
shall cease to be the owner(s) of the shares referred to in the redemption notice and his (their) name shall be removed
as the holder(s) of such shares from the register of shareholders. Any such person will cease to have any rights as a
5479
shareholder in the Corporation with respect to the shares so redeemed as from the close of business of the Redemption
Date specified in the redemption notice referred to above.
In any case, the redemption notice shall be served upon holder(s) of shares by sending the same by mail addressed
to such holder(s) of shares at his (their) last address appearing in register of shareholders or known to the Corporation.
The holder(s) of shares concerned shall thereupon forthwith be obliged to indicate a bank account to which the re-
demption price for his (their) shares redeemed is to be transferred to.
The redemption price to be paid for each share so redeemed (the «Redemption Price») shall be the Net Asset Value
of such share calculated as at the next Valuation Date, less an amount, if any, equal to any duties and charges which will
be incurred upon the disposal of the Corporation’s investments as at the Redemption Date in order to make such a
redemption.
Payment of the Redemption Price shall be made by the Corporation to the bank account indicated by the holder(s)
of shares concerned or as may be agreed between the parties. In the event the holder(s) of shares concerned does not
indicate a bank account to which the Redemption Price shall be transferred, the Corporation may either deposit such
amount on an account opened for such purpose or send a cheque for such amount to the last address of such holder(s)
of shares appearing in register of shareholders or known to the Corporation, each time at the sole risk and costs of the
holder(s) of shares concerned. Upon transfer or deposit of the Redemption Price or the posting of a cheque as aforesaid,
no person interested in the relevant shares redeemed pursuant to the redemption notice shall have any further interest
in shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof or of the Redemption
Price.
Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.
Art. 17. Valuation Date. The net asset value of shares shall, for the purposes of the redemption and issue of shares,
be determined by the Corporation from time to time, but in no instance less than twice annually, as the board of direc-
tors by regulation may direct (every such day or time for determination of Net Asset Value being referred to herein as
a «Valuation Date»).
Art. 18. Determination of Net Asset Value The net asset value of shares (the «Net Asset Value») in the Cor-
poration shall be expressed in euro as a per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date. For
that purpose, the board of directors shall value separately each pool of assets and liabilities to be created for each Class
created within the Corporation. In the accounts of the Corporation, it shall be established specific pools as follows:
a) the proceeds to be received from the issue of shares of different Classes in connection with a transaction shall be
applied in the books of the Corporation to the pool established for such Class and, as the case may be, the assets and
liabilities and income and expenditure attributable to such pool shall be applied to the corresponding pool subject to
the following provisions;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corpora-
tion to the same pool as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or
diminution in value shall be applied to the relevant pool;
c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall for internal accounting purposes be allocated to the
relevant pool provided however that all liabilities, whatever pool they are attributable to for internal accounting pur-
poses, will as a legal matter be binding upon and liabilities of the Corporation as a whole;
d) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the Net Asset Values of the relevant pools.
Equity investments in portfolio companies or investment entities shall be valued as follows:
- at cost in the case of portfolio companies or investment entities acquired in the 12 months period prior to the
Valuation Date unless the board of directors considers that there has been a material deterioration in the financial sit-
uation of such portfolio companies or investment entities.
- at the foreseeable sales price estimated in good faith, in the case of portfolio companies or investment entities ac-
quired more than 12 months prior to the Valuation Date.
- Liquid assets shall be valued at their face value with interest accrued.
The board of directors may however adopt other fair valuation methods, when circumstances or market conditions
so warrant. The value of assets denominated in a currency other than the Euro shall be determined by taking into ac-
count the rate of exchange prevailing at the time of the determination of the Net Asset Value.
The Net Asset Value will be made available to shareholders at the registered office of the Corporation together with
the annual report (as of the Valuation Date of 31st December) and with the half-year financial accounts (as of the Val-
uation Date of 30th June).
For the purpose of determining the net asset value of a pool assets and liabilities denominated in a currency other
than Euro shall be converted into Euro at the rate of exchange in force at the Valuation Date as determined by the board
of directors.
The Corporation may suspend the determination of the net asset value of shares in exceptional cases where circum-
stances so require and provided the suspension is justified having regard to the interests of shareholders when:
(a) the net asset value of any underlying investment is itself suspended or cannot be determined accurately so as to
reflect the fair market value of the assets of the Corporation as at the Valuation Date;
(b) any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the investments of the Corpo-
ration are quoted is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or sus-
pended;
(c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of
assets owned by the Corporation would be impracticable;
5480
(d) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the invest-
ments or the current prices on any market or stock exchange; or
(e) any period when the Corporation is unable to repatriate funds or during which any transfer of funds involved in
the realization or acquisition of investments cannot in the opinion of the board of directors be effected at normal rates
of exchange.
Any such suspension shall be notified to the investors requesting issue of shares.
Art. 19. Custodian Agreement The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall
satisfy the requirements of Luxembourg laws and in particular of the SICAR Law (the «Custodian»). All securities and
cash of the Corporation are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Corporation
and its shareholders the responsibilities provided by the law.
Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year
and shall terminate on the 31st of December of the same year.
Art. 21. Appropriation of profits. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of
directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever ex-
ceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-
rectors.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such
share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders
of shares.
Art. 22. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Corporation or, upon decision of the
board of directors, of one Class of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders resolving on such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
The net proceeds of liquidation shall be distributable by the liquidators to the holders of shares. The net proceeds
may be distributed in kind. Proceeds which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquida-
tion of the Corporation or the Class concerned will be deposited with the Custodian for a period of six months after
the close of liquidation. After such time, the assets will be deposited in escrow with the Caisse de Consignation on behalf
of their beneficiaries.
Art. 23. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-
ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 24. Governing law. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended and the SICAR Law.
<i>Transitory dispositionsi>
(1) The first accounting year will begin on the date of the incorporation of the Corporation and will end on 31st
December 2006.
(2) The first annual general meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of incorporation of the Corporation having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing
parties has subscribed and entirely paid up the following shares:
Proof of the payment has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately five thousand euro.
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
Shareholders
Subscribed
Number
Capital
of shares
1. QUILVEST SERVICES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 30,990
3,099 shares
2. QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP Société Anonyme. . . . . . . . . . . . . EUR 10
1 share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 31,000
3,100 shares
5481
I. «KPMG Audit», having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg is appointed as independent
auditor («réviseur d’entreprises agréé») for a term to expire at the next annual ordinary general meeting.
II. The registered office is fixed at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
III. The following persons are appointed as directors of the Corporation:
a. Mr Christian Baillet, CEO, with professional address at 243, bd St. Germain, F-75007 Paris
b. Mr F. Michel Abouchalache, CEO Private Equity, with professional address at 243, bd St. Germain, F-75007 Paris
c. Mr Carlo J. Hoffmann, secrétaire general, with professional address at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg
d. Mr Georges Majerus, expert-comptable, with professional address at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg,
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surname,
first name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) QUILVEST SERVICES LIMITED, société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège so-
cial à Craigmur Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Island, représentée par Monsieur Xavier Le
Sourne, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg en vertu d’une pro-
curation datée du 28 décembre 2005.
2) QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, Société Anonyme, société constituée selon les lois du Grand-Du-
ché de Luxembourg, ayant son siège social au 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, représentée par Monsieur Xavier
Le sourne, prénommé, en vertu d’une procuration datée du 28 décembre 2005.
Les procurations susmentionnées, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées à ce document pour être soumises à l’enregistrement.
Les comparants, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter comme suit les statuts d’une so-
ciété anonyme qu’ils déclarent constituée entre eux:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination sociale. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui en deviendront
actionnaires, une société sous la forme d’une société anonyme, sous le nom de QUILVEST MANAGERS SICAR S.A. (la
«Société»).
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une période illimitée. La Société peut être à tout moment dissoute par
une décision des actionnaires qui sera adoptée de la manière requise pour la modification des statuts (les «Statuts»),
telle que stipulée à l’Article 23 des présents Statuts.
Art. 3. Objet Social. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose dans des valeurs et autres
actifs représentant du capital à risque, au sens de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital
à risque (la «loi sur les SICAR»), dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses actifs
en contrepartie du risque qu’ils encourent.
La Société peut détenir à titre accessoire des actifs liquides tels que, des espèces ou des dépôts bancaires ou des
instruments du marché monétaire ayant une échéance inférieure à douze mois et prendra par la suite toutes les mesures
et effectuera toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social
dans les limites les plus larges prévues par la loi sur les SICAR.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré
à l’intérieur de Luxembourg-Ville, par décision du conseil d’administration. Il peut être créé des succursales ou autres
bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, par décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social; de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre le
siège et des personnes se trouvant à l’étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 5. Capital - Actions
(a) Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100)
actions ayant un pair comptable de dix Euros (10,- EUR) par action, entièrement souscrites et libérées.
(b) Le capital social autorisé est fixé à trente millions d’Euros (30.000.000,- EUR) divisé en trois millions d’actions
ayant un pair comptable de dix Euros (10,- EUR) par action.
Le conseil d’administration pourra déléguer à tout membre de la Société dûment autorisé ou à toute personne dû-
ment autorisée le devoir d’accepter les souscriptions et de délivrer ainsi que de recevoir paiement des actions devant
être émises.
5482
(c) Dans les limites fixées par le capital social autorisé et jusqu’au cinquième anniversaire de la publication des Statuts
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le conseil d’administration est autorisé à émettre
des actions pour un prix de souscription totale de trente millions d’Euros (30.000.000.- EUR). La durée de cette auto-
risation pourra être prorogée par l’assemblée générale des actionnaires.
La Société émettra deux classes d’actions (les «Classes»), dont le produit d’émission sera investi conformément aux
dispositions de l’article 3 ci-dessus:
(i) les actions de la classe A seront émises exclusivement aux sociétés du groupe Quilvest; et
(ii) les actions de la classe B seront émises aux investisseurs avertis membres des équipes de gestionnaires employés
par le groupe Quilvest et qui fournissent des conseils au conseil d’administration concernant les investissements de la
Société. En conséquence, les actions de la classe B seront désignées par autant de séquences numériques différentes
qu’il y aura de membres différents dans ces équipes.
Les transactions seront financées soit par voie d’investissement direct de la Société dans les sociétés de portefeuille
soit en vertu d’une décision discrétionnaire du conseil d’administration, par voie de financement indirect au profit des
sociétés de portefeuille, à travers des sociétés d’investissement constitués ad hoc.
Le conseil d’administration peut décider d’émettre des actions partiellement libérées, pour lesquelles un minimum de
5% doit être versé. Le conseil d’administration peut, par ailleurs, décider d’émettre des actions avec prime d’émission
ou tout autre droit d’entrée devant être comptabilisés dans les comptes sous la catégorie primes d’émission.
(d) Les investisseurs s’engagent à investir dans des actions et à financier les transactions. Les souscriptions par les
investisseurs éligibles, comme défini sous la section (f) de cet article, seront acceptées par le conseil jusqu’à la fin du
premier closing. Confirmation sera envoyée aux investisseurs que leur souscription a été acceptée. Le conseil pourra
lorsqu’il l’estime approprié, décider par la suite d’offrir aux actionnaires existants, ainsi qu’à toute autre personne éligi-
ble, l’opportunité de souscrire à des actions supplémentaires lors de tout closing subséquent. Le prix de souscription
pour chaque action sera dû à la date déterminée par le conseil d’administration. Le conseil d’administration agissant pour
le compte de la Société a un pouvoir discrétionnaire quant à l’organisation des procédures de closings, aux paiements
des actions souscrites et aux primes qui y sont attachées ou encore aux frais d’acceptation et à l’exercice des droits de
souscription attachés aux actions et il renseignera ces derniers dans les documents de vente de la Société et dans les
contrats qui pourront être conclus par un actionnaire déterminant entre autres ces engagements de souscription.
(e) Chaque fois que le conseil d’administration devra voter, afin de rendre effective, pour partie ou en totalité, une
augmentation de capital telle qu’ autorisée par les dispositions précédentes, cet article 5 des Statuts devra être modifié
afin de refléter le résultat d’une telle action et le conseil d’administration devra prendre ou autoriser toute mesure né-
cessaire pour atteindre l’objectif relatif à l’exécution et à la publication d’une telle modification en accord avec les dis-
positions légales.
(f) Les actions ne pourront être souscrites que par des investisseurs avertis au sens de la loi sur les SICAR, c’est-à-
dire (i) par tout investisseur institutionnel, tout investisseur professionnel ou (ii) tout autre investisseur confirmant par
écrit qu’il a le statut d’un investisseur averti et (a) qui s’engage à investir un minimum de cent vingt-cinq mille Euros
(125.000,- EUR) dans la Sicar ou (b) qui a reçu d’un établissement de crédit ou d’un autre professionnel du secteur fi-
nancier une attestation certifiant de son expertise, son expérience et sa faculté à évaluer de manière adéquate un inves-
tissement dans du capital à risque.
Les actions seront uniquement émises sous la forme nominative.
La Société devra considérer comme étant le propriétaire des actions, la personne au nom de laquelle les actions se-
ront valablement enregistrées dans le registre des actionnaires.
Des certificats attestant d’une telle inscription pourront être délivrés aux actionnaires.
Art. 6. Augmentation de capital. Le capital social de la Société, tel que décrit sous l’article 5 (b), peut être aug-
menté ou réduit par décision des actionnaires prise en la forme requise pour la modification des Statuts, conformément
aux dispositions de l’article 23 des présents Statuts.
Art. 7. Transfert, nantissement et cession des actions. Tout transfert, nantissement ou cession d’actions au
sein de la Société, s’effectuant à titre gratuit ou onéreux, nécessite l’autorisation préalable et écrite du conseil d’admi-
nistration.
Lorsque le conseil d’administration a autorisé un transfert, nantissement ou une cession d’actions, alors l’acquéreur,
le créancier gagiste ou le cessionnaire devra répondre aux critères de conformité exposés à l’article 5 ci-dessus et devra
accepter de répondre de tout engagement contractuel pris, et autres responsabilités du cédant envers la Société.
Le conseil d’administration disposera de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date à laquelle toute notification
de transfert, nantissement ou cession de parts lui sera communiqué afin de prendre sa décision, cette dernière ne né-
cessitant pas de justification.
Art. 8. Assemblée d’actionnaires - Généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représente l’ensemble des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire
ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Chaque action dispose d’une voix. Un actionnaire pourra agir à chaque assemblée d’actionnaires en désignant par
écrit, par câble ou télégramme ou télex, une autre personne comme étant son mandataire.
A défaut de disposition légale contraire, les décisions d’assemblée d’actionnaires dûment convenues seront approu-
vées par simple majorité des actionnaires présents ou votant.
Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition devant être remplie par les actionnaires afin qu’ils
puissent prendre part à toute assemblée d’actionnaires.
5483
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires, et s’ils déclarent avoir
été informés de l’ordre du jour de celle-ci, l’assemblée pourra se tenir sans notification préalable ou publication.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires devra
se tenir, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Luxembourg,
qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année, à 15 heures.
Si ce jour est férié au Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant.
L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 10. Le conseil d’administration. La Société sera dirigée par le conseil d’administration, composé d’au moins
trois membres qui n’ont pas l’obligation d’être actionnaires de la Société. Le conseil d’administration ne devra, à aucun
moment, compter une majorité des membres résidants fiscaux du Royaume-Uni.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une durée maximale
de six ans et conserveront cette fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Un administrateur peut être révoqué, de manière justifiée ou non, et remplacé à tout moment par une décision prise
par les actionnaires.
En cas de vacance du poste d’administrateur pour cause de décès, retraite ou autre raison, les administrateurs res-
tants éliront, à la majorité des votes, un administrateur chargé d’y suppléer lors de ladite vacance, et ce jusqu’à la pro-
chaine assemblée des actionnaires.
Art. 11. Les procédures relatives aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration
pourra désigner, au sein de ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi désigner un secrétaire,
n’ayant pas forcément la qualité d’administrateur, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réu-
nions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration devra se réunir à la demande du président ou de deux administrateurs au lieu mentionné
dans l’avis de réunion.
Le président dirigera chaque assemblée d’actionnaires et réunion du conseil d’administration, toutefois en son absen-
ce l’assemblée des actionnaires ou le conseil d’administration désignera un président pro tempore par un vote à la ma-
jorité présente à cette assemblée ou à cette réunion.
Une notification écrite de toute réunion du conseil d’administration devra être donnée à chaque administrateur au
moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour ladite réunion sauf dans l’hypothèse de la survenance de circonstan-
ces d’urgences dont la nature sera exposée dans la notification d’une telle réunion. Il pourra être dispensé de l’envoi
d’une telle notification par le consentement de chaque administrateur par écrit ou par fax ou télégramme ou télex. Des
avis spécifiques ne seront pas requis pour des réunions individuelles tenues à des heures et lieux prévus par un pro-
gramme établi par décision du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra agir à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par fax ou té-
légramme ou télex un autre administrateur comme étant son mandataire. Les votes pourront également s’effectuer par
écrit, par fax ou télégramme ou télex ou téléphone, pourvu que dans une telle hypothèse, le vote soit confirmé par écrit.
Le conseil d’administration pourra délibérer ou agir valablement, à la condition qu’au moins la majorité des adminis-
trateurs soient présents ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Les décisions devront être prises à
la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à une telle réunion. A toute réunion, en cas d’égalité
de nombre de votes en faveur ou en défaveur d’une décision, le président disposera d’une voix prépondérante.
Dans l’hypothèse où l’un des administrateurs ou membres de la Société aurait un quelconque intérêt personnel dans
quelque transaction que ce soit en rapport avec la Société (autre que ceux provenant du fait d’agir en tant qu’adminis-
trateur, membre ou employé de l’autre partie co-contractante), l’administrateur ou le membre en question devra faire
savoir un tel intérêt personnel au conseil d’administration et devra s’abstenir d’examiner ou de voter les transactions
en question. L’intérêt de l’administrateur ou du membre devra être notifié à la prochaine assemblée d’actionnaires.
Un administrateur aura la possibilité d’assister à une réunion de conseil d’administration et d’être considéré comme
étant présent, au moyen d’une conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication par lequel toutes
les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre et discuter les unes avec les autres.
Les administrateurs, agissant de manière unanime par le biais d’une résolution circulaire, pourront exprimer leur con-
sentement à l’aide d’un ou plusieurs moyen de communications distincts par écrit ou par télex, fax, télégramme ou fax
simulés, confirmé par écrit, qui constitueront ensemble les procès-verbaux appropriés dans le but de prouver une telle
décision.
Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Le procès-verbal de chaque réunion
du conseil d’administration devra être signé par le président, ou en son absence, par le président pro tempore qui aura
dirigé ladite réunion.
Des copies et des extraits de ces procès-verbaux, pouvant être produits au cours d’actions judiciaires ou autres, de-
vront être signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 13. Les pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus
étendus en vue d’accomplir tous les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pou-
voirs non expressément réservés, par la loi ou par les présents Statuts, à l’assemblée générale des actionnaires seront
de la compétence du conseil d’administration.
5484
Le conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs de conduire la gestion journalière et
les affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société dans le cadre de cette gestion ou de ces affaires, et
avec l’accord préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à tout membre ou à tous les membres du conseil d’ad-
ministration qui pourront constituer des comités délibérants selon les termes fixés par le conseil d’administration. Il
pourra également conférer tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, n’ayant pas l’obligation d’avoir la
qualité d’administrateur, afin de nommer ou de révoquer de ses fonctions tous membres et employés et fixer leurs émo-
luments.
Art. 14. Pouvoirs de signature. La Société sera engagée par la signature de deux de ses administrateurs ou par la
signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s), à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d’administration.
Art. 15. Réviseur d’entreprises agréé. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant no-
tamment la tenue de sa comptabilité, seront contrôlées par un réviseur («Réviseur d’Entreprises Agréé»), qui devra sa-
tisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concernant son honorabilité et son expérience professionnelle, et qui
exercera les fonctions prescrites par la loi relative aux SICAR. Le Réviseur d’Entreprises Agréé sera élu par l’assemblée
générale des actionnaires.
Le premier Réviseur d’Entreprises Agréé devra être élu par l’assemblée générale des actionnaires devant se tenir im-
médiatement après la constitution de la Société et remplira cette mission jusqu’à la prochaine assemblée générale an-
nuelle des actionnaires.
Le Réviseur d’Entreprises Agréé exerçant ne pourra être révoqué par les actionnaires que pour motifs graves.
Art. 16. Le rachat des actions. Les actions de la Société ne pourront être rachetées par celle-ci que sur décision
du conseil d’administration. Aucun rachat ne pourra être demandé par les détenteurs d’actions.
Des rachats obligatoires pourront par ailleurs être faits par la Société sur décision du conseil d’administration et selon
les conditions spécifiées par le conseil d’administration dans un avis envoyé aux actionnaires. A réception de cet avis,
l’actionnaire pourra demander le rachat de toute ou partie de ses actions. Les demandes de rachat en excès des mon-
tants de rachats seront automatiquement rejetées.
Nonobstant ce qui précède, les rachats d’actions devront normalement s’effectuer au pro rata du nombre respectif
d’actions détenu par chaque actionnaire.
L’avis de rachat sera envoyé à la (aux) personne(s) mentionnée(s) dans le registre des actionnaires comme étant le(s)
détentrice(s) des actions, en spécifiant le nombre d’actions qui devront être rachetées, le jour d’évaluation applicable et
le prix de rachat correspondant, tel que défini ci-après et la date à laquelle un tel rachat deviendra effectif (le «Jour de
Rachat»).
Immédiatement après la clôture des bureaux au Jour de Rachat mentionné dans l’avis de rachat (et nonobstant le fait
que l(es)’actionnaire(s) ai(en)t ou non fourni les informations relatives au compte bancaire tel que requis ci-après), ce(s)
actionnaire(s) cessera(ont) d’être les propriétaires des actions mentionnées dans l’Avis de Rachat et son(es) nom(s) ne
devra(ont) plus apparaître en tant que détenteur de ces actions dans le registre des actionnaires. Toute personne ces-
sera de bénéficier des droits relatifs à la qualité d’actionnaire de la Société en relation avec les actions ainsi rachetées à
compter de la clôture des bureaux au Jour de Rachat mentionné dans l’avis de rachat mentionné ci-dessus.
Dans tous les cas, l’avis de rachat sera distribué au(x) détenteur(s) d’actions en envoyant cette notice par courrier
adressé à ce(s) détenteur(s) d’actions à son (leur) adresse mentionnée au registre des actionnaires ou connue de la So-
ciété. L’(es) actionnaire(s) concerné(s) devra (devront) sans délai fournir un compte bancaire sur lequel le prix de rachat
pour ses (leurs) actions rachetées sera transféré.
Le prix de rachat à payer pour chacune des actions ainsi rachetées (le «Prix de Rachat») sera la valeur nette d’inven-
taire de cette action calculée lors du prochain Jour d’Evaluation, moins, le cas échéant, un montant égal aux obligations
et aux charges encourues lors de la réalisation des investissements de la Société au Jour d’Evaluation en vue de procéder
à un tel rachat.
Le paiement du Prix de Rachat sera effectué par la Société sur le compte bancaire indiqué par le(s) détenteur(s) d’ac-
tions concernée(s) ou sur celui convenu entre les parties. Dans l’hypothèse où le(s) détenteur(s) d’actions concerné(s)
n’indiquerai(en)t pas un compte bancaire sur lequel le Prix de Rachat devrait être transféré, la Société pourrait soit dé-
poser ce montant sur un compte ouvert dans ce but, soit envoyer un chèque de ce montant à la dernière adresse du
(des) détenteur(s) d’ actions mentionnées dans le registre des actionnaires ou connue de la Société, et ce, à chaque fois,
au seul risque et à la charge du (des) détenteur(s) d’actions concerné(s). Après le transfert ou le dépôt du Prix de Rachat
ou de l’envoi du chèque mentionné ci-dessus, aucune personne intéressée dans les actions rachetées conformément à
l’avis de rachat n’aura plus d’intérêt en relation avec ces actions ou l’une d’entre elles, ou n’aura de créance envers la
Société ou ses avoirs en relation avec elles ou le Prix de Rachat.
Les actions du capital de la Société qui auront été rachetées par cette dernière devront être annulées.
Art. 17. Jour d’Evaluation. La valeur nette d’inventaire des actions sera, en vue du rachat et de l’émission d’actions,
déterminée périodiquement par la Société, en aucun cas moins de deux fois par an, ainsi que le conseil d’administration
en décidera (le jour de la détermination de la valeur nette d’inventaire étant désigné dans les présents Statuts comme
«Date d’Evaluation»).
Art. 18. Détermination de la valeur nette d’inventaire. La valeur nette d’inventaire des actions (la «Valeur
Nette d’Inventaire») de la Société est exprimée en Euro représentée par un chiffre pour chaque action et est déterminé
pour toute Date d’Evaluation. Dans ce but, le conseil d’administration évaluera séparément chaque masse commune
d’avoirs et de passifs à créer pour chaque Classe créé au sein de la société. Il sera établi dans les comptes de la Société
des masses communes spécifiques comme suit:
5485
a) les bénéfices à recevoir de l’émission d’actions de différentes Classes d’Actions, tels qu’alloués pour une transac-
tion, seront inscrits dans les comptes de la Société pour la masse commune établie pour cette Classe et, le cas échéant,
les avoirs et engagements ainsi que le revenu et les immobilisations attribuables à cette masse commune seront inscrits
pour la masse commune correspondante sous réserve des dispositions suivantes;
b) lorsqu’un actif est dérivé d’un autre actif, cet actif dérivé doit être inscrit dans les comptes de la Société pour la
même masse commune que les actifs dont il est dérivé et lors de chaque réévaluation de l’actif, l’augmentation et la
diminution de valeur devra être appliquée à la masse commune correspondante;
c) lorsque la Société encourt un engagement qui se rapporte à un actif d’une masse commune particulière ou à une
action entreprise en rapport avec un actif d’une masse particulière, un tel engagement devra être attribué à la masse
commune correspondante sous réserve que tous les engagements, quelque soit la masse commune à laquelle ils sont
attribuables, engageront la Société dans son ensemble;
d) dans l’hypothèse où un actif ou un engagement de la Société ne peut pas être considéré comme étant attribuable
à une masse commune particulière, cet actif ou cet engagement sera alloué à toutes les masses communes au pro rata
de la valeur nette d’inventaire des masses communes.
Les investissements dans les sociétés en portefeuille ou dans des structures d’investissement seront évalués comme
suit:
- à leur coût dans le cas des sociétés de portefeuille ou de structure d’investissement acquises dans la période de
douze mois précédant le jour d’évaluation à moins que le conseil d’administration ne considère qu’il y a eu une détério-
ration importante dans la situation financière d’une telle société de portefeuille ou de la structure d’investissement;
- au prix de vente prévisible estimé de bonne foi, dans le cas des sociétés de portefeuille ou de structure d’investis-
sement acquises plus de douze mois avant le jour d’évaluation;
- les avoirs liquides seront évalués à leur valeur faciale augmentée des intérêts échus.
Le conseil d’administration peut cependant adopter d’autres méthodes d’évaluation justes si des circonstances ou des
conditions de marché le garantissent. La valeur des avoirs exprimée dans une monnaie autre que l’Euro sera déterminée
en prenant en compte le taux de change applicable au jour de la détermination de la Valeur Nette d’Inventaire.
La Valeur Nette d’Inventaire sera tenue à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ensemble avec
le rapport annuel (au jour de la Date d’Evaluation au 31 décembre) ainsi qu’avec le rapport financier semi-annuel (à la
Date d’Evaluation du 30 juin).
Afin de déterminer la valeur nette d’inventaire d’une masse commune d’avoirs et d’engagements exprimés dans une
monnaie différente de l’Euro, il sera procédé à la conversion en Euro aux taux d’échange applicable au jour d’évaluation
tel que déterminé par le conseil d’administration.
La Société peut suspendre la détermination de la Valeur Nette d’Inventaire par action, dans des cas exceptionnels,
dans lesquels les circonstances le requièrent et pourvu que la suspension soit justifiée au regard des intérêts des action-
naires, lorsque:
(a) La valeur nette d’inventaire de tout investissement sous-jacent est elle-même suspendue, ou ne peut pas être dé-
terminée avec exactitude afin de refléter la juste valeur de marché des actifs de la Société au Jour d’Evaluation;
(b) Les marchés principaux ou bourses de valeurs sur lesquels une partie substantielle des investissements de la So-
ciété sont cotés, sont fermés pour une autre raison que pour des congés habituels, ou pendant laquelle les opérations
y sont limitées ou suspendues;
(c) L’existence de tout évènement constituant une urgence ayant pour effet la vente ou l’évaluation des actifs déte-
nues par la Société seraient irréalisables;
(d) Les moyens de communication normalement employés pour déterminer le prix de tout investissement ou les prix
courants sur un marché ou une bourse de valeur ne fonctionnent plus; ou
(e) Il existe une période au cours de laquelle la Société est incapable de rapatrier les fonds ou durant laquelle tout
transfert de fonds lors de la réalisation ou de l’acquisition d’investissement, ne peut être, selon l’opinion du conseil d’ad-
ministration, effectué aux taux normaux d’échange.
Pareille suspension devra être notifiée aux investisseurs souhaitant souscrire à des actions.
Art. 19. Le contrat de banque dépositaire. La Société conclura un contrat de banque dépositaire avec une ban-
que qui satisfera aux exigences de la loi luxembourgeoise et de la loi sur les SICAR (la «Banque Dépositaire»). Toutes
les valeurs ou espèces de la Société seront détenus par ou pour ordre de la Banque Dépositaire, qui assumera vis-à-vis
de la Société et de ses actionnaires les responsabilités prévues par la loi.
Art. 20. L’exercice social. L’exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se termi-
nera le 31 décembre de la même année.
Art. 21. Distribution des profits. L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’admi-
nistration, devra déterminer de quelle façon le reliquat des profits nets annuels sera utilisé et pourra, sans jamais excéder
les montants proposés par le conseil d’administration, déclarer occasionnellement des dividendes.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, au regard des conditions énoncées par la loi, et ce sur décision
du conseil d’administration.
Les dividendes annoncés pourront être payés en quelque devise que ce soit choisie par le conseil d’administration et
pourront être payés aux places et lieux déterminés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra en dernier ressort déterminer le taux de change applicable pour convertir les di-
videndes dans la devise de leur paiement.
Un dividende déclaré mais impayé pendant cinq années ne pourra plus être réclamé par la suite par le détenteur d’une
telle action, celui-ci perdant tout droit attaché à une telle action et le montant sera reversé à la Société.
5486
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés, mais non réclamés et détenus par la Société pour le compte
des détenteurs d’actions.
Art. 22. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, ou, sur décision du conseil d’administration
d’une Classe d’actions de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs (qui peu-
vent être des personnes physiques ou des entités juridiques) nommés par l’assemblé générale des actionnaires statuant
sur une telle dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Les bonis de liquidation seront distribuables par le(s) liquidateur(s) aux détenteurs d’actions. Les bonis pourront être
distribués en nature. Les bonis qui ne pourraient pas être distribués à leurs bénéficiaires à la clôture de la liquidation de
la Société ou d’une Classe d’actions concernée seront placés en dépôt auprès de la Banque Dépositaire pour une pé-
riode de six mois courant à la clôture de la liquidation. Après cette période, les avoirs seront placés en dépôt à la Caisse
de Consignation pour le compte de leur bénéficiaire.
Art. 23. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés par une assemblée des actionnai-
res, faisant l’objet du quorum et des conditions de vote prévues par les lois luxembourgeoises.
Art. 24. Lois applicables. Toutes les matières, non régies par les présents Statuts, seront soumises à la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telles que modifiées, et à la loi sur les SICAR.
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice comptable commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre
2006.
(2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts de la Société ayant été arrêtés par les comparants, les comparants ont souscrit et ont libéré entièrement
les actions suivantes:
La preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais de quelque forme que ce soit qui résultent de la constitution de la Société
seront supportés par la Société et sont estimés à environ cinq mille euros.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Aussitôt les associés ont pris immédiatement les résolutions suivantes:
I. KPMG AUDIT, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé réviseur d’entreprises
agréé pour une durée arrivant à son terme lors de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
II. Le siège social de la Société est fixé au 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
III. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
a. Monsieur Christian Baillet, CEO, ayant son adresse professionnelle au 243, bd St. Germain, F-75007 Paris,
b. Monsieur F. Michel Abouchalache, CEO Private Equity, ayant son adresse professionnelle au 243, bd St. Germain,
F-75007 Paris,
c. Monsieur Carlo J. Hoffmann, secrétaire général, ayant son adresse professionnelle au 84, Grand-Rue, L-1660
Luxembourg,
d. Monsieur Georges Majerus, expert comptable, ayant son adresse professionnelle au 84, Grand-Rue, L-1660
Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: X. Le Sourne, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2006, vol. 899, fol. 83, case 11. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003851.3/239/703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Actionnaires
Capital
Nombre
souscrit
d’actions
1. QUILVEST SERVICES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 30,990
3,099 actions
2. QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP Société Anonyme. . . . . . . . . . . . . EUR 10
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 31,000
3,100 actions
Belvaux, le 9 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
5487
DELTA LLOYD REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.210.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
DELTA LLOYD DEUTSCHLAND AG, a company incorporated under the laws of Germany, with registered office
in Wittelsbacher Strasse 1, 65189 Wiesbaden, register number HR Wiesbaden 12644,
hereby represented by Arnaud Van Waeyenberge, juriste, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Wiesbaden on 24 November 2005.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned no-
tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée, Gesellschaft
mit beschränkter Haftung), which is hereby formed:
Chapter I. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité lim-
itée, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the name of DELTA LLOYD REAL ESTATE MANAGEMENT
COMPANY, S.à r.l., (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial com-
panies, as amended (the «1915 Law»), as well as by these Articles.
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate purpose. The purpose of the Company is the creation, the administration and the management
of DELTA LLOYD REAL ESTATE FUND (the «Fund»), a Luxembourg fonds commun de placement and the issue of
certificates or statements of confirmation evidencing ownership interests in the Fund.
The Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promotion of the
Fund. It may on behalf of the Fund, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities or other
assets, process to any registrations and transfers in its own name or in third parties names in the register of shares or
debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders all rights
and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting the Fund’s assets. The foregoing powers
shall not be considered as exhaustive.
The Company may carry on any activities linked directly or indirectly and deemed useful for the accomplishment of
its object, remaining however within the limitations set forth by chapter 14 of the law of 20th December, 2002 governing
collective investment undertakings.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary
general meeting of shareholders.
The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Share capital
Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at Euro hundred twenty-five thousand (EUR 125,000),
represented by hundred twenty-five (125) shares having a nominal value of Euro one thousand (EUR 1,000) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders’ meeting deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-
portion to the number of shares in existence.
Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-
ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders
will not bring the Company to an end.
The Company, or one or more persons designated by the Company, shall prepare and maintain a register in accord-
ance with the provisions of Article 185 of the 1915 Law. The persons in this register will be treated as shareholders by
the Company.
Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-
shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders as foreseen by article 189 of the 1915 Law. No such authorisation is required for a transfer
of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-
ters of the rights belonging to the survivors.
5488
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have the power, subject to due observance of the provisions
of the 1915 Law, to acquire shares in its own capital.
Chapter III. Management - Meetings of the board of managers - Representation
Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to
state any reason) revoke and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
Art. 9. Meetings of the board of managers. The board of managers shall elect from among its members a chair-
man (the Chairman) and, if necessary, one or more deputy chairman.
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency,
which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast. In the event that at any meeting the number of votes
for or against a resolution is equal, the Chairman shall have a casting vote.
Resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-
vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, facsimile or telex.
Art. 10. Representation. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
objects.
All powers not expressly reserved by the 1915 Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall
within the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities
and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.
Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the 1915 Law.
Chapter IV. General meetings of shareholders
Art. 12. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general
shareholders’ meeting.
Should the Company have more than twenty-five shareholders, at least one annual general meeting must be held each
year on first Thursday in the month February. Should there be less than twenty-five shareholders, one annual general
meeting may, but is not required to be, held each year on that date. Shareholders may attend the meetings in person
or by proxy.
If the Company has less than twenty-five shareholders, resolutions of shareholders can, instead of being passed at a
general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or
several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of share-
holders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share
capital.
5489
However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the 1915 Law.
Chapter V. Financial year - Financial statement - Profit sharing - Auditor
Art. 13. Financial year. The Company’s accounting year begins on the 1st January and ends on the 31st December
of the same year.
Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers,
the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 15. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-
counts at the Company’s registered office.
Art. 16. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. In-
terim dividends may be declared and paid by the general meeting of shareholders or by the manager/board of managers
at any time out of distributable profits.
Art. 17. Auditor. The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several external audi-
tors, appointed by the general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of
office.
They may be re-elected and removed at any time.
Chapter VI. Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-
holders deliberating in accordance with the requirements applicable for the amendment of the Articles.
Art. 19. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.
Chapter VII. Governing law
Art. 20. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Law for all matters for
which no specific provision is made in the Articles.
<i>Subscription and paymenti>
DELTA LLOYD DEUTSCHLAND AG, prenamed, hereby declares that it subscribes to all 125 shares (one hundred
twenty-five) representing the total subscribed share capital as follows:
All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of hundred twenty-five thousand Euro
(EUR 125,000) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisioni>
The Company’s first accounting year is to run from the date of this deed to 31st December, 2005.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately three thousand six hundred Euro (EUR 3,600.00).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1) The meeting appoints as its managers for an unlimited period:
- Mr Hartmut Hagemann, CFO, DELTA LLOYD DEUTSCHLAND AG, residing at Wittelsbacher Str. 1, 65189 Wi-
esbaden
- Mr Frans van de Veer, CEO, DELTA LLOYD DEUTSCHLAND AG, residing at Wittelsbacher Str. 1, 65189 Wies-
baden
- Mr Frank Linker, DELTA LLOYD INVESTMENT MANAGERS GmbH, residing at Wittelsbacher Str. 1, 65189 Wi-
esbaden
- Mr Thomas Augustini, Geschäftsführer, DELTA LLOYD IMMOBILIEN GmbH, Wittelsbacher Str.1, 65189 Wies-
baden
- Mr Gerhard Trubel, General Partner, COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., residing at 34, avenue
de la Liberté, L-1013 Luxembourg
2) The registered office is established at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxembourg.
3) The meeting appoints PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered offices at 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg, as auditor of the Company until revocation of its mandate.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the
same proxy holder and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be
prevailing.
5490
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundfünf, den neunundzwanzigsten November.
Vor Uns, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.
Ist erschienen:
DELTA LLOYD DEUTSCHLAND AG, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Wittelsbacher
Strasse 1, 65189 Wiesbaden, Amtsgericht Wiesbaden HR 12644,
hier vertreten durch Herr Arnaud Van Waeyenberge, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Wiesbaden, am 24. November 2005.
Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den am-
tierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Diese Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung (die Satzung) einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I. Name - Dauer - Gegenstand - Sitz
Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) unter der Bezeichnung DELTA LLOYD REAL ESTATE MANAGEMENT, S.à r.l., (die Gesellschaft), welche der
luxemburgischen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften (nachfolgend das Gesetz von 1915), sowie der nachfolgenden Satzung unterliegt.
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 2. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung, die Verwaltung und das Management von DELTA
LLOYD REAL ESTATE FUND (der Fonds), ein Luxemburger fonds commun de placement, sowie die Ausstellung von
Zertifikaten oder Bescheinigungen des Miteigentums an dem Fondsvermögen.
Die Gesellschaft unternimmt jegliche Aktivitäten, welche im Zusammenhang mit dem Management, der Verwaltung
und der Förderung des Fonds stehen. Sie kann im Namen des Fonds Verträge eingehen, Wertpapiere oder andere Ver-
mögenswerte kaufen, verkaufen, tauschen und aushändigen, Registrierungen und Übertragungen für eigene oder fremde
Rechnung in den Aktienregistern von jeglichen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften vornehmen und im
Namen des Fonds und der Anteilinhaber des Fonds, alle Rechte und Privilegien, insbesondere die Stimmrechte, welche
dem Fondsvermögen anhängen, ausüben. Die vorgenannte Befugnisliste ist nicht als ausschöpfend zu betrachten, son-
dern nur zu Informationszwecken erstellt.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestim-
mungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen bleiben,
ausüben.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere
Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der
Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, in Luxemburg und im Ausland, Vertretungen und Zweigniederlassungen zu eröffnen.
Kapitel II. Gesellschaftskapital
Art. 4. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR
125.000) und ist eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je tausend Euro
(EUR 1.000).
Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter, gemäß den Bestimmungen für eine Sat-
zungsänderung, abgeändert werden.
Art. 5. Gesellschaftsanteile. Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögen und der Profite
im direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.
Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar und nur einen Inhaber pro Anteil ist zugelassen. Co-Inha-
ber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.
Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, die Zahlungsunfä-
higkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.
Die Gesellschaft, oder eine oder mehrere Personen die von der Gesellschaft bestellt wurden, werden ein Register
gemäss den Bestimmungen des Artikels 185 des Gesetzes von 1915 erstellen und führen. Die im Register eingetragenen
Personen gelten als Gesellschafter der Gesellschaft.
Art. 6. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Ge-
sellschaft frei übertragbar.
Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach
Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine solche
Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.
Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss von drei Viertel der überlebenden Gesellschafter
angenommen werden.
5491
Art. 7. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, ge-
mäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.
Kapitel III. Geschäftsführung - Sitzungen des Geschäftsführerrates - Vertretung
Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei einer Mehrzahl von Ge-
schäftsführern wird ein Geschäftsführerrat aufgestellt. Der(die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter
sein. Der (die) Gesellschaftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterver-
sammlung kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäfts-
führers.
Art. 9. Sitzungen des Geschäftsführerrates. Der Geschäftsführerrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
sowie, falls erforderlich, einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende
Sitzungen des Geschäftsführerrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.
Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrates einberufen. Ausgenommen in Dring-
lichkeitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor
der Sitzung schriftlich einberufen.
Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer
anwesend oder vertreten sind.
Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind.
Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, schriftlich oder per Fax oder durch jedes
andere angemessene Kommunikationsmittel, verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als
auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, bedarf es keiner geson-
derten Einberufung.
Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Geschäftsführerratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten
lassen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Kommunikationsmittel zu seinem Bevoll-
mächtigten ernennt.
Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäfts-
führer an der Sitzung teilnehmen.
Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung per Telefon oder Videokonferenzschaltung oder
einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen gewährt,
teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Geschäftsführerrates als persönlich anwe-
send.
Die Beratungen und Entscheidungen des Geschäftsführerrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mit-
glieder vorhanden oder vertreten sind.
Entscheidungen des Geschäftsführerrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen. Falls auf einer
Sitzung des Geschäftsführerrates Stimmengleichheit für und gegen einen Beschluß besteht, gibt die Stimme des Vorsit-
zenden den Ausschlag.
Umlaufbeschlüsse, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet werden, sind gültig und verbindlich, als wären sie
bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Die Unterschriften können auf einer einzigen Urkunde er-
scheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften können per Brief, Fax
oder Telex erfolgen.
Art. 10. Vertretung. Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im Na-
men der Gesellschaft zu handeln sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind,
durchzuführen und zu genehmigen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesell-
schafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern, des Geschäftsführerrates.
Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers
und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des
Geschäftsführerrates gebunden.
Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat kann einen oder
mehrere ad hoc Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.
Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, wird die Verant-
wortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des
Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.
Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persön-
lich auf Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft
eingehen, solange diese gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.
Kapitel IV. Gesellschafterversammlungen
Art. 12. Gesellschafterversammlungen Der alleinige Gesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafts-
versammlung auf sich.
Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, findet wenigsten eine jährliche Generalversamm-
lung am ersten Donnerstag im Monat Februar statt. Bei weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, kann an diesem Da-
tum eine jährliche Generalversammlung stattfinden, jedoch muss diese nicht stattfinden. Gesellschafter können
persönlich oder an der Generalversammlungen teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
5492
Wenn die Gesellschaft weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, können Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlung, anstatt bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung, schriftlich per Umlaufbeschluss von
allen Gesellschaftern gefasst werden. In einem solchen Fall werden den Gesellschaftern explizite Entwürfe der Beschlüs-
se zugesandt, welche dann von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Schriftliche Beschlüsse, deren Unterschrif-
ten auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erscheinen, sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse,
welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefasst worden sind.
Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen
zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemein-
same Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, gestimmt worden sind.
Abänderungen der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäss den Bestimmungen des
Gesetzes von 1915, beschlossen werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung - Wirtschaftsprüfer
Art. 13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 14. Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen
und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäfts-
führern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Art. 15. Einsicht der Gesellschafter. Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und
in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) für die
Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht.
Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital aus-
geschüttet werden. Aus den ausschüttbaren Gewinnen können zu jeder Zeit Zwischendividende von der Gesellschaf-
terversammlung oder vom Geschäftsführer/Geschäftsführerrat beschlossen und gezahlt werden.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft werden ein oder mehrere
Wirtschaftsprüfer betraut. Die Generalversammlung bestellt den/die Wirtschaftsprüfer und legt dessen/deren Anzahl,
Entschädigung sowie die Amtsdauer fest.
Der oder die Wirtschaftsprüfer können jederzeit wiedergewählt und abberufen werden.
Kapitel VI. Auflösung - Abwicklung
Art. 18. Auflösung. Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher ge-
mäß den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.
Art. 19. Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidato-
ren, ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befug-
nisse und Vergütungen festlegen, ernannt.
Kapitel VII. Anwendbares Recht
Art. 20. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung ge-
regelt werden, wird auf das Gesetz von 1915 verwiesen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die DELTA LLOYD DEUTSCHLAND AG, vorgenannt, erklärt hiermit dass sie die 125 (einhundertfünfundzwanzig)
Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen alle zeichnet:
Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro
(EUR 125.000) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr dreitausendsechshundert Euro (EUR 3.600,00).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann fasste die Erschienene, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:
1) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:
- Herr Hartmut Hagemann, CFO, DELTA LLOYD DEUTSCHLAND AG, mit Berufsanschrift in Wittelsbacher Str. 1,
65189 Wiesbaden
- Herr Frans van de Veer, CEO, DELTA LLOYD DEUTSCHLAND AG, mit Berufsanschrift in Wittelsbacher Str. 1,
65189 Wiesbaden
- Herr Frank Linker, DELTA LLOYD INVESTMENT MANAGERS GmbH, mit Berufsanschrift in Wittelsbacher Str. 1,
65189 Wiesbaden
5493
- Herr Thomas Augustini, Geschäftsführer, DELTA LLOYD IMMOBILIEN GmbH, mit Berufsanschrift in Wittelsba-
cher Str.1, 65189 Wiesbaden
- Herr Gerhard Trubel, General Partner, COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., mit Berufsanschrift
in 34, avenue de la Liberté, L-1013 Luxemburg
2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes befindet sich in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri.
3) PricewaterhouseCoopers, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d’Esch, wird zum Wirtschaftsprüfer ernannt.
Worüber Urkunde
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in
Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der engli-
schen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.
Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit
Uns, dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Van Waeyenberge, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, vol. 26CS, fol. 46, case 7. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105459.3/230/391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
CORELIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9543 Wiltz, 61B, Résidence Emeraude, rue de Noertrange.
R. C. Luxembourg B 72.639.
—
L’an deux mille cinq, le sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORELIA S.A., avec siège
social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de rési-
dence à Junglinster, en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
50 du 15 janvier 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur René Elia, indépendant, demeurant au 66, rue de Londres,
F-62520 Le Touquet,
qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Cordonnier, démographe, demeurant à F-62780 Stella Plage, 560,
avenue de St. Quentin.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Pranzetti, employé privé, demeurant professionnellement
31, rue Mies à L-7557 Mersch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social au 61B, Résidence Emeraude, rue de Noertrange, L-9543 Wiltz et par conséquent adap-
tation de l’article premier de statuts;
2. Modification de l’objet social et de l’article 2 paragraphe premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet les prestations de services, conseils, formation, étude et mise en oeuvre de tout procédé ou
concept en rapport avec les métiers de l’HORECA»;
3. Révocation de UVENSIS S.A. au poste d’administrateur et nomination d’un nouvel administrateur;
4. Entérinement de la conversion automatique de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros, suppression
de la désignation de la valeur nominale des actions et adaptation de l’article 3 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-
bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, à L-9543
Wiltz, 61B, Résidence Emeraude, rue de Noertrange.
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article premier (deuxième et troisième paragra-
phes) des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. (deuxième et troisième paragraphes). Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du Conseil d’Adminis-
tration.»
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
5494
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et d’adapter en conséquence le premier paragraphe de
l’article deux des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. (premier paragraphe). La société a pour objet les prestations de services, conseils, formation, étude et
mise en oeuvre de tout procédé ou concept en rapport avec les métiers de l’HORECA.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer de son poste d’administrateur avec effet immédiat la société UVENSIS S.A.
L’assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur révoqué Monsieur Bernard Pranzetti, précité,
né le 10 mai 1950 à Piennes (F), employé privé, demeurant professionnellement 31, rue Mies à L-7557 Mersch. Le man-
dat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
L’assemblée confirme le mandat des deux autres administrateurs, le conseil d’administration étant donc composé de
Madame Catherine Cordonnier, Monsieur René Elia (administrateur délégué) et Monsieur Bernard Pranzetti.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’entériner la conversion automatique de la devise du capital de francs luxembourgois en euros
(cours: 1,- EUR = 40,3399 LUF) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) divisé en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
nouvellement arrêtée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: R. Elia, C. Cordonnier, B. Pranzetti, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085804.3/202/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.
LAMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 110.816.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fifteenth of September.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depository of the
present minutes.
There appeared:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 46.448,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, ave-
nue Victor Hugo,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on September 9, 2005.
The said proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the here-above stated capacity, has requested the officiating notary to document the
following articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Arti-
cles»), it deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in
the future.
Senningerberg, le 9 septembre 2005.
P. Bettingen.
5495
Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under
the name LAMAR, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxem-
bourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of Sep-
tember 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».
Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any
commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.
The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the
manager or the board of managers as the case may be.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-
ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of
any partner.
Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented
by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)
adopted in the same manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-
mensurate to his shareholding.
The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital
shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-
olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.
Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the
Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes
of managers (A and B).
The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the
votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner
(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.
Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-
agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount determined by the board of
5496
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members
a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such
meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of
each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one
class A manager and one class B manager present.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of
communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of
the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-
ing of the board of managers.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-
tent.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.
Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-
cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,
failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
specify the time and place of the meeting.
If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the
agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Each partner may participate in general meetings of partners.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more
than half of the share capital of the Company.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at
a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be
held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.
Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December
each year.
Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-
counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.
Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.
Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-
pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following
appointment.
At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the
general meeting of partners.
5497
Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall
have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.
Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.
The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-
uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.
Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior
approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,
or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) pro-
portionally to the shares they hold.
Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made
in these Articles.
<i>Subscription and paymenti>
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, subscribed for the five hundred (500)
shares.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR
12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.
<i>Transitory measurei>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of December 2005.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand five hundred (EUR
2,500.-) Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its
registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 9.098.
2) The Company shall have its registered office at 46 A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed with Us, the No-
tary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-
seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
5498
Comparaît:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois de Luxembourg
ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro under R.C.S. Luxembourg B
46.448,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionellement à L-1750 Luxembourg,
74, avenue Victor Hugo,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 septembre 2005.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée au présent acte pour être déposée avec lui auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement.
La comparante, de par sa qualité, a requis le notaire instrumentaire de dresser comme suit les statuts (les «Statuts»)
d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme associée ou avec toute personne ou entité qui
deviendrait associé de la société par la suite:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination
LAMAR, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.
Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt fi-
nancier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant ou du conseil de
gérance selon le cas.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-
tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits
de vote proportionnels à sa participation au capital social.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par
les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.
Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-
queront.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-
sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.
Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les
gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.
Les gérants peuvent ne pas être associés.
5499
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,
ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, de leur rémunération et
de la durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment,
et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.
Art. 8. Représentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas
de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs
agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/
leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).
Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il
peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée
pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.
Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique
de communication approprié.
Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié de chaque gérant.
La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le
représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen
de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.
Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des
gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par
courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.
Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le
même contenu.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-
sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-
seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
5500
Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-
probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-
nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-
fits et pertes.
Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera
confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant
sa nomination.
A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par
une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.
Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société
confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-
solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).
Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des
frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au
titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.
Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une
approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.
Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que
fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.
La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés
par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-
tion.
Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-
quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG)
S.A., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros
(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille cinq cents (2.500,-) euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée selon
les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro under
R.C.S. Luxembourg B 9.098.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
5501
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête du mandataire de la
comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête du même mandataire
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 149S, fol. 89, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087076.3/230/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.
BELLA MARTA, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1728 Luxemburg, 20, rue du Marché-aux-Herbes.
H. R. Luxemburg B 110.539.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, am zweiten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.
Ist erschienen:
Frau Marta Belz, geborene Kochmanik, Geschäftsfrau, geboren in Weipert, am 5. März 1958, wohnhaft in D-97529
Sulzheim, Am Unkenbach 24.
Diese Erschienene ersuchte den instrumentierenden Notar wie folgt die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden und zwar:
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung BELLA MARTA,
G.m.b.H.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am
Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss vorüberge-
hend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die dies-
bezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschaftsgremi-
um, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Restaurants mit Verkauf von alkoholischen sowie nicht-alko-
holischen Getränken.
Im übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte vornehmen, finanzieller, mobiliarer und immobiliarer Natur, die ge-
eignet sind den Gesellschaftszweck zu fördern oder ihm dienlich zu sein.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in einhundert
(100) Gesellschaftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).
Die hundert Geschäftsanteile werden voll und ganz von Frau Marta Belz, gezeichnet.
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-
fünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar durch Bankzertifikat nach-
gewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen
der Gesellschaft.
Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie wer-
den von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nichts anderes bestimmt haben, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter al-
len Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und diese rechtskräftig zu vertreten.
Art. 9. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Luxembourg, le 3 octobre 2005.
A. Schwachtgen.
5502
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Art. 11. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss, welcher ermittelt wird durch den Abzug aller dem Geschäftsjahr zu-
rechenbaren Aufwendungen einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen und sonstigen Kosten, von al-
len Erträgen des Geschäftsjahres.
Jährlich sind fünf Prozent (5,0%) des Reingewinnes dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, und zwar solange bis
der Reservefonds zehn Prozent (10,0%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Falls der Reservefonds, aus welchem
Grunde es auch sei, verwendet werden sollte, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent des Reingewinnes
wieder aufzunehmen.
Über den darüber hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.
Art. 12. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche selbst keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse der Liquidatoren.
Art. 13. Für alle Punkte, welche nicht durch diese Statuten bestimmt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere auf das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 und den hierzu er-
folgten Änderungen und Ergänzungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2006 statt.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in gleichgültig welcher Form, die der Gesellschaft durch ihre Gründung entstehen oder
zu ihren Lasten berechnet werden, werden auf 1.600,- Euro geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung
zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1728 Luxemburg, 20, rue du Marché-aux-Herbes.
2) Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Zeit, werden ernannt:
- Frau Marta Belz, vorgenannt,
als administrative Geschäftsführerin.
- Herr Marko Nau, Koch, geboren in Morbach, am 16. August 1966, wohnhaft in D-54459 Wiltingen, 124, Kloster-
bergstrasse,
als technischer Geschäftsführer.
Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft verpflichtet, bis zu einem Maximalbetrag von tausendzweihundert-
fünfzig Euro (1.250,- EUR), durch die alleinige Unterschrift des technischen oder administrativen Geschäftsführers.
Alle anderen Verpflichtungen der Gesellschaft Drittpersonen gegenüber sind nur rechtsverbindlich durch die gemein-
same Unterschrift der beiden Geschäftsführer, oder mit entsprechender Vollmacht durch die alleinige Unterschrift eines
Geschäftsführers im Rahmen dieser Vollmacht.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Komparentin, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Belz, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 55, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(082171.3/216/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
NEOMED HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 62.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02192, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081690.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Luxemburg, den 15. September 2005.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
5503
NELL US ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,400.
Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 107.543.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
NELL FUNDING, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with reg-
istered office at L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich,
here represented by Simon Baker, expert-comptable, residing in Steinsel.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- NELL FUNDING, S.à r.l. is the sole shareholder of NELL US ACQUISITION, S.à r.l., a private limited liability com-
pany (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, no-
tary residing in Luxembourg, on April, 20, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the Company);
- the Company’s share capital is presently set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) divided into one
hundred (100) shares of one hundred twenty-four Euro (EUR 124.-) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
NELL FUNDING, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed cap-
ital by an amount of ten million one hundred and four Euro (EUR 10,000,104.-) to bring it from its present amount of
twelve thousand four hundred (EUR 12,400.-) to ten million twelve thousand five hundred and four Euro (EUR
10,012,504.-) by the issuance of eighty thousand six hundred forty-six (80,646) new shares with a par value of one hun-
dred twenty-four Euro (EUR 124.-) each, having the same rights as the already existing shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, NELL FUNDING, S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe the new
shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of part of all of its assets and liabilities, in the
framework of a contribution of all of the assets and liabilities of NELL FUNDING, S.à r.l., known or unknown as per the
date hereof, made simultaneously to the Company and NELL BIDCO B.V., a company incorporated and organised under
the laws of the Netherlands, the part of the contribution made to the Company is being made for a value of ninety-eight
million five hundred forty thousand Euro (EUR 98,540,000.-), of which ten million one hundred and four Euro (EUR
10,000,104.-) is allocated to the share capital of the Company, the remaining amount, equal to eighty-eight million five
hundred thirty-nine thousand eight hundred ninety-six Euro (EUR 88,539,896.-), to be allocated to share premium.
Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a bal-
ance sheet of NELL FUNDING, S.à r.l. as per the date hereof.
It results from a certificate issued on the date hereof by the management of NELL FUNDING, S.à r.l. that:
- all assets and liabilities of NELL FUNDING, S.à r.l. are shown on the attached certified balance sheet as of the date
hereof;
- based on generally accepted accountancy principles the value of the contribution made by NELL FUNDING, S.à r.l.
to the Company per attached balance sheet as of the date hereof is estimated to be ninety-eight million five hundred
forty thousand Euro (EUR 98,540,000.-);
- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such part of all of the assets and liabilities
to NELL US ACQUISITION, S.à r.l. exist;
- all formalities to transfer legal ownership of such part of all of the assets and liabilities to NELL US ACQUISITION,
S.à r.l. will be accomplished by NELL FUNDING, S.à r.l.
Such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company decides to decrease the subscribed share capital of the Company by twelve
thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) by cancellation of one hundred (100) shares issued upon the Company’s
incorporation so that the share capital of the Company is set at ten million one hundred and four Euro (EUR
10,000,104.-) divided into eighty thousand six hundred forty-six (80,646) shares of a par value of one hundred twenty-
four Euro (EUR 124.-) each.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder of the Company decides to amend article 5, first
paragraph of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:
«Art. 5. The Company’s corporate capital is fixed at ten million one hundred and four Euro (EUR 10,000,104.-) rep-
resented by eighty thousand six hundred forty-six (80,646) shares in registered form with a par value of one hundred
twenty-four Euro (EUR 124.-) each, all subscribed and fully paid-up.»
There being no further business, the meeting is terminated.
5504
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately seven thousand
Euro (EUR 7,000.-).
Insofar as the contribution in kind results in NELL FUNDING, S.à r.l., a company incorporated and organised under
the laws of Luxembourg, Member State of the European Union, contributing all of its assets and liabilities to the Com-
pany and NELL BIDCO B.V. pursuant to a notarial deed to be executed in the Netherlands on or about the date hereof,
the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital
duty.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-sixième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
NELL FUNDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue
Gaston Diderich,
ici représentée par Monsieur Simon Baker, expert-comptable, residing in Steinsel.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- NELL FUNDING, S.à r.l. est l’associé unique de NELL US ACQUISITION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 20 avril 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).
- le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
NELL FUNDING, S.à r.l., en sa qualité d’associé unique de la Société, décide d’augmenter le capital social souscrit à
concurrence d’un montant de dix millions et cent quatre euros (EUR 10.000.104,-) pour le porter de son montant actuel
de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à un montant de dix millions douze mille cinq cent quatre euros (EUR
10.012.504,-) par l’émission de quatre-vingt mille six cent quarante-six (80.646) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, NELL FUNDING, S.à r.l., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, a déclaré souscrire
les nouvelles parts sociales de la Société et les libérer intégralement par un apport en nature d’une partie de tous ses
actifs et passifs, dans le cadre d’un apport de tous les actifs et passifs de NELL FUNDING, S.à r.l., connus ou inconnus
à ce jour, fait simultanément à la Société et NELL BIDCO B.V., une société de droit néerlandais, la partie de l’apport fait
à la Société est fait pour une valeur de quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent quarante mille euros (EUR 98.540.000,-),
dont dix millions et cent quatre euros (EUR 10.000.104,-) sont crédités au compte capital de la Société et l’excédant de
quatre-vingt-huit millions cinq cent trente-neuf mille huit cent quatre-vingt-seize euros (EUR 88.539.896,-) est compta-
bilisé en tant que prime d’émission.
Preuve de l’existence et de la valeur de ses actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan inté-
rimaire de NELL FUNDING, S.à r.l. daté de ce jour.
Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de NELL FUNDING, S.à r.l. en date de ce jour que:
- tous les actifs et passifs de NELL FUNDING, S.à r.l. sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté de ce jour;
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur de l’apport fait par NELL FUNDING, S.à r.l. à
la Société selon le bilan intérimaire daté de ce jour est évaluée à quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent quarante mille
euros (EUR 98.540.000,-);
- il n’existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ladite partie de tous ses actifs
et passifs à NELL US ACQUISITION, S.à r.l.;
- toutes les formalités pour le transfert juridique de ladite partie de tous ses actifs et passifs à NELL US ACQUISI-
TION, S.à r.l. ont été accomplies par NELL FUNDING, S.à r.l.
Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le no-
taire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de douze mille quatre cents euros (EUR
12.400,-) par l’annulation de cent (100) parts sociales émises lors de la constitution de la Société pour ainsi fixer le capital
social de la Société à un montant de dix millions et cent quatre euros (EUR 10.000.104,-) représenté par quatre-vingt
mille six cent quarante-six (80.646) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-).
5505
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’associé unique de la Société décide de modifier l’article 5, premier
paragraphe des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions et cent quatre euros (EUR 10.000.104,-), représenté par quatre-vingt
mille six cent quarante-six (80.646) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent vingt-quatre
euros (EUR 124,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ sept mille euros (EUR
7.000,-).
Dans la mesure où l’apport en nature résulte en ce que NELL FUNDING, S.à r.l., une société de droit de Luxembourg,
Etat-membre de l’Union Européenne, apporte tout son actif et tout son passif à la Société et NELL BIDCO B.V. suivant
un acte notarié devant être exécuté aux Pays-Bas en date de ce jour, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29
décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties
comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: S. Baker, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1
er
août 2005, vol. 432, fol. 66, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085806.3/242/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.
NELL US ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 107.543.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085808.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.
BROOKBYLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 75,000.-.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 109.757.
—
In the year two thousand and five, on the second day of August.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Mersch, to whom remains the present deed.
There appeared:
BROOKBY LLC, a limited liability company organised under the laws of the State of Delaware, with registered office
at c/o National Corporate Research, Ltd., 615 South DuPont Highway, County of Kent, City of Dover, State of Dela-
ware 19901,
here represented by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on Au-
gust 2, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- BROOKBY LLC is the sole shareholder of BROOKBYLUX, S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of M
e
Henri Hellinckx, prenamed, on July 26, 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
- the Company’s share capital is presently set at seventy-five thousand United States Dollars (USD 75,000.-) repre-
sented by one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
Mersch, le 27 septembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 27 septembre 2005.
H. Hellinckx.
5506
<i>First resolutioni>
BROOKBY LLC, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed share capital
by an amount of nine million United States Dollars (USD 9,000,000.-) to bring it from its present amount of seventy-
five thousand United States Dollars (USD 75,000.-) to nine million seventy-five thousand United States Dollars (USD
9,075,000.-) by the issuance of one hundred eighty thousand (180,000) new preferred equity stock certificates with a
par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each (the PESCs), having the rights and obligations attached thereto
following the restatement of the Company’s articles of association.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, BROOKBY LLC, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for the new PESCs
and to have them fully paid up by way of a contribution in kind of a claim against InverCap HOLDINGS S.A. de C.V.
According to a certificate dated as per the date hereof from the management of BROOKBY LLC, the contributed
claim has a value of nine million Euro (USD 9,000,000.-) and is certain and due for payment without deduction (certaine,
liquide et exigible).
The said certificate and a balance sheet of BROOKBY LLC as per the date hereof, after having been signed ne varietur
by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with
it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend articles 5., 15. and 16. of the
articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:
«Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at nine million seventy-five thousand United States Dollars (USD
9,075,000.-) represented by one thousand five hundred (1,500) shares in registered form with a par value of fifty United
States Dollars (USD 50.-) each (the Ordinary Shares), all subscribed and fully paid-up and one hundred eighty thousand
(180,000) preferred equity stock certificates with a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) each (the PESCs),
which are redeemable in accordance with these Articles.
The Ordinary Shares and the PESCs are collectively referred to as the Shares.
The holders of Ordinary Shares are hereinafter referred to as the Ordinary Partners and the holders to as the PESC
Partners. The Ordinary Partners and the PESC Partners are collectively referred to as the Partners.
5.2. The Company shall maintain a share premium reserve account for the PESCs (the PESCs Share Premium Reserve
Account) in United States Dollars (USD), and there shall be recorded to such account, the amount or value of any pre-
mium paid up on the PESCs. Amounts so recorded to this share premium reserve account will constitute freely distrib-
utable reserves of the Company.
5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
General - Acquisition or redemption of Shares
5.4. The Company may acquire or redeem its Ordinary Shares and PESCs to the extent permitted by these Articles
on the basis of amounts available for distribution in accordance with article 15.3.
Mandatory redemption or acquisition of the PESCs by the Company
5.5. To the extent permissible by law, on December 31, 2030 the Company must redeem or acquire all (but not
some) of the PESCs remaining on issue on that date.
Optional redemption of the PESCs by the Company
5.6. Subject to article 5.7., the Company may redeem all (but not some) of the PESCs with at least 6 calendar days
prior written notice to each PESC Partner, setting out the proposed redemption date (which must be a Business Day)
and the redemption consideration including reasonable detail of calculations as against the requirements of article 5.7.
(as the case may be).
Consideration payable to PESC Partners on redemption or acquisition
5.7. The PESC Partners, in consideration of a redemption or acquisition of their PESCs by the Company under article
5.5. or article 5.6., shall be entitled to receive an amount equal to the sum of:
(a) the PESC Investment Amount; and
(b) the PESC Coupon Entitlement; less
(c) any dividends declared but not yet paid to the PESC Partners on the date the PESCs are redeemed or acquired
by the Company under article 5.5. or article 5.6.
Art. 15. Profit and Loss
General
15.1. The Company shall maintain:
(a) a legal reserve account (the Legal Reserve Account);
(b) a PESC profit account (the PESC Profit Account); and
(c) a general profit account (the General Profit Account) (which is not a PESC Profit Account),
all to be kept in United States Dollars (USD).
Allocation of Losses
15.2. Any losses appearing from the profit and loss account adopted by the general meeting of partners shall be allo-
cated as follows:
(a) first, to the General Profit Account, if and to the extent this account shows a positive amount;
5507
(b) second, the balance after the allocation pursuant to paragraph (a) above, if any, to the PESC Profit Account, if and
to the extent this account shows a positive amount; and
(c) third, the balance after the allocation pursuant to paragraphs (a) and (b) above, if any, to the General Profit Ac-
count.
Allocation of Profits
15.3. Each financial year, all of the profit distributable by law shown in the annual accounts of the Company must be
(i) first, aggregated with the sum of the PESC Coupon Entitlements, for prior PESC Coupon Periods which have re-
mained undistributed; and
(ii) thereafter, the total of such sums (the Total Net Earnings available for Distribution or Tned) must be allocated
to the Profit Accounts referred to in article 15.1. in the following order:
(a) first, an amount corresponding to 5% of the profit distributable by law shall be allocated to the Legal Reserve
Account, until the aggregate amount allocated to the Legal Reserve Account is equal to 10% of the issued share capital
of the Company; and
(b) second, with respect to any financial year, the PESC Coupon Entitlement that has not been fully allocated to the
PESC Profit Account due to insufficient profits in any previous financial year shall be allocated to the PESC Profit Ac-
count; and
(c) third, with respect to any financial year, the PESC Coupon Entitlement that has been allocated to the PESC Profit
Account and which has thereafter been withdrawn from the PESC Profit Account due to allocation of losses under ar-
ticle 15.2. in a subsequent financial year shall be allocated to the PESC Profit Account; and
(d) fourth, with respect to any financial year, an amount equal to the sum of the PESC Coupon Entitlement for such
financial year shall be allocated to the PESC Profit Account; and
(e) finally, the part of the profit remaining after the allocations pursuant to paragraph (a) to and including (d) shall be
allocated to the General Profit Account.
Coupons
15.4. Subject to article 15.6., on each PESC Period End Date, the balance of the PESC Profit Account will be paid to
the PESC Partners as a dividend, calculated on the following basis:
(a) in case of a final dividend - the balance of the PESC Profit Account (taking into account the reduction in the PESC
Profit Account effected by any advance payment on dividends made to the PESC Partner);
(b) in the case of an advance payment on dividends made to the PESC Partners - the balance of the PESC Profit Ac-
count determined on the assumption that the calendar day immediately preceding the relevant PESC Period End Date
is the end of a financial year.
15.5. Any distribution out of the Profit Accounts which is not contemplated by Article 15.4. can only be made to the
Partners pursuant to a unanimous resolution of the general meeting of Partners where the entire voting share capital
of the Company is present or represented, it being understood, for the avoidance of doubt, that the PESC Partners shall
not be entitled to any distributions except those made out of the PESC Profit Account.
15.6. To the extent permitted by law, the board of managers may pay out an advance payment on dividends.
15.7. The following capitalised terms used in these Articles shall have the following meanings:
PESC Coupon Entitlement means an amount (with respect to any PESC Coupon Period) calculated as the product of
(a) the PESC Coupon Rate, (b) a fraction, the numerator of which is the actual number of days in the PESC Coupon
Period and the denominator is 365, and (c) the PESC Investment Amount.
PESC Coupon Rate means a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is all income (including in-
terest and gains), net of taxes, derived by the Company from the PESC Investment for the relevant PESC Coupon Pe-
riod, minus the Minimum Required Taxable Amount for the relevant PESC Coupon Period, and the denominator of
which is the PESC Investment Amount for the relevant PESC Coupon Period.
Minimum Required Taxable Amount means the amount of profit to be annually reported in Luxembourg as taxable
income calculated as the product of (a) a fraction, the numerator of which is the actual number of days in the PESC
Coupon Period and the denominator is 365, (b) the Spread Margin for the relevant PESC Coupon Period and (c) the
PESC Investment Amount.
Spread Margin means 0.25% unless determined differently by the board of managers of the Company.
PESC Coupon Period means the period:
(a) starting on (and including) the Commencement Date or a PESC Period End Date; and
(b) ending on (but not including) the next PESC Period End Date,
based on a year of 365 days and the number of whole days in the PESC Coupon Period.
PESC Investment means the subscription and payment by the Company for a note and warrants to be issued by In-
verCap HOLDINGS S.A. de C.V., a corporation organized and existing under the laws of Mexico, for which subscription
and payment the Company shall utilize the PESC Investment Amount.
PESC Investment Amount means the sum of:
(a) the nominal value of each PESC multiplied by the number of PESCs on issue; and
(b) the balance of the PESC Share Premium Reserve Account; and
(c) with respect to any financial year, the amounts that have not been fully allocated to the PESC Profit Account due
to insufficient profits in any previous financial year, or which have been allocated to the PESC Profit Account but with-
drawn due to the allocation of losses.
PESC Liquidation Entitlement means the proceeds, net of taxes and costs, resulting from the disposal by the Company
of the PESC Investment.
PESC Period End Date means:
(a) December 31st of each year occurring before the date specified in Article 5.5; and
5508
(b) each date of redemption of the PESCs by the Company pursuant to Article 5.4 and Article 5.6; and
(c) each date of payment on the PESCs by the Company pursuant to Article 15.6,
or, if such date is not a Business Day, the next Business Day (unless that day falls in the following financial year, in
which case the PESC Period End Date ends on the previous Business Day).
PESC Profit Account has the meaning given to it in Article 15.1.
PESC Share Premium Reserve Account has the meaning given to it in Article 5.2.
Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday or public holiday) on which commercial banks are gen-
erally open for business in Luxembourg.
Commencement Date means August 2, 2005.
Legal Reserve Account has the meaning given in article 15.1.
Period End Date means each PESC Period End Date.
Profit Accounts means the PESC Profit Account and the General Profit Account.
Total Net Earnings available for Distribution or TNED has the meaning given in Article 15.3.
15.8. The final dividend with respect to a financial year must be declared by a resolution of the general meeting of
Partners, taking into consideration any advance payment on dividends declared by the board of managers with respect
to the same financial year.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution and liquidation of the Company
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be Partners, appointed by a resolution of the general meeting of Partners which will determine
their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the Partners or by law, the liquida-
tors shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the
Company.
16.2. These Articles shall remain in effect during the liquidation.
16.3. Any assets remaining after payment of all of the Company’s debts shall be applied as follows:
(a) first, to the PESC Partners, the PESC Investment Amount, where the balance of the PESC Profit Account is de-
termined on the assumption that the calendar day immediately preceding the resolution of the Partners provided for in
article 16.1. is the end of a financial year, it being understood that if such amount is in excess of the PESC Liquidation
Entitlement, the PESC Partners shall only be entitled to receive the PESC Liquidation Entitlement, to the exclusion of
any other liquidation distributions;
(b) second, to the Ordinary Partners, the paid up part on the Ordinary Shares;
(c) third, to the Ordinary Partners, the remainder after the distributions pursuant to paragraphs (a) to (b).
Upon liquidation, no distributions may be made to the Company in respect of Shares held by it.
16.4. After the liquidation has been completed, the books and records of the Company shall be kept for the period
prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the single partner or the general meeting
of partners to dissolve the Company. Where the single partner or the general meeting of partners has not appointed
such person, the liquidators shall do so.»
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to suppress article 6.1. of the articles of association and to renumber the other points
of article 6 of the articles of association.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the amount of nine million United States Dollars (USD 9,000,000.-) is valuated
at seven million three hundred and sixty-one thousand one hundred Euro (7,361,100.- EUR).
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 78,000.-.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le deuxième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue, Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
BROOKBY LLC, une société de droit de l’Etat du Delaware avec siège social à c/o National Corporate Research,
Ltd., 615 South DuPont Highway, County of Kent, City of Dover, Etat du Delaware 19901,
ici représentée par Maître Dirk Leermakers, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée le 2 août 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
5509
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- BROOKBY LLC est l’associé unique de BROOKBYLUX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sui-
vant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 26 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (la Société).
- le capital social de la Société est actuellement fixé à soixante-quinze mille dollars des Etats-Unis (USD 75.000,-) re-
présenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD
50,-) chacune.
La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
BROOKBY LLC, en sa qualité d’associé unique de la Société, décide d’augmenter le capital social souscrit à concur-
rence d’un montant de neuf millions de dollars des Etats-Unis (USD 9.000.000,-) pour le porter de son montant actuel
de soixante-quinze mille dollars des Etats-Unis (USD 75.000,-) à neuf millions soixante-quinze mille dollars des Etats-
Unis (USD 9.075.000,-) par l’émission cent quatre-vingt mille (180.000) certificats de parts privilégiées d’une valeur no-
minale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune (les PESCs), ayant les droits et obligations décrit ci-après
suite à la modification des statuts de la Société.
<i>Intervéntion - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, BROOKBY LLC, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les nou-
veaux PESCs et les libérer entièrement par apport en nature consistant en une créance sur InverCap HOLDINGS S.A.
de C.V.
Suivant un certificat de la gérance de BROOKBY LLC datée de ce jour, la créance apportée s’élève à un montant de
neuf millions de dollars des Etats-Unis (USD 9.000.000,-) et est certaine, liquide et exigible.
Le certificat mentionné ci-avant ainsi que le bilan de BROOKBY LLC daté de ce jour, signés ne varietur par le repré-
sentant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour y être
soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique de la Société décide de modifier les articles 5., 15. et
16. des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à neuf millions soixante-quinze mille dollars des Etats-Unis (USD 9.075.000,-), représenté
par mille cinq cents (1.500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-
Unis (USD 50,-) chacune (les Parts Ordinaires), toutes souscrites et entièrement libérées et cent quatre-vingt mille
(180.000) certificats de parts privilégiées d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune
(les PESCs) qui sont rachetables conformément aux présents Statuts.
Les Parts Ordinaires et les PESCs sont définis collectivement comme étant les Parts.
Les détenteurs de Parts Ordinaires sont définis ci-après comme étant les Associés Ordinaires et les détenteurs de
PESCs comme étant les Associés PESCs. Les Associés Ordinaires et les Associés PESCs sont définis collectivement com-
me étant les Associés.
5.2. La Société devra conserver un compte de réserve de prime d’émission pour les PESCs (le Compte de Réserve
de Prime d’Emission PESCs) étant tenu en dollars des Etats-Unis (USD), et il sera enregistré pour ce compte, le montant
ou la valeur de toute prime d’émission payée pour les PESCs. Les montants ainsi inscrits dans le compte de réserve
correspondant constitueront des réserves librement distribuables de la Société.
5.3. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Général - Acquisition ou rachat de Parts
5.4. La Société pourra acquérir ou racheter ses propres Parts et PESCs dans les limites établies par les présents Sta-
tuts sur base des montants disponibles pour distribution en conformité avec l’article 15.3.
Rachat ou acquisition obligatoire des PESCs par la Société
5.5. Dans les limites permises par la loi, le 31 décembre 2030, la Société devra racheter ou acquérir tous (et pas seu-
lement une partie) les PESCs encore émis à cette date.
Rachat optionnel des PESCs par la Société
5.6. Sous réserve de l’article 5.7, la Société pourra racheter tous (et pas seulement une partie) les PESCs sur notifi-
cation écrite d’au moins 6 jours à chaque Associé, informant de la date proposée pour le rachat (qui doit être un Jour
Ouvrable) et le prix de rachat avec un détail raisonnable sur les calculs tels que requis par l’article 5.7. (le cas échéant).
Rémunération payable aux Associés PESCs en cas de rachat ou d’acquisition
5.7. Les Associés PESCs, en rémunération d’un rachat ou d’une acquisition de leurs PESCs par la Société conformé-
ment à l’article 5.5. ou l’article 5.6., auront droit à une somme d’un montant équivalent au:
(a) Montant d’Investissement PESC; et
(b) le Coupon PESC; moins
(c) tous les dividendes déclarés mais non encore payés aux Associés PESC à la date à laquelle les PESCs sont rachetés
ou acquis par la Société conformément aux articles 5.5. ou 5.6.
5510
Art. 15. Profits et pertes
General
15.1. La Société devra maintenir:
(a) un compte de réserve légale (le Compte de Réserve Légale);
(b) un compte de profits de PESC (le Compte de Profits PESC); et
(c) un compte général de profits (le Compte Général de Profits) (qui n’est pas un Compte de Profits PESC),
qui seront tous en dollars des Etats-Unis (USD).
Affectation des pertes
15.2. Les pertes de la Société reprises dans le compte des bénéfices et des pertes, telle qu’adopté par l’assemblée
générale des Associés, devront être affectées de la manière suivante:
(a) premièrement, sur le Compte Général de Profits, dans la mesure où ce compte présente un solde positif;
(b) deuxièmement, le solde restant après l’opération prévue par le paragraphe (a) sera, le cas échéant, affecté sur le
Compte de Profits PESC dans la mesure où ce compte présente un solde positif; et
(c) troisièmement, le solde restant après les opérations prévues par les paragraphes (a) et (b) ci-dessus sera, le cas
échéant, affecté sur le Compte Général de Profits.
Affectation des bénéfices
15.3. Chaque année sociale, la totalité des bénéfices à affecter conformément à la loi telle que mentionnée dans les
comptes annuels de la Société doit:
(i) premièrement, être majoré du montant des Coupons PESC pour les précédentes Périodes de Coupons PESC qui
n’ont pas été distribuées; et
(ii) par la suite, le total de ces sommes (le Montant Total Net disponible pour des Distributeurs ou Tned) sera affecté
aux Comptes de Profits dont il est question à l’article 15.1. dans l’ordre suivant:
(a) premièrement, un montant correspondant à 5% des bénéfices distribuables selon la loi sera affecté au Compte de
Réserve Légale, jusqu’à ce que le montant alloué au Compte de Réserve Légale atteigne 10% du capital social de la So-
ciété; et
(b) deuxièmement, pour n’importe quelle année sociale, les montants équivalents aux Coupons PESC qui n’auront
pas été pleinement affectés au Compte de Profits de PESC, en raison de bénéfices insuffisants lors d’années sociales
précédentes, seront affectés au Compte de Profits PESC; et
(c) troisièmement, pour n’importe quelle année sociale, les Coupons PESC qui auront été affectés au Compte de Pro-
fits PESC et qui auront par après été retirés de ce compte en raison d’affectation de pertes conformément à l’article
15.2. lors d’un exercice social ultérieur, seront affectés au Compte de Profits PESC; et
(d) quatrièmement, pour n’importe quelle année sociale, un montant équivalent aux Coupons PESC sera, pour l’année
concernée, affecté au Compte de Profits PESC; et
(e) finalement, le solde du bénéfice restant après l’accomplissement des opérations décrites aux alinéas (a) à (d) sera
affecté au Compte Général de Profits.
Coupons
15.4. Sous réserve de l’article 15.6., à chaque Fin de Période PESC, le solde du Compte de Profits PESC sera payé
aux Associés PESC comme un dividende, calculé comme suit:
(a) en cas de dividende final: le solde du Compte de Profits PESC (tenant compte de la réduction du fait d’avances
sur paiement de dividendes faits à l’Associé PESC);
(b) dans l’hypothèse d’un versement d’acomptes sur dividendes fait à l’Associé PESC: le solde du Compte de Profits
PESC déterminé sur la présomption que le jour calendrier immédiatement précédant la Fin de Période PESC prévue
pour le PESC est la fin d’une année sociale.
15.5. Toute distribution sur les Comptes de Profits qui n’est pas prévue par 15.4. peut seulement être faite aux As-
sociés suite à une résolution unanime de l’assemblée générale des Associés où la totalité des Associés représentant l’en-
semble du capital social votant de la Société est présent ou représenté, étant entendu, pour autant que de besoin, que
les Associés PESC ne seront en droit de recevoir que les seules distributions effectuées à partir du Compte de Profits
PESC.
15.6. Dans les limites permises par la loi, le conseil de gérance peut effectuer un versement d’acomptes sur dividen-
des.
15.7. Les termes suivants qui seront utilisés dans ces Statuts auront les significations suivantes:
Coupon PECS signifie le montant (en rapport avec toute Période de Coupon PESC) calculé comme étant le produit
(a) du Taux du Coupon PESC, (b) d’une fraction dont le numérateur est le nombre de jours compris dans la Période de
Coupon PESC et le dénominateur est 365, et (c) du Montant de l’Investissement PESC.
Taux du Coupon PESC signifie une fraction, exprimée en pourcentage, dont le numérateur est tous les revenus nets
(comprenant les intérêts et plus-values) reçus par la Société dans le cadre de l’Investissement PESC pour la Période de
Coupon PESC correspondante, moins le Montant Minimum Imposable Requis pour la Période de Coupon PESC corres-
pondante, et le dénominateur est le Montant de l’Investissement PESC pour la Période de Coupon PESC correspondan-
te.
Montant Minimum Imposable Requis signifie le montant des bénéfices devant être retenus au Luxembourg chaque
année comme revenu imposable calculé comme étant le produit (a) d’une fraction dont le numérateur est le nombre de
jours de la Période de Coupon PESC et le dénominateur est 365, (b) la Marge de Division (Spread Margin) pour la Pé-
riode de Coupon PESC correspondante et (c) le Montant de l’Investissement PESC.
Marge de Division (Spread Margin) signifie 0,25% sauf pourcentage différent déterminé par le conseil de gérance de
la Société.
5511
Période de Coupon PESC signifie la période:
(a) commençant à (et comprenant) la Date de Commencement ou une Fin de Période PESC; et
(b) finissant à (mais sans comprendre) la Fin de Période PESC; et
basée sur une année de 365 jours et le nombre de jours entiers dans la Période de Coupon PESC.
Investissement PESC signifie la souscription et le paiement par la Société pour une promesse et des warrants devant
être émis par InverCap HOLDINGS S.A. de C.V., une société de droit mexicain, pour lesquels la Société utilisera le
Montant de l’Investissement PESC.
Montant de l’Investissement PESC signifie la somme de:
(a) la valeur nominale de chaque PESC multiplié par le nombre de PESCs; et
(b) le solde du Compte de Réserve de Prime d’Emission PESC; et
(c) par rapport à chaque année sociale, les montants qui n’ont pas été pleinement affectés au Compte de Profits PESC
en raison de profits insuffisants lors d’années sociales précédentes ou qui ont été affectés au Compte de Profits PESC
mais retirés du fait d’affectation à des pertes.
Part de Liquidation PESC signifie le produit, net d’impôts et de charges, de la vente ou autre disposition par la Société
de l’Investissement PESC.
Fin de Période PESC signifie:
(a) le 31 décembre de chaque année arrivant avant la date mentionnée à l’article 5.5.; et
(b) chaque date de rachat des PESCs par la Société conformément à l’article 5.4. et l’article 5.6.,
(c) chaque date de paiement des PESCs par la Société conformément à l’article 15.6,
ou si telle date n’est pas un Jour Ouvrable, le premier Jour Ouvrable suivant (à moins que ce jour ne tombe dans
l’année sociale suivante, auquel cas la Fin de Période PESC finira le Jour Ouvrable précédent).
Compte de Profits PESC a le sens précisé à l’article 15.1.
Compte de Réserve de Prime d’Emission PESC a le sens précisé à l’article 5.2.
Jour ouvrable signifie une journée (autre qu’un samedi, dimanche ou un jour férié) où les banques commerciales sont
généralement ouvertes au Luxembourg.
Date de commencement signifie le 2 août 2005.
Compte de Réserve Légale a le sens précisé à l’article 15.1.
Fin de Période signifie chaque Fin de Période PESC.
Comptes de Profits signifie le Compte de Profits PESC et le Compte Général de Profits.
Montant Total Net disponible pour Distribution ou TNED a le sens précisé à l’article 15.3.
15.8. Le dividende final d’une année sociale doit être déclaré par une résolution de l’assemblée générale des Associés,
en tenant compte de tout versement d’acomptes sur dividendes déclarés par le Conseil d’Administration pour la même
Année sociale.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Dans la mesure du possible, les Statuts conserveront leurs effets pendant la durée de la liquidation.
16.3. Tous les actifs restant après paiement de toutes les dettes de la Société devront être répartis comme suit:
(a) premièrement, aux Associés PESC, le Montant d’Investissement PESC, où le solde du Compte de Profits PESC est
déterminé sur la présomption que le jour calendrier précédent immédiatement la résolution de l’Article 16.1. est la fin
de l’année sociale, étant entendu qu’au cas où ce montant devait être supérieur à la Part de Liquidation PESC, les Asso-
ciés PESC ne seront en droit que de recevoir la Part de Liquidation PESC, à l’exclusion de toute autre distribution dans
le cadre de la liquidation;
(b) deuxièmement, aux Associés Ordinaires, la part libérée sur ces Parts Ordinaires;
(c) troisièmement, aux Associés Ordinaires, le solde restant après les distributions conformément aux alinéas (a) et
(b).
Pendant la liquidation, aucune distribution ne pourra être faite à la Société en vertu des Parts qu’elle détient.
16.4. Après que la liquidation ait été terminée, les livres et documents sociaux seront conservés pendant la période
prescrite par la loi par la personne désignée pour cette mission dans la résolution de l’assemblée générale des Associés
prononçant la dissolution de la Société. Si l’assemblée générale des Associés n’a désigné personne, les liquidateurs de-
vront s’en charger.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de supprimer l’article 6.1. des statuts et de renuméroter les autres points de l’article 6 des
statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Pour les besoin de l’enregistrement, le montant de neuf millions de dollars des Etats-Unis (9.000.000,- USD) est éva-
lué à sept millions trois cent soixante et un mille cent euros (7.361.100,- EUR).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ EUR 78.000,-
5512
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties
comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: D. Leermakers, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 8 août 2005, vol. 432, fol. 74, case 10. – Reçu 73.611 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086892.3/242/419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
BROOKBYLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 109.757.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086893.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
SHARPWELL TECHNOLOGY, OEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 100.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02129, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081292.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
ANNE WERY EDITIONS ET RESSOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1452 Luxembourg, 6, rue Théodore Eberhard.
R. C. Luxembourg B 74.286.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01626, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081311.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
KING’S CROSS ASSET FUNDING N° 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 109.191.
—
<i>Extrait de la résolution prise le 23 août 2005 par l’associé unique de la sociétéi>
L’actionnaire de la société a nommé avec effet immédiat et pour une durée indéterminée M. Michael S. Thomas, de-
meurant 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.
Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Godfrey Abel et Monsieur Michael S. Thomas.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00703. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081457.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Mersch, le 30 septembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 30 septembre 2005.
H. Hellinckx.
Strassen, le 13 septembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
5513
MONTE CERVINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 110.175.
—
In the year two thousand and five, on the fifteenth day of September.
Before Us, M
e
Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED, a limited liability company formed and existing under the laws of Cay-
man Islands on October 24, 1997 (formerly known as MORGAN STANLEY STRUCTURED PRODUCTS (CAYMAN)
II LIMITED), registered with the Cayman Register (Companies’ House) under number CR 77244 and having its regis-
tered office at M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands, and having its effective centre of management («siège de direction effective») in the
United Kingdom,
here represented by M
e
Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London,
on September 12, 2005.
Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed entity, MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED, is the sole partner of MONTE CERVINO, S.à
r.l., having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by
a deed of the undersigned notary on the 22th of August 2005, not yet published in the Mémorial C, registered with the
Register of commerce of Luxembourg under number B 110.175.
Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as
follows:
That the agenda of the meeting is the following:
1. Modification of the in the object of the company as follows:
- amendment of the item a) of Article 4 in order to add to the business purposes the entering into «repurchase trans-
actions, reverse repurchase transactions»;
- amendment of the Article 4 in order to add the following new item e) «to make uncollateralized loans under and
in accordance with Option Deeds entered into between the partners».
2. Amendment of Article 10 of the by-laws in order to integrate provisions with respect to the convening of the board
of managers.
3. Amendment of Article 15 of the by-laws in order to integrate provisions with respect to the convening of the gen-
eral meeting of the partners.
4. Amendment of Article 19 of the by-laws in order to specify the notice period before the inspection of the compa-
ny’s documentation.
5. Increase of the subscribed share capital of the company by an amount of fifty-eight million eighty-five thousand Euro
(EUR 58,085,000.-) to bring it from its present amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) to an amount of fifty-
eight million one hundred thousand Euro (EUR 58,100,000.-) by the creation and the issue of two million three hundred
twenty-three thousand four hundred (2,323,400) new parts having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, hav-
ing the same rights and obligations as the existing parts, together with total issue premiums of five hundred twenty-two
million nine hundred thousand Euro (EUR 522,900,000.-).
6. Subscription for all the two million three hundred twenty-three thousand four hundred (2,323,400) new parts by
MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED, a limited liability company formed and existing under the laws of Cayman
Islands on October 24, 1997, registered with the Cayman Register (Companies’ House) under number CR 77244, having
its registered office at M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands and having its effective centre of management («siège de direction effective») in
the United Kingdom, and paying up of these parts by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities.
7. Amendment of the first sentence of article 6 of the company’s by-laws so as to reflect the proposed increase of
the share capital.
Then, the sole partner takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner resolves to modify Article 4 item a) of the by-laws, which will from now on read as follows:
«Art. 4. (...) to lend moneys to or invest moneys in, to enter into repurchase transactions or reverse repurchase
transactions with, its partners, group companies of its partners, professional market parties and group companies of
professional market parties, and to make investments in securities (equity and/or debt securities) issued by such per-
sons;»
(...) and to add a last item:
«e) to make uncollateralized loans under and in accordance with Option Deeds to be entered into between the part-
ners.»
<i>Second resolutioni>
The sole partner resolves to add a third sentence to the fifth paragraph of the Article 10 of the by-laws which will
from now on read as follows:
«Art. 10. (...) The meeting is convened by a notice not less than fourteen clear days before the envisaged meeting.
The notice period may be waived provided all the managers are attending the manager’s meeting or, if not attending,
5514
confirm their agreement for the managers’ meeting to be held validly despite the notice period having been waived. The
notice will provide in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant
papers to be discussed at the meeting. Resolutions passed by managers at a board meeting in contravention to the notice
period, notice period waiver rules and notice information details shall be void.»
<i>Third resolutioni>
The sole partner resolves to include a fifth paragraph in Article 15 of the by-laws, which will read as follows:
«Art. 15. (...) The board of managers of the company, as well as partners representing together at least fifty percent
of the outstanding share capital may call general partners’ meetings. If, as a result of vacancies at the level of the board
of managers, there are insufficient managers to call a general meeting, any manager may call a general meeting. Unless
stated otherwise in these by-laws, all general meetings shall be called by giving at least seven clear days’ notice. Any
general meeting may be called by a shorter notice if agreed by all the partners of the company. The notice shall specify
the time and place of the meeting which shall necessarily be in Luxembourg.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner resolves to modify Article 19 of the by-laws which will from now read as follows:
«Art. 19. Each partner may, at any time upon 10 business days notice during working hours, inspect at the registered
office the inventory, the balance sheet, the profit and loss and generally all books and records of the company.»
<i>Fifth resolutioni>
The sole partner resolves to increase the share capital of the company by an amount of fifty-eight million eighty-five
thousand Euro (EUR 58,085,000.-) to bring it from its present amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) to an
amount of fifty-eight million one hundred thousand Euro (EUR 58,100,000.-) by the creation and the issue of two million
three hundred twenty-three thousand four hundred (2,323,400) new parts having a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts, together with total issue premiums of five hundred
twenty-two million nine hundred thousand Euro (EUR 522,900,000.-).
<i>Subscriptioni>
MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED, a limited liability company formed and existing under the laws of Cay-
man Islands on October 24, 1997, registered with the Cayman Register (Companies’ House) under number CR 77244,
having its registered office at M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and having its effective centre of management («siège de direction ef-
fective») in the United Kingdom here represented by Mr Alain Steichen, prenamed, has declared to subscribe for all the
two million three hundred twenty-three thousand four hundred (2,323,400) new parts, and to pay them a total price of
fifty-eight million eighty-five thousand Euro (EUR 58,085,000.-) together with a total issue premiums of five hundred
twenty-two million nine hundred thousand Euro (EUR 522,900,000.-) by a contribution in kind of all its assets and all its
liabilities, together constituting its entire net equity, whose existence and value are documented by an interim balance
sheet dated September 15, 2005.
The assets and liabilities contributed by MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED comprise:
<i>Assets:i>
- Investment portfolio;
- 600 parts of MONTE CERVINO, S.à r.l. for a value of EUR 15,000.-;
- Cash/all credit balances in its bank account.
<i>Liabilities:i>
- Liabilities (counsel fees, audit fees, ...); and
and generally, without limitation, any and all assets which are the property of MORGAN STANLEY YARMOUTH
LIMITED and any and all liabilities which are incumbent upon MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED.
<i>Sixth resolutioni>
The sole partner resolves to amend the article 6 of the by-laws of the company in order to reflect such increase of
capital, which now reads as follows:
«Art. 6. The capital is fixed at fifty-eight million one hundred thousand Euro (EUR 58,100,000.-), represented by two
million three hundred twenty-four thousand (2,324,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each, entirely subscribed for and fully paid up.»
<i>Costsi>
The contribution in kind consisting of the Total Assets and Liabilities of a company incorporated under the laws of
the Cayman Islands with effective centre of management («siège de direction effective») in the United Kingdom, a mem-
ber state of the European Union. The Company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971, which provides
for capital tax exemption. The expression Total Assets and Liabilities includes the items listed above and more specifi-
cally the items listed in the interim balance sheet of MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED dated September, 15,
2005 and any unknown assets and liabilities as at the time the contribution is made.
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged
to it by reason of the present deed are estimated at six thousand and five hundred Euro (EUR 6,500.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
5515
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée conformément aux lois
des Iles Cayman la 24 octobre 1997, enregistrée auprès du Registre de Sociétés de Cayman sous le numéro CR 77244,
ayant son siège social au M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Geor-
ge Town, Grand Cayman, Cayman Islands et ayant son siège de direction effective au Royaume-Uni,
représentée par M
e
Alain Steichen, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à
Londres, le 12 septembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
La société prénommée, MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED, est l’associé unique de of MONTE CERVINO,
S.à r.l. («la Société»), ayant son siège au 1, allée Scheffer, L 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée
suivant acte du notaire soussigné en date du 22 août 2005, non encore publié au Mémorial C (et non encore inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg).
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet de la société comme suit:
- modification du point (a) de l’Article 4 des statuts pour y intégrer une référence aux «opérations de vente et de
rachat ferme, opérations d’achat et de revente ferme» dans l’objet de la société;
- modification de l’Article 4 des statuts afin de rajouter un nouveau point e) «faire des prêts non garantis sous et
suivant les contrats d’option à conclure entre associés».
2. Modification de l’Article 10 des statuts de la société pour y inclure des dispositions sur la convocation des conseils
de gérance.
3. Modification de l’Article 15 des statuts de la société pour y inclure des dispositions sur la convocation des assem-
blées générales.
4. Modification de l’Article 19 des statuts de la société pour y introduire la durée de la notification préalable à la con-
sultation des documents sociaux.
5. Augmentation du capital souscrit de la société à concurrence de cinquante-huit millions quatre-vingt-cinq mille
euros (EUR 58.085.000,-) pour le porter de son montant actuel quinze mille euros (EUR 15.000,-) à cinquante-huit mil-
lions cent mille euros (EUR 58.100.000,-) par la création et l’émission de deux millions trois cent vingt-trois mille quatre
cents (2.323.400) parts nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les parts déjà existantes, ensemble avec une prime d’émission de cinq cent vingt-deux millions neuf
cents mille euros (EUR 522.900.000,-).
6. Souscription des deux millions trois cent vingt-trois mille quatre cents (2.323.400) nouvelles parts par MORGAN
STANLEY YARMOUTH LIMITED, une société constituée conformément aux lois des Iles Cayman la 24 octobre 1997,
enregistrée auprès du Registre de Sociétés de Cayman sous le numéro CR 77244, ayant son siège social au M&C Cor-
porate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands et ayant son siège de direction effective au Royaume-Uni, et libération de ces parts par un apport en nature de
tous ses actifs et passifs.
7. Modification de l’article 6 des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée.
Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’Article 4 a) des statuts de la société comme suit:
«Art. 4. (...)
a) «prêter des fonds ou investir des fond dans, conclure des opérations de vente et de rachat ferme, des opérations
d’achat et de revente ferme avec ses associés, les sociétés du groupe de ses associés, des professionnels du secteur
financier et les sociétés du groupe de ces professionnels du secteur financier et investir dans des titres (titres de capital/
ou titres de créances) émis par de telles personnes.»
(...) et de rajouter un autre paragraphe:
e) «faire des prêts non garantis sous et suivant les contrats d’option à conclure entre associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide d’ajouter une troisième phrase au paragraphe 5 de l’Article 10 des statuts:
5516
Art. 10. paragraphe 5. «La réunion est convenue par des convocations faites au moins 14 jours francs avant la date
escomptée de cette réunion. La période de convocation peut être annulée pourvu que tous les gérants assistent à cette
réunion du conseil ou, si ils ne sont pas tous présents à la réunion, s’ils confirment leur accord pour que la réunion soit
tenue valablement malgré l’annulation de la convocation. La convocation comprendra de façon suffisamment détaillée
les sujets qui seront discutés lors de cette réunion ainsi que la copie des documents sur lesquels porteront les discus-
sions lors de la réunion. Les résolutions passées par les gérants lors d’une réunion pour laquelle la période de convo-
cation, les règles d’annulations de cette convocation ou l’obligation d’information détaillée n’ont pas été respectées
seront nulles.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’Article 15 des statuts pour y inclure un paragraphe 5 comme suit:
«Le conseil de gérance de la société ainsi que des associés représentant ensemble au moins 50% du capital social en
vigueur peuvent appeler la tenue d’assemblées générales. Si suite à une vacance au niveau du conseil de gérance, il n’y a
pas assez de gérants pour convoquer une assemblée, n’importe quel gérant peut convoquer une assemblée. Sauf dispo-
sition contraire des statuts, toutes les assemblées doivent être convoquées par une convocation émise au moins 7 jours
francs avant la date prévue de l’assemblée. Toute assemblée générale peut être convoquée par une convocation plus
courte si tous les associés de la société y consentent. La convocation doit préciser l’heure et le lieu de la réunion qui
doit nécessairement se tenir à Luxembourg.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide modifier l’Article 19 des statuts comme suit:
«Art. 19. Chaque associé aura le droit de consulter, à tout moment après notification faite 10 jours auparavant lors
des heures ouvrables, l’inventaire au siège social, le bilan, le compte de pertes et profits et de manière générale tous les
livres et registres de la société.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un montant de cinquante-huit millions
quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 58.085.000,-) pour le porter de son montant actuel quinze mille euros (EUR 15.000,-)
à cinquante-huit millions cent mille euros (EUR 58.100.000,-) par la création et l’émission de deux millions trois cent
vingt-trois mille quatre cents (2.323.400) parts nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes, ensemble avec une prime d’émission de cinq cent
vingt-deux millions neuf cent mille euros (EUR 522.900.000,-).
<i>Souscriptioni>
MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée conformément aux lois
des Iles Cayman la 24 octobre 1997, enregistrée auprès du Registre de Sociétés de Cayman sous le numéro CR 77244
et ayant son siège social au M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands et ayant son siège de direction effective au Royaume-Uni, ici représentée
par M
e
Alain Steichen, prénommé, a déclaré souscrire toutes les deux millions trois cent vingt-trois mille quatre cents
(2.323.400) nouvelles parts et les payer un prix total de cinquante-huit millions quatre-vingt-cinq mille euros (EUR
58.085.000,-) avec une prime d’émission de cinq cent vingt-deux millions neuf cent mille euros (EUR 522.900,000,-) par
un apport en nature de tous ses actifs et passifs, constituant son actif net total, dont l’existence et la valeur sont indi-
quées par un bilan intérimaire daté du 15 septembre 2005.
Les actifs et passif apportés par MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED comprennent (mais ne se limitent pas
à):
<i>Actifs:i>
- Portefeuille d’investissements;
- 600 parts de MONTE CERVINO, S.à r.l. d’une valeur de EUR 15.000,-;
- Liquidités/tous les soldes créditeurs du compte bancaire.
<i>Passifs:i>
- Dettes (honoraries, frais d’audit, ...);
Et, en général, sans limites, tous les actifs, propriété de par MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED et tous les
passifs à la charge de MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED.
<i>Sixième résolutioni>
Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la
société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. «Le capital social de la société est fixé cinquante-huit millions cent mille euros (EUR 58.100.000,-) représenté
par deux millions trois cent vingt-quatre mille (2.324.000) parts d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, entièrement souscrites et totalement libérées.»
<i>Coûti>
Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans «l’intégralité du patrimoine» d’une société constituée aux Iles
Cayman mais ayant son siège de direction effective au Royaume-Uni, Etat membre de l’Union Européenne, la Société se
réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport. L’expression «intégralité
du patrimoine» comprend les éléments figurant ci-dessus et plus précisément les éléments figurant au bilan intérimaire
5517
de MORGAN STANLEY YARMOUTH LIMITED, en date du 15 septembre 2005 ainsi que tous les autres actifs et passifs
de cette société
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
du présent acte, sont évalués à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, vol. 149S, fol. 87, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085831.3/202/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.
COVALBA S.A., COMPTOIR DE VALEURS DE BANQUE, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 2.759.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 juin 2005i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la ratification de la nomination de Madame Isabelle Bastier coopté en tant que commissaire lors
de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
décembre 2004 en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Valot dont
le mandat se termine lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée accepte le renouvellement des mandats d’administrateur de Messieurs Auguste Gruber, Albert Le Di-
rac’h et Vincent Decalf pour une nouvelle période de six années prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2011.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée accepte également le renouvellement du mandat de commissaire de Madame Isabelle Bastier pour une
nouvelle période de six années prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01346. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081554.3/045/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
PLD GERMANY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.587.
—
Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05249. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081485.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Senningerberg, le 27 septembre 2005.
P. Bettingen.
<i>COVALBA S.A. COMPTOIR DE VALEURS DE BANQUE
i>A. Le Dirac’h / V. Decalf
<i>Administrateuri>s
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
5518
OFILUX FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 102.383.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01829, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
(081357.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
I.G.C., INTERNATIONAL GROUP COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 43.932.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du <i>3 février 2006i> à 10.00
heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes au 31 décembre 2004;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
I (00086/1161/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CONVENTUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CONVENTUM à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 février 2006i> à 10.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
• Adaptation de la Sicav aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes
de placement collectif;
• Refonte des statuts.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Ac-
tionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés est à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la Sicav.
I (00099/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.128.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>27 janvier 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2005 et affectation des résultats,
<i>Pouri> <i>OFILUX FINANCE, S.à r.l.
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans
5519
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00016/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MOTWIT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 8.351.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 janvier 2006i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (04589/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
1. SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 96.344.
—
Die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Anteilinhaber der 1. SICAV wird am Gesellschaftssitz am <i>26. Januar 2006i> um 14.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2005
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2006
6. Sonstiges
a) Verwaltungsratsvergütung
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
II (04702/584/21)
<i>Der Verwaltungsrati>.
INDIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.263.
—
THE ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of INDIAN INVESTMENT COMPANY (the «Company»), will be held at 11.00 a.m. (local time) on <i>25
January 2006i> at the registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg for the following purposes:
<i>Agenda:i>
1. To approve the annual report comprising the audited accounts of the Company for the financial year ended 30
September 2005 and to approve the Auditor’s report thereon;
2. To approve the balance sheet, profit and loss accounts as of 30 September 2005 and the allocation of the net prof-
its;
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended 30 September 2005;
5520
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next annual general meeting of sharehold-
ers and until his or her successor is duly elected:
Roberto Seiler, André Elvinger, Simon Airey, Laurence Llewellyn, Antonio Thomas, Jacques Elvinger and Nick
Criticos.
5. The election of the Auditor for the ensuing year;
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.
Only shareholders on record at the close of business on 23 January 2006 are entitled to vote at the Annual General
Meeting of shareholders and at any adjournments thereof.
Proxy Forms are available free of charge at the registered office of the Company.
Shareholders are advised that the resolutions are not subject to specific quorum or majority requirements.
II (04756/755/25)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.113.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of THE ASIAN TECHNOLOGY FUND will be held at 3.30 p.m. (local time) on Wednesday <i>January 25,
2006i> at the offices of ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg for
the following purposes:
<i>Agenda:i>
1. To approve the auditors’ report and audited financial statements for the fiscal year ended September 30, 2005.
2. To approve the annual report of the Fund for the fiscal year ended September 30, 2005.
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended September
30, 2005.
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Share-
holders and until his or her successor is duly elected and qualified:
Geoffrey L. Hyde, James J. Posch, Yves Prussen, T. L. Tsim.
5. To appoint ERNST & YOUNG, Luxembourg, as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal year.
6. To transact such other business as may properly come before the Meeting.
Only shareholders of record at the close of business on Friday, January 20, 2006, are entitled to notice of, and to
vote at, the 2006 Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.
January 4, 2006.
II (04813/755/23)
<i>By Order of The Board of Directorsi>.
ProLogis NETHERLANDS XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.300.000.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.315.
—
Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05046. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081490.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Wind River (Luxembourg), S.à r.l.
HSBC Partners Group Global Private Equity
Quilvest Managers Sicar S.A.
Delta Lloyd Real Estate Management Company, S.à r.l.
Corelia S.A.
Lamar, S.à r.l.
Bella Marta, G.m.b.H.
Neomed Holding S.A.
Nell US Acquisition, S.à r.l.
Nell US Acquisition, S.à r.l.
Brookbylux, S.à r.l.
Brookbylux, S.à r.l.
Sharpwell Technology, OEM S.A.
Anne Wéry Editions et Ressources, S.à r.l.
King’s Cross Asset Funding N˚ 6, S.à r.l.
Monte Cervino, S.à r.l.
COVALBA S.A., Comptoir de Valeurs de Banque
PLD Germany VI, S.à r.l.
Ofilux Finance, S.à r.l.
I.G.C., International Group Company S.A.
Conventum
Financière de Beaufort S.A.
Motwit S.A.
1. SICAV
Indian Investment Company
The Asian Technology Fund
ProLogis Netherlands XI, S.à r.l.