logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

4609

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 97

14 janvier 2006

S O M M A I R E

STRATUS EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 80.612. 

Les comptes annuels au 27 février 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00581, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079142.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Anglo-Dutch Investment Group, S.à r.l., Luxem- 

IFE II, Intermediate Finance Europe II Sicar, S.C.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4625

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4655

Baker Tilly Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

4610

IGEFI Group, S.à r.l., Luxembourg-Strassen . . . . . 

4640

BCP Caylux Holdings Luxembourg S.C.A., Luxem- 

IGEFI International, S.à r.l., Luxembourg-Strassen

4631

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4626

Instal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4630

Chris & Co Logistic Assistance S.A., Eppeldorf. . . .

4610

Kenmare Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

4611

Comité Inter.national des Festivités de la Schue- 

MATSC S.C., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4644

berfouer Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . .

4628

Macquarie Industrie Beteiligungen S.A.,  Luxem- 

DH Real Estate Finance Holdings S.C.A., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4652

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4641

Patrimvest, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

4626

DIA Tritonco 2 (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

4625

Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding 

DIA Tritonco 3 (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

4626

S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4612

Direkt Investment Management S.A., Luxemburg.

4655

Shaka Invest S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4611

Elfa-Auto, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4626

SOCLINPAR,  Société Luxembourgeoise d’Inves- 

Fashion One Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

4656

tissements  et  de  Participations  S.A.H.,  Luxem- 

Fashion One Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . .

4631

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4630

Fern, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4642

Station Service Durand, S.à r.l., Dudelange. . . . . . 

4627

Fern, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4644

Stratus Equity, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

4609

FN Hermes S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . .

4610

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . . 

4630

Grapy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4627

Symbiose, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

4611

Helfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4627

Textile Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

4628

Humanitarian World Holding S.A., Luxembourg . .

4626

Vebeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4625

IFE II, Intermediate Finance Europe II Sicar, S.C.A., 

Waterford Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

4625

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4653

Yura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4650

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

4610

BAKER TILLY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.289. 

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 30 juin 2005, ont été prises les décisions suivantes:
1) A été nommée nouvel Administrateur et Administrateur-Délégué en remplacement de l’administrateur ARMOR

S.A. démissionnaire:

Madame Sabine Koos, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, allée Mar-

coni.

Son mandat vient à expiration lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décem-

bre 2008.

2) Le siège de la société a été transféré de L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi à L-1724 Luxembourg, 25, boule-

vard du Prince Henri.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071949.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FN HERMES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 92.044. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. August 2005

Die außerordentliche Generalversammlung vom 10. August 2005, gehalten am Gesellschaftssitz in L-9991 Weiswam-

pach, bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, FN-SER-
VICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet), mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 144, route
de Stavelot. 

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.
Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 30. August 2005.

Enregistré à Diekirch, le 31 août 2005, réf. DSO-BH00179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(902894.3/667/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 2005.

CHRIS &amp; CO LOGISTIC ASSISTANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9365 Eppeldorf, 5, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 101.649. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 10 août 2005

La séance est ouverte à 16.00 heures.
L’Assemblée procède à l’installation de son bureau:
La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian Smets, indépendant, demeurant à L-9365 Eppeldorf 5,

Haaptstrooss.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Carla Vanpuyvelde, administrateur de sociétés, demeurant à L-9365 Ep-

peldorf 5, Haaptstrooss.

A été appelé aux fonctions de scrutateur M. Jean-Marie Wohl, employé privé, demeurant professionnellement à L-

1128 Luxembourg 37, Val St. André

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare que l’Assemblée Générale est régulièrement convoquée.
I. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Acceptation de la démission de M. Christophe Debroux, demeurant à L-9227 Diekirch 2, Esplanade.
2. Divers.
II. La totalité du capital social étant présente ou représentée à l’Assemblée et tous les associés présents ou représen-

tés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait abstraction des
convocations d’usage.

III. L’Assemblée, représentant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus par l’Assemblée, cette dernière aborde l’ordre du jour.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Pour extrait conforme
Signature 

<i>Für FN HERMES S.A., Aktiengesellschaft
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

4611

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de M. Christophe Debroux, demeurant à L-9227 Diekirch 2,

Esplanade comme administrateur.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.

Eppeldorf, le 10 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902886.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 2005.

Shaka Invest S.A. , Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 104.676. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2005

L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat des administrateurs et administrateur-délégue pour une pé-

riode de six ans: 

- Monsieur Fernand Toussaint, administrateur-délégué de société, demeurant à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue;
- Monsieur Marc Toussaint, administrateur de société, demeurant à B-1080 Bruxelles, 165, rue Osseghem;
- S.A. CALCUL, L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Le mandat de commissaire aux comptes de LUX-AUDIT S.A. est renouvelé aussi pour une période de six ans.

Clervaux, le 2 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03278. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902905.3/601/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2005.

SYMBIOSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 490, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 41.198. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00069, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078979.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

KENMARE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 43.419. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1993, acte publié au 

Mémorial C n

°

 289 du 14 juin 1993.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07338, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2005.

(079087.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SHAKA INVEST S.A. 
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature 

<i>Pour <i>SYMBIOSE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour KENMARE INVESTMENTS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

4612

PLANSEE MITSUBISHI MATERIALS GLOBAL SINTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 110.469. 

STATUTES 

In the year two thousand five, on the sixteenth day of August at 15.45.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. PLANSEE HOLDING A.G., a company organised and existing under the laws of Austria, registered with the local

court of Innsbruck under No. FN 42472i and having its principal place of business at 6600 Reutte, Austria,

here represented by Mr Gilles Dusemon, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Re-

utte on August 3, 2005; and

2. MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, having

its principal place of business at 5-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan,

here represented by Mr Gilles Dusemon, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Tokyo

on August 10, 2005.

The said proxies of the represented shareholders, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on

behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together
with it with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association (the Articles)

of a company which they declare to establish as follows:

Art. 1. Company name and registered office
1.1. The name of the public limited liability company (société anonyme) organized under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the «Law»), and
the present articles of association (the «Articles of Association») is PLANSEE MITSUBISHI MATERIALS GLOBAL SIN-
TER HOLDING, S.A. (the «Company»), in Japanese: (Japanese characters).

1.2. The Company has its registered office in the municipality of Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, and the board

of directors of the Company (the «Board of Directors») may decide to transfer the registered office within the bound-
aries of that municipality and/or to establish branches, subsidiaries and/or offices either in the Grand Duchy of Luxem-
bourg or abroad. 

1.3. The Company has been established for an unlimited duration.
1.4. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general shareholders’ meeting of the Company

adopted in the manner required for amendment of the Articles of Association.

Art. 2. Corporate objects
2.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement and operation of patents and other intellectual property rights, the acquisition and granting of licences, sub-
licences and similar rights under any name whatsoever, and, if required, the protection of such rights derived from pat-
ents and other intellectual property rights, licences, sub-licences and similar rights against infringement by third parties.

2.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

2.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risks, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

2.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose. The Company may en-
gage in any other lawful act or activity for which a public limited liability company may be organised under the Law.

Art. 3. Share capital
3.1. The subscribed share capital of the Company is fixed at three million five hundred thousand Euro (EUR 3,500,000)

represented by one thousand seven hundred fifty (1,750) Class A shares (the «Class A Shares») and one thousand seven
hundred fifty (1,750) Class B shares (the «Class B Shares») having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each.

3.2. The Company shall have an authorized share capital of five million Euro (EUR 5,000,000).
The Board of Directors of the Company is hereby authorized to issue seven hundred fifty (750) Class A1 shares (the

«Class A1 Shares») and seven hundred fifty (750) Class B1 shares (the «Class B1 Shares») each having a par value of one
thousand Euro (EUR 1,000), with or without issue premium so as to bring the total share capital of the Company up to
the total authorized share capital in whole or in part from time to time as it, in its discretion, may determine and to

4613

accept subscriptions for such Class A1 Shares and Class B1 Shares within a period determined in accordance with arti-
cles 32 (2) and 32 (5) of the Law.

The Board of Directors of the Company may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscrip-

tions, receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital, issuing shares and car-
rying out all such acts and things as are necessary to document the increase of the share capital and, in particular, to
amend the share capital in the legally required notarial form.

3.3. All shares shall be in registered form. The Class A Shares, the Class A1 Shares, the Class B Shares and the Class

B1 Shares are collectively referred to as the «Shares» unless the context otherwise requires.

3.4. Subject to the provisions of these Articles of Association, the Class A Shares, the Class A1 Shares, the Class B

Shares and the Class B1 Shares grant special rights as to the nomination of the members of the Board of Directors, the
payment in any form whatsoever of any reserve funds constituted by issue premiums, whereby any such issue premium
shall always track the class of Shares in respect of which the premium was paid and, in the case of the Class A Shares,
a special dividend entitlement as per article 9.3; apart from these rights the Class A Shares, the Class A1 Shares, the
Class B Shares and the Class B1 Shares grant the same rights to their respective holders.

3.5. Notwithstanding any decision of the general shareholders’ meeting to the contrary, in case of an increase of the

share capital of the Company, each shareholder is entitled to subscribe for newly issued Shares within its class of Shares
only on a pro rata basis.

3.6. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law and in conformity with the prin-

ciple of equal treatment of all shareholders.

Art. 4. Shareholders register
4.1. The Board of Directors will keep a register at the office of the Company, where it will be available for inspection

by any shareholder, in which the names and addresses of all shareholders shall be recorded as well as the date on which
they have acquired the Shares, the date of acknowledgement or serving, the amount paid on every Share and the transfer
of Shares and the dates of such transfers. Ownership of Shares will be established by the entry in this register.

4.2. Upon request, the Board of Directors will, without charge, provide a holder of Shares with an extract from the

register as regards that holder’s right to a Share.

Art. 5. Transfer of shares, Transfer restrictions
5.1. Prior Written Consent
Unless otherwise expressly permitted in these Articles of Association, until December 1, 2010, neither shareholder

may sell, transfer, assign, dispose of, create or permit to subsist any lien, or grant any option or other right over («Trans-
fer»), all or any of the Company’s Shares held by it or any right or interest in them without the prior written consent
of the general shareholders’ meeting; provided, however, that either shareholder (the «Transferring Party») may, with-
out the prior written consent of the general shareholders’ meeting, Transfer all or any of its Shares to any of its affiliates
which the Transferring Party owns directly or indirectly as a wholly-owned subsidiary.

5.2. Right of First Refusal
After December 1, 2010, either shareholder may Transfer all or part of its Shares only (i) with the consent of the

general shareholders’ meeting or (ii) in accordance with the following provisions:

(a) If a shareholder (the «Offeror») proposes to Transfer all or part of its Shares (the «Offered Shares») to any per-

son, the Offeror shall deliver a written notice (the «Offered Notice») to the other shareholders (the «Offeree») stating:
(i) the Offeror’s bona fide intention to Transfer the Offered Shares, (ii) the identity of the proposed transferee (the
«Proposed Transferee»), and (iii) the consideration, which shall be paid in cash only, and the other principal terms and
conditions (including the expected closing date) of such proposed bona fide Transfer;

(b) Within sixty (60) days after receipt of the Offered Notice (the «Refusal Period»), the Offeree shall have the first

right to (i) purchase all of the Offered Shares upon the terms and conditions set forth in the Offered Notice or (ii)
designate another person and cause such person to purchase all of the Offered Shares upon the terms and conditions
set forth in the Offered Notice or (iii) designate one or more persons and cause such person(s) to purchase jointly and/
or jointly with the Offeree all of the Offered Shares upon the terms and conditions set forth in the Offered Notice. In
the event that the Offeree so desires, the Offeree shall notify the Offeror in writing of its intention to purchase or des-
ignate another person who will purchase all of the Offered Shares. At the closing of such purchase, Offeror shall Trans-
fer all of the Offered Shares to the Offeree or such other person(s), as the case may be, free and clear of all liens on
the same terms and condition as those set forth in the Offered Notice. For the avoidance of doubt, in any of the cases
set forth in subparagraphs (i) through (iii) of this article 5.2 (b), the consideration for the Offered Shares shall be paid
by the Offeree or such other person(s), as the case may be, in cash only; and

(c) If the Offeree elects not to purchase or designate (an)other person(s) who will purchase the Offered Shares, then

the Offeror may Transfer the Offered Shares to the Proposed Transferee; provided that such Transfer (i) is completed
within sixty (60) days after the expiration of the Refusal Period and (ii) is made on the terms and conditions set forth
in the Offered Notice. If such Offered Shares are not so transferred, the Offeror must give notice in accordance with
this article 5.2 prior to any other or subsequent transfer of such Offered Shares.

5.3. No Lien on Shares
Notwithstanding any provision in these Articles of Association to the contrary, no shareholder shall pledge or hy-

pothecate any Shares nor otherwise use such Shares as collateral nor for any other purpose which could result in an
involuntary transfer or assignment of such Shares or any part thereof by means of a lien on such Shares or otherwise
to another person, unless prior consent to such pledge, hypothecation or such other use has been received in writing
from the general meeting of shareholders.

5.4. Effect of Breach

4614

In the event that either shareholder Transfers all or any of the Shares held by it or any right or interest in them in

breach of this article 5 (excluding any minor technical breach of article 5.2), in addition to any other remedies that the
non-breaching shareholder(s) may have, the breaching shareholder shall, at the option of non-breaching shareholder(s):
(a) within thirty (30) days of notice from the non-breaching shareholder(s), transfer to the non-breaching shareholder(s)
all proceeds received from the purchaser for the sale of its Shares; (b) repurchase its Shares from such purchaser within
thirty (30) days of the transfer and sell, free and clear of all liens, all such shares to the non-breaching shareholder(s) at
the lower of the fair market value as determined by agreement between the shareholders or in accordance with such
other procedures agreed upon from time to time by and between the shareholders (the «Fair Market Value»), or any
price agreed to by the breaching shareholder and any other person; or (c) within thirty (30) days of notice from the
non-breaching shareholder(s), purchase, free and clear of all liens, all the Shares held by the non-breaching sharehold-
er(s) at the greater of Fair Market Value, or any price agreed to by the breaching shareholder and any other person.

5.5. Miscellaneous
5.5.1. In the event of a Transfer contemplated by Article 5.4(b) or (c), the shareholders shall execute a share transfer

agreement (the «Share Transfer Agreement») to the extent required under Law to give effect to such Transfer.

5.5.2. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the shareholders’ register of the

Company, such declaration of Transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suit-
able powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory
to the Company.

5.5.3. Any notice required or permitted hereunder has to be in writing sent by registered mail or receipt of delivery

or delivered in person; any period shall be calculated from the date of receipt by the addressee, if the notice has to be
delivered to several persons, from the date of receipt by the latest addressee. Any notice shall be deemed to be in time
if handed over to the postal office and/or a courier service on the last day of the period; if the last day of a period is a
Saturday, Sunday or public holiday in the home country of the sender, the period is extended until the next business day.

Art. 6. Board of Directors
6.1. The Board of Directors shall have full responsibility and exclusive authority to make all business and management

decisions not expressly reserved to the general shareholders’ meeting pursuant to Luxembourg law and these Articles
of Association.

6.2. The Board of Directors shall be composed of 8 (eight) directors, 4 (four) of whom shall be executive directors

(the «Executive Directors») entrusted with the daily management (administrateurs-délégués à la gestion journalière),
the other 4 (four) shall be non-executive directors (the «Non-Executive Directors»). The members of the Board of
Directors are collectively referred to as the «Directors». The Directors shall be elected and dismissed by the general
shareholders’ meeting; a dismissal of a Director is admissible at any time without any cause. Non-Executive Directors
may either be individuals or corporate bodies.

6.3. 2 (two) Executive Directors and 2 (two) Non-Executive Directors shall be elected by the general shareholders’

meeting from a list of candidates nominated by the holders of a majority of Class A Shares and Class A1 Shares (the
«Class A Directors») and 2 (two) Executive Directors and 2 (two) Non-Executive Directors shall be elected from a list
of candidates nominated by the holders of a majority of Class B Shares and Class B1 Shares (the «Class B Directors»).
The first term of the Directors will expire on the date of the annual general shareholders´ meeting resolving on the ac-
counts closed on February 29, 2008. Thereafter, each Director shall serve a term of 2 (two) years.

6.4. If a vacancy occurs, the remaining Directors are entitled to provisionally appoint a new Director upon written

request of the Group of Shareholders (it being understood that a «Group of Shareholders» either refers to the holders
of Class A Shares, as a group and Class A1 Shares, as a group, and the holders of Class B Shares, as a group and Class
B1 Shares, as a group) which has nominated the Director for election which has to be replaced; until such appointment
or the election of a new Director by the general shareholders’ meeting, the Board of Directors cannot decide on any
issue listed under Article 7.

The general shareholders’ meeting shall determine the remuneration and all other terms and conditions of the em-

ployment contracts of each Director.

6.5. The Board of Directors shall elect a Chairman and a Vice Chairman, which shall both be Non-Executive Direc-

tors, from among its members, whereby the Chairman and Vice Chairman each time have to be elected from the list of
candidates of a different Group of Shareholders and every 2 (two) years, with the exception of the first term which shall
expire on the date of the annual general shareholder’s meeting resolving on the accounts closed on February 29, 2008,
the Chairman and the Vice Chairman each time have to be elected from the candidates of the other Group of Share-
holders. The first Chairman shall be elected from the list of candidates nominated by the holders of a majority of the
Class A Shares and Class A1 Shares, and the first Vice-Chairman shall be elected from the list of candidates nominated
by the holders of a majority of the Class B Shares and Class B1 Shares.

6.6. The Board of Directors shall meet whenever deemed necessary in the interest of the Company but at least four

(4) times a year, in each case, no later than one (1) month after the closing of each fiscal quarter, and otherwise upon
request of 2 (two) Directors, within 2 (two) weeks of any such request, at the latest. The budget meeting will be held
in the month before the new fiscal year of the Company commences. Meetings of the Board of Directors may be held
outside the Grand Duchy of Luxembourg.

6.7. Decisions may be taken by the Board of Directors without a meeting if a proposal for a decision is submitted to

each of the members of the Board of Directors and each Director consents to such decision. In such case decisions of
the Board of Directors may be adopted if all of the Directors have consented in writing to the proposal by circulating
the proposed resolution. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed
by each and every Director (résolution écrite ou résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of
the last signature.

4615

6.8. Meetings of the Board of Directors shall be called by the Chairman of the Board of Directors, and if the Chairman

is hindered from calling such a meeting, by the Vice Chairman; if the request of 2 (two) Directors to call a meeting is
not complied with, a meeting may be called by the 2 (two) Directors themselves. Any notice to call a meeting shall in-
dicate time and place where the meeting shall be held, together with the agenda of the meeting.

6.9. The meeting quorum for the Board of Directors shall be the presence of at least 5 (five) Directors. If such a

quorum is not present at a meeting, a second meeting which shall be limited to the agenda of the preceding meeting
shall be called together with a statement referring to the lack of a quorum at the preceding meeting and shall constitute
a quorum regardless of the number of Directors present or represented at the second meeting provided at least one
Class A Director and one Class B Director is present or represented.

6.10. Decisions of the Board of Directors shall be adopted by a simple majority vote unless otherwise stated in these

Articles of Association. Each Director has one vote. Neither the Chairman nor the Vice-Chairman has a decisive vote.
If there is no majority, the issue has to be presented to the general shareholders’ meeting to decide on it upon request
of any Director.

6.11. A Director may authorize another Director nominated by the same Group of Shareholders in writing, including

by e-mail or fax to represent him in a meeting of the Board of Directors; a Director can also participate in a meeting
by phone and/or video conference provided all Directors participating at that meeting can listen and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

6.12. Meetings, resolutions, protocols and minutes shall be held and executed in English. All resolutions of the Board

of Directors have to be laid down in minutes which shall be signed by the Chairman; any proxy shall be attached to the
minutes. Copies and/or excerpts of minutes which have to be presented to the Court or other persons, shall be certified
by the Chairman. 

Art. 7. Executive directors
7.1. Subject to the approval of the general shareholders’ meeting, the Board of Directors is authorised to transfer

the day-to-day-management of the Company to the Executive Directors and/or other representatives which need not
to be Directors.

7.2. The Board of Directors shall elect a President and a Vice President, which shall both be Executive Directors,

from among its members, whereby the President and Vice President at each time have to be elected from a list of can-
didates nominated by a different Group of Shareholders and every 2 (two) years, with the exception of the first term
which shall expire on the date of the annual general shareholder’s meeting resolving on the accounts closed on February
29, 2008, the President and the Vice President have to be elected from a list of candidates nominated by the other Group
of Shareholders. The first President shall be elected from the list of candidates proposed by the holders of a majority
of Class B Shares and Class B1 Shares, and the first Vice-President shall be elected from the list of candidates proposed
by the holders of a majority of Class A Shares and Class A1 Shares. At no time shall candidates nominated by the same
Group of Shareholders be elected President and Chairman unless otherwise agreed by the general shareholders’ meet-
ing.

7.3. The Company shall be legally represented by the Executive Directors, whereby 2 (two) Executive Directors are

jointly and collectively authorised to represent the Company.

7.4. The Executive Directors conclude the contracts with employees and terminate the employment contracts.

Art. 8. Fiscal year, Annual financial statements and audit
8.1. The fiscal year of the Company shall commence on the first day of March and end on the last day of February.
8.2. Each year after the end of the fiscal year, the Board of Directors shall draw up annual financial statements and an

annual report on that fiscal year.

8.3. The annual financial statements shall be signed by all Directors and shall provide the annual report and all other

documentation as required under Luxembourg law.

8.4. The annual financial statements shall be made available to all shareholders and any of the Directors for inspection

and/or obtaining of copies.

8.5. The Company shall utilise accounting systems and procedures in accordance with mandatory provisions of Lux-

embourg law and in accordance with the Luxembourg Accounting Standards.

8.6. One or more statutory auditors shall be elected by the general shareholders’ meeting for a period not exceeding

6 (six) years; statutory auditors can be elected for one or more consecutive terms. The statutory auditors may be re-
moved by the general shareholders’ meeting at any time, without cause. The general shareholders’ meeting decides on
the fees of the statutory auditors. Each statutory auditor has the unlimited right to review all and any transactions of
the Company and its affiliated companies and to review, inspect and audit all financial documents, correspondence, pro-
tocols, minutes and all other documents of the Company and its affiliated companies. The auditors have to inform the
general shareholders’ meeting about the result of the audit of the consolidated and the non-consolidated financial state-
ments of the Company and its affiliated companies, the kind and nature of inspection of the inventory and present any
proposals for improvement, if at all.

Art. 9. Dividend policy
9.1. Subject to the Law, the general shareholders meeting will declare and pay any and all dividends, if any, payable to

the shareholders in respect of any fiscal year by March 30 of the next fiscal year even if such declaration is required to
be based upon projected financial statements as of February 28/29 of the relevant fiscal year, safe that any payment in
any form whatsoever from reserve funds constituted by issue premiums shall only be paid in respect of the class of
Shares in respect of which the premium was initially paid.

4616

An amount corresponding to at least 5 (five) % of the annual distributable profits shall be allocated to the legal reserve

as long as the legal reserve does not exceed the tenth part of the share capital of the Company or the greater part as
determined in these Articles of Association.

9.2. The Board of Directors is authorised to effect advance (interim) payments on dividends in accordance with the

Law.

9.3. The holders of Class A Shares, as a whole, shall be exclusively entitled to a one time preferential special dividend

payment of up to 13,197,000 EUR (thirteen million one hundred ninety-seven thousand) (the «Special Dividend»), unless
otherwise decided by the general shareholders meeting resolving in the manner required for the amendment of the
present Articles of Association. The Special Dividend shall be declared by the annual general shareholders meeting not
earlier than at the annual general shareholders’ meeting of the Company approving the financial accounts relating to the
fiscal year in which the 13,197,000 EUR (thirteen million one hundred ninety-seven thousand Euro) of share capital and
reserves (retained earnings of SINTERSTAHL ASTURIAS S.A., or SSA) (SSA RESERVES) have been distributed to and
received by the Company. Between the time the Company has received such distribution of SSA RESERVES from SSA
and the Company’s distribution of the Special Dividend to the holders of the Class A Shares, the Company shall not
distribute any other profits to its shareholders.

Art. 10. General shareholder meetings
10.1. Procedures
10.1.1. The annual general shareholders’ meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Mamer at the

address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may
be specified in the convening notice of meeting, on the first Tuesday of June of each year at 10.00 a.m. If such day is not
a business day for banks in Luxembourg, the annual general shareholders’ meeting shall be held on the next following
business day.

10.1.2. The annual general shareholders’ meeting of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the Board of Directors of the Company, exceptional circumstances so require.

10.1.3. Other general shareholders’ meetings, including ordinary and extraordinary general meetings of the Company,

may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting. 

10.1.4. The general shareholders’ meeting shall be called by the Board of Directors by means of written notices to

be sent to the shareholders registered in the register referred to in Article IV. at least fifteen (15) days before the date
on which the meeting is to be held. If all shareholders participate at a general shareholders’ meeting and if all sharehold-
ers consent to vote on the presented agenda, such meeting can also be held without prior notice.

10.1.5. A general shareholders’ meeting shall also be called without delay if shareholders whose shares representing

one fourth of the share capital of the Company submit a written request demanding the call and stating the purpose. If
the Board of Directors does not comply with such a request within 14 (fourteen) days of the demand, the entitled share-
holders themselves may call the general shareholders’ meeting and shall give an account of the facts when doing so. In
such case, the general shareholders’ meeting shall decide on whether the Company is to bear the costs relating to that
call.

10.1.6. Each shareholder is entitled to authorize another person, which need not be a shareholder, in writing to rep-

resent him and vote in the general shareholders’ meeting.

10.1.7. The notice of convening a general shareholders’ meeting shall indicate the date, time and place where the

meeting shall be held, together with the agenda of the meeting, in compliance with mandatory rules of Luxembourg law.

10.1.8. Any general shareholders’ meeting shall be directed by the Chairman, if the Chairman is hindered, by the Vice-

Chairman.

10.1.9. Unless the mandatory provisions of Luxembourg law or the provisions of these Articles of Association provide

otherwise, at least 51 (fifty-one) % of the issued and paid-up share capital of the Company shall be present or duly rep-
resented at general shareholders’ meetings to constitute a quorum at such a meeting. If such a quorum is not present
at a meeting, a second meeting, which shall be limited to the same agenda of the preceding meeting, shall be called, to-
gether with a statement referring to the lack of quorum at the preceding meeting and shall constitute a quorum regard-
less of the amount of the share capital represented at it.

10.1.10. Unless mandatory provisions of the Luxembourg law or these Articles of Association determine otherwise,

ordinary shareholders’ resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast. Extraordinary shareholders’
resolutions shall always require a majority of 2/3 (two thirds) of the votes cast.

10.1.11. The copies and/or excerpts of the minutes of the general shareholders’ meetings which have to be presented

to the Court or any other person, shall be certified by the Chairman.

10.2. Powers
Matters to be resolved by the general shareholders’ meeting shall include: 
10.2.1. Insofar as ordinary general shareholders’ meetings are concerned: 
(i) mergers and acquisitions (including, without limitation, reorganization) of the Company;
(ii) appointment or removal of the directors and the auditor(s) of the Company;
(iii) determination of the remuneration of the directors and the auditor(s) of the Company;
(iv) approval of the audited annual accounts of the Company;
(v) allocation of profits, with the exception of interim dividends of the Company;
(vi) transfer or sale of all or a substantial part of any business owned by the Company;
(vii) lease, outsourcing of or entrusting to a third party of the management of, a substantial part of any business of

the Company and an arrangement for the sharing of profits or losses of a substantial part of any business of the Company
with a third party;

(viii) post-incorporation acquisition of assets from one of the founding shareholders (i.e., quasi-contribution);

4617

(ix) entering into new businesses outside of the scope of the business purpose set forth in these Articles of Associ-

ation; and

(x) any other matters that are required to be approved by the affirmative vote of shareholders at ordinary general

shareholders’ meetings of the Company.

10.2.2. Insofar as extraordinary general shareholders’ meetings are concerned:
(i) increase/decrease of the capital of the Company;
(ii) amendment of the Articles of Association of the Company;
(iii) any other matters that are required to be approved by the affirmative vote of shareholders at an extraordinary

general shareholders’ meeting of the Company; and

(iv) the dissolution and liquidation of the Company.

Art. 11. Dissolution, liquidation
11.1. The general shareholders’ meeting can decide on the dissolution of the Company at any time.
11.2. If the general shareholders’ meeting decides to dissolve the Company, it also has to appoint at least two liqui-

dators which can be natural or legal persons and to decide on the fees for the liquidators, whereas at least one liquidator
shall be elected by the general shareholders’ meeting from a list of candidates nominated by the holders of Class A
Shares and Class A1 Shares and at least one liquidator shall be elected by the general shareholders’ meeting from a list
of candidates nominated by the holders of Class B Shares and Class B1 Shares. If the general shareholders’ meeting does
not appoint the liquidators, the members of the Board of Directors will be the liquidators.

Art. 12. Miscelleanous. These Articles of Association have to be interpreted, construed and amended in accord-

ance with the Law.

<i>Transitory provisions

1. The first financial year shall begin today and it shall end on 28 February 2006.
2. The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The Shares in the Company have been subscribed as follows: 

The Shares have all been fully paid up by payment in cash of Yen 510,467,350 (JPY five hundred ten million four hun-

dred sixty-seven thousand three hundred and fifty), being the equivalent amount of Euro 3,770,069.05 (EUR three mil-
lion seven hundred seventy thousand sixty-nine and five cent), the surplus over the nominal value of the share capital of
the Company being accounted for as share premium in respect of the Class A Shares and the Class B Shares, evidence
of which has been given to the undersigned notary by the production of a blocking certificate.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the

Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles com-
ply with the provisions of Article 27 of the Companies Act 1915.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its formation amount approximately to forty thousand four hundred Euro (EUR
40,400).

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been

duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) That the number of directors of the Company be set at eight;
(ii) That the number of statutory auditors (commissaires aux comptes) of the Company be set at one;
(iii) That the members of the board of directors be authorised to be in charge of daily management (executive direc-

torship) of the Company;

(iv) That there be appointed as members of the board of directors of the Company for a term expiring on the date

of the annual general shareholders’ meeting resolving on the accounts closed at February 29, 2008:

- Dr Michael Schwarzkopf, Chairman of the Executive Board of PLANSEE HOLDING AG, with professional address

at A-6600 Reutte, Austria, as Non-Executive Class A Director;

- Mr Karlheinz Wex, Member of the Executive Board of PLANSEE HOLDING AG, with professional address at A-

6600 Reutte, Austria, as Non-Executive Class A Director;

- Dr Michael Krehl, Managing Director of SINTERSTAHL FÜSSEN, G.m.b.H, with professional address at Hiebeler-

straße 4, D-87629 Füssen, Germany, as Executive Class A Director;

- Mr Holger Steinweg, Managing Director of SINTERSTAHL FÜSSEN, G.m.b.H, with professional address at Hiebel-

erstraße 4, D-87629 Füssen, Germany, as Executive Class A Director;

- Mr Tsuneo Katsuki, Executive Vice President of MITSUBISHI MATERIAL CORPORATION, with professional ad-

dress at 5-1, Othemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan, as Non-Executive Class B Director;

(a) PLANSEE HOLDING A.G., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,750 Class A Shares
(b) MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,750 Class B Shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,500

Shares

4618

- Mr Fumio Shimada, Senior Executive Officer of MITSUBISHI MATERIAL CORPORATION, with professional ad-

dress at 5-1, Othemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan, as Non-Executive Class B Director;

- Mr Masafumi Koga, Executive Officer of MITSUBISHI MATERIAL CORPORATION, with professional address at 5-

1, Othemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan, as Executive Class B Director;

- Mr Yoshiyasu Iino, General Manager, POWDER METTALURGY DIVISION, ADVANCED MATERIALS AND

TOOLS COMPANY, MITSUBISHI MATERIAL CORPORATION, with professional address at 5-1, Othemachi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan, as Executive Class B Director.

(v) That there be appointed as statutory auditor for a period of three years (commissaire aux comptes) of the Com-

pany:

KPMG AUDIT, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer;
(vi) That the address of the registered office of the Company is set at L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of differences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together

with the notary the present deed.

Follows the German translation:

Im Jahre zweitausendfünf, den sechzehnten August um 15.45 Uhr.
Vor Uns, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. PLANSEE HOLDING A.G., eine Gesellschaft österreichischen Rechts, eingetragen beim lokalen Gericht von Inns-

bruck unter der Nummer FN 42472i und mit Gesellschaftssitz in 6600, Reute, Österreich,

hier vertreten durch Herrn Gilles Dusemon, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht ausgestellt in Reutte am 3. August 2005; und

2. MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, eine Gesellschaft japanischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 5-1, Oh-

ternachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8117, Japan,

hier vertreten durch Herrn Gilles Dusemon, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht ausgestellt in Tokio am 10. August 2005.

Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten, handelnd im Namen der

erschienenen Parteien, und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben
einregistriert zu werden.

Welche Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, den unterzeichneten Notar ersuchten die Satzung einer Akti-

engesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Bezeichnung und Sitz der Gesellschaft 
1.1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, die dem Gesetz vom 10.

August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das «Gesetz») und dieser Satzung (die «Satzung»)
unterliegt, welche die Bezeichnung PLANSEE MITSUBISHI MATERIALS GLOBAL SINTER HOLDING, S.A. (die «Ge-
sellschaft»), auf Japanisch: (japanische Schriftzeichen) führt.

1.2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mamer, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann in-

nerhalb derselben Gemeinde durch einen einfachen Beschluss des Vorstandes (der «Vorstand») verlegt werden. Durch
einfachen Beschluss des Vorstandes können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

1.3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
1.4. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche die gesetzlich vorgeschriebenen Vor-

aussetzungen für eine satzungsändernde Generalversammlung erfüllen muss, aufgelöst werden.

Art. 2. Gesellschaftszweck
2.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Eigentumsrechten im In- und Ausland, an Gesellschaften oder Unter-

nehmen jedweder Form und die Verwaltung solcher Eigentumsrechte. Die Gesellschaft kann insbesondere alle Wert-
papiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung durch
Zeichnungsverpflichtungen oder Optionen, durch Handel oder auf sonstige Weise erwerben oder durch Tausch oder
auf sonstige Weise veräußern, entweder ausgegeben von einer öffentlichen oder einer privaten Organschaft, Personen-
gesellschaften inklusive. Sie kann an der Gründung, der Entwicklung, der Verwaltung und der Kontrolle jedes Unterneh-
mens teilnehmen. Die Gesellschaft kann ebenfalls Patente, Markenschutzrechte, Lizenzzuweisungen, Sub-Lizenzen und
ähnliche Rechte, und alle sonstigen gewerblichen Schutzrechte unter irgendeinem Namen halten und verwerten, wie,
falls erforderlich den Schutz der Rechte die aus der Erwerbung dieser Patente, Markenschutzrechte, Lizenzzuweisung,
Sub-Lizenzen und ähnliche Rechte Dritten gegenüber garantieren.

2.2. Die Gesellschaft kann in jeder Form leihen. Sie darf Schuldverschreibungen, Obligationen und Schuldscheine und

jedwede Schuld und/oder Aktie ausgeben. Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehen,
Vorschüsse, Garantien oder Unterstützung jedweder Art erteilen. Die Gesellschaft kann auch Sicherheiten jedweder
Art (Bürgschaften, Garantien, Grundschuldner) in eigenem Namen sowie für Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist,
gegenüber Dritten stellen. Die Gesellschaft kann außerdem alle oder einige Ihrer Aktiva mit Hypothek, Unterpfand oder
Transfer belasten oder sie auf jede andere weise hypothekarisch belasten.

4619

2.3. Die Gesellschaft darf im Allgemeinen jede Maßnahme anwenden und jedes Instrument benutzen hinsichtlich Ihrer

Investitionen zwecks effizienter Verwaltung, darunter Maßnahmen und Instrumente entworfen zum Schutz der Gesell-
schaft gegen Kreditrisiken, Währungsschwankungen, Zinssatzschwankungen und andere Risiken.

2.4. Die Gesellschaft kann jede kommerzielle, finanzielle oder industrielle Operation ausführen in Zusammenhang mit

Immobilien oder beweglichen Gütern, welche direkt oder indirekt mit Ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die
Gesellschaft kann sich jeder anderen legalen Handlung oder Aktivität zuwenden, welche einer Aktiengesellschaft dem
Gesetz nach zusteht.

Art. 3. Kapital der Gesellschaft
3.1. Das Gesellschaftskapital beträgt drei Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 3.500.000) und ist eingeteilt in ein-

tausendsiebenhundertfünfzig (1.750) A Klasse Aktien (die «A Klasse Aktien») und eintausendsiebenhundertfünfzig B
Klasse Aktien (die «B Klasse Aktien») mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000) pro Aktie.

3.2. Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Gesellschaftskapital von fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000).
Der Vorstand der Gesellschaft ist hiermit ermächtigt das Gesellschaftskapital bis zum genehmigten Kapital zu erhö-

hen, durch die Ausgabe von siebenhundertfünfzig (750) neuen A Klasse Aktien (die «A1 Klasse Aktien») und siebenhun-
dertfünfzig (750) neuen B Klasse Aktien (die «B1 Klasse Aktien») mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000)
pro Aktie, mit oder ohne Ausgabenprämie, und dies von Zeit zu Zeit und vollständig oder teilweise, sowie, zum Ermes-
sen dessen, die Erwerbung von A1 Klasse Aktien und B1 Klasse Aktien innerhalb der Frist festgelegt in Artikel 32(2) und
32(5) des Gesetzes festzustellen und zu akzeptieren.

Der Vorstand kann jeder zeichnungsberechtigten Person, die hierzu bevollmächtigt ist, das Recht übertragen, Akti-

enzeichnungen entgegenzunehmen, die entsprechend ausgegebenen Aktien, die die ganze oder einen Teil der Kapitaler-
höhung darstellen, auszuhändigen und die Zahlung hierfür entgegenzunehmen, und alles zu unternehmen was nötig ist,
damit eine solche Kapitalerhöhung dokumentiert wird, und insbesondere um das Gesellschaftskapital abzuändern in der
vom Gesetz benötigten notariellen Form.

3.3. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Die A Klasse Aktien, die A1 Klasse Aktien, die B Klasse Aktien

und die B1 Klasse werden zusammen als «Aktien» bezeichnet, außer wenn der Kontext es anders verlangen sollte.

3.4. Sofern nicht anders verfügt in dieser Satzung, verleihen die A Klasse Aktien, die A1 Klasse Aktien, die B Klasse

Aktien und die B1 Klasse Aktien spezielle Rechte in Bezug auf die Ernennung der Vorstandsmitglieder, die Zahlung in
jedweder Form von jedweden Rücklagenfonds, die durch Ausgabeprämien konstituiert wurden, wobei jedwede solcher
Ausgabeprämien immer derjenigen Aktienklasse zugeordnet werden, in Bezug auf welche die Prämie bezahlt wurde und,
im Falle der A1 Klasse Aktien, eine spezielle Dividendenausschüttung nach Artikel 9.3; abgesehen von diesen Rechten
verleihen die A Klasse Aktien, die A1 Klasse Aktien, die B Klasse Aktien und die B1 Klasse Aktien dieselben Rechte an
Ihre respektiven Gesellschafter.

3.5. Im Falle einer Kapitalerhöhung hat jeder Gesellschafter das Recht auf einer pro-rata Basis neu ausgegebene Aktien

zu erwerben innerhalb seiner Klasse und dies ungeachtet eines jeden anderslautenden Entschlusses der Generalver-
sammlung der Gesellschafter.

3.6. Die Gesellschaft darf Ihre eigenen Aktien zurückkaufen innerhalb der gesetzlichen Einschränkungen und gemäß

dem Prinzip der Gleichbehandlung sämtlicher Gesellschafter.

Art. 4. Aktienregister
4.1. Der Vorstand hält ein Aktienregister am Gesellschaftssitz, wo es zwecks Einsicht eines jeden Gesellschafters zur

Verfügung stehen wird, in dem die Namen und Adressen aller Gesellschafter registriert werden sowie das Datum an
dem sie die Aktien erworben haben, das Datum dessen Bestätigung oder Vollstreckung, der eingezahlte Betrag für jede
Aktie und die Übertragung von Aktien und das Datum einer solchen Übertragung. Eigentum von Aktien wird durch die
Eintragung in dieses Register etabliert.

4.2. Auf Verlangen eines jeden Gesellschafters wird der Vorstand kostenlos einen Auszug des Registers an jeden Ge-

sellschafter ausstellen.

Art. 5. Aktienübertragungen, Übertragungseinschränkungen
5.1. Vorhergehende Schriftliche Erlaubnis
Sofern nicht ausdrücklich anderswo in dieser Satzung erlaubt, darf bis zum 1. Dezember 2010 keiner der Gesellschaf-

ter alle oder einen Teil der Aktien die er hält, oder irgendwelche Rechte oder Optionen auf diese Aktien, verkaufen,
übertragen, zuerkennen, darauf verzichten, die Existenz einer Verbindlichkeit darauf schaffen oder dulden, oder Optio-
nen oder Rechte darauf gewähren («Übertragen»), ohne die vorhergehende schriftliche Erlaubnis der Generalversamm-
lung der Gesellschafter; unter der Voraussetzung jedoch, dass jeder Gesellschafter (die «Übertragende Partei») ohne
die vorhergehende schriftliche Erlaubnis der Generalversammlung der Gesellschafter alle oder einen Teil seiner Aktien
an seine Tochtergesellschaften, welche die Übertragende Partei gänzlich oder teilweise als Tochtergesellschaften besitzt,
Übertragen.

5.2. Vorkaufsrecht
Ab dem 1. Dezember 2010 darf jeder Gesellschafter, jedoch nur (i) mit Einverständnis der Generalversammlung der

Gesellschafter oder (ii) zu folgenden Bedingungen, sämtliche oder einen Teil seiner Aktien Übertragen:

(a) Falls ein Gesellschafter (der «Anbieter») vorschlägt sämtliche oder einen Teil seiner Aktien zu Übertragen (die

«Angebotenen Aktien») an irgendeine Person, wird der Anbieter ein schriftliches Angebotsschreiben (das «Angebots-
schreiben») an den anderen Gesellschafter zukommen lassen (der «Angebotsempfänger») in dem er (i) seine gutgläubige
Absicht zur Übertragung der Angebotenen Aktien erklärt, (ii) die Identität des vorgeschlagen Empfängers enthüllt (der
«Vorgeschlagene Empfänger») und (iii) den Kaufpreis, welcher nur gegen Barzahlung beglichen werden kann, und die
anderen prinzipiellen Bedingungen (inklusive das voraussichtliche Abschlussdatum) einer solcher gutgläubigen Übertra-
gung enthüllt;

4620

(b) Innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Empfang des Angebotsschreibens (die «Verweigerungsperiode») hat der

Angebotsempfänger das Vorrecht (i) auf den Kauf von allen Angebotenen Aktien unter denen im Angebotsschreiben
gegebenen Bedingungen oder (ii) auf die Ernennung einer anderen Person, die alle Angebotenen Aktien unter denen im
Angebotsschreiben gegebenen Bedingungen zu kaufen wird oder (iii) auf die Ernennung einer oder mehrerer Personen,
die gemeinschaftlich und/oder gemeinschaftlich mit dem Angebotsempfänger die Angebotenen Aktien unter den im An-
gebotsschreiben gegebenen Bedingungen kaufen soll. Falls ein Angebotsempfänger es so wünscht, wird der Angebots-
empfänger den Anbieter schriftlich über seine Absicht informieren, sämtliche Angebotenen Aktien zu kaufen oder eine
andere Person zu bestimmen, die sämtliche Angebotenen Aktien kaufen wird. Beim Kaufabschluss wird der Anbieter
sämtliche Angebotenen Aktien dem Angebotsempfänger oder, falls zutreffend, anderen Personen Übertragen, frei von
irgendwelchen Pfandrechten und unter denselben Bedingungen wie im Angebotsschreiben beschrieben. Um Zweifel zu
vermeiden: in allen Fällen, die in den Unterabsätzen (i) bis (iii) dieses Artikels 5.2.(b) beschrieben wurden, soll die Ge-
genleistung für den Erwerb der Angebotenen Aktien durch den Angebotsempfänger oder, falls zutreffend, den anderen
Personen, ausschließlich durch eine Bargeldzahlung beglichen werden; und

(c) Falls der Angebotsempfänger sich entscheidet, keine der Angebotenen Aktien zu kaufen oder keine andere(n) Per-

son(en) zu ernennen, die dies tun soll(en), dann darf der Anbieter die Angebotenen Aktien an den Vorgeschlagenen
Empfänger Übertragen; unter der Bedingung, dass eine derartige Übertragung (i) innerhalb von sechzig (60) Tagen nach
Ende der Verweigerungsperiode abgeschlossen wird und (ii) ausgeführt wird mit Einhaltung der im Angebotsschreiben
ausgeführten Bedingungen. Falls solche Angebotenen Aktien nicht auf diese Weise übertragen werden, muss der Anbie-
ter die anderen Gesellschafter gemäß diesem Artikel 5.2. benachrichtigen, ehe irgendwelche anderen oder folgenden
Übertragungen solcher Angebotenen Aktien gemacht werden dürfen.

5.3. Kein Pfandrecht auf Aktien
Ungeachtet irgendeiner gegenteiligen Bestimmung dieser Satzung wird keiner der Gesellschafter irgendwelche Aktien

verpfänden oder mit Hypotheken belasten oder die Aktien auf irgendwelche andere Weise als Sicherheit oder für ir-
gendeinen anderen Zweck benutzen, der zu einer unfreiwilligen Übertragung oder Zuweisung solcher Aktien oder eines
Teils davon führen könnte durch ein Pfandrecht auf solchen Aktien oder auf andere Weise an andere Personen, außer
es wurde eine schriftliche Zustimmung der Generalversammlung der Gesellschafter für so eine solche Verpfändung, Hy-
pothek oder andere Zuweisung erhalten.

5.4. Folgen eines Vertragsbruches
Falls irgendein Gesellschafter sämtliche oder einen Teil der Aktien die er hält oder in welche er ein Interesse hält in

Verletzung dieses Artikels V. Überträgt (ausgenommen kleine technische Verletzungen des Artikels 5.2.), neben irgend-
welchen anderen Rechtsmitteln die dem nicht-verletzenden Gesellschafter zur Verfügung stehen, wird der verletzende
Gesellschafter, nach Wahl des nicht-verletzenden Gesellschafters: (a) innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Mitteilung
von den nicht-verletzenden Gesellschaftern, den gesamten Ertrag, welcher vom Käufer für den Verkauf der Aktien emp-
fangen wurde, an den nicht-verletzenden Gesellschafter übertragen; (b) die Aktien von einem solchen Käufer zurück-
kaufen innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Übertragung und dem nicht-verletzenden Gesellschafter alle solche
Aktien verkaufen, frei von irgendwelchen Pfandrechten, zum niedrigeren Wert, entweder vom angemessenen Markt-
wert, so wie dieser zwischen den Gesellschaftern ausgehandelt wurde oder im Einklang mit solchen anderen Prozedu-
ren, welche von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern ausgehandelt wurden (der «Angemessene Marktwert»), oder
von solchem anderen Preis, welcher vom verletzenden Gesellschafter und jeder anderen Person ausgehandelt wurde;
oder (c) innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Mitteilung durch den/die nicht-verletzende(n) Gesellschafter, alle
Aktien des nicht-verletzenden Gesellschafters zu kaufen, frei von irgendwelchen Pfandrechten, zum höheren Wert, ent-
weder vom Angemessenen Marktwert oder von solchem anderen Preis, welcher vom verletzenden Gesellschafter und
jeder anderen Person ausgehandelt wurde.

5.5. Verschiedenes
5.5.1. Insoweit das Gesetz es verlangt, im Falle einer gemäß Artikel 5.4(b) oder (c) vorgesehenen Übertragung werden

die Gesellschafter einen Aktienübertragungsvertrag (der «Aktienübertragungsvertrag») unterschreiben, um der Über-
tragung Wirkung zu verleihen.

5.5.2. Aktien werden übertragen durch eine schriftliche Übertragungserklärung im Aktienregister der Gesellschaft;

solch eine Übertragungserklärung soll vom Überträger und dem Übertragenden oder durch diejenige Personen, die gül-
tige Prokura besitzen, ausgeführt werden. Die Gesellschaft darf auch andere Übertragungsinstrumente als Beweis einer
Übertragung annehmen, falls diese der Gesellschaft ausreichen.

5.5.3. Jede Mitteilung, die hierunter notwendig oder gestattet ist, muss schriftlich per Einschreiben oder mit Zuliefe-

rungsbestätigung gesendet werden oder persönlich abgeliefert werden; jede Frist wird gerechnet vom Datum des Emp-
fangs durch den Adressaten, falls die Mitteilung an mehrere Personen versandt wurde, vom Datum des Empfangs durch
den letzten Adressaten. Jede Mitteilung wird als zeitig versendet betrachtet falls sie am letzten Tag der Frist der Post
und/oder einem Kurierdienst übergeben wurde. Falls der letzte Tag ein Samstag, Sonntag oder Feiertag ist im Heimat-
land des Absenders, so wird die Frist verlängert bis zum nächsten Werktag.

Art. 6. Vorstand
6.1. Der Vorstand hat völlige Verantwortung und exklusive Vollmacht um sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsent-

scheidungen zu treffen, die nicht ausdrücklich der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind gemäß Lu-
xemburgischen Rechts oder dieser Satzung.

6.2. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus 8 (acht) Vorstandsmitgliedern, wovon 4 (vier) geschäftsführende Vor-

standsmitglieder (die «Geschäftsführenden Vorstandsmitglieder») sein sollen, betraut mit der tagtäglichen Führung der
Gesellschaft (administrateurs-délégués à la gestion journalière), und die anderen 4 (vier) sollen nicht-geschäftsführende
Vorstandsmitglieder (die «Nicht-Geschäftsführenden Vorstandsmitglieder») sein. Die Mitglieder des Vorstandes wer-
den von der Generalversammlung der Gesellschafter bestellt; die Generalversammlung kann ein Mitglied des Vorstandes

4621

jederzeit abberufen. Nicht-Geschäftsführende Vorstandsmitglieder können entweder natürliche oder rechtliche Perso-
nen sein.

6.3. 2 (zwei) Geschäftsführende Vorstandsmitglieder und 2 (zwei) Nicht-Geschäftsführende Vorstandsmitglieder wer-

den von der Generalversammlung der Gesellschafter aufgrund einer Liste von Kandidaten gewählt, welche von den In-
habern einer Mehrheit von A Klasse Aktien und A1 Klasse Aktien (die «A Klasse Vorstandsmitglieder») erstellt wurde
und 2 (zwei) Geschäftsführende Vorstandsmitglieder und 2 (zwei) Nicht-Geschäftsführende Vorstandsmitglieder wer-
den aufgrund einer Liste von Kandidaten gewählt, welche von den Inhabern einer Mehrheit von B Klasse Aktien und B1
Klasse Aktien (die «B Klasse Vorstandsmitglieder») erstellt wurde. Das erste Mandat der Vorstandsmitglieder endet mit
der jährlichen Hauptversammlung der Gesellschafter, die über die am 29. Februar 2008 abgeschlossenen Geschäftsbü-
cher entscheiden wird. Danach wird das Mandat jedes Vorstandsmitglieds 2 (zwei) Jahre betragen.

6.4. Bei freigewordenem Vorstandssitz steht den verbleibenden Vorstandsmitgliedern das Recht zu, für die vorläufige

Ersetzung durch ein neues Vorstandsmitglied Sorge zu tragen. Dies geschieht auf schriftliche Anfrage einer Gesellschaf-
tergruppe hin (wobei eine «Gesellschaftergruppe» sich auf die Inhaber der A Klasse Aktien als Gruppe bezieht, die In-
haber der A1 Klasse Aktien als Gruppe bezieht, die Inhaber der B Klasse Aktien als Gruppe bezieht und die Inhaber der
B1 Klasse Aktien als Gruppe bezieht), welche das zu ersetzende Vorstandsmitglied zur Wahl ernannt hat; bis zum Zeit-
punkt einer solchen Ernennung oder Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds durch die Generalversammlung der Gesell-
schafter kann der Vorstand keinen Beschluß fassen in Bezug auf irgendeinen der im Artikel 7 erwähnten Punkte.

Die Generalversammlung der Gesellschafter entscheidet über die Vergütung und alle anderen Bestimmungen der Ar-

beitsverträge eines jeden Vorstandsmitglieds.

6.5. Der Vorstand wird unter seinen Mitgliedern einen Vorstandsvorsitzenden und einen Stellvertretenden Vor-

standsvorsitzenden ernennen, die beide Nicht-Geschäftsführende Vorstandsmitglieder sind, wobei der Vorstandsvorsit-
zende und der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende jedes Mal von der Kandidatenliste einer anderen Gruppe gewählt
werden müssen und alle 2 (zwei) Jahre, mit Ausnahme der ersten Amtszeit, welche am Tag der Hauptversammlung der
Gesellschafter, die über die am 29. Februar 2008 abgeschlossenen Geschäftsbücher entscheiden wird, endet, soll der
Vorstandsvorsitzende und der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende jedes Mal von der Kandidatenliste der anderen
Gruppe gewählt werden. Der erste Vorstandsvorsitzende wird von der Kandidatenliste gewählt, welche von Inhabern
einer Mehrheit von A Klasse Aktien und die A1 Klasse Aktien aufgestellt wurde, und der erste Stellvertretende Vor-
standsvorsitzende wird gewählt von der Kandidatenliste, welche von den Inhabern einer Mehrheit von B Klasse Aktien
und B1 Klasse Aktien augestellt wurde.

6.6. Der Vorstand trifft sich so oft wie es das Interesse der Gesellschaft verlangt, aber mindestens vier (4) mal im Jahr,

jedes Mal nicht später als ein Monat nach Abschluss eine Steuerquartals, und ansonsten falls 2 (zwei) Vorstandsmitglieder
darum bitten, spätestens innerhalb von 2 (zwei) Wochen nach einer solchen Anfrage. Die Haushaltsversammlung wird
im Monat vor dem Anfang des neuen Geschäftsjahres der Gesellschaft abgehalten. Versammlungen des Vorstandes dür-
fen außerhalb des Großherzogtum Luxemburgs abgehalten werden.

6.7. Entscheidungen dürfen durch den Vorstand getroffen werden, ohne dass eine Versammlung abgehalten worden

ist, falls ein Entscheidungsvorschlag an alle Mitglieder des Vorstandes gegeben wurde und jedes Vorstandsmitglied einer
solchen Entscheidung zustimmt. In solch einem Fall können Entscheidungen des Vorstandes nur dann angenommen wer-
den, falls alle Vorstandsmitglieder einem solchen Antrag durch Rundreichung desselben schriftlich zugestimmt haben.
Eine solche Entscheidung soll aus einem oder mehrere Dokument(en) bestehen, welche die Entscheidungen enthalten
und unterzeichnet sind von jedem Vorstandsmitglied (résolution écrite ou résolution circulaire). Das Datum einer sol-
chen Entscheidung wird der Tag sein an welchem die Entscheidung vom letzten Vorstandsmitglied unterschrieben wur-
de.

6.8. Versammlungen des Vorstandes werden durch den Vorstandsvorsitzenden einberufen, und falls der Vorstands-

vorsitzende verhindert ist solch eine Versammlung einzuberufen, durch den Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden;
falls ein Antrag zur Einberufung einer Versammlung durch 2 (zwei) Vorstandsmitglieder nicht eingehalten wurde, darf
eine Versammlung durch die 2 (zwei) Vorstandsmitglieder selbst einberufen werden. Jede Mitteilung zur Einberufung
einer Versammlung soll Zeit und Ort angeben wo die Versammlung stattfinden soll, zusammen mit der Tagesordnung
der Versammlung.

6.9. Die beschlussfähige Anzahl der Vorstandsmitglieder beläuft sich auf mindestens 5 (fünf) Vorstandsmitglieder. Falls

diese beschlussfähige Anzahl nicht erfüllt ist, wird eine zweite Versammlung einberufen, welche die Tagesordnung der
vorigen Versammlung, zusammen mit einer Erklärung die auf die Nichterfüllung der Beschlussfähigkeit der letzten Ver-
sammlung verweist, und diese zweite Versammlung ist beschlussfähig ungeachtet der Zahl der anwesenden oder vertre-
tenen Vorstandsmitglieder, unter der Bedingung, dass zumindest ein A Klasse Vorstandsmitglied und ein B Klasse
Vorstandsmitglied anwesend oder vertreten ist.

6.10. Entscheidungen des Vorstandes werden durch einfache Mehrheitswahl angenommen, außer in den Fällen wo

diese Satzung es anders verordnet. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Weder der Vorstandsvorsitzende noch
der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende hat eine ausschlaggebende Stimme. Falls keine Mehrheit besteht, muss die
Angelegenheit der Generalversammlung der Gesellschafter zur Entscheidung vorgelegt werden und dies auf Anfrage jed-
weden Vorstandsmitglieds hin.

6.11. Ein Vorstandsmitglied kann ein anderes Vorstandsmitglied, welches durch dieselbe Gesellschaftergruppe schrift-

lich wurde, mittels einer schriftlichen Erlaubnis, elektronische Post oder Fax inbegriffen, ermächtigen ihn auf einer Vor-
standsversammlung zu vertreten; ein Vorstandsmitglied kann auch an einer Versammlung teilnehmen mittels Telefon-
und/oder Videokonferenz, unter der Bedingung, dass alle teilnehmende Vorstandsmitglieder der Versammlung sich hö-
ren und miteinander reden können und dass sie sich angemessen beraten können; eine Teilnahme mit solchen Mitteln
steht einer persönlichen Präsenz bei einer solchen Versammlung gleich.

4622

6.12. Versammlungen, Entscheidungen und Protokolle werden auf Englisch gehalten und ausgeführt. Alle Entscheidun-

gen des Vorstandes müssen zu Protokoll gegeben werden, welcher durch den Vorstandsvorsitzenden unterschrieben
wird; jede Vollmacht wird dem Protokoll angeheftet. Kopien und/oder Auszüge des Protokolls, die dem Gericht oder
anderen Personen zur Verfügung gestellt werden müssen, werden vom Vorstandsvorsitzenden beglaubigt.

Art. 7. Geschäftsführende Vorstandsmitglieder
7.1. Vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung der Gesellschafter kann der Vorstand die tägliche Ge-

schäftsführung der Gesellschaft an die Geschäftsführenden Vorstandsmitglieder und/oder andere Stellvertreter, welche
nicht Vorstandsmitglieder sein müssen, übertragen.

7.2. Der Vorstand bestimmt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (President) sowie einen Stellvertretenden

Vorsitzenden (Vice President), die beide Geschäftsführende Vorstandsmitglieder sein müssen, wobei der Vorsitzende
und der Stellvertretende Vorsitzende jedes mal aufgrund einer Kandidatenliste, die von einer anderen Gesellschafter-
gruppe aufgestellt wird, bestimmt werden sollen; alle zwei Jahre, mit Ausnahme der ersten Laufzeit, die mit der ordent-
lichen jährlichen Hauptversammlung, welche über die am 29. Februar abgeschlossenen Geschäftsbücher beschließt,
werden der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende aus einer Kandidatenliste, die von der anderen Gesell-
schaftergruppe ernannt wird, bestimmt. Der erste Vorsitzende wird aufgrund einer Kandidatenliste, welche von den In-
habern einer Mehrheit von B Klasse Aktien und B1 Klasse Aktien festgelegt wird, gewählt und der erste Stellvertretende
Vorsitzende wird aufgrund einer Kandidatenliste, welche von den Inhabern einer Mehrheit von A Klasse Aktien und A1
Klasse Aktien festgelegt wird, gewählt. Der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende können nie von derselben
Gruppe gewählt werden, er Vorgehensweise von der Generalversammlung der Gesellschafter wurde.

7.3. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam verpflichtet durch die Geschäftsführenden Vorstandsmitglieder

wobei 2 (zwei) Geschäftsführende Vorstandsmitglieder durch gemeinschaftliche Zeichnung gemeinsam die Gesellschaft
vertreten können.

7.4. Die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder schließen die Arbeitnehmerverträge mit den Arbeitsnehmern ab and

kündigen die Arbeitnehmerverträge.

Art. 8. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Abschlussprüfung
8.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten März und endet am letzen Tag des Monats Februar.
8.2. Jedes Jahr nach Ende des Geschäftsjahres erstellt der Vorstand den Jahresabschluss und einen Jahresbericht be-

züglich dieses Geschäftsjahres.

8.3. Der Jahresabschluss wird von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet und muss den Jahresbericht und alle vom

luxemburgischen Gesetz vorgeschriebenen Unterlagen beinhalten.

8.4. Der Jahresabschluss muss den Gesellschaftern und jedem der Vorstandsmitglieder zur Einsichtnahme und/oder

Erhalt von Kopien zur Verfügung gestellt werden.

8.5. Die Gesellschaft muss das Rechnungswesen und das Buchhaltungsverfahren gemäß den zwingenden Vorschriften

des luxemburgischen Rechts und in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Bilanzrichtlinien anwenden.

8.6. Ein oder mehrere Abschlussprüfer (commissaires aux comptes) werden von der Generalversammlung der Ge-

sellschafter für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren gewählt; Abschlussprüfer können für eine oder mehrere Amts-
zeiten ernannt werden. Abschlussprüfer können von der Generalversammlung der Gesellschafter jederzeit und ohne
Grund abgerufen werden. Die Generalversammlung der Gesellschafter entscheidet über die Vergütung der Ab-
schlussprüfer. Jeder Abschlussprüfer hat ein uneingeschränktes Recht zur Prüfung aller Geschäfte der Gesellschaft und
ihrer n und kann alle finanziellen Dokumente, Korrespondenzen, Protokolle, Unterlagen sowie alle anderen finanziellen
Dokumente der Gesellschaft und ihrer n prüfen und untersuchen. Die Abschlussprüfer müssen die Generalversammlung
der Gesellschafter über das Ergebnis der Abschlussprüfung des konsolidierten und des unkonsolidierten Jahresabschlus-
ses der Gesellschaft und ihrer n, die Art und Weise und die Natur der Prüfung der Inventur informieren und müssen
Verbesserungsvorschläge einreichen, falls notwendig.

Art. 9. Dividendenpolitik
9.1. Gemäß des Gesetzes wird die Generalversammlung der Gesellschafter jede und alle Dividenden, falls vorhanden,

zahlbar in Bezug auf jedes Geschäftsjahr am 30. März des nächsten Geschäftsjahres, den Gesellschaftern angeben und
auszahlen, selbst wenn diese Erklärung sich auf den geplanten Jahresabschluss vom 28./29. Februar des gegebenen Ge-
schäftsjahres stützen muss, vorausgesetzt dass jede Zahlungen jeder Form aus Kapitalrücklagen, die durch die Zahlung
von Prämien errichtet worden sind, nur hinsichtlich dieser Aktienklasse bezahlt werden in Bezug auf die die Prämie ur-
sprünglich gezahlt wurde.

Ein Betrag von 5 (fünf) Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes ist der gesetzlichen Rücklage zuzu-

weisen, bis diese oder einen in der Satzung bestimmten höheren Anteil des Gesellschaftskapitals beträgt.

9.2. Unter Berücksichtigung des Gesetzes ist der Vorstand ermächtigt, Zwischendividenden auszuzahlen.
9.3. Die Inhaber der A Klasse Aktien, in ihrer Gesamtheit, sind exklusiv berechtigt zu einer einmaligen (one time)

bevorzugten speziellen Dividendenausschüttung bis zu einem Betrag von EUR 13.197.000 (dreizehn Millionen einhun-
dertsiebenundneunzigtausend Euro) (die «Spezielle Dividende»), sofern nicht anders von der Generalversammlung der
Gesellschafter entschieden wurde, für die Änderung dieser Satzung. Die Spezielle Dividende soll von der ordentlichen
jährlichen Hauptversammlung der Gesellschafter entschieden werden, jedoch nicht eher als bei der ordentlichen jährli-
chen, die über den Jahresabschluss für jenes Geschäftsjahr beschließt, in welchem die EUR 13.197.000 (dreizehn Millio-
nen einhundertsiebenundneunzigtausend Euro) des Gesellschaftskapitals und der Reserven (Gewinnrücklage von
SINTERSTAHL ASTURIAS S.A. oder SSA (SSA RÜCKLAGE) an die Gesellschaft verteilt und somit von der Gesellschaft
empfangen wurden. In der Zeitspanne zwischen dem Empfang der SSA RÜCKLAGE von SAA und dem Zeitpunkt wo
die Gesellschaft die Spezielle Dividende an die Inhaber der A Klasse Aktien ausgezahlt hat, kann die Gesellschaft keine
anderen Gewinne an die Gesellschafter auszahlen.

4623

Art. 10. Generalversammlungen der Gesellschafter
10.1. Verfahren
10.1.1. Die ordentliche jährliche Generalversammlung der Gesellschafter findet, in Übereinstimmung mit dem luxem-

burgischen Gesetz, in Mamer am Sitz der Gesellschaft statt oder an einem anderen im Einberufungsschreiben angege-
benen Ort der Gemeinde, am ersten Dienstag im Juni jedes Jahres um 10 Uhr morgens. Ist dieser Tag kein gesetzlicher
Arbeitstag für Banken in Luxemburg, so findet die ordentliche jährliche Generalversammlung der Gesellschafter am
nächsten Arbeitstag statt.

10.1.2. Die ordentliche jährliche Generalversammlung der Gesellschafter kann im Ausland stattfinden wenn es auf-

grund, im absoluten und endgültigen Urteil des Vorstandes, außergewöhnlichen Umständen notwendig ist.

10.1.3. Andere Generalversammlungen der Gesellschafter, einschließlich ordentliche und außerordentliche General-

versammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft, werden an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten, wie
dies in dem entsprechenden Einberufungsschreiben angegeben wird.

10.1.4. Die Generalversammlungen der Gesellschafter werden vom Vorstand durch Einschreiben an alle im Register

unter Artikel IV registrierten Gesellschafter, mindestens fünfzehn (15) Tage vor dem geplanten Termin, einberufen. Sind
alle Gesellschafter anwesend oder vertreten und einverstanden um über die vorgelegte Tagesordnung abzustimmen, so
kann die Generalversammlung der Gesellschafter auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

10.1.5. Eine Generalversammlung der Gesellschafter kann auch unverzüglich einberufen werden falls Gesellschafter,

die mindestens ein Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, einen schriftlichen Antrag unter Angabe der Tagesord-
nung auf Einberufung auffordern. Falls der Vorstand den Antrag innerhalb non 14 (vierzehn) Tagen nicht befolgt, so kön-
nen die berechtigten Gesellschafter selbst die Generalversammlung der Gesellschafter einberufen, wobei sie einen
Erklärungsbericht vorlegen sollen. In diesem Fall soll die Generalversammlung der Gesellschafter entscheiden, ob die
Gesellschaft die Kosten der Einberufung tragen soll.

10.1.6. Jeder Gesellschafter ist berechtigt eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss, zu bevollmächtigen,

ihn zu vertreten und an seiner Stelle bei der Generalversammlung der Gesellschafter abzustimmen.

10.1.7. Das Einberufungsschreiben der Generalversammlungen der Gesellschafter soll, in Übereinstimmung mit den

zwingenden Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes, das Datum, die Zeit und den Ort der Generalversammlung
der Gesellschafter, sowie die Tagesordnung der Generalversammlung der Gesellschafter, bekanntgeben.

10.1.8. Jede Generalversammlung der Gesellschafter wird durch den Vorstandsvorsitzenden oder, bei seiner Verhin-

derung, durch den Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden geleitet.

10.1.9. Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung nichts Anderes bestimmen,

müssen mindestens 51 (einundfünfzig) % des eingezahlten Kapitals der Gesellschaft anwesend oder ordnungsgemäß ver-
treten sein, damit die Generalversammlung der Gesellschafter beschlussfähig ist. Falls diese beschlussfähige Anzahl nicht
erfüllt ist, wird eine zweite Generalversammlung der Gesellschafter einberufen, wobei diese zweite Generalversamm-
lung der Gesellschafter sich auf dieselbe Tagesordnung beschränken soll wie die letzte Generalversammlung der Gesell-
schafter, mit einer Erklärung bezüglich der Nichterfüllung der Beschlussfähigkeit der letzten Generalversammlung der
Gesellschafter und, unabhängig vom dabei vertretenen Kapital, beschlussfähig ist.

10.1.10. Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung nichts anderes bestimmen,

werden Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlungen der Gesellschafter durch eine Mehrheit der Stimmen gefasst.
Außerordentliche Beschlüsse bedürfen immer der Mehrheit von 2/3 (zwei Drittel) der Stimmen.

10.1.11. Beglaubigte Kopien oder Auszüge der Protokolle der Generalversammlung der Gesellschafteren, die dem

Gericht oder irgendeiner Person vorgelegt werden sollen, werden vom Vorstandsvorsitzenden unterzeichnet.

10.2. Kompetenzen
Angelegenheiten, die von der Generalversammlung der Gesellschafter beschlossen werden müssen:
10.2.1. Insofern als ordentliche Hauptversammlungen zuständig sind:
(i) Verschmelzungen und Übernahmen (einschließlich und ohne Einschränkung,) der Gesellschaft;
(ii) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Abschlussprüfer;
(iii) Bestimmung der Vergütungen der Mitglieder des Vorstandes und der Abschlussprüfer;
(iv) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses;
(v) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses, mit Ausnahme der Zwischendividenden;
(vi) Abtretung oder Verkauf von allen oder von einem substantiellen Teil des Geschäfts der Gesellschaft;
(vii) Miete, Auslagerung oder Betrauung eines Dritten mit der Betriebsführung oder mit einem substantiellen Teil des

Betriebes der Gesellschaft sowie Absprache mit einem Dritten für das Teilen der Gewinne oder der Verluste eines sub-
stantiellen Teiles des Betriebes der Gesellschaft; 

(viii) Erwerb, nach der Gründung der Gesellschaft, von einem Gründungspartner (d.h. Quasibeitrag);
(ix) Eintreten in neue Geschäfte außerhalb der Rahmen dessen in dieser Satzung dargelegten Gesellschaftszweckes;

und

(x) Jede anderen Angelegenheiten, die durch die Stimmen der Gesellschafter bei der ordentlichen Generalversamm-

lungen der Gesellschafter genehmigt werden müssen.

10.2.2. Insofern außerordentliche Generalversammlungen der Gesellschafter betroffen sind:
(i) Kapitalerhöhung/ Kapitalherabsetzung der Gesellschaft;
(ii) Änderung der Satzung;
(iii) Jede anderen Angelegenheiten, die durch die positive Stimme der Gesellschafter bei der außerordentlichen Ge-

neralversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft genehmigt werden müssen.

(xi) Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

Art. 11. Auflösung und Liquidation
11.1. Die Hauptversammlung kann die Auflösung der Gesellschaft jederzeit beschließen.

4624

11.2. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter aufgelöst, so wird die Liqui-

dation von mindestens zwei Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die
von der Generalversammlung der Gesellschafter bestellt werden, welche ihre Vergütung festsetzt, wobei mindestens
ein Liquidator aus der Kandidatenliste, die von den Inhabern der A Klasse Aktien und A1 Klasse Aktien festgelegt wird,
von der Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt wird und mindestens ein Liquidator aus der Kandidatenliste,
die von den Inhabern der B Klasse Aktien und B1 Klasse Aktien festgelegt wird, von der Generalversammlung der Ge-
sellschafter bestimmt wird. Falls die Generalversammlung der Gesellschafter keinen Liquidator bestellt, wird die Liqui-
dation von den Mitgliedern des Vorstandes durchgeführt.

Art. 12. Allgemeine Bestimmung. Diese Satzung muss in Übereinstimmung mit dem Gesetz interpretiert, aus-

gelegt und ergänzt werden.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 28. Februar 2006.
2. Die erste ordentliche Hauptversammlung findet im Kalenderjahr 2006 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Erschienenen haben die Aktien wie folgt gezeichnet: 

Die Aktien sind durch Bargeldzahlung von Yen 510.467.350 (JPY fünfhundertzehn Millionen vierhundertsiebenund-

sechzigtausenddreihundertfünfzig) des gleichwertigen Betrages in Euro von 3.770.069,05 (EUR drei Millionen siebenhun-
dertsiebzigtausendneunundsechzig und fünf Cent) eingezahlt worden, wobei der hierdurch erzielte Mehrbetrag in die
Rücklage hinsichtlich der A Klasse Aktien und der B Klasse einzustellen ist, worüber dem unterzeichneten Notar Nach-
weis durch eine Bankbescheinigung erbracht wurde.

<i>Bestätigung

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes genannten Bedingungen erfüllt sind und be-

stätigt ebenfalls, dass diese Satzung die Bestimmungen des Artikels 27 des Gesetzes erfüllt.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr vierzigtausendvierhundert Euro (EUR 40.000).

<i>Generalversammlung der Gesellschafter

Sodann treten die Erschienenen, die das gesamte unterzeichnete Gesellschaftskapital vertreten, zu einer ersten Ge-

neralversammlung der Gesellschafter zusammen.

Nachdem sie anerkennt haben, dass sie ordnungsgemäß einberufen worden sind, fassen sie einstimmig folgende Be-

schlüsse:

(i) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf acht festgesetzt;
(ii) Die Zahl der Abschlussprüfer (commissaires aux comptes) wird auf einen festgesetzt;
(iii) Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird an die Mitglieder des Vorstandes übertragen;
(iv) Es werden zu Mitgliedern des Vorstandes ernannt, bis zum Ende der folgenden Hauptversammlung, welche über

die am 29. Februar 2008 abgeschlossenen Geschäftsbücher beschließt:

- Dr. Michael Schwarzkopf, Vorsitzender des Geschäftsführenden Vorstandes von PLANSEE HOLDING AG, beruf-

lich wohnhaft in A-6600 Reutte, Österreich, als Nicht-Geschäftsführendes A Klasse Vorstandsmitglied;

- Herr Karlheinz Wex, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes von PLANSEE HOLDING AG, beruflich wohn-

haft in A-6600 Reutte, Österreich, als Nicht-Geschäftsführendes A Klasse Vorstandsmitglied;

- Dr. Michael Krehl, Geschäftsführer von SINTERSTAHL FÜSSEN, G.m.b.H, beruflich wohnhaft in Hiebelerstraße 4,

D-87629 Füssen, Deutschland, als Geschäftsführendes A Klasse Vorstandsmitglied;

- Herr Holger Steinweg, Geschäftsführer von SINTERSTAHL FÜSSEN, G.m.b.H, beruflich wohnhaft in Hiebelerstraße

4, D-87629 Füssen, Deutschland, als Geschäftsführendes A Klasse Vorstandsmitglied;

- Herr Tsuneo Katsuki, Executive Vice President von MITSUBISHI MATERIAL CORPORATION, beruflich wohnhaft

in 5-1, Othemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8117, Japan, als Nicht-Geschäftsführendes B Klasse Vorstandsmit-
glied;

- Herr Fumio Shimada, Senior Executive Officer von MITSUBISHI MATERIAL CORPORATION, beruflich wohnhaft

in 5-1, Othemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8117, Japan, als Nicht-Geschäftsführendes B Klasse Vorstandsmit-
glied;

- Herr Masafumi Koga, Executive Officer von MITSUBISHI MATERIAL CORPORATION, beruflich wohnhaft in 5-1,

Othemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117, Japan, als Geschäftsführendes B Klasse Vorstandsmitglied;

- Herr Yoshiyasu lino, General Manager, Powder Mettalurgy Division, Advanced Materials and Tools Company, MIT-

SUBISHI MATERIAL CORPORATION, beruflich wohnhaft in 5-1, Othemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117,
Japan, als Geschäftsführendes B Klasse Vorstandsmitglied.

(v) Zum Abschlussprüfer (commissaire aux comptes) der Gesellschaft für eine Periode von drei Jahren wird ernannt:
KPMG AUDIT, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer;
(vi) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-8232 Mamer, 101, route de Holzem festgelegt.

(a) PLANSEE HOLDING A.G., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.750 A Klasse Aktien
(b) MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.750 B Klasse Aktien

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.500

Aktien

4625

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass auf Antrag der oben genannten

Erschienenen die gegenwärtige Urkunde auf Englisch verfasst ist und von einer deutschen Version gefolgt ist. Auf Antrag
derselben Erschienenen und falls sich der englische und der deutsche Text unterscheiden, wird die englische Version
Vorrang haben.

Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorhergehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit

dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. Dusemon, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 64, case 11. – Reçu 37.700,69 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081573.3/230/852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

VEBECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 67.118. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00073, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078982.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

DIA TRITONCO 2 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.622. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07778, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078986.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ANGLO-DUTCH INVESTMENT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 80.881. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07777, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078988.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

WATERFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 46.401. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 janvier 1994, acte publié 

au Mémorial C n

°

 143 du 15 avril 1994.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07337, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2005.

(079089.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Luxembourg, le 30 août 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour <i>VEBECO S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

<i>Pour WATERFORD INVESTMENTS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

4626

DIA TRITONCO 3 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.617. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07780, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078990.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ELFA-AUTO, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.949. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07769, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078991.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

HUMANITARIAN WORLD HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 33.003. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079034.3/207/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

PATRIMVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 74.938. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07288, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079387.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

BCP CAYLUX HOLDINGS LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.771. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 25 août 2005 

Il résulte du procès-verbal que l’Assemblée Générale des Actionnaires a décidé de reconduire dans leurs fonctions

les membres du Conseil de Surveillance mentionnés ci-après jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires
appelée à statuer sur l’exercice social clos au 30 septembre 2005:

- Monsieur Robert M. Barrack, né le 22 mai 1951 à New York (Etats-Unis d’Amérique), ayant son adresse profes-

sionnelle au 345, Park Avenue, 10154, New York (Etats-Unis d’Amérique),

- Monsieur Benjamin J. Jenkins, né le 26 février 1971 dans le Tennessee (Etats-Unis d’Amérique), ayant son adresse

professionnelle au 345, Park Avenue, 10154, New York (Etats-Unis d’Amérique),

- Monsieur Anjan Mukherjee, le 15 novembre 1973 dans le Massachusetts (Etats-Unis d’Amérique), ayant son adresse

professionnelle au 345, Park Avenue, 10154, New York (Etats-Unis d’Amérique).

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00781. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079077.3/1005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

G. d’Huart
<i>Notaire

Signature.

Signature.

4627

HELFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 42.231. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 août 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert, Domenico Piovesana, administrateur-

délégué viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert, Domenico Piovesana, administrateur-délégué sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra
en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07719. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079036.3/1022/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

GRAPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.917. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 août 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07717. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079044.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

STATION SERVICE DURAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 214, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.532. 

Constituée par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 juin 1995, acte publié au

Mémorial C n

°

 469 du 20 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire, en date du 19 novembre 1996,

acte publié au Mémorial C n

°

 70 du 14 février 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2001,

l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 315 du 26 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00055, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2005.

(079091.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Extrait sincère et conforme
HELFIN S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
GRAPY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour STATION SERVICE DURAND, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

4628

TEXTILE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.716. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 août 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07716. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079046.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

COMITE INTERNATIONAL DES FESTIVITES DE LA SCHUEBERFOUER LUXEMBOURG, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R. C. Luxembourg F 1.222. 

STATUTS

Entre les soussignés:
- M. Becker Gaston, 113, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg;
- M. Bodet François, 61, Spellewerkstraat, B-9030 Gand;
- M. Bouvier William, 12, av. de la Rouveraie, F-83580 Gassin;
- M. Bruch Willy, Zabernerstrasse 11, D-40468 Düsseldorf;
- M. Buchner Félix, 8, rue des Artisans, L-3895 Foetz;
- M. Cao Jean Claude, 36, Grand-rue, F-55100 Haudainville;
- M. Capesius Pierre, 3, rue Jean-Pierre Pier, L-2333 Luxembourg;
- M. De Vries Jany, Groenstraat 412, B-1800 Vilvorde;
- M. Hary Charles, 6, rue Nic. Grang, L-8610 Buschrodt;
- M. Jörn Hans, 15, Schmalzweg, D-55252 Mainz-Kastel;
- M. Kopp François, Grande-rue, F-88170 Chatenois;
- M. Ludewigt Horst, 28, Brookweg, D-26127 Oldenburg;
- M. Pelzer Roger, 51, rue de la Carrière, B-4720 Kelmis;
- M. Ramboux Joseph, 22, rue de Mensdorf, L-5380 Übersyren;
- M. Schmit Charles, 126, rue de la Semois, B-6700 Arlon;
- M. Wyma Paul, 6, rue des Artisans, L-3895 Foetz;
et toutes les personnes qui en feront la demande ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif

réglée par la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt-huit ainsi que par les présents statuts.

Chapitre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination COMITE INTERNATIONAL DES FESTIVITES DE LA SCHUEBER-

FOUER LUXEMBOURG, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège social de l’association est établi à Luxembourg.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra en tout temps être dissoute.

Art. 4. L’association a pour objet:
- la propagation des fêtes annuelles telles que la SCHUEBERFOUER et le marché dénommé OCTAVMÄRTCHEN,
- l’organisation de toutes les activités facilitant la réalisation et la diffusion desdites fêtes. Ces fêtes sont organisées

d’un commun accord entre le COMITE INTERNATIONAL DES FESTIVITES A.s.b.l. et la Ville de Luxembourg.

Chapitre II. Membres

Art. 5. Le nombre des membres n’est pas limité; il ne peut cependant pas être inférieur à trois.

Art. 6. Peut devenir membre toute personne en manifestant sa volonté, déterminée à observer les présents statuts

et agréée par le comité.

Art. 7. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de

l’association, lui prête une aide financière annuelle, dont le montant ne peut dépasser la somme de 100,- EUR.

Extrait sincère et conforme
TEXTILE INVEST S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

4629

Les membres d’honneur ont le droit d’assister à toutes les manifestations et de participer aux assemblées générales,

mais sans y disposer ni du droit de vote actif, ni du droit de vote passif.

Art. 8. Le comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait des

dons à l’association.

Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres est fixée à 5,- EUR.Elle ne peut dépasser la somme de 25,- EUR.

Art. 10. La qualité de membre se perd: 
1.- par démission écrite au comité;
2.- par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents en cas

d’actions contraires aux statuts ou préjudiciables à l’objet et à l’intérêt général de l’association.

Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le rembourse-

ments des cotisations.

Chapitre III. Du comité

Art. 12. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair de membres entre 3 et 7

dont le président, le secrétaire et le trésorier.

Les membres du comité sont élus pour 5 ans par l’assemblée générale.
Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pour-

voir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat
de son prédécesseur.

Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du comité désignent entre eux pour la durée de cinq ans un président, un secrétaire et un trésorier.

Ils sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures

avant l’assemblée générale.

Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent sur convocation du président ou

de son représentant. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société. Les membres du

comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité
se limite aux mandats qu’ils ont reçus.

Art. 15. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou

du trésorier.

Chapitre IV. De l’assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale se réunit annuellement le jeudi précédant le dimanche de carnaval, aux jour, heure et

lieu indiqués dans l’avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance par lettres individuelles indiquant sommairement l’ordre

du jour.

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas

de partage la voix du président est prépondérante.

Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Tout membre peut se faire représenter à l’assemblée générale moyennant procuration écrite par un mandataire ayant

lui-même droit de vote, sans qu’il soit cependant permis à un membre de représenter plus d’un membre absent.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.
Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et délibère sur les questions à l’ordre du jour.
Deux réviseurs de caisse, non-membres du comité, sont désignés annuellement par l’assemblée générale.

Chapitre V. Divers

Art. 18. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les art. 8 et 9 de la loi du

21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. 

Art. 19. La dissolution de l’association est régie par les art. 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 20. En cas de dissolution de l’association, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les

dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance de son choix.

Art. 21. Pour les cas non spécialement visés par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la suite.

Art. 22. L’assemblée constituante qui s’est réunie à Luxembourg le 22 avril 2004 a approuvé les présents statuts. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

De suite les soussignés prénommés, fondateurs de l’association, se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont élu le comité ci-après pour la durée de cinq ans:

Signatures.

4630

Monsieur Pelzer Roger, président;
Monsieur Bodet Francis, vice-président;
Monsieur De Vries Janny, vice-président;
Monsieur Kopp François, vice-président;
Monsieur Ludewigt Horst, vice-président;
Monsieur Becker Gaston, secrétaire;
Monsieur Capésius Pierre, trésorier.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07018. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079508.3/000/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SOCLINPAR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS

ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.980. 

EXTRAIT

L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Günter K. Strauss, Administrateur et nomme Madame

Patricia Velge, épouse Sanchez Castillo, domiciliée Finca et Espinajero, Partado de Correos 3, 28410 Manzanares El Real
- Madrid (Espagne) jusqu’à l’Assemblée statutaire de 2007.

L’Assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Guy Fasbender, Commissaire aux Comptes, pour une

période d’un an, jusqu’à l’Assemblée statutaire de 2006. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079082.3/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

INSTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 14.780. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, alors notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, le 15 décembre 1976, acte

publié au Mémorial C n

°

 24 du 28 janvier 1977; statuts modifiés le 19 mars 1980 suivant acte reçu par le même

notaire alors de résidence à Dudelange, publié au Mémorial C n

°

 137 du 2 juillet 1980, modifiés le 24 juillet 1990

suivant acte reçu par M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, publié au Mémorial C n

°

 25 du 28

janvier 1991.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00051, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2005.

(079092.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

Les comptes annuels consolidés au 27 février 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-

BI00567, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079139.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour INSTAL S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

4631

FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 1.591.200,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.425. 

Par résolution datée du 19 août 2005, les associés de FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l. ont pris les décisions

suivantes:

- acceptation de la démission de Peter Gangsted, gérant de classe A, de conseil de gérance avec effet au 1

er

 septembre

2005,

- nomination au poste de gérant, pour une durée indéterminée, avec effet au 1

er

 septembre 2005 de:

Christian Dosch, gérant classe A, demeurant au 31, Myliusstrasse, D-60323 Frankfurt am Main,
Hans Andersson, demeurant au 68, Sülldorfer Kirchenweg, D-22587 Hamburg.
En conséquence, au 1

er

 septembre 2005, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Christian Dosch (gérant classe A),
- Mirko Meyer Schoenherr (gérant classe A),
- Hans Andersson,
- Pascale Nutz,
- Stefan Oostvogels,
- François Pfister,
- Frank Matthias Przygodda.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07800. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079093.3/581/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

IGEFI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2361 Luxembourg-Strassen, 7, rue des Primeurs.

R. C. Luxembourg B 110.897. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Mersch, to whom remains the present deed.

There appeared:

- Mr Bertyl Rouveure, director, born in La Tronche (France) on the eleventh day of August, nineteen hundred forty-

eight, residing in 3, Chemin des Grands-Champs, 1299 Crans-lès-Céligny, Switzerland, married, of French nationality,
duly represented by Olivia Tournier, avocat, with professional address at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue
of a proxy given in Crans, on August 26th, 2005,

- Mrs Van Ta, director, born in Saigon (Vietnam) on the eighteenth day of July nineteen hundred fifty-four, residing

at 3, Chemin des Grands-Champs, 1299 Crans-lès-Céligny, Switzerland, married, of French nationality, duly represented
by Olivia Tournier, prenamed, by virtue of a proxy given in Crans on August 26th, 2005.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

I. Mr Bertyl Rouveure is the owner of one thousand and eight hundred (1,800) shares, having a par value of one United

State Dollar (1 USD) each, in the corporate capital of BITHYNIA CORPORATION N.V., a company incorporated and
organized under the laws of the Netherlands Antilles, having its registered office at Berg Arrarat 1, Curaçao, The Neth-
erlands Antilles (the Company).

II. Mrs Van Ta is the owner of four thousand and two hundred (4,200) shares, having a par value of one United States

Dollar (1 USD) each in the corporate capital of the Company.

III. By a resolution of the managing director of the Company validly adopted on September 15th, 2005, a copy of

which shall remain annexed to the present deed, the Company resolved to transfer its registered seat, principal estab-
lishment and place of effective management from Curaçao in the Netherlands Antilles to Strassen (Luxembourg) with
immediate effect without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.
All formalities required under the laws of the Netherlands Antilles to give effect to that resolution have been duly per-
formed.

IV. The agenda of the meeting is as follows:
1. Transfer of the registered seat, the principal establishment and place of effective management of the Company from

the Netherlands Antilles to Strassen (Luxembourg) with immediate effect, without the Company being dissolved but on
the contrary with full corporate and legal continuance;

2. Conversion of the functional currency of the Company from the United States Dollar to Euro; Increase of the con-

verted share capital to twelve thousand and five hundred Euro (12,500 EUR); Consolidation of the number of shares in

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

4632

circulation so as to result in a subscribed share capital represented by five hundred (500) shares having a par value of
twenty-five Euro (25 EUR) each; Allocation of the conversion excess amount to the share premium reserve of the Com-
pany; Subscription of the newly issued shares;

3. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability Company (société à responsabilité limitée)

with the name IGEFI INTERNATIONAL, S.à r.l. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer
of the registered seat, the principal establishment and place of effective management of the Company to Strassen (Lux-
embourg); Amendment and complete restatement of the Company’s articles of association so as to conform them to
the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality;

4. Approval of the opening balance sheet of the Company as at September 15th, 2005;
5. Revocation of the current managing director and appointment of one (1) manager for an unlimited duration;
6. Establishment of the registered seat, the principal establishment and place of effective management of the Company

at 7, rue des Primeurs, L-2361 Strassen.

Thereupon, the appearing parties, represented as stated here above, requested the notary to record that:

<i>First resolution

The partners of the Company resolve to transfer the registered seat, the principal establishment and place of effective

management of the Company from the Netherlands Antilles to Strassen (Luxembourg) with immediate effect, without
the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. The partners further declare
that all formalities required under the laws of the Netherlands Antilles to give effect to such transfer have been duly
performed.

<i>Second resolution

The partners of the Company resolve to convert the functional currency of the Company from the United States

Dollar to Euro, to reduce and set for rounding purposes the so converted share capital amount to four thousand and
five hundred Euro (4,500 EUR) with any excess amount resulting from the rounding being allocated to the share premi-
um reserve account of the Company and to thus consolidate the six thousand (6,000) shares of one United States Dollar
(1 USD) each in circulation to one hundred and eighty (180) shares each having a par value per share of twenty-five Euro
(25 EUR) and to further increase the so converted initial share capital of four thousand and five hundred Euro (4,500
EUR) represented by one hundred and eighty (180) shares each having a par value of twenty-five Euro (25 EUR), to
twelve thousand and five hundred Euro (12,500 EUR) by the issuance of three hundred and twenty (320) new shares,
each share having a par value of twenty-five Euro (25 EUR). 

<i>Subscription - Payment

The partners resolve to subscribe to the capital increase in proportion to their participation in the capital of the Com-

pany and thus to have the three hundred and twenty (320) new shares of twenty-five Euro (25 EUR) each fully paid-up
by way of a contribution in cash as follows:

- Mr Bertyl Rouveure contributes an amount of two thousand and four hundred Euro (2,400 EUR), in exchange for

ninety-six (96) new shares with the result that he will own one hundred and fifty (150) shares of the Company having a
par value of twenty-five Euro (25 EUR) each; and

- Mrs Van Ta contributes an amount of five thousand and six hundred Euro (5,600 EUR), in exchange for two hundred

and twenty-four (224) new shares with the result that she will own three hundred and fifty (350) shares of the Company
having a par value of twenty-five Euro (25 EUR) each.

The three hundred and twenty (320) shares having a par value of twenty-five Euro (25 EUR) each are thus fully paid-

up by way of a contribution in cash so that the amount of eight thousand Euro (8,000 EUR) is at the disposal of the
Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Third resolution

The partners resolve that the Company shall adopt the form of a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) with the name IGEFI INTERNATIONAL, S.à r.l., shall accept the Luxembourg nationality and shall as
from the date of the present deed be subject to the laws of Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The partners approve the opening balance sheet of the Company as at September 15th, 2005, a copy of which shall

remain attached to the present deed.

<i>Fifth resolution

As a result of the beforegoing resolutions, the partners resolve to amend and completely restate the articles of as-

sociation of the Company so as to conform them to Luxembourg laws.

The restated articles of association of the Company shall read as follows: 

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There exists hereby a private limited company under the name of IGEFI INTERNATIONAL, S.à r.l. (hereafter the

Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Ar-
ticles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg. The registered

office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of man-

4633

agers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of a single man-
ager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles, «general meeting
of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner required for the
amendment of these Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated
company.

Art. 3. Purpose
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries,affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 4. Duration
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of partners adopted in the

manner required for amendment of these Articles.

4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or other similar event affecting one or more of its partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500 EUR) represented

by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (25 EUR) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced one or more times by a resolution of the general

meeting of partners, adopted in the manner required for amendment of these Articles.

5.3. The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The Company’s decision to redeem its own shares shall be taken by a unanimous vote of the partners representing
one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the
share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of

the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

4634

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of partners

which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of partners shall fall within

the competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or

not, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requireor upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by a consent in writing (by letter or facsimile or any other electronic means of
communication, including e-mail) of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing (by letter or facsimile or

any other electronic means of communication, including e-mail) another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of an
identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be obligated to third parties in all matters by the signature of the sole manager if only one manager

has been appointed, or by the joint signature of any two managers if more than one manager have been appointed, or
by the signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been duly delegated in accordance with article
8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance with these Articles and with
applicable Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. Any regularly constituted meeting of the partners of the Company shall represent the entire body of the Com-

pany. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers conferred by Law to the general meeting
of partners.

12.2. Each partner shall have voting rights in proportion to the partner’s ownership interest in the Company.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, fac-

simile or any other electronic means of communication, including e-mail, to represent him at the general meetings of
partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners may be taken without a meeting by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by facsimile or
any other electronic means of communication, including e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolu-
tion. Signatures of partners may appear on a single document or on multiple counterparts of an identical resolution and
may be evidenced by original or facsimile signature. 

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one-half

of the share capital of the Company.

13.3. However, resolutions to alter these Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

a majority in number of the partners who together own at least three quarters of the Company’s share capital.

4635

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting year
14.1. The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on December 31st of each year.
Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s annual accounts including a

balance sheet, profit and loss account as well as notes are established.

14.2. Each partner may inspect the said balance sheet and profit and loss account at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners, which will determine the powers and
remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be dis-

tributed to the partners in proportion to their share ownership in the Company.

VII. General provision

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Sixth resolution

The partners resolve to revoke MeesPierson TRUST (CURACAO) N.V., with registered office Berg Arrarat 1,

Curaçao, Netherlands Antilles, registered with Curaçao Commercial Register under number 4147 as Managing Director
of the Company with immediate effect and to appoint with effect as of today as sole manager of the Company for an
unlimited duration: 

- Bertyl Rouveure, director, born on August 11, 1948, with address at 3, Chemin des Grands-Champs, 1299 Crans-

près-Céligny, Suisse.

<i>Seventh resolution

The partners resolve to establish the registered office, the principal establishment and the place of effective manage-

ment of the Company at 7, rue des Primeurs, L-2361 Strassen.

<i>Estimated costs

The capital duty applicable to the transfer of the Company to Luxembourg and the subsequent contribution shall be

reduced in accordance with Article 7 of the law of December 29, 1971, as amended, as the two partners qualify for the
familiy capital duty reduction as husband and wife.

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 135,000.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning be-
tween the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue, Maître

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- Monsieur Bertyl Rouveure, administrateur de sociétés, né à La Tronche, France, le 11 août 1948, résidant au 3,

Chemin des Grands-Champs, 1299 Crans-lès-Céligny, Suisse, marié, de nationalité française, dûment représenté par Oli-
via Tournier, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Crans, le
26 août 2005,

- Madame Van Ta, administrateur de sociétés, née à Saigon, Vietnam, le 18 juillet 1954, résidant au 3, Chemin des

Grands-Champs, 1299 Crans-lès-Céligny, Suisse, mariée, de nationalité française, dûment représentée par Olivia Tour-
nier, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Crans, le 26 août
2005.

4636

Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistre-
ment. 

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

I. Monsieur Bertyl Rouveure est titulaire de mille huit cents (1.800) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale

d’un Dollar américain (1 USD), dans le capital social de BITHYNIA CORPORATION N.V., une société formée et orga-
nisée selon les lois des Antilles Néerlandaises, avec siège social au 1, Berg Arrarat, Curaçao, Antilles Néerlandaises (la
Société).

II. Madame Van Ta est titulaire de quatre mille deux cents (4.200) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale

d’un Dollar américain (1 USD), dans le capital social de la Société.

III. En vertu d’une résolution de l’administrateur de la Société valablement adoptée le 15 septembre 2005, une copie

de laquelle restera annexée au présent acte, la Société a décidé de transférer son siège social ainsi que son principal
établissement et son lieu de direction effective depuis Curaçao (Antilles Néerlandaises) vers Strassen (Luxembourg)
avec effet immédiat sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité sociétaire et juridique. Toutes
les formalités requises par les lois des Antilles Néerlandaises afin que la résolution produise ses effets ont été dûment
effectuées.

IV. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
1. Transfert du siège social de la Société ainsi que de son principal établissement et son lieu de direction effective

depuis les Antilles Néerlandaises vers Strassen (Luxembourg) avec effet immédiat, sans dissolution de la Société, mais
au contraire avec pleine continuité sociétaire et juridique;

2. Conversion de la devise du capital social du Dollar américain à l’euros; Augmentation du capital social à douze mille

cinq cents euros (12.500 EUR); Consolidation du nombre de parts existantes de façon que le capital social souscrit soit
représenté par cinq cents (500) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR); Affec-
tation du solde de conversion à la réserve de prime d’émission de la Société; Souscription des nouvelles parts émises;

3. Adoption par la Société de la forme légale d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination de IGEFI

INTERNATIONAL, S.à r.l. et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, du
principal établissement et du lieu de direction effective de la Société à Strassen (Luxembourg); Modification et reformu-
lation des statuts de la Société afin de les adapter aux dispositions légales luxembourgeoises, en conséquence de l’ac-
ceptation de la nationalité luxembourgeoise; 

4. Approbation du bilan d’ouverture de la Société au 15 septembre 2005;
5. Révocation de l’administrateur de la Société actuel et nomination d’un (1) gérant, pour une durée illimitée; 
6. Fixation du siège social, du principal établissement et du lieu de direction effective de la Société au 7, rue des Pri-

meurs, L-2361 Strassen.

Ces faits exposés, les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, prient le notaire instrumentant

d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés de la Société décident de transférer le siège social de la Société ainsi que son principal établissement et

son lieu de direction effective depuis les Antilles Néerlandaises vers Strassen (Luxembourg) avec effet immédiat sans
dissolution de la Société mais, au contraire, avec pleine continuité sociétaire et juridique. Les associés de la Société dé-
clarent, en outre, que toutes les formalités requises par les lois des Antilles Néerlandaises, afin qu’un tel transfert pro-
duise ses effets, ont été dûment effectuées.

<i>Deuxième résolution

Les associés de la Société décident de convertir la devise du capital social du Dollar américain à l’Euro, de réduire et

d’arrondir le capital social ainsi converti à quatre mille cinq cents euros (4.500 EUR), tout montant résiduel résultant de
l’arrondi étant affecté à la réserve de prime d’émission, et de consolider ensuite les six mille (6.000) parts sociales ayant
chacune une valeur nominale d’un Dollar américain (1 USD), en cent quatre-vingts (180) parts sociales ayant chacune
une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) et ensuite d’augmenter le capital social ainsi converti de quatre mille
cinq cents euros (4.500 EUR), représenté par cent quatre-vingts (180) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25 EUR), à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) par l’émission de trois cent vingt (320) nou-
velles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR).

<i>Souscription et libération

Les associés de la Société décident de souscrire une augmentation de capital au proratas de leur participation dans

le capital de la Société et ainsi d’avoir trois cent vingt (320) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune
entièrement libérée par contribution en espèces comme suit:

- Monsieur Bertyl Rouveure contribue pour un montant de deux mille quatre cents euros (2.400 EUR), en échange

de quatre-vingt-seize (96) nouvelles parts sociales, de façon à devenir propriétaire de cent cinquante (150) parts dans
la Société, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR); et

- Mme Van Ta contribue pour un montant de cinq mille six cents euros (5.600 EUR), en échange de deux cent vingt-

quatre (224) nouvelles parts sociales, de façon à devenir propriétaire de trois cent cinquante (350) parts dans la Société,
chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR).

Les trois cent vingt (320) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) sont ainsi

entièrement libérées par contribution en espèces, avec pour résultat que le montant de huit mille euros (8.000 EUR)
est mis à disposition de la Société ainsi qu’il l’a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

4637

<i>Troisième résolution

Les associés de la Société décident que la Société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dé-

nomination sociale de IGEFI INTERNATIONAL, S.à r.l., accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à partir de la
date du présent acte, soumise aux lois du Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les associés de la Société approuvent le bilan d’ouverture de la Société au 15 septembre 2005, dont une copie restera

annexée au présent acte.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les associés de la Société décident de modifier et de reformuler entiè-

rement les statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les dispositions légales luxembourgeoises.

Les statuts de la Société reformulés auront la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination IGEFI INTERNATIONAL, S.à r.l. (la Société),

qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans les

limites de la commune par une résolution du conseil de gérance (dans les présents Statuts, l’expression «conseil de gé-
rance» signifie l’unique gérant si ledit conseil est composé d’un unique gérant) de la Société. Le siège social peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés
(dans les présents Statuts, l’expression «assemblée générale des associés» signifie l’unique associé s’il n’existe qu’un as-
socié unique) délibérant dans les formes prescrites pour les modifications des présents Statuts.

2.2. Il peut être créé par résolution du conseil de gérance de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance de la Société estime que des événements
extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège so-
cial ou la communication entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être
transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Cette mesure
provisoire ne peut toutefois avoir aucun effet sur la nationalité de la Société qui demeurera une société luxembourgeoi-
se, malgré le transfert provisoire de son siège social.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres valeurs, obligations, créan-
ces, certificats de dépôt et autres titres de créances, et en général toutes valeurs et instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute
société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’emprunts, obligations et créances et d’autres titres de partici-
pations et/ou de créances. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
de titres de créances, à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties
et des sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de
toute autre société. La Société pourra en outre hypothéquer, gager, nantir, céder ou aliéner de toute autre manière,
tout ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et utiliser tous les instruments liés à ses

investissements en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de crédit, les risques de change, les risques liés aux taux d’intérêts et tous autres risques. 

3.4. La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes les

transactions de propriété mobilières ou immobilières, qui directement ou indirectement, favorisent la réalisation de son
objet social ou s’y rapportent.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des associés délibérant

dans les formes prescrites pour la modification des Statuts.

4.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs de ses associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

4638

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l’as-

semblée générale des associés délibérant dans les formes prescrites pour la modification des Statuts.

5.3. La Société peut racheter ses propres parts.
Cependant, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts rachetées, le rachat ne peut être décidé qu’à con-

dition que la Société dispose d’un montant de réserves distribuable suffisant pour couvrir la différence. La décision de
la Société de racheter ses propres parts devra être prise par l’unanimité des associés représentant 100% du capital so-
cial, convoqués en assemblée générale extraordinaire et entraînera la réduction du capital social par annulation de toutes
les parts rachetées.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre de parts sociales en circulation.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne pour les représenter auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément préa-

lable de l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil luxembourgeois.

Pour toute autre question, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gé-
rant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment et sans juste motif (ad nutum).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts sont de la compétence du conseil de gérance, qui a tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des gé-

rants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il est donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sont mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (soit par lettre ou
téléfax ou tout autre moyen de communication électronique, y compris courrier électronique).

9.4. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire (par lettre ou téléfax ou tout autre moyen de communication électronique, y compris par cour-
rier électronique).

9.5. Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises à la majorité des voix des gérants présents ou re-
présentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par

tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et opposables de la même façon que les

résolutions adoptées lors d’une réunion régulièrement convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs exemplaires d’une même résolution, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation
La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature de son gérant unique ou par les

signatures conjointes de deux gérants dans le cas où plusieurs gérants ont été nommés ou par la signature de toute
personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

4639

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée est réputée représenter toute la Société. Elle

a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, conduire ou ratifier tous les actes en relation avec toutes les activités
de la Société. Si la Société est détenue par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par
la Loi à l’assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé dispose des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, téléfax, ou par tout autre moyen de communication électronique, y compris par e-mail, une autre
personne ou entité comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être prises sans réu-

nion, par résolution circulaire dont le texte est envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par téléfax ou
par tout autre moyen de communication électronique, y compris par courrier électronique. Les associés expriment leur
vote en signant la résolution. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs
exemplaires d’une même résolution, envoyés par original ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social de la Société.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société ne peuvent être adoptées qu’à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. 

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes annuels de la Société, incluant le bilan, le compte de résultat

et les emprunts de la Société, sont arrêtés.

14.2. Tout associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de résultat au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les résultats bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net annuel de la Société est affecté à la
réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décide discrétionnairement de l’affectation du solde du bénéfice net annuel.

Elle peut en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus en vertu de la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-

tribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de révoquer MeesPierson TRUST (CURACAO) N.V., dont le siège social se situe au 1, Berg

Arrarat, Curacao, Antilles Néerlandaises, immatriculée au Registre du Commerce de Curaçao sous le numéro 4147 en
tant qu’administrateur de la Société avec effet immédiat et de nommer dès aujourd’hui comme unique gérant de la So-
ciété pour une durée illimitée:

- Bertyl Rouveure, administrateur de sociétés, né à La Tronche, France, le 11 août 1948, résidant au 3, Chemin des

Grands-Champs, 1299 Crans-lès-Céligny, Suisse.

<i>Septième résolution

Les associés décident de fixer le siège social, le principal établissement ainsi que le lieu de direction effective de la

Société au 7, rue des Primeurs, L-2361 Strassen.

4640

<i>Frais

Le taux du droit d’apport applicable pour le transfert de la Société au Luxembourg et les contributions subséquentes

est réduit conformément à l’Article 7 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifié, en ce que les deux associés
qualifient pour la réduction de taux applicable aux sociétés familiales, en leur qualité de mari et femme.

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes résolutions s’élèvent à environ EUR 135.000.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais prévaut.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, ladite comparante a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: O. Tournier, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 22 septembre 2005, vol. 433, fol. 12, case 9. – Reçu 113.757,75 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087907.3/242/553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

IGEFI GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. IGEFI INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2361 Luxembourg-Strassen, 7, rue des Primeurs.

R. C. Luxembourg B 110.897. 

In the year two thousand and five, on the fifth day of October. 
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of IGEFI INTERNATIONAL, S.à r.l. (the Company),

having its registered office 7, rue des Primeurs, L-2361 Strassen (Luxembourg), incorporated by a deed of M

e

 Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, in replacement of M

e

 Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on September

15, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Societes et Associations.

The meeting is presided by Mrs Olivia Tournier, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, who ap-

points as secretary Ms Catherine Pogorzelski, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Ms Vincente Messina, secretary, with professional address in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, the bureau and the undersigned notary.

II. It appears from the attendance list, that the five hundred (500) shares, representing the entirety of the share capital

of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed on the agenda of
the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities.

III. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the following agenda:
1. Modification of the Company’s name; and
2. Correlative amendment of Article 1 of the Articles of association.
III. The entire share capital of the Company being represented at this meeting, it is regularly constituted and may

validly deliberate on all the items of the agenda.

After deliberation, the following resolutions were approved unanimously:

<i>First resolution

The Partners of the Company resolve to change the Company’s name into IGEFI GROUP, S.à r.l.

<i>Second resolution

The Partners resolve to amend the Article 1 of the Articles of association of the Company, which shall henceforth

read as follows:

«Art. 1. There exists hereby a private limited company under the name of IGEFI GROUP, S.à r.l. (hereafter the Com-

pany), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial
companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).»

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day mentioned at the beginning of this document.

Mersch, le 30 septembre 2005.

H. Hellinckx.

4641

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est tenue l’assemblée extraordinaire des associés de la Société, dont le siège social est sis 7, rue des Primeurs,

L-2361 Strassen (Luxembourg), constituée par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en rempla-
cement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 15 septembre 2005, en cours de publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Madame Olivia Tournier, avocat, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire Mademoiselle Catherine Pogorzelski, juriste, ayant son domicile professionnel à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Vincente Messina, secrétaire, ayant son domicile professionnel à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux sont indiqués sur

la liste de présence signée par les associés ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné.

II. Il résulte de la liste de présence, que cinq cents (500) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de

la Société, sont représentées à cette assemblée. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre
du jour de l’assemblée et ont renoncé à toutes formalités de convocation.

III. L’assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre décision sur l’ordre du

jour suivant:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société; et
2. Modification corrélative de l’article 1

er

 des Statuts de la Société.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés décident de modifier la dénomination de la Société en IGEFI GROUP, S.à r.l.

<i>Seconde résolution

Les Associés décident de modifier l’Article 1

er

 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination IGEFI GROUP, S.à r.l. (la Société),

qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants, le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en

anglais suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: O. Tournier, C. Pogorzelski, V. Messina, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 octobre 2005. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087908.2/242/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

DH REAL ESTATE FINANCE HOLDINGS S.C.A., Société en commandite par actions.

Capital souscrit: EUR 147.100,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.960. 

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du du 26 février 2003, les associés de la société DH

REAL ESTATE FINANCE HOLDINGS S.C.A. ont décidé d’accepter la démission du conseil de surveillance suivant avec
effet immédiat:

- Dominique Robyns, commissaire, avec adresse professionnelle au Luxembourg.
- Philippe Duren, commissaire, avec adresse professionnelle au Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03914. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079110.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Mersch, le 6 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Signature.

4642

FERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 16,500.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.664. 

In the year two thousand and five, on the eleventh day of August.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CERBERUS FERN HOLDINGS LTD., a company incorporated and existing under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda, and recorded with the Registrar of
Companies under number 36900,

here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy granted under private seal,
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to this deed to be filed

at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of FERN, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office

at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
Section B, number 104.664, incorporated pursuant to a notarial deed of 3 December 2004 of Maître Alphonse Lentz,
notary residing in Remich, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of 3 March 2005, number
190 (hereafter the «Company»).

The Articles of Association have been last modified by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,

on 13 July 2005, not yet published.

The agenda of the meeting shall be as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the company from its current value of sixteen thousand five hundred US Dollars

(USD 16,500) up to two million five hundred sixteen thousand three hundred eighty-seven US Dollars (USD 2,516,387)
through a contribution in kind.

2. Decision to reduce the par value of the shares of the Company from one hundred thirty-two US Dollars (USD

132) to fifty-three US Dollars (USD 53).

3. Subsequent amendment of Article 5, paragraph one, of the Articles of Association of the Company.
4. Miscellaneous.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, representing the whole corporate capital requires

the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolved to increase the share capital of the Company from its current value of sixteen thousand

five hundred US Dollars (USD 16,500) up to an amount of two million five hundred sixteen thousand three hundred
eighty-seven US Dollars (USD 2,516,387).

A total amount of two million four hundred ninety-nine thousand nine hundred thirty-seven US Dollars and fifty cents

(USD 2,499,937.50) will be paid by CERBERUS FERN HOLDINGS LTD., pre-named, through a contribution-in-kind of
an outstanding cash facility in the amount of two million four hundred ninety-nine thousand nine hundred thirty-seven
US Dollars and fifty cents (USD 2,499,937.50) due by the Company to CERBERUS FERN HOLDINGS LTD. under a
Letter Agreement effective as of 30 June 2005.

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of two million four

hundred ninety-nine thousand nine hundred thirty-seven US Dollars and fifty cents (USD 2,499,937.50) of the contrib-
uted assets, through a Statement of Contribution Value issued by the sole manager of the Company and which shall
remain attached hereto in order to be filed together with this deed with the registration authorities.

Out of the two million four hundred ninety-nine thousand nine hundred thirty-seven US Dollars and fifty cents (USD

2,499,937.50) contributed to the Company, two million four hundred ninety-nine thousand eight hundred eighty-seven
US Dollars (USD 2,499,887) have been allocated to the share capital and fifty US Dollars and fifty cents (USD 50.50)
have been allocated to the share premium.

<i>Second resolution

The sole member resolved to reduce the par value of the shares of the Company from one hundred thirty-two US

Dollars (USD 132) to fifty-three US Dollars (USD 53) per share. Pursuant thereto, the share capital of the Company
shall now be represented by forty-seven thousand four hundred seventy-nine (47,479) shares with a par value of fifty-
three US Dollars (USD 53) per share. 

All the shares were allocated to the sole member CERBERUS FERN HOLDINGS LTD., prenamed.

<i>Third resolution

As a consequence of the previous resolutions, the sole member resolved to amend Article 5, paragraph one, of the

Articles of Association of the Company which shall now read as follows:

«The Company’s corporate capital is set at two million five hundred sixteen thousand three hundred eighty-seven

US Dollars (USD 2,516,387), represented by forty-seven thousand four hundred seventy-nine (47,479) shares with a
par value of fifty-three US Dollars (USD 53) each.»

There being no further business the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

4643

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their names, first names, civil status

and residences, said persons signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onze août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CERBERUS FERN HOLDINGS LTD., une société constituée selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à

Clarendon House, 2, rue Church Street, Hamilton, HM11, Bermudes, et inscrite auprès du Registrar of Companies sous
le numéro 36900,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé.

Ladite procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquel comparant est l’unique associé de FERN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à

L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la
Section B, numéro 104.664, constituée suivant acte reçu en date du 3 décembre 2004, par acte de Maître Alphonse
Lentz, notaire de résidence à Remich, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 190 du 3 mars
2005 (ci-après, la «Société»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxem-

bourg, le 13 juillet 2005, non encore publié.

L’ordre du jour de l’assemblée se compose comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de sa valeur actuelle de seize mille cinq cents US Dollars (USD 16.500)

jusqu’à deux millions cinq cent seize mille trois cent quatre-vingt-sept US Dollars (USD 2.516.387) par un apport en
nature.

2. Réduction de la valeur nominale des parts sociales de la Société de cent trente-deux US Dollars (USD 132) à cin-

quante-trois US Dollars (US 53).

3. Modification subséquente du paragraphe 1

er

 de l’article 5 des statuts de la Société.

4. Divers.
Après avoir analysé les différents points à l’ordre du jour, le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a

requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société de sa valeur actuelle de seize mille cinq cents US

Dollars (USD 16.500) jusqu’à deux millions cinq cent seize mille trois cent quatre-vingt-sept US Dollars (USD
2.516.387).

Le montant total de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-sept US Dollars et cin-

quante cents (USD 2.499.937,50) sera payé par CERBERUS FERN HOLDINGS LTD., préqualifiée, par un apport en na-
ture provenant d’une facilité de paiement de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-sept
US Dollars et cinquante cents (USD 2.499.937,50) dû par la Société à CEBERUS FERN HOLDINGS LTD. de part un
«Letter Agreement» avec effet au 30 juin 2005.

A été attesté au notaire soussigné la preuve de l’existence et de l’intégralité de la somme de deux millions quatre

cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-sept US Dollars et cinquante cents (USD 2.499.937,50) représentant
le bien apporté, de part une Déclaration sur la Valeur de l’Apport émise par le gérant unique de la Société et qui restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l’enregistrement.

Sur le montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-sept US Dollars et cinquante

cents (USD 2.499.937,50) apporté à la Société, deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-
vingt-sept US Dollars (USD 2.499.887) sont affectés au capital social, et cinquante US Dollars et cinquante cents (USD
50,50) sont affectés à la prime d’émission.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de réduire la valeur nominale des parts sociales de la Société de cent trente-deux US Dollars

(USD 132) à cinquante-trois US Dollars (USD 53) chacune. De part ce fait, le capital social de la Société sera désormais
représenté par quarante-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf (47.479) parts sociales ayant une valeur nominale de
cinquante-trois US Dollars (USD 53) chacune.

L’intégralité des parts sociales a été attribuée à CERBERUS FERN HOLDINGS LTD., préqualifiée.

<i>Troisième résolution

A la suite de la résolution précédente, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

4644

«Le capital social est fixé à la somme de deux millions cinq cent seize mille trois cent quarante-vingt-sept US Dollars

(USD 2.516.387), représenté par quarante-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf (47.479) parts sociales ayant une va-
leur nominale de cinquante-trois US Dollars (USD 53) chacune».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 69, case 1. – Reçu 20.152,66 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087655.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.

FERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.664. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.

(087656.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.

MATSC, Société Civile.

Capital social: EUR 5.706.970,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg E 187. 

<i>Constat de Réduction du Capital social

Le soussigné, en sa qualité de gérant de la société «MATSC» (la «Société»), une société civile de droit luxembourgeois

établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a pris note et constate conformément
à l’article 6 des statuts de la Société

1. En dates du 21 février 2005, du 8 avril 2005, du 18 mai 2005et du 24 mai 2005 la Société a, conformément à l’article

6 des statuts de la Société, racheté

- 1.076 parts sociales détenues par Monsieur Cristian Padovan,
- 1.200 parts sociales détenues par Monsieur Marc Broquin,
- 360 parts sociales détenues par Madame Dorothy Escobedo
- 390 parts sociales détenues par Monsieur Robert King,
suite à la cessation de leurs fonctions au sein du groupe Materis, et en application du «Protocole d’accord et Promesse

d’acquisition et de cession de parts» signé avec chacun des associés.

2. En conséquence, le capital social de la Société est diminué de 30.260,- Euros pour être fixé à un montant de

5.676.710,- Euros, représenté par 567.671 parts sociales d’une valeur nominale de 10,- Euros .

3. Le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société se trouve en conséquence modifié afin de refléter ce qui

précède et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 6, 1

er

 alinéa: Le capital social souscrit est fixé à la somme de EUR 5.676.710,- (cinq millions six cent soixante

seize mille sept cent dix euros) divisé en 567.671 parts de 10,- euros chacune, attribuées aux associés en représentation
de leurs apports respectifs, à savoir 

Luxembourg, le 24 août 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Alt Charles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500 Parts

Amathieu Lorris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 000 Parts

Amelot Bertrand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 900 Parts

Anderson Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 500 Parts

Assis Genine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 125 Parts

Averlant Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 Parts

Baillagou Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500 Parts

Biraghi Marco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 Parts

Bonneviale Brice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500 Parts

Bottomley Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500 Parts

Boussage Patrick   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Broquin Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Parts

Bunt Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 Parts

4645

Bussoli Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Caldwell Robin   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 000 Parts

Carlier Lisiane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750 Parts

Chartier Loic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Chateau Isabelle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Chen Sin-Fook   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Crevecoeur Gérard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Darsy Laurence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Dattee-Vernat Bénédicte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Deffrasnes Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 000 Parts

Delaunay Christine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Desmidt Guy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Dodge Bryan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 100 Parts

Douheret Blandine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750 Parts

Dupreez Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 250 Parts

Durand Claude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Elorza Enrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 100 Parts

Esposito Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 000 Parts

Estienne Frédéric   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Evangelista Paulo César   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Falaschi Jean-pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Fassier Armelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 Parts

Fevzi Elmas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Figueira Luis Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Fitzgerald Mark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Foulon Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 200 Parts

Frenkian Michael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 650 Parts

Fryda Hervé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Garonnat Mireille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750 Parts

Gimat Denis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 125 Parts

Glander Margaret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Goossens Derek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 000 Parts

Guillon Pierre-Antoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Guinot Dominique   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 000 Parts

Haemers Arnaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

450 Parts

Hodenius Karl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Hogg David  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Hu Chong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Hulin Xavier   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 650 Parts

Jary Jean-Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Jolly Remi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 000 Parts

King Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

260 Parts

Kwasny Echterhagen Rudiger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Labourt Ibarre Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Laguillez Jean-Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 500 Parts

Lalouette Vincent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Lastennet Edouard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Laugerette Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Lempereur Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Lenfant Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 Parts

Levet Jean-Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Löf Bengt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Mathieu Alain   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 000 Parts

Milbrath Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Mirra Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750 Parts

Molitor Patrick   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Mosser Bernard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 500 Parts

Mucha Wociech   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Newton Tony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Norelius Per  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Oxley Colin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

4646

Parr Christopher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500 Parts

Porzgen Dirk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 Parts

Prautzsch Volker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Rabiet Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 320 Parts

Raulin Marielle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000 Parts

Raveneau Philippe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 500 Parts

Raynaud Lionel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Reid Graham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Richardson Martin A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Roesky Reiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500 Parts

Roma Marco   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 100 Parts

Roux Elise   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 Parts

Saucier François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2 500 Parts

Simon Thomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 125 Parts

Simonin Fabien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Taquet Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 Parts

Touzo Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Trassard Jean-Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 Parts

De la Tribouille Valérie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 200 Parts

Valdelievre Benoît. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 Parts

Valmary Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000 Parts

Wohrmeyer Christoph  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000 Parts

Wolf Nicolas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 Parts

Ziegler Guido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000 Parts

Broz Vaclav   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650 Parts

Chassaing Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500 Parts

Engel Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 400 Parts

Eronat Volkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 Parts

Faynot Benoit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts

Garden Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 200 Parts

Gires Valerie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 Parts

Lamotte Jack   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

850 Parts

Landry Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 Parts

Lebre Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Lopez de Azcona Diego   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 600 Parts

Pellerin Bruno   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts

Plancon Marc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 Parts

Ribeiro Nuno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 Parts

Riou Arnaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 Parts

Seymore Norman   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Tengattini Tullio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 600 Parts

Terrade Jean-Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts

Tricotelle Jack   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 200 Parts

Trzewiczynska Agata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 Parts

Ado Valentin   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 Parts

Caraux Catherine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

De la Gorce Marie-Christine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

Gordien Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 Parts

Muller Laurence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 500 Parts

N’Guyen Noc Tung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 800 Parts

Robin Jean-Paul   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 Parts

Saint Cricq Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Parts

Soubranne Alain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 300 Parts

Tassin Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Parts

Abarzua   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830 Parts

Amesto Jean Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 700 Parts

Asseraf Frédéric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2 700 Parts

Astengo José   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000 Parts

Azevedo Ricardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 Parts

Barr Doug   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 788 Parts

Bergalli Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 400 Parts

4647

Boddaert Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 000 Parts

Bonnet François   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 900 Parts

Brey Carlos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 900 Parts

Buchanan Carlton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 000 Parts

Comiskey John   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 000 Parts

Cres Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Cummins Kenny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 000 Parts

De la Roche Aymon Guillaume   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 100 Parts

Desbordes Hervé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 800 Parts

Devlin Liam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 916 Parts

Dieudonné Sylvestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 800 Parts

Escobedo Dorothy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

240 Parts

Ferreira Sergio M   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 800 Parts

Fischer Glenn   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 900 Parts

Foré Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 350 Parts

Fouchault Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 300 Parts

Galloux Laurent   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Gnagne Agnero Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 300 Parts

Gonzales Montse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Hahn Hubert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

800 Parts

Hautsch Stéphane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600 Parts

Hoste Darren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 200 Parts

Huisken Duane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Jayles Jérôme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 Parts

Jeanneau Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Jones Ted   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Koo Richard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 600 Parts

Latrille Julien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2 500 Parts

Le Nedic Jean-François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2 000 Parts

Lemahieu Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 900 Parts

Iotti Denis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Martos Riera Antonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 700 Parts

Maume Patrice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Mayet Didier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Medina Aberlado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 4 800 Parts

Meslet Gendron Ghislaine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 900 Parts

Moses John   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 788 Parts

Muniz Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 200 Parts

Nunn Andrew  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3 788 Parts

Nunes Marco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Owens Richard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Pace Corey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

800 Parts

Pagnon Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 800 Parts

Parra Medina Miguel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 400 Parts

Philippe Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

670 Parts

Puigvert Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Ravagnani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

830 Parts

Richard Nathalie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 900 Parts

Rivière Sylvie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 900 Parts

Rossi Véronique   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600 Parts

Saez Viviana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600 Parts

Sancho Ventura Juan José  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 900 Parts

Shackle Steve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 200 Parts

Smigielski Jean-Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 500 Parts

Tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

830 Parts

Tarascon Jean-Claude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 800 Parts

Théron Bernard   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 200 Parts

Thomas François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 000 Parts

Torres Cabello José Ramon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 700 Parts

Tourbier Philippe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 900 Parts

Trivelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

830 Parts

4648

Vicente Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 Parts

Vieville Georges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

708 Parts

Whitfield Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 000 Parts

Zwobada Mario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830 Parts

Alarcon Beltran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 673 Parts

Antonello Stefano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 400 Parts

Arcolini Franco   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

836 Parts

Aubert Jean-Paul   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 090 Parts

Ben Arriba San Augustin Eric   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500 Parts

Bianchi Massimiliano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 150 Parts

Blandini Ignacio   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 836 Parts

Bonassi Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 994 Parts

Bonnet Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 928 Parts

Bouedec Pascal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 321 Parts

Boutonnet Sabine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 286 Parts

Brochard Grégory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 286 Parts

Calvet Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 807 Parts

Caron Delphine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 317 Parts

Casajus Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 345 Parts

Castaldi Paolo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 049 Parts

Catalani Guiseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

836 Parts

Cavagna Gian Pietro   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts

Chapuis François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 150 Parts

Clausier Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 091 Parts

Compiegne Jean-Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 025 Parts

D’Harcourt Aline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 320 Parts

David Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 090 Parts

De Freitas Catherine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 464 Parts

De Lacam Hubert   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 136 Parts

Delas André  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 464 Parts

Della Maggiore Andrea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 263 Parts

Deri Luca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 886 Parts

Falcetti Stefano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 Parts

Fauvarque Ludovic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 760 Parts

Favali Manuela   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 104 Parts

Fierro Curado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 045 Parts

Folgringer Patricia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

802 Parts

Fusetti Anna Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 900 Parts

Galardini Enrico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 263 Parts

Garcia Francesc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 742 Parts

Gasperetto G. Battista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 320 Parts

Genet Benoît  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 464 Parts

Geri Roberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 150 Parts

Ghilardi Francesco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 988 Parts

Gianni Roberto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

941 Parts

Girard Jean-Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 835 Parts

Gorla Valentino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 400 Parts

Grassini Gabriella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 263 Parts

Guerin Patrick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 298 Parts

Hubo Didier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 807 Parts

Innocenti Paolo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

836 Parts

L’Aminot Ronan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 151 Parts

Larozze Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 464 Parts

Le Got Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 321 Parts

Malfatti Sylvia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 150 Parts

Manicardi Roberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 988 Parts

Mantovani Laura   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 150 Parts

Marabotti Paolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 502 Parts

Masson Marcel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 000 Parts

Michieletto Serse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 585 Parts

Milan Denise   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280 Parts

4649

Ce constat a été fait en date du 17 octobre 2005. 
En outre, le soussigné, donne tous pouvoirs à Monsieur John SEIL ou Mademoiselle Gentiane Préalux ou Mademoi-

selle Alexia Uhl, à l’effet de procéder (i) à toutes formalités requises, (ii) signer tous actes et documents et (iii) plus
généralement faire le nécessaire, en relation avec la réduction de capital ci-dessus.

En tant que besoin, la présente décision fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des associés

de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05188. – Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093706.3/534/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.

Montior Hervé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 288 Parts

Lorenzin Orlando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 450 Parts

Padovan Cristian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 Parts

Pennel Stéphane   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 321 Parts

Pillon Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 321 Parts

Poujol Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 807 Parts

Quemener Alain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 286 Parts

Roussel Jo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 025 Parts

Rouze Alain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 025 Parts

Serdoz Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 884 Parts

Taconnet François . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 150 Parts

Taddei Stefano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 879 Parts

Trinchello Massimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 500 Parts

Triolo Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 597 Parts

Zeni Sergio   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 129 Parts

Zilahi Catherine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 320 Parts

Atkinson Peter   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 030 Parts

Brachet François-Guy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Canovas Michel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 096 Parts

Choi Hun-Mok   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601 Parts

Digenis George  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

760 Parts

Doll Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

419 Parts

Dunnes Tomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

800 Parts

Gondolf Marc   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 736 Parts

Hsieh George  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 600 Parts

Jackson Mike  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 736 Parts

Klimov Vladimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601 Parts

Kucera Zdenek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

260 Parts

Lecointe Serge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 475 Parts

Lee Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601 Parts

Leong Michael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 471 Parts

Lindahl Clemens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 096 Parts

Meunier Pierre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

441 Parts

Mongellas Didier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601 Parts

Morgenstern Uwe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 Parts

Morris Derrick   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Neumann Robert   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 000 Parts

Nicklasson Ulf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

775 Parts

Ploncard Patrick   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 400 Parts

Plummer Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

494 Parts

Radal Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

800 Parts

Renault Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 600 Parts

Rennison Grant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

655 Parts

Robinson Derek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 096 Parts

Roodsari Sarang   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601 Parts

Schatten Monika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 Parts

Soudier Jérôme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 Parts

Weber Friedrich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

839 Parts

Ziarovski Emile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

800 Parts

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  567 671 Parts

Olivier Legrain
<i>Le Gérant

4650

YURA S.A., Société Anonyme,

Capital social: EUR 11.238.994,10.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 49.617. 

L’an deux mille cinq, le vingtième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

YURA S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes, inscrite au registre du com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.617 (ci-après, la Société), constituée le 8 décembre 1994
suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et des Associations n

o

 132 du 24 mars 1995, dont les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant les réso-

lutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 décembre 2004, non encore publiées au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et des Associations, sujettes à un acte rectificatif du 30 juin 2005, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et des Associations.

L’assemblée est présidée par M

e

 Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, dont l’adresse professionnelle est à Luxem-

bourg.

Le président nomme comme Secrétaire M

e

 Xavier Nevez, avocat au Barreau de Paris, dont l’adresse professionnelle

est à Luxembourg.

L’assemblée élit comme Scrutateur M

e

 Vivian Walry, Avocat à la Cour, dont l’adresse professionnelle est à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi formé, le Président a déclaré et a requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par les actionnaires sont indiqués dans

une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire,
resteront attachées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

II. Cette liste de présence montre que les vingt-neuf mille huit cent vingt-trois (29.823) actions, représentant l’inté-

gralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire permettant ainsi
à l’assemblée de pouvoir valablement se prononcer sur tous les points de l’agenda qui sont connus de l’actionnaire.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des articles 4, 6, 7, 8, 9 et 11 des statuts de la Société.
Ces faits ayant été exposés et reconnus comme vrais par l’assemblée, l’assemblée a adopté à l’unanimité la résolution

suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de reformuler les articles 4, 6, 7, 8, 9 et 11 des statuts de la Société qui se liront désormais de la

façon suivante:

Art. 4. Le capital social est fixé à onze millions deux cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros dix

cents (EUR 11.238.994,10), représenté par vingt-neuf mille huit cent vingt-trois (29.823) actions sans désignation de
valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions confèrent des droits égaux à leurs détenteurs.
Quant aux modalités d’émission et de cession des actions, il est renvoyé aux lois applicables en la matière, sauf en ce

qui concerne les points qui suivent. Les actionnaires peuvent toutefois par accord unanime décider de ne pas appliquer
les paragraphes suivants du présent article.

Les actions peuvent être librement cédées aux descendants en ligne directe du cédant ou, à condition qu’ils soient

déjà détenteurs d’actions, aux ascendants ou aux frères et soeurs du cédant.

Dans tous les autres cas, les actions ne peuvent être cédées à un quidam, si elles n’ont pas été offertes au préalable

à la société elle-même et, au cas où la société déclinerait cette offre de vente d’actions, aux autres actionnaires.

Dans le cas de l’alinéa précédent, l’offre de vente d’actions doit obligatoirement être communiquée au président du

conseil d’administration moyennant lettre recommandée avec avis de réception. La société pourra accepter l’offre de
vente en cause moyennant lettre recommandée avec avis de réception, expédiée endéans les 30 jours suivant la récep-
tion par la société de l’offre de vente en cause.

En cas d’acceptation par la société de l’offre de vente d’actions, le transfert des actions offertes et le paiement du prix

convenu doit se faire endéans un mois à compter de la date à laquelle le président du conseil d’administration a envoyé
l’acceptation de l’offre au cédant. Le prix par action sera déterminé sur base de la valeur de marché de l’actif de la société
moins l’éventuel passif de la société ainsi que l’éventuelle fiscalité latente, en respectant les règles suivantes d’évaluation
des actions:

les actions de sociétés cotées en bourse seront évaluées sur base de la moyenne du prix en bourse des douze der-

niers mois;

les actions ou les participations dans des sociétés non cotées en bourse seront évaluées sur base du patrimoine net

rectifié par les plus-values ou les moins- values latentes sur les participations directes ou indirectes, ces dernières étant
calculées sur base de la moyenne des prix en bourse des douze derniers mois pour les participations dans des sociétés
cotées et sur base du patrimoine net pour les participations dans des sociétés non cotées.

Au cas où la société n’a pas l’intention d’accepter une telle offre de vente d’actions et que le ou les cessionnaires

initialement envisagés étaient des actionnaires autres que ceux mentionnés au cinquième paragraphe du présent article,
alors cette cession pourra se faire dès à présent librement et sans contrainte.

4651

Au cas où la société n’a pas l’intention d’accepter l’offre de vente d’actions et que le ou les cessionnaires initialement

envisagés étaient des non-actionnaires, alors le président du conseil d’administration doit, endéans les 15 jours suivant
expiration du délai imparti pour accepter l’offre de vente en cause, communiquer cette offre aux autres actionnaires
moyennant lettre recommandée avec avis de réception. Chaque actionnaire pourra alors exercer son droit de préemp-
tion pour l’acquisition des actions dont la cession est proposée, au prix et selon les modalités indiqués, mutatis mutandis,
au huitième paragraphe du présent article, moyennant lettre recommandée avec avis de réception expédiée au président
du conseil d’administration endéans les 30 jours de la réception de la communication. Le droit de préemption s’exerce
proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun des actionnaires.

Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. Ainsi, en cas

de défaut d’acceptation de l’offre de la part de certains actionnaires, les actions leur revenant d’après le quota initial
seront à nouveau offertes proportionnellement à tous les autres actionnaires, ceci selon la même procédure et avec les
mêmes délais pour la communication et l’acceptation que ceux prévus au paragraphe précédent. Ce processus se répé-
tera jusqu’à épuisement des actions offertes en vente.

Par «cession» il faut comprendre non seulement le transfert de la pleine propriété des actions, mais aussi le simple

transfert de la nue-propriété voire même la constitution ou le transfert de droits réels sur les actions; les droits d’option
dérivant d’opérations sur le capital sont également subordonnés à la procédure prévue pour la cession du titre de pro-
priété. Dans ces cas, l’offre aura pour objet le droit réel limité ou bien le droit d’option et le relatif prix de transfert
sera déterminé par l’organe administratif, de commun accord avec les censeurs, selon les critères exposés au huitième
paragraphe du présent article.

Les actions acquises par donation ou succession légale ou testamentaire par des personnes n’étant ni descendants en

ligne directe de l’actionnaire donateur ou défunt ni autres actionnaires devront être offertes en option à la société et
puis aux autres actionnaires au prix et selon les modalités indiqués aux paragraphes précédents du présent article.

Jusqu’au moment où l’offre de vente d’actions a été expressément déclinée à la fois par la société et par tous les

autres actionnaires, respectivement pendant tout le délai pendant lequel la société et/ou les autres actionnaires auraient
pu accepter l’offre de vente en cause, l’héritier, le légataire ou le donataire ne sera inscrit dans le registre des actionnai-
res, ni sera légitimé à l’exercice du vote et des autres droits administratifs inhérents aux actions, ni ne pourra aliéner
les actions à des tiers autres que les actionnaires déjà existants.

Si l’offre de vente d’actions est expressément déclinée à la fois par la société et par tous les autres actionnaires,

respectivement après expiration du délai pendant lequel la société et/ou les autres actionnaires auraient encore pu ac-
cepter l’offre de vente en cause, l’actionnaire cédant pourra librement transférer les actions en cause à des descendants
en ligne directe et à des actionnaires non descendants en ligne directe. En ce qui concerne des cessionnaires tiers par
rapport à ceux cités ci-devant, l’actionnaire cédant devra demander au conseil d’administration, moyennant lettre re-
commandée avec avis de réception, l’autorisation préalable de vendre tout ou partie de ses actions à un ou plusieurs
tiers. Le conseil d’administration peut refuser cette autorisation dans le cas où la qualité d’actionnaire du cessionnaire
proposé serait préjudiciable à l’intérêt social. Le conseil d’administration doit porter à la connaissance de l’actionnaire
intéressé sa décision endéans les 45 jours à compter de la date à laquelle la demande de transfert d’actions lui est par-
venue. En cas de refus d’autorisation, le conseil d’administration fera tout effort raisonnable pour trouver endéans un
délai de 90 jours un cessionnaire potentiel qui trouve son approbation ainsi que celle de l’actionnaire cédant. Si aucun
accord sur l’identité d’un cessionnaire n’a pu être trouvé jusqu’à l’expiration d’un tel délai, les actions en cause pourront
être librement transférés au tiers endéans les six mois suivants. Si au terme de ce délai de six mois, l’actionnaire cédant
n’a toujours pas réussi à vendre les actions indiquées dans son offre de vente, et s’il souhaite encore les vendre, il devra
recommencer la procédure décrite aux paragraphes précédents.

Au cas où la société entend recéder ses propres actions, elle devra les offrir d’abord aux actionnaires déjà existants,

qui pourront exercer alors leur droit de préemption proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun
d’eux. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. Le prix
des actions sera déterminé selon les critères exposés au huitième alinéa du présent article.

Art. 6. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre en-

droit indiqué dans les convocations, le quatrième mardi du mois d’avril à 13.00 heures, et pour la première fois en 1996.

Si ce jour est férié, l’Assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Si l’Assemblée est convoquée en un lieu se situant en dehors des frontières de la commune du siège social, le conseil

d’administration devra prévoir un avis écrit avec accusé de réception remis au moins quinze jours avant la réunion de
l’Assemblée aux actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires à leur domicile respectif ou bien, si communiqués
à cet effet, à leur numéro de fax ou à leur adresse de courrier électronique.

Les administrateurs doivent convoquer l’Assemblée dans les meilleurs délais quand des actionnaires représentant au

moins un dixième du capital social requièrent cela dans une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée peut avoir lieu sans convocation préalable.

Art. 7. L’Assemblée ordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital social est représentée,

sachant que ne rentrent pas dans ce compte les actions sans droit de vote. Les décisions de l’Assemblée ordinaire sont
prises à la majorité absolue des voix.

Les décisions de l’Assemblée extraordinaire, pour être valables, devront réunir les voix des actionnaires représentant

la moitié au moins du capital social.

Les décisions de l’Assemblée ordinaire en deuxième convocation sont prises à la majorité absolue des voix, quelle

que soit la partie du capital représentée par les actionnaires y participant.

4652

L’Assemblée extraordinaire en deuxième convocation ne délibère valablement que si plus d’un tiers du capital social

est représenté. Ses décisions, pour être valables, devront réunir les voix des actionnaires représentant au moins deux
tiers du capital représenté.

Dans tous les cas où la Loi prévoit un quorum ou des majorités particulières, ceux-ci prévalent sur ceux prévus aux

paragraphes précédents du présent article.

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder trois ans. Ils sont déchus de leurs fonctions à la date de l’Assemblée con-

voquée pour l’approbation du bilan annuel relatif au dernier exercice de leur mandat.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ont le

droit d’y pourvoir provisoirement, jusqu’à ce que l’Assemblée, lors de sa première réunion, procède à l’élection défini-
tive., Si par contre la moitié au moins des postes d’administrateurs nommés par l’assemblée générale sont vacants, les
administrateurs restants devront convoquer dans les meilleurs délais une Assemblée extraordinaire, afin que les action-
naires de la société puissent révoquer les administrateurs restés en charge et élire de nouveaux administrateurs cons-
tituant le conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire.
Il se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation. La convo-

cation du conseil d’administration se fait par communication écrite, même par fax ou par courrier électronique, à trans-
mettre aux membres du conseil d’administration par les soins du président ou du vice-président ou d’un administrateur
délégué cinq jours au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence pour lequel un préavis d’un jour sera suffisant.

Le conseil ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction sont présents ou représentés,

le mandat donné par lettre, télex ou télégramme entre administrateurs en fonction étant admis. Les décisions sont

prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés; en cas de parité des voix, celle du

président de la séance prévaut.

Art. 11. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservés à l’assemblée
générale par la loi ou par les statuts.

Relève cependant de la seule compétence de l’assemblée générale toute décision concernant un acte de disposition

relatif à une participation que détient la société dans une autre société. Sont requises pour le vote d’une telle résolution
les majorités prévues à l’article 6 des présents statuts dans le cas d’une Assemblée extraordinaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: C. Feyereisen, X. Nevez, V. Walry, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 juillet 2005, vol. 432, fol. 54, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080907.2/242/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.255. 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 juin 2005, les actionnaires de la société ont décidé:
1. d’accepter la démission avec effet immédiat des administrateurs suivants:
- Monsieur James Stuart Craig, avec adresse professionnelle au 1 Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume

Uni;

- Monsieur Remy Cohen, avec adresse professionnelle au 16 Via Mario Donati, I-20146 Milan, Italie;
- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. d’accepter la nomination avec effet immédiat et pour une durée de trois ans les administrateurs suivants:
- Monsieur Mark Johnson, avec adresse professionnelle au 1 Martin Place, Level 9, Sydney NSW 2000, Australie;
- Monsieur Frank Bush, avec adresse professionnelle au 39, Nelson Street, Gordon NSW 2072, Australie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079115.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Mersch, le 30 août 2005.

 H. Hellinckx.

Luxembourg, le 23 juillet 2005.

Signature.

4653

IFE II, INTERMEDIATE FINANCE EUROPE II SICAR, Société en commandite par actions SICAR.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 109.432. 

In the year two thousand five, on the eight day of September.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Nicolas Gauzès, avocat, residing professionally in Luxembourg,
acting in his capacity as special attorney in fact of the board of directors of IFE II GESTION, a société anonyme, having

its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated on 7th July 2005 pursuant to a deed of the
undersigned notary, not yet published and registered at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg un-
der the number B 109.767, whose articles of associations have not been amended since this date (the «Manager»), acting
in its capacity as sole manager of IFE II, a société en commandite par actions SICAR, having its registered office at 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated on 7th July 2005 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet
published and registered at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 109.432,
whose articles of associations have not been amended since this date (the «Company») by virtue of the authority con-
ferred on him by resolutions adopted by the board of directors of the Company on 22nd July 2005, and in consideration
of the resolutions adopted by the special attorney of the board of directors on 25th August 2005, a copy of which res-
olutions by the board of directors and resolutions by the special attorney, signed ne varietur by the appearing person
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 32,500)

divided into one (1) class A share (the «Class A Share» or in the plural the «class A Shares»), three hundred and twenty-
three (323) class B shares (the «Class B Shares»), which Class A Shares and Class B Shares shall be held by the limited
partners in representation of a limited partnership interest in the Company, and one (1) Class C share (the «Class C
Share»), which shall be held by the unlimited partner, in representation of its unlimited partnership interest in the Com-
pany (collectively the «Shares»), each Share having a nominal value of one hundred (100) Euro.

II. That pursuant to Article 5 of the Company’s articles of association, the authorised capital of the Company has been

fixed at fifty million five hundred ten thousand Euro (EUR 50,510,000) divided into five hundred thousand (500,000)
Class A Shares, five thousand (5,000) Class B Shares and one hundred (100) Class C Shares with a nominal value of one
hundred Euro (EUR 100) each.

III. That the board of directors of the Manager, in its meeting of 22nd July 2005 and in accordance with the authority

conferred on it pursuant to Article 5 of the Company’s articles of association, has decided to issue two hundred seven
thousand two hundred eighty-six (207,286) new Class A Shares and to cancel the preferential subscription rights of the
Company’s existing shareholders to subscribe for the new shares and has granted authority to and instructed any di-
rector of the Manager to finally issue the shares upon confirmation that the subscription funds corresponding to 10%
of the nominal value of each Class A Share to be issued have been received by the Company.

IV. That Mr Michel Dupont, in his capacity as special attorney in fact of the board of directors confirmed on 25th

August 2005 that an amount of two million seventy-two thousand eight hundred sixty Euro (EUR 2,072,860) corre-
sponding to 10% of the nominal value of the two hundred seven thousand two hundred eighty-six (207,286) new Class
A Shares, each share with a nominal value EUR 100 per share, to be issued, has been received and resolved to increase
the share capital of the Company by an amount of twenty million seven hundred twenty-eight thousand six hundred
Euro (EUR 20,728,600) by the issue of two hundred seven thousand two hundred eighty-six (207,286) new Class A
Shares.

V. That the amount of two million seventy-two thousand eight hundred sixty Euro (EUR 2,072,860) has been on 25th

August 2005 at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the
supporting documents for the relevant payments.

VI. That as a consequence of the above mentioned issue of shares, with effect as of 25th August 2005, paragraph one

of Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

«Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twenty million seven hundred sixty-one thousand one

hundred Euro (EUR 20,761,100) divided into two hundred seven thousand two hundred eighty-seven (207,287) class A
shares (the «class A Shares»), three hundred and twenty-three (323) class B shares (the «Class B Shares»), which Class
A Shares and Class B Shares shall be held by the limited partners in representation of a limited partnership interest in
the Company, and one (1) Class C share (the «Class C Share»), which shall be held by the unlimited partner, in repre-
sentation of its unlimited partnership interest in the Company (collectively the «Shares»), each Share having a nominal
value of one hundred (100) Euro.»

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately 7,500 EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

4654

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le huit septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Nicolas Gauzès, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de IFE II GESTION, une société anonyme ayant

son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, constituée le 7 juillet 2005 suivant acte du notaire instrumen-
tant, non encore publié et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.767,
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis cette date (le «Gérant»), agissant en sa qualité de gérant unique de IFE II,
une société en commandite par actions SICAR ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, consti-
tuée le 7 juillet 2005 suivant acte du notaire instrumentant, non encore publié et inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.432, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis cette date (la
«Société»),

en vertu du pouvoir qui lui a été conféré par résolutions adoptées par le conseil d’administration du Gérant en date

du 20 juillet 2005 et compte tenu des résolutions adoptées par le mandataire spécial du conseil d’administration le 25
août 2005, une copie desdites résolutions du conseil d’administration et résolutions adoptées par le mandataire spécial,
après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec
lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et cons-

tatations suivantes:

I. Que le capital social de la société s’élève actuellement à trente-deux mille cinq cents euros (32.500) divisé en une

(1) action de catégorie A (l’«Action de Catégorie A» ou au pluriel «les Actions de Catégorie A»), trois cent vingt-trois
(323) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), lesquelles Actions de Catégorie A et de Catégorie B seront
détenues par les Associés Commanditaires en représentation de leur participation limitée dans la Société et une (1)
action de catégorie C (l’«Action de Catégorie C»), qui sera détenue par l’Associés Commandité en représentation de
sa participation illimitée dans la Société (collectivement les «Actions»), chaque action ayant une valeur nominale de cent
euros (EUR 100).

II. Qu’en vertu de l’article 5 des statuts de la société, le capital autorisé de la société a été fixé à cinquante millions

cinq cent dix mille euros (EUR 50.510.000), divisé en cinq cent mille (500.000) Actions de Catégorie A, cinq mille (5.000)
Actions de Catégorie B et cent (100) Actions de Catégorie C, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) cha-
cune.

III. Que le conseil d’administration du gérant, lors de sa réunion du 22 juillet 2005 et conformément au pouvoir qui

lui a été conféré en vertu de l’article 5 des statuts de la Société, a décidé d’émettre deux cent sept mille deux cent
quatre-vingt-six (207.286) nouvelles Actions de Catégorie A et d’annuler le droit préférentiel de souscription des ac-
tionnaires existants de la Société pour la souscription des nouvelles actions et a donné pouvoir et instruction à tout
administrateur du gérant pour émettre les actions après confirmation que les fonds relatifs à leurs souscriptions et cor-
respondant à 10% de la valeur nominale de chaque Action de Catégorie A à émettre auront été reçus par la Société.

IV. Que Monsieur Michel Dupont, en sa capacité de mandataire spécial du conseil d’administration a confirmé le 25

août 2005 qu’un montant de deux millions soixante-douze mille huit cent soixante euros (EUR 2.072.860) correspon-
dant à 10% de la valeur nominale des deux cent sept mille deux cent quatre-vingt-six (207.286) nouvelles Actions de
Catégorie A, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à émettre, a été reçu par la Société et a
décidé d’augmenter le capital de la Société d’un montant de vingt millions sept cent vingt-huit mille six cents euros (EUR
20.728.600) par l’émission de deux cent sept mille deux cent quatre-vingt-six (207.286) nouvelles Actions de Catégorie
A. 

V. Que le montant de deux millions soixante-douze mille huit cent soixante euros (EUR 2.072.860) est à compter du

25 août 2005 à la libre disposition de la société, comme prouvé au notaire instrumentant par présentation des docu-
ments concernant lesdits paiements.

VI. Qu’en conséquence de l’émission d’actions mentionnée ci-dessus, avec effet au 25 août 2005, le premier paragra-

phe de l’article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à vingt millions sept cent soixante et un mille cents euros (EUR

20.761.100) divisé en deux cent sept mille deux cent quatre-vingt-six (207.287) actions de catégorie A («les Actions de
Catégorie A»), trois cent vingt-trois (323) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), lesquelles Actions de
Catégorie A et de Catégorie B seront détenues par les Associés Commanditaires en représentation de leur participation
limitée dans la Société et une (1) action de catégorie C (l’«Action de Catégorie C»), qui sera détenue par l’Associés
Commandité en représentation de sa participation illimitée dans la Société (collectivement les «Actions»), chaque action
ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100).»

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de 7.500 EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

4655

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzès, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 150S, fol. 1, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(087992.3/206/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

IFE II, INTERMEDIATE FINANCE EUROPE II SICAR, Société en commandite par actions SICAR.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 109.432. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 6 octobre 2005.

(087994.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

DIREKT INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 60.320. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendfünf, den einunddreissigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft ING-DiBa AG, mit Sitz in Theodor-Heuss-Allee 106, D-60486 Frankfurt am Main, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 7727,

alleiniger Aktionär der Gesellschaft DIREKT INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (hiernach «die Gesellschaft»),
hier vertreten durch Herrn Fernand Schaus, Vice President CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE

(LUXEMBOURG) S.A. mit professioneller Adresse in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet (hiernach der «Komparent»).

Der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, erklärt:
1) Dass die Gesellschaft DIREKT INVESTMENT MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet,

eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B, Nummer 60.320, unter der Firmen-
bezeichnung QUELLE BANK INVESTMENT MANAGEMENT S.A. gegründet wurde, gemäss Urkunde, aufgenommen
durch den Notar Reginald Neuman, mit damaligem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 7. August 1997, veröffentlicht im
Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations Nummer 488 vom 8. September 1997,

umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch vorbenannten Notar Reginald Neumann, am 23. August 1999, ver-

öffentlicht im Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations C Nummer 8647 vom 18. November 1999,

umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in

Niederanven, am 17. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations C Nummer 192
vom 17. Februar 2004,

umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in

Niederanven, am 27. Februar 2004, veröffentlicht im Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations C Nummer 439
vom 26. April 2004, beinhaltend die Änderung des Firmennamens von ENTRIUM INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
in DIREKT INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

2) Dass das Gesellschaftskapital der Gesellschaft einen jetzigen Stand von einhundertsiebenundzwanzigtausendacht-

hundertzweiundzwanzig Komma achtundneunzig Euro (EUR 127.822,98) hat, eingeteilt in zweitausendfünfhundert
(2.500) Aktien mit einem Nennwert von je einundfünfzig Komma zwölf Euro (EUR 51,12).

3) Dass der Komparent, vorbenannt, alleiniger Eigentümer aller Gesellschaftsaktien der Gesellschaft geworden ist.
4) Dass der Komparent, als alleiniger Aktionär ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft auflösen zu wollen und diesbe-

züglich mit sofortiger Wirkung eine erste Generalversammlung einberuft.

5) Dass in dieser ersten Generalversammlung der Komparent die Gesellschaft CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-

MENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A. mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, als Li-
quidator der Gesellschaft ernennt.

Luxembourg-Eich, le 27 septembre 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire
Par délégation M. Mayer

4656

6) Dass der Komparent anschliessend die zweite und dritte ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft

einberuft, gemäss Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und seine Absicht dar-
legt, beide sofort hintereinander abhalten zu wollen.

7) Dass in der zweiten Generalversammlung der Komparent erklärt:
- genaue Kenntnis der Satzung, der Finanzlage der Gesellschaft sowie des Liquidationsberichts zu besitzen;
- alle Aktiva sowie alle bekannten und unbekannten Passiva der Gesellschaft zu übernehmen;
- dass der Liquidationsbericht, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt;
- den Wirtschaftsprüfer ERNST &amp; YOUNG, L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall zum Prüfungskommissar der

Liquidation zu ernennen, und diesem den Auftrag zu erteilen den Liquidationsbericht zu prüfen.

8) Dass in der darauf folgenden dritten Generalversammlung der Komparent erklärt:
- vom Bericht des Prüfungskommissars Kenntnisnahme genommen zu haben; 
- den Schlussfolgerungen des Berichtes des Prüfungskommissars zuzustimmen;
- den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Liquidator der Gesellschaft Entlastung für die Ausübung ihres Mandates

zu erteilen;

- dass der Bericht des Prüfungskommissars, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt;
- dass unter Vorbehalt der Übernahme aller etwaigen Verpflichtungen der Gesellschaft durch den Komparenten, er

die Auflösung der Gesellschaft beschliesst;

- dass die Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet ist;
- dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren von der CREDIT SUIS-

SE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBURG) S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxemburg, aufbe-
wahrt werden;

- dass die Aktien der Gesellschaft annulliert werden sollen.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft DIREKT INVESTMENT MANAGEMENT

S.A., vorgenannt, festgestellt.

Dem Komparenten wird eine Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde ausgehändigt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Schaus, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 50, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081059.3/202/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

FASHION ONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 1.622.450,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.878. 

Par résolution datée du 19 août 2005, les associés de FASHION ONE HOLDING, S.à r.l. ont nommé Christian

Dosch, demeurant au 31, Myliusstrasse, D-60323 Frankfurt am Main, au poste de gérant classe A, pour une durée indé-
terminée, avec effet au 1

er

 septembre 2005, en remplacement de Peter Gangsted, gérant de classe A, démissionnaire au

1

er

 septembre 2005.
En conséquence, au 1

er

 septembre 2005, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Christian Dosch (gérant classe A);
- Mirko Meyer Schoenherr (gérant classe A);
- Pascale Nutz;
- Stefan Oostvogels;
- Frank Matthias Przygodda.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079094.3/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Senningerberg, den 9. September 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 29 août 2005

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Stratus Equity, S.à r.l.

Baker Tilly Luxembourg S.A.

FN Hermes S.A.

Chris &amp; Co Logistic Assistance S.A.

Shaka Invest S.A.

Symbiose, S.à r.l.

Kenmare Investments S.A.

Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding S.A.

Vebeco S.A.

DIA Tritonco 2 (Luxembourg) S.A.

Anglo-Dutch Investment Group, S.à r.l.

Waterford Investments S.A.

DIA Tritonco 3 (Luxembourg) S.A.

Elfa-Auto, S.e.n.c.

Humanitarian World Holding

Patrimvest

BCP Caylux Holdings Luxembourg S.C.A.

Helfin S.A.

Grapy S.A.

Station Service Durand, S.à r.l.

Textile Invest S.A.

Comité International des Festivités de la Schueberfouer Luxembourg

SOCLINPAR, Société Luxembourgeoise d’Investissements et de Participations S.A.

Instal S.A.

Stratus Technologies Group S.A.

Fashion One Luxembourg, S.à r.l.

IGEFI International, S.à r.l.

IGEFI Group, S.à r.l.

DH Real Estate Finance Holdings S.C.A.

Fern, S.à r.l.

Fern, S.à r.l.

MATSC

Yura S.A.

Macquarie Industrie Beteiligungen S.A.

IFE II, Intermediate Finance Europe II Sicar

IFE II, Intermediate Finance Europe II Sicar

Direkt Investment Management S.A.

Fashion One Holding, S.à r.l.