logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

63793

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1330

6 décembre 2005

S O M M A I R E

Ad Hoc Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63795

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63810

Ad Hoc Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63795

International Wear Parts S.A., Luxembourg. . . . . 

63794

AMF International Holding S.A., Luxembourg . . . .

63807

International Wear Parts S.A., Luxembourg. . . . . 

63794

Atlantis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63810

J.P.  Morgan  Partners  (BHCA)  M&H  Luxembourg, 

BCM Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .

63820

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63838

Belfry Limited Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

63797

J.P.  Morgan  Partners  (BHCA)  M&H  Luxembourg, 

Belfry Managing Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . .

63811

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63840

Chauffage Entringer, S.à r.l., Welfrange  . . . . . . . . .

63821

Kertes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63807

Chinese King, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

63810

Locations  Privées  /  Agence  Aldringen,   S.à r.l., 

Civalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63806

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63807

Colony Sardegna, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

63808

Locations  Privées  /  Agence  Aldringen,   S.à r.l., 

Colony Sardegna, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

63808

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63807

Compagnie de Conseils et de Services   S.A.,   Lu- 

Luxor Consulting S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . 

63837

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63836

Med Lease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63824

Corspi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63822

MP Business S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . 

63809

CST Investment Holding S.A., Luxembourg. . . . . .

63837

Nylof S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63828

Demo Solutions S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . .

63809

Parc-Immo, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . 

63836

Direct-Locations / Agence Royal Business,  S.à r.l.,

Pied-Plume, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63837

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63795

Potyka, GmbH, Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63840

Direct-Locations / Agence Royal Business,  S.à r.l.,

Rommels Maschinn, S.à r.l., Senningen  . . . . . . . . . 

63826

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63795

S.C.I. Drai Eechelen, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63808

Distribution et Consulting S.A., Mamer  . . . . . . . . .

63823

S.C.I. Drai Eechelen, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63808

Dorian Hellenic Holdings S.A., Senningerberg . . . .

63821

S.C.I. Drai Eechelen, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63808

Entreprise de Transports Micolino et Fils, S.à r.l., 

S.C.I. Drai Eechelen, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63808

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63823

Safag S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63821

Euro Port S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63795

Sieg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

63809

Florinvest Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63823

Sieg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

63809

Florinvest Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63823

Sifolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63826

Florinvest Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

63828

Space S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63821

Foyer  Ré,  Compagnie  Luxembourgeoise  de  Ré- 

Stroud S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63835

assurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

63835

Stroud S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63835

Golden Entertainment Productions Holding S.A., 

Talpa, S.à r.l., Noertzange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63826

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63810

Texfina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63794

Golden Entertainment Productions Holding S.A., 

Thanatos Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

63809

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63810

Tref Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

63794

Grand Bazar Schirtz, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . .

63807

Tref Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

63794

Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

63822

Tridex A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63836

Hubble Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

63821

VCM Golding Mezzanine Sicav, Luxembourg . . . . 

63828

Iberian Foods, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63829

VCM Golding Mezzanine Sicav, Luxemburg . . . . . 

63827

Immobilière Drai Eechelen, S.à r.l., Luxembourg. .

63796

Vital Center International S.A., Luxembourg . . . . 

63796

Immobilière Drai Eechelen, S.à r.l., Luxembourg. .

63796

Vital Center International S.A., Luxembourg . . . . 

63796

Immobilière Drai Eechelen, S.à r.l., Luxembourg. .

63796

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

63822

Immobilière Drai Eechelen, S.à r.l., Luxembourg. .

63796

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

63822

Integrated Network Solutions (Luxembourg) S.A.,

63794

TREF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.824. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05855, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063805.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

TREF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.824. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05851, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063804.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

TEXFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.803. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05857, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063806.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.309. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05867, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063809.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.309. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05860, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063808.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour TREF INVESTMENTS S.A.
Signature

<i>Pour TREF INVESTMENTS S.A.
Signature

<i>Pour TEXFINA S.A.
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A.
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A.
Signature

63795

AD HOC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.789. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG5875, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063813.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

AD HOC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.789. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05872, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063811.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

EURO PORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.281. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05879, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063815.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DIRECT-LOCATIONS / AGENCE ROYAL BUSINESS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.532. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01464, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063837.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DIRECT-LOCATIONS / AGENCE ROYAL BUSINESS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.532. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05723, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063835.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour AD HOC CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour AD HOC CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour EURO PORT S.A.
Signature

P/O COSELUX, S.à r.l.
Signature

P/O COSELUX, S.à r.l.
Signature

63796

IMMOBILIERE DRAI EECHELEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 69.689. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04652, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063814.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

IMMOBILIERE DRAI EECHELEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 69.689. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04654, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063817.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

IMMOBILIERE DRAI EECHELEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 69.689. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04656, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063818.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

IMMOBILIERE DRAI EECHELEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 69.689. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04658, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063820.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

VITAL CENTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.706. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08539, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063905.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

VITAL CENTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.706. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08541, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063908.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

63797

BELFRY LIMITED PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 7,200,000.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.559. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventh of July.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg

on 7 July 2005, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, not yet registered in the
Luxembourg company and commercial register,

represented by Mrs Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 7th 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

limited liability company:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the

«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on
commercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of BELFRY LIMITED PARTNER, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of the City of Luxem-

bourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a

resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social

developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may tempo-
rarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tempo-
rary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at seven million two hundred thousand Euro

(EUR 7,200,000.-) divided into two hundred and eighty-eight thousand (288,000) shares, with a par value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

The authorized capital of the Company is set at two hundred million Euro (EUR 200,000,000.-), divided into eight

million (8,000,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers is/are authorised and empowered, to (i) realise any

increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the
issuing of new shares with or without share premium, against payment in cash or in kind as the board of Managers in
their discretion may determine notably following the exercise of any subscription and/or conversion rights granted by
the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers under the terms of share subscription warrants (which
may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible preferred equity certificates, convert-

63798

ible notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by conversion of claims or in any other
manner; (ii) issue any rights in whatever form under the terms of share subscription warrants (which may be separate
or attached to shares, notes or similar instruments), convertible preferred equity certificates, convertible notes or sim-
ilar instruments entitling to the subscription of such shares; and (iii) determine the place and date of the issue or the
successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares. 

This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the

resolutions taken by the Company’s sole shareholder on July 7, 2005 in the Mémorial C and it may be renewed by the
sole shareholder or, as the case may be, by a general meeting of shareholders.

The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may delegate to any duly authorized officer of the

Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares
representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the
legally required form by the the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers within the limits of the au-
thorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders.

The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of sharehold-

ers representing at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. - Manager(s), Board of managers, Statutory Auditors

Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers

which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and
who need not be shareholders (the «Manager(s)»).

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Manager(s) and one or

several Class B Manager(s).

Art. 10. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman

(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

63799

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence
or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A Manager and one
Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such
meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and |valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in

case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Man-
ager(s) or of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature

of any single Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.

However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one

or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A
Manager and one Class B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV. - Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exer-

cises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August
10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by
the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obli-
gation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written
vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in

compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more
subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.

63800

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-

er(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of

Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on 31 October at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Manager.

Chapter V. - Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of August in every year and ends on

the last day of July.

Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than twenty-five shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on

dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixe the amount and the date of payment of any such advance pay-
ment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution. Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Shareholder Subscribed 

capital

Number Amount 

paid-in

(EUR)

of shares

(EUR)

BELFRY LUX PARTICIPATION S.à r.l., prenamed,  . . . . . . . . . . . . . .

7,200,000.-

288,000

7,200,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,200,000.-

288,000

7,200,000.-

63801

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 77,500.- EUR.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of July 2005.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1. The sole shareholder resolved to set at four (4) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as Class A Managers for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year
ended 31 December 2005:

Mr Robert Ian Kauffman, Financier, born on 22 October 1963 in New York (United States of America), residing at

39, via della Mercede, 00187 Rome (Italy); and

Mr Jonathan Ashley, Financier, born on 28 February 1966 in New York (United States of America), residing at 21

Carlton Hill Road, London NW8 0JX (United Kingdom).

The sole shareholder further resolved to appoint the following as Class B Manager for a period ending at the date of

approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005:

- Mr Luc Hansen, chartered accountant, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

- Mr John Seil, chartered accountant, born on 28 September 1948 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

2. The registered office shall be at:
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am 7. Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht des Grossherzogstums

Luxemburg am 7. Juli 2005 gegründet worden ist, mit Sitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, noch nicht im
Luxemburger Handelsregister eingetragen,

vertreten durch Frau Sabine Hinz, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 7. Juli 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung erstellt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit durch den Alleingesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschafts-
vertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Die Gesellschaft zählt ursprünglich einen Alleingesellschafter, Eigentümer aller Geschäftsanteile. Die Gesellschaft

kann jedoch jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Geschäftsanteilen oder der Ausgabe neuer Geschäfts-
anteile, aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf.

Der Name der Gesellschaft ist BELFRY LIMITED PARTNER, S.à r.l.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Ge-

schäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in

anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-

scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft

63802

vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vor-
übergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu brin-
gen.

Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in

luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Be-
teiligungen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-

scheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafter-Versammlung, die gemäss

den Gesetzesbestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden. 

Kapitel II. - Kapital, Geschäftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf siebenmillionenzweihunderttausend Euro (EUR

7.200.000,-) festgesetzt, eingeteilt in zweihundertachtundachzigtausend (288.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert
von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll eingezahlt.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundert Millionen Euro (EUR 200.000.000,-), aufgeteilt in acht

Millionen (8.000.000) Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Der/die Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführungsrat ist/sind in den Grenzen des genehmigten Ka-

pitals dazu ermächtigt, (i) in ihrem bzw seinem Ermessen eine Ermessen eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals vorzu-
nehmen, und zwar in einer oder in mehreren Phasen durch die Ausgabe neuer Geschäftsanteile. entweder mit oder
ohne Emissionsaufged, gegen eine Geldoder eine Sacheinlage und insbesondere, gemäss den Bedingungen von ausgege-
benen Zeichnungsoptionen, Wandelvorzugszertifikate, Wandelanleihen, Schuldscheinen oder ähnlichen, von Zeit zu
Zeit von der Gesellschaft ausgebebenen Wertpapieren, der von ihm beziehungsweise ihnen, im Rahmen des genehmig-
ten Kapitals, gewährten Zeichnungs- und/oder Umwandlungsrechte (die entweder gesondert von den Geschäftsanteilen,
Schuldscheinen oder anderen Wertpapieren oder diesen beigefügt ausgegeben wurden), durch eine Umwandlung von
Ansprüchen gegenüber der Gesellschaft oder auf jede andere Weise; (ii) Rechte in jedweder Form gemäß den Ge-
schäftsbedingungen von Zeichnungsoptionen, Wandelvorzugszertifikaten, Wandelanleihen, Schuldscheinen (die entwe-
der gesondert von den Geschäftsanteilen, Schuldscheinen oder anderen Wert papieren oder diesen beigefügt
ausgegeben wurden) zu gewähren, die die Zeichnung von Gesellschaftsanteilen gestatten; und (iii) den Ort und den Zeit-
punkt der Geschäftsanteilausgabe oder der aufeinander folgenden Geschäftsanteilausgaben, den Ausgabepreis, die Be-
dingungen der Zeichnung und der Einzahlung der neuen Geschäftsanteile festzulegen.

Diese Ermächtigung gilt bis zum Ende eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung des Protokolls

der durch den Alleingesellschafter am 7. Juli 2005 getroffenen Beschlüsse im Mémorial C und kann durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafterversammlung erneuert werden.

Der/die Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführungsrat kann/können jedem befugten Mitarbeiter der

Gesellschaft oder jeder anderen ordnungsgemäß ermächtigten Person die Aufgaben der Annahme der Zeichnung und
der Einzahlung der neuen Geschäftsanteile überlassen, die das erhöhte Kapital ganz oder teilweise vertreten. Nach jeder
Erhöhung des ausgegebenen Kapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form
durch den/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls den Geschäftsführungsrat, wird dieser Artikel dergestalt abgeän-
dert, dass er die vorgenommene Erhöhung wiedergibt.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die ge-
setzliche Rücklage verwendet werden.

Art. 6. Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Ver-

mögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum
eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. 
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen

gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft meh-

rere Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen

63803

die Geschäftsanteile lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei
der drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.

Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen

Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder

mehrmals durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabge-
setzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorlie-
gendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden
Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Art. 8. Entmündigung. Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird

weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das
den Alleingesellschafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Kapitel III. Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare

Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern,

die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden können (der «Geschäftsführungs-
rat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).

Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafter-Versammlung, die deren

Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nach-
folger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder
der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Der Alleingesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung können beschließen, einen oder mehrere

Geschäftsführer der Kategorie A sowie einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.

Art. 10. Geschäftsführungsrat. Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen

Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Ge-
schäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungs-rates und
der Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist

einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen

den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt
sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum
zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schrift-

licher Einberufüngsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehe-
nen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über
Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche
Zustimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet
werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Geschäftsführungs-
ratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungs-

rat von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen

Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind. Sind Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B bestellt worden, so ist der
Geschäftsführungsrat nur dann beschlussfahig, wenn gleichzeitig mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer
sowie mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder ver-
treten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnli-

chen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig
miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleich-
wertig.

In Dringlichkeitsfallen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-

bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden,
wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungs-vorsitzenden

und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.

63804

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-

legt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitglie-
dern unterzeichnet.

Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein

solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für
die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz
oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäfts-
führungsrats.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne

Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte
Personen oder Vertreter übertragen.

Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-

einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/
sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma
ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der
Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma,
mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbin-
dung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-

schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsfüh-
rungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber
abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleinge-
sellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift jedes

Geschäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die
Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Ge-
schäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertra-
genen Befugnisse gilt.

Sind jedoch ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie

B durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt worden, so wird die Gesellschaft gegen-
über Dritten durch die gemeinschaftlichen Unterschriften eines Geschäftsführers der Kategorie A sowie eines Ge-
schäftsführers der Kategorie B oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von
Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich
verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

Art. 16. Kommissare. Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,

muss einem oder mehreren Kommissaren anvertraut werden, welche keine Gesellschafter sein müssen.

Die Kommissare werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, von der Gesellschafterver-

sammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie blei-
ben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können
jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesell-
schafterversammlung abberufen werden.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 17. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die

Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Ge-
schäftsführer oder den Geschäftsführungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden.
Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem
Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberu-

fung gemäss luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführungsrat, oder
subsidiär, durch den Kommissar, oder subsidiär dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird,
beinhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige
Einberufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder

Telegramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

63805

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,

wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats liegen, dies erforderlich machen.

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschaf-

terversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Mit Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den Ge-

schäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsrat vorbehalten sind, ist sie mit den weitestreichendsten Befug-
nissen ausgestattet, um jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung durchzuführen oder zu
genehmigen.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten

ist, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am 31. Oktober um 14 Uhr am Gesellschafts-
sitz oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

Art. 20. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages

und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Geset-
zes, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Be-schlussfähigkeit und Mehrheit un-
terliegt, muss von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten
Gesellschaftskapitals vertreten.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages werden alle

übrigen Beschlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichts-instanzen oder anderweitig vorgebracht wer-

den können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschaftsführer unterzeichnet.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats August und endet

am einunddreißigsten Tag des Monats Juli eines jeden Jahres.

Art. 22. Bilanz. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder

der Geschäftsführungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesell-

schafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz

einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen
vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 23. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn

abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann
nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jähr-

lichen Reingewinns. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen,
ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen

eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Betrag und
das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.

Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

Art. 24. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der gemäß den-
selben Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die für die Abänderung des vorliegenden
Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder

juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt
werden, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegen.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird

das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet, und zwar im Verhältnis
zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag

geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.

63806

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei erstellt worden ist, hat diese Partei

folgende Anzahl Geschäftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt: 

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht, der bestätigt, dass die Bestimmungen des

Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung ein-
gehalten worden sind.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr 77.500,- EUR geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Juli 2005.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Der Alleingesellschafter, der stellvertretend für die Gesellschafterversammlung handelt, hat unverzüglich die folgen-

den Beschlüsse gefasst:

1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf vier (4) festzulegen, und beschließt außer-

dem folgende Personen zu Geschäftsführern der Kategorie A für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestäti-
gung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:

- Herrn Robert Ian Kauffman, Finanzier, geboren am 22. Oktober 1963 in New-York (Vereinigte Staaten von Ame-

rika), wohnhaft in Via della Mercede 39, 00187 Rom (Italien); und

- Herrn Jonathan Ashley, Finanzier, geboren am 28. Februar 1966 in New-York (Vereinigte Staaten von Amerika),

wohnhaft in Carlton Hill Road 21, NW8 0JX London (Großbritannien).

Der Alleingesellschafter beschließt außerdem, folgende Person zum Geschäftsführer der Kategorie B für einen Zeit-

raum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene
Geschäftsjahr endet:

- Herrn Luc Hansen, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, wohnhaft in 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

- Herr John Seil, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 28. September 1948 in Luxemburg, wohnhaft in 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

2 Der Sitz der Gesellschaft wird sich befinden in:
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg). 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

obengenannten erschienen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst
ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird
der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekann-

ten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet. 

Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 14, case 11. – Reçu 72.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(066713.3/206/611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

CIVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.150. 

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05890, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063816.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Gesellschafter

Gezeichnetes

Anzahl Einzahlung

Kapital (EUR) Geschäftsanteile

(EUR)

LUXGATE GmbH, vorbenannt,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.200.000,-

288.000 7.200.000,-

Summe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.200.000,-

288.000 7.200.000,-

Luxembourg-Eich, den 18. Juli 2005.

P. Decker.

<i>Pour CIVALUX S.A.
Signature

63807

AMF INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.762. 

Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05892, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063819.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

KERTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.126. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05896, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063821.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

GRAND BAZAR SCHIRTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 19, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.173. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03823, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(902434.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

LOCATIONS PRIVEES / AGENCE ALDRINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.115. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05724, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063839.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

LOCATIONS PRIVEES / AGENCE ALDRINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.115. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05725, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063841.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour AMF INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour KERTES S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

P/O COSELUX, S.à r.l.
Signature 

P/O COSELUX, S.à r.l.
Signature 

63808

S.C.I. DRAI EECHELEN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04690, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063824.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

S.C.I. DRAI EECHELEN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04709, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063844.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

S.C.I. DRAI EECHELEN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04709, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063845.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

S.C.I. DRAI EECHELEN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04754, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063849.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

COLONY SARDEGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.482.100,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 94.362. 

Le bilan social au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05501, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063931.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

COLONY SARDEGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.482.100,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 94.362. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05503, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063932.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique habilitée par la Gérance

V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique habilitée par la Gérance

63809

THANATOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 89.307. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 juillet 2005 que:

- le siège social de la société est transféré au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07229. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063826.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DEMO SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 96.397. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2005, réf. DSO-BG00106, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 juillet 2005.

(902436.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

MP BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 87.137. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2005, réf. DSO-BG00105, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 juillet 2005.

(902437.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

SIEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.703. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08556, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063912.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SIEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.703. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08558, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063910.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Signature

A.-F. Moutschen
<i>Administrateur

E. Proesmans
<i>Administrateur-délégué

 

Signature.

 

Signature.

63810

ATLANTIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 87, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.207. 

Le bilan, arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06304, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, le 20 juillet 2005.

(063850.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

CHINESE KING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 204, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 30.790. 

Le bilan, arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06306, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, le 20 juillet 2005.

(063852.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

GOLDEN ENTERTAINMENT PRODUCTIONS HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. GOLDEN AVIATION HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 83.738. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07421, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 juillet 2005.

(063878.3/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

GOLDEN ENTERTAINMENT PRODUCTIONS HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. GOLDEN AVIATION HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 83.738. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07425, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 juillet 2005.

(063877.3/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.779. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06120, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063961.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

JEAN BRAAS, Bureau Comptable
Signature

JEAN BRAAS, Bureau Comptable
Signature

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

63811

BELFRY MANAGING PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 20,000.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.560. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventh of July.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg

on 7 Juli 2005, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, not yet registered in the
Luxembourg company and commercial register,

represented by Mrs Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 7th 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

limited liability company:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the

«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of BELFRY MANAGING PARTNER, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of the City of Luxem-

bourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a

resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social

developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may tempo-
rarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tempo-
rary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes. 

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) di-

vided into eight hundred (800) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

The authorized capital of the Company is set at seventy million Euro (EUR 70,000,000.-), divided into two million

eight hundred thousand (2,800,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers is/are authorised and empowered, to (i) realise any

increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the
issuing of new shares with or without share premium, against payment in cash or in kind, following the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers under
the terms of share subscription warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments),
convertible preferred equity certificates, convertible notes or similar instruments issued from time to time by the Com-

63812

pany, by conversion of claims or in any other manner; (ii) issue any rights in whatever form under the terms of share
subscription warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible pre-
ferred equity certificates, convertible notes or similar instruments entitling to the subscription of such shares; and (iii)
determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the sub-
scription of and paying up on the new shares.

This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the

resolutions taken by the Company’s sole shareholder on July 7, 2005 in the Mémorial C and it may be renewed by the
sole shareholder or, as the case may be, by a general meeting of shareholders. The Manager(s) or, as the case may be,
the Board of Managers may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the the Manager(s)
or, as the case may be, the Board of Managers within the limits of the authorized capital, the present article is, as a
consequence, to be adjusted to this amendment.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. - Manager(s), Board of managers, Statutory auditors

Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers

which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and
who need not be shareholders (the «Manager(s)»).

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Manager(s) and one or

several Class B Manager(s).

Art. 10. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman

(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.

63813

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence
or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A Manager and one
Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such
meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in

case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Man-
ager(s) or of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature

of any single Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.

However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one

or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A
Manager and one Class B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV. - Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exer-

cises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August
10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by
the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obli-
gation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written
vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in

compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more
subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.

63814

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-

er(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of

Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on 31 March at 4:30 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Manager.

Chapter V. - Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on

the last day of December.

Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than twenty-five shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on

dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixe the amount and the date of payment of any such advance pay-
ment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter - VII. Applicable law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Shareholder Subscribed 

capital

Number Amount 

paid-in

(EUR)

of shares

(EUR)

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., prenamed  . . . . . . . . . . . . . .

20,000.-

800

20,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,000.-

800

20,000.-

63815

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 3,000.- EUR.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2005.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1. The sole shareholder resolved to set at four (4) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as Class A Managers for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year
ended 31 December 2005:

Mr Robert Ian Kauffman, Financier, born on 22 October 1963 in New York (United States of America), residing at

39, via della Mercede, 00187 Rome (Italy); and

Mr Jonathan Ashley, Financier, born on 28 February 1966 in New York (United States of America), residing at 21

Carlton Hill Road, London NW8 OJX (United Kingdom).

The sole shareholder further resolved to appoint the following as Class B Manager for a period ending at the date of

approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005:

Mr Luc Hansen, chartered accountant, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Mr John Seil, chartered accountant, born on 28 September 1948 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

2. The registered office shall be at:
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am 7. Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht des Grossherzogstums

Luxemburg am 7. Juli 2005 gegründet worden ist, mit Sitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, noch nicht im
Luxemburger Handelsregister eingetragen,

vertreten durch Frau Sabine Hinz, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 7. Juli 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung erstellt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit durch den Alleingesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschafts-
vertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Die Gesellschaft zählt ursprünglich einen Alleingesellschafter, Eigentümer aller Geschäftsanteile. Die Gesellschaft

kann jedoch jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Geschäftsanteilen oder der Ausgabe neuer Geschäfts-
anteile, aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf.

Der Name der Gesellschaft ist BELFRY MANAGING PARTNER, S.à r.l.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Ge-

schäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsrührungsrat können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in

anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsrührungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-

scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung

63816

zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vor-
übergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu brin-
gen.

Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in

luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Be-
teiligungen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form. Die Ge-
sellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche
oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-

scheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchfuhren, welche zur Aus-

führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, die gemäss den

Gesetzesbestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden. 

Kapitel II. - Kapital, Geschäftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) festgesetzt,

eingeteilt in achthundert (800) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle
voll eingezahlt. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt siebzig Millionen Euro (EUR 70.000.000,-), aufgeteilt in
zwei Millionen achthunderttausend (2.800.000) Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil hat einen Nennwert von fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25,-).

Der/die Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführungsrat ist/sind in den Grenzen des genehmigten Ka-

pitals dazu ermächtigt, (i) jede, eventuell auf einer Ausübung, gemäss den Bedingungen der ausgegebenen Zeichnungs-
optionen, Wandelvorzugszertifikate, Wandelanleihen, Schuldscheinen oder ähnlichen, von Zeit zu Zeit von der
Gesellschaft ausgebebenen Wertpapieren, der von ihm beziehungsweise ihnen, im Rahmen des genehmigten Kapitals,
gewährten Zeichnungs- und/oder Umwandlungsrechte (die entweder gesondert von den Geschäftsanteilen, Schuld-
scheinen oder anderen Wertpapieren oder diesen beigefügt ausgegeben wurden) beruhende Erhöhung des Gesell-
schaftskapitals vorzunehmen, und zwar in einer oder in mehreren Phasen durch die Ausgabe neuer Geschäftsanteile,
entweder mit oder ohne Emissionsaufgeld, gegen eine Geld- oder eine Sacheinlage, durch eine Umwandlung von An-
sprüchen gegenüber der Gesellschaft oder auf jede andere Weise; (ii) Rechte in jedweder Form gemäß den Geschäfts-
bedingungen von Zeichnungsoptionen, Wandelvorzugszertifikaten, Wandelanleihen, Schuldscheinen (die entweder
gesondert von den Geschäftsanteilen, Schuldscheinen oder anderen Wertpapieren oder diesen beigefügt ausgegeben
wurden) zu gewähren, die die Zeichnung von Gesellschaftsanteilen gestatten; und (iii) den Ort und den Zeitpunkt der
Geschäftsanteilausgabe oder der aufeinander folgenden Geschäftsanteilausgaben, den Ausgabepreis, die Bedingungen
der Zeichnung und der Einzahlung der neuen Geschäftsanteile festzulegen.

Diese Ermächtigung gilt bis zum Ende eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung des Protokolls

der durch den Alleingesellschafter am 7. Juli 2005 getroffenen Beschlüsse im Mémorial C und kann durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafterversammlung erneuert werden.

Der/die Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführungsrat kann/können jedem befugten Mitarbeiter der

Gesellschaft oder jeder anderen ordnungsgemäß ermächtigten Person die Aufgaben der Annahme der Zeichnung und
der Einzahlung der neuen Geschäftsanteile überlassen, die das erhöhte Kapital ganz oder teilweise vertreten. Nach jeder
Erhöhung des ausgegebenen Kapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form
durch den/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls den Geschäftsführungsrat, wird dieser Artikel dergestalt abgeän-
dert, dass er die vorgenommene

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die ge-
setzliche Rücklage verwendet werden. 

Art. 6. Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Ver-

mögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum
eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. 
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen

gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft meh-

rere Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen

63817

die Geschäftsanteile lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei
der drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.

Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen

Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder

mehrmals durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabge-
setzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorlie-
gendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden
Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird

weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das
den Alleingesellschafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Kapitel III. - Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare

Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsfiihrern,

die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsfuhrungsrat bilden können (der «Geschäftsfuhrungs-
rat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).

Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafter-Versammlung, die deren

Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nach-
folger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder
der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Der Alleingesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung können beschließen, einen oder mehrere

Geschäftsführer der Kategorie A sowie einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.

Art. 10. Geschäftsführungsrat. Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen

Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Ge-
schäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der
Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist

einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen

den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt
sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum
zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfallen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schrift-

licher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehe-
nen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über
Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche
Zustimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet
werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Geschäftsführungs-
ratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungs-

rat von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen

Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfahig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind. Sind Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B bestellt worden, so ist der
Geschäftsfuhrungsrat nur dann beschlussfähig, wenn gleichzeitig mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer
sowie mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder ver-
treten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnli-

chen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig
miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleich-
wertig.

In Dringlichkeitsfallen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-

bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden,
wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden

und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.

63818

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-

legt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitglie-
dern unterzeichnet.

Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein

solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für
die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz
oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäfts-
führungsrats.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne

Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte
Personen oder Vertreter übertragen.

Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-

einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/
sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma
ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der
Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma,
mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbin-
dung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-

schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsfüh-
rungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber
abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleinge-
sellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift jedes

Geschäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die
Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbeftignisse durch den/die Geschäftsführer oder den Ge-
schäftsfuhrungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertra-
genen Befugnisse gilt.

Sind jedoch ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie

B durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt worden, so wird die Gesellschaft gegen-
über Dritten durch die gemeinschaftlichen Unterschriften eines Geschäftsführers der Kategorie A sowie eines Ge-
schäftsführers der Kategorie B oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von
Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich
verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

Art. 16. Kommissare. Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,

muss einem oder mehreren Kommissaren anvertraut werden, welche keine Gesellschafter sein müssen.

Die Kommissare werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, von der Gesellschafterver-

sammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie blei-
ben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können
jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesell-
schafterversammlung abberufen werden.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 17. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die

Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Ge-
schäftsführer oder den Geschäftsfuhrungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden.
Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zu-
gang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberu-

fung gemäss luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsfuhrungsrat, oder
subsidiär, durch den Kommissar, oder subsidiär dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, be-
inhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Tele-

gramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

63819

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,

wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsfuhrungsrats liegen, dies erforderlich machen.

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschaf-

terversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Mit Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den

Geschäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsrat vorbehalten sind, ist sie mit den weitest-reichendsten
Befugnissen ausgestattet, um jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung durchzuführen oder zu
genehmigen.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten

ist, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am 31. März um 16:30 Uhr am Gesellschafts-
sitz oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

Art. 20. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages

und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Geset-
zes, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfahigkeit und Mehrheit un-
terliegt, muss von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten
Gesellschaftskapitals vertreten.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages werden alle

übrigen Beschlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht

werden können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschaftsführer unterzeichnet.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen 

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet

am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 22. Bilanz. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder

der Geschäftsfuhrungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesell-

schafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz

einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen
vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 23. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn

abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann
nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jähr-

lichen Reingewinns. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen,
ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen

eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Betrag und
das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.

Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

Art. 24. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der gemäß den-
selben Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die für die Abänderung des vorliegenden Ge-
sellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder

juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegen. Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren
der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an
die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet, und zwar im Verhältnis zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen
Geschäftsanteile.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag

geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.

63820

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei erstellt worden ist, hat diese Partei

folgende Anzahl Geschäftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt: 

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht, der bestätigt, dass die Bestimmungen des

Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung ein-
gehalten worden sind.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr 3.000,- EUR geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung 

Der Alleingesellschafter, der stellvertretend für die Gesellschafterversammlung handelt, hat unverzüglich die folgen-

den Beschlüsse gefasst:

1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf vier (4) festzulegen, und beschließt außer-

dem folgende Personen zu Geschäftsführern der Kategorie A für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestäti-
gung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:

Herrn Robert Ian Kauffman, Finanzier, geboren am 22. Oktober 1963 in New-York (Vereinigte Staaten von Amerika),

wohnhaft in Via della Mercede 39, 00187 Rom (Italien); und

Herrn Jonathan Ashley, Finanzier, geboren am 28. Februar 1966 in New-York (Vereinigte Staaten von Amerika),

wohnhaft in Carlton Hill Road 21, NW8 OJX London (Großbritannien).

Der Alleingesellschafter beschließt außerdem, folgende Person zum Geschäftsführer der Kategorie B für einen Zeit-

raum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene
Geschäftsjahr endet:

Herrn Luc Hansen, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, wohnhaft in 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Herr John Seil, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 28. September 1948 in Luxemburg, wohnhaft in 5, boule-

vard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

2. Der Sitz der Gesellschaft wird sich befinden in:
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg). 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

obengenannten erschienen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst
ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird
der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekann-

ten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet. 

Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 14, case 10. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(066714.3/206/609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

BCM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 32.226. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07427, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 juillet 2005.

(063879.3/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Gesellschafter

Gezeichnetes

Anzahl Einzahlung

Kapital (EUR) Geschäftsanteile

(EUR)

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., vorbenannt  . . . . . . . . . . . . .

20.000,-

800

20.000,-

Summe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,-

800

20.000,-

Luxembourg-Eich, den 18. Juli 2005.

P. Decker.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

63821

DORIAN HELLENIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 32.066. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07429, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 juillet 2005.

(063880.3/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

HUBBLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.643. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 juillet 2005.

(063885.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4783 Pétange, 1, rue Jean Waxweiler.

R. C. Luxembourg B 62.986. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 juillet 2005.

(063886.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

CHAUFFAGE ENTRINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5698 Welfrange, 9, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 31.025. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08579, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(063890.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SAFAG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.526. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2005

Est nommé administrateur, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au

31 décembre 2009:

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Armand Haas, administrateur démissionnaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06364. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063978.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

P. Bettingen
<i>Notaire

P. Bettingen
<i>Notaire

 

Signature.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

63822

CORSPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 98.272. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06463, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(063903.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 33.875. 

Avec effet au 10 juin 2005, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée par voie de
cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter, administrateur démission-
naire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064076.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 90.028. 

Société mère: WPP.

Siège social: London W1J 5RJ, 27, Farm Street, England.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08252, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063938.3/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 90.028. 

Société mère: WPP.

Siège social: Longon W1J 5RJ, 27, Farm Street, England.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08251, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063936.3/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

CORSPI S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Ch. Agata / G. Birchen

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

63823

ENTREPRISE DE TRANSPORTS MICOLINO ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 12.633. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06468, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 21 juillet 2005.

(063904.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FLORINVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 57.223. 

Madame, Monsieur, 
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur de la société ci-dessus ré-

férencée à compter du 2 mai 2005.

La société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD ne sera donc plus administrateur au 2 mai 2005.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08173. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063994.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FLORINVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 57.223. 

Madame, Monsieur, 
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat en qualité d’administrateur et administrateur-

délégué de la société ci-dessus référencée avec effet 2 mai 2005.

La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. ne sera donc plus administrateur et administrateur-délégué au 2 mai

2005. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063997.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DISTRIBUTION ET CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.724. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2005

Mireille Masson est renommée administrateur pour une durée de 6 ans.
Monsieur Werner Langer est renommé administrateur pour une durée de 6 ans.
Monsieur Aniel Gallo est renommé administrateur pour une durée de 6 ans.
Monsieur Aniel Gallo est conforté dans son poste d’administrateur-délégué pour une durée de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064077.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

MICOLINO &amp; FILS, S.à r.l.
Signature

Pour FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD
Signature

Pour FIDUGROUP HOLDING S.A.H.
J. Jumeaux

Pour extrait sincère et conforme
Le bureau:
I. Deschuytter / G. Poncé / S. Livoir
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

63824

MED LEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 69.306. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire annuelle réunie extraordinairement qui s’est tenue à Luxembourg

<i>au siège social le 16 février 2005 à 10.00 heures

Sont présents:
1. La société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.,
société constituée en date du 24 avril 2001 par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.

Immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

sous le matricule n

o

 B 81.795,

représentée aux termes de la présente par M

e

 Alain Lorang, en sa qualité d’administration régulièrement en fonctions.

La société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H. justifie détenir 319 actions, acquises par acte sous seing

privé d’une valeur nominale unitaire de souscription de 100,- EUR chacune, et numérotées 1 à 309.

2. M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Celle-ci justifie détenir 1 action acquise par acte sous seing privé, d’une valeur nominale unitaire de souscription de

100,- EUR chacune, et numérotée 310.

La séance est ouverte à 14.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Sont à ce titre nommés:
1. Aux fonctions de président: M

e

 Alain Lorang, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des

Dahlias;

2. Aux fonctions de secrétaire: Mlle Anissa Ayad, employée privé, demeurant à F-57120 Rombas, 10, rue de la Tour;
3. Aux fonctions de scrutateur: M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411

Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

L’assemblée constate alors qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau;
Que l’intégralité du capital social, est effectivement représenté;
Qu’il a pu être valablement fait abstraction des convocations d’usage, et qu’en conséquence la présente assemblée

peut être irréfragablement considérée comme valablement réunie.

De même que pour assister à la présente assemblée les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales en la

matière.

Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points suivants à

l’ordre du jour, à savoir:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de siège social.
2. Révocation des fonctions d’administrateur de Messieurs:
- Derek Ruxton;
- Patrick Meunier;
- Alexander Ruxton.
3. Nommer en remplacement des administrateurs révoqués:
- M. Jean-Robert Levy;
- la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.;
- M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul;

respectivement aux fonctions d’administrateur-délégué avec conséquemment prérogative de signature individuelle:
- M. Jean-Robert Levy.
4. Révocation du commissaire aux comptes à savoir MRM CONSULTING S.A., société anonyme avec siège social à

Luxembourg;

respectivement la nomination en son remplacement de FIDU-CONCEPT, avec siège social à 9, rue de l’Ordre de la

Couronne de Chêne L-1013 Luxembourg. 

1

er

. point: Changement de siège social.

Il soumet au vote des actionnaires présents et représentés de la décision de changer le siège social, à savoir, le trans-

fert de celui-ci en l’Etude M

e

 Lorang et Wingerter De Santeul, sise 2, rue des Dahlias L-1411 Luxembourg.

Il soumet cette décision au vote des actionnaires réunis:
Après délibération l’assemblée adopte à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

A l’unanimité, l’assemblée générale des actionnaires de MED LEASE S.A. décide du transfert du siège social, 2, rue

des Dahlias L-1411 Luxembourg.

Le président de séance procède alors à la lecture du second point à l’ordre du jour. 
2

e

 point: Révocation des fonctions d’administrateur de Messieurs:

- Derek Ruxton;
- Patrick Meunier;
- Alexander Ruxton.
Le président de séance rappelle aux actionnaires présents, que:
- Derek Ruxton;
- Patrick Meunier;

63825

- Alexander Ruxton.
Ont été nommés aux fonctions d’administrateurs à l’issue de l’acte constitutif de MED LEASE S.A. le 9 avril 1999.
Il soumet au vote des actionnaires présents, la décision de révoquer ceux-ci avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité, les actionnaires présentement réunis décident de révoquer des fonctions d’administrateur, avec effet

immédiat au jour de la présente:

- Alexander Ruxton;
et encore de constater la démission des fonctions d’administrateurs et administrateur-délégué de Messieurs:
- Derek Ruxton;
- Patrick Meunier.
Le président de séance procède alors à la lecture du troisième point à l’ordre du jour. 
3

e

 point: Nomination en remplacement des administrateurs démissionnaires et de l’administrateur-délégué révoqué

de

- M. Jean-Robert Levy;
- la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.;
- M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul;

respectivement aux fonctions d’administrateur-délégué avec conséquemment prérogative de signature individuelle:
- M. Jean-Robert Levy.
Le président de séance propose aux actionnaires présents de nommer en remplacement des administrateurs

révoqués:

- M. Jean-Robert Levy,
Demeurant à Demeurant à 112, boulevard de Courcelles F-75017 Paris,
né le 21 mars 1959 à Alger (Algerie),
de nationalité française,
titulaire du passeport n

o

 03TH587777,

- la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.
Société constituée en date du 24 avril 2001 par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,

immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

sous le matricule n

o

 B 81.795,

représentée aux termes de la présente par M

e

 Alain Lorang, en sa qualité d’administration régulièrement en fonctions.

- M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul,

Avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,
respectivement aux fonctions d’administrateur délégué avec conséquemment prérogative de signature individuelle:
- M. Jean-Robert Levy, prénommé;
Il soumet cette, décision au vote actionnaires présents et représentés.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires de MED LEASE S.A., décident de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires et

de l’administrateur-délégué:

- M. Jean-Robert Levy;
- la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.;
- M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul;

respectivement aux fonctions d’administrateur délégué avec conséquemment prérogative de signature individuelle.
Le président de séance procède alors à la lecture du quatrième point à l’ordre du jour. 
4

e

 point: Révocation du commissaire aux comptes MRM CONSULTING S.A., société anonyme avec siège social à

Luxembourg respectivement nomination en remplacement de FIDU-CONCEPT, avec siège social à 9, rue de l’Ordre
de la Couronne de Chêne L-1013 Luxembourg.

Le président de séance soumet cette décision au vote des actionnaires présents et représentés.

<i>Quatrième résolution

A l’unanimité, l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires constate la révocation du

commissaire aux comptes MRM CONSULTING S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg;

respectivement nomme en remplacement la société FIDU-CONCEPT, avec siège social à 9, rue de l’Ordre de la Cou-

ronne de Chêne L-1013 Luxembourg.

Le président de séance constate alors qu’aucun autre point ne figure à l’ordre du jour, déclare la présente séance

levée à 12.30 heures.

Fait à Luxembourg, le 16 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07671. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Les actionnaires
P. FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H.
A. Lorang / M.-B. Wingerter De Santeul
Le bureau
A. Lorang / A. Ayad / M.-B. Wingerter De Santeul
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

63826

Liste de présence de l’Assemblée générale ordinaire annuelle réunie extraordinairement qui s’est tenue à Luxembourg

au siège social le 16 février 2005 

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066946.3/1268/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

ROMMELS MASCHINN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6960 Senningen, 133, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 92.022. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06470, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningen, le 21 juillet 2005.

(063907.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

TALPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3380 Noertzange, 86, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 55.176. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06471, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Noertzange, le 21 juillet 2005.

(063909.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SIFOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 68.623. 

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 juin 2005

- Est réélu Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant

sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010:

- M. Bruno Marchais, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, domicilié professionnellement au 26, avenue

de Villiers, F-75017 Paris.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03396. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064116.3/1629/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Actionnaires 

Actions Signatures

P. FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H.
M. Alain Lorang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

319

Signature

M

e

 Marie-Béatrice Wingerter De Santeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320

Le bureau
A. Lorang / A. Ayad / M.-B. Wingerter De Santeul
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

ROMMELS MASCHINN, S.à r.l.
Signature

TALPA, S.à r.l.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

63827

VCM GOLDING MEZZANINE SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

H. R. Luxemburg B 102.202. 

Im Jahre zweitausendundfünf, den dreizehnten Juli.
Vor Uns, Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Wurde eine Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der VCM GOLDING MEZZANINE SICAV (die

«Gesellschaft») abgehalten, einer Aktiengesellschaft («société anonyme») mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch nota-
rielle Urkunde vom 9. August 2004 welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 863 vom 24.
August 2004 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Francis Kass, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg,

eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herr Nikolaus Rummler, Bankangestellter, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jean-Marie Schomer, Investmentdirektor, mit Berufsan-

schrift in Luxemburg.

Nach der Bildung des Präsidiums der Versammlung erklärte der Vorsitzende die Versammlung für eröffnet und er-

suchte den Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Die Namen der in der Versammlung persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre, die der Be-

vollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien, die von den Aktionären gehalten werden, gehen
aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Ak-
tionäre und den Mitgliedern des Präsidiums der Außerordentlichen Generalversammlung unterzeichnet wurde. Die vor-
genannte Anwesenheitsliste sowie die rechtsgültig paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben diesem
Protokoll beigefügt und werden gemeinsam mit diesem Protokoll registriert.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass tausendzweiunddreißig (1.032) von den insgesamt tausendzweiund-

fünfzig (1.052) sich im Umlauf befindlichen Aktien anwesend oder vertreten sind.

III. Die gegenwärtige Generalversammlung wurde per Einschreiben vom 4. Juli 2005 an alle Aktionäre einberufen.
IV. Die gegenwärtige Generalversammlung ist demnach ordnungsgemäß gebildet und ist zu nachstehender Tagesord-

nung beschlussfähig:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung des bestehenden vierten Absatzes von Artikel 7 der Satzung und Einführung eines neuen, fünften Absat-

zes:

«Art. 7. Vierter Absatz. Um zu gewährleisten, dass die Aktionäre der Gesellschaft zu jeder Zeit den Anforderun-

gen des Gesetzes von 1991 entsprechen (der Käufer kann nur ein institutioneller Investor im Sinne des genannten Ge-
setzes sein, das heißt, dass insbesondere natürliche Personen ausgeschlossen sind), dass die Aktien der Gesellschaft von
nicht mehr als 30 institutionellen Investoren gehalten werden und dass der Käufer voll und ganz die restlichen Verpflich-
tungen gegenüber die Gesellschaft übernimmt, benötigen Übertragungen von Aktien der vorherigen Zustimmung des
Verwaltungsrates. Ausgenommen von der Zustimmung des Verwaltungsrates sind Übertragungen von Aktien, die im
gebundenen Vermögen eines Versicherungsunternehmens gehalten werden, sofern die Übertragung dieser Aktien an
institutionelle Investoren im Sinne des Gesetzes von 1991 erfolgt und die Zahl der Aktionäre insgesamt 30 nicht über-
steigt.»

«Art. 7. Fünfter Absatz. Werden Namensaktien an der Gesellschaft im gebundenen Vermögen eines deutschen

Versicherungsunternehmens geführt, darf das betreffende Versicherungsunternehmen über diese Namensaktien nur bei
vorheriger schriftlicher Zustimmung des gemäß § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes («VAG») bestellten
Treuhänders für das Sicherungsvermögen oder seines Stellvertreters verfügen, andernfalls gemäß § 110 VAG nur mit
Zustimmung der zuständigen deutschen Aufsichtsbehörde.»

2. Verschiedenes.
Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 7 der Gesellschaftssatzung wie folgt zu ändern:
Änderung des bestehenden vierten Absatzes:
«Um zu gewährleisten, dass die Aktionäre der Gesellschaft zu jeder Zeit den Anforderungen des Gesetzes von 1991

entsprechen (der Käufer kann nur ein institutioneller Investor im Sinne des genannten Gesetzes sein, das heißt, dass
insbesondere natürliche Personen ausgeschlossen sind), dass die Aktien der Gesellschaft von nicht mehr als 30 institu-
tionellen Investoren gehalten werden und dass der Käufer voll und ganz die restlichen Verpflichtungen gegenüber der
Gesellschaft übernimmt, benötigen Übertragungen von Aktien der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates. Aus-
genommen von der Zustimmung des Verwaltungsrates sind Übertragungen von Aktien, die im gebundenen Vermögen
eines Versicherungsunternehmens gehalten werden, sofern die Übertragung dieser Aktien an institutionelle Investoren
im Sinne des Gesetzes von 1991 erfolgt und die Zahl der Aktionäre insgesamt 30 nicht übersteigt.»

Einfügung eines neuen fünften Absatzes:
«Werden Namensaktien an der Gesellschaft im gebundenen Vermögen eines deutschen Versicherungsunternehmens

geführt, darf das betreffende Versicherungsunternehmen über diese Namensaktien nur bei vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des gemäß § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes («VAG») bestellten Treuhänders für das Siche-
rungsvermögen oder seines Stellvertreters verfügen, andernfalls gemäß § 110 VAG nur mit Zustimmung der zuständigen
deutschen Aufsichtsbehörde.»

63828

Nachdem zum Tagesordnungspunkt «2. Verschiedenes» keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der

Vorsitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.

Worüber Urkunde, aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen so-

wie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Präsidiums der Außerordentlichen Generalversammlung mit
Uns, dem Notar, die vorliegende Original-Urkunde unterzeichnet. Kein Aktionär wünschte diese Original-Urkunde zu
unterzeichnen.

Gezeichnet: F. Kass, N. Rummler, J.M. Schomer, J.-J. Wagner.
Enregistriert zu Luxemburg, am 19. Juli 2005, Band 895, Blatt 56, Feld 6. – Erhalten 12 Euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066989.2/239/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

VCM GOLDING MEZZANINE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 102.202. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066990.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 4.573. 

Avec effet au 10 juin 2005, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée par voie de
cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter, administrateur démission-
naire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06219. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064165.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FLORINVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.223. 

CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LIMITED renonce à son mandat d’administrateur de la société

ci-dessus référencée avec effet 2 mai 2005.

La société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LIMITED ne sera donc plus administrateur à compter

du 2 mai 2005.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063999.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Beles, den 25. Juli 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Ch. Agata / G. Birchen

<i>Pour la société
Signature

63829

IBERIAN FOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 16, Grand Rue.

R. C. Luxembourg B 109.605. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-first day of July.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

APAX WW NOMINEES LTD, a limited liability company, organized under the laws of England and Wales, having its

registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the Companies House under the number
04693597, 

hereby represented by Mr. Stéphane Hadet, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law
dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of
association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying
to one member company.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination IBERIAN FOODS S.à r.l.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares 
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500

(five hundred) shares («parts sociales») of 25.- Euro (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

63830

6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management 
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or a class B manager. The number of class A managers and the number of class B managers shall
be equal at all times.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a class A manager and a class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers, and if the number of class A managers present or represented and the
number of class B managers present or represented is equal.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A and class

B managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

63831

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an an-

nual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of
the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the
month of May, at 2.45 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held
on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be sharehold-
er. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of
auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts 
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2005.

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction

of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share

capital as follows:  

All the shares have been paid-up to the extent or one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand and four hundred Euro (EUR 1,400.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by one Class A manager:
- Mrs. Martine Gerber, attorney at law, born in Saint-Dié (France) on 19 July 1965, residing at 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg;

and by one Class B manager:
- Mr. Stephane Hadet, attorney at law, born in Nancy (France), on 25 May 1968, residing at, 20, avenue Monterey L-

2163 Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

Subscriber

Number of

shares

Subscribeda-

mount(in Eu-

ro)

% of share-

capital

 Paid-up

capital

 APAX WW NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

 12,500,-

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500,-

100%

100%

63832

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

APAX WW NOMINEES LTD., une limited liability company, constituée sous les lois d’Angleterre, ayant son siège

social au 15, Portland Place, Londres W1B 1PT, Royaume Uni enregistrée au Companies House sous le numéro
04693597.

ici représentée par Monsieur Stéphane Hadet, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2,
6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que
le transfert par vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres
de quelque forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La
société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: IBERIAN FOODS S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales 
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

63833

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management 
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de classe A ou de classe

B. Le nombre de gérant(s) de classe A devra à tout moment être égal à celui du/des gérant(s) de classe B.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du respect des ter-
mes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de la classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance, et si le nombre des gérants de classe A présents ou représentés est égal
au nombre des gérants de classe B présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la double majorité des voix exprimées par

les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents séparés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

63834

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une

assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou
à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée, le 15 du mois de mai, à 14.45
heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances
exceptionnelles le requièrent

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la So-

ciété sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne
requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en col-
lège et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels 
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits

civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)

s’en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire le capital comme suit:  

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Résolution de l’associé unique

1. La Société est administrée par un gérant de catégorie A à savoir:
- Madame Martine Gerber, avocat, née Saint-Dié (France) le 19 juillet 1965, demeurant au 20, avenue Monterey, L-

2163 Luxembourg;

et un gérant de catégorie B, à savoir:
- Monsieur Stéphane Hadet, avocat, né à Nancy (France) le 25 mai 1968, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

Souscripteur

Nombre de

parts sociales

Montant-

souscrit(en

euro)

% de capital-

social

Capitalli-

béré

APAX WW NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 12.500.-

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500.-

100%

100%

63835

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête de ladite comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: S. Hadet, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, vol. 149S, fol. 33, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067061.3/202/388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

FOYER RE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.621. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 16 février 2005

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 16 février 2005 que le Conseil a pris la réso-

lution suivante concernant la nomination d’un dirigeant agréé:

Art. 7. Nomination d’un dirigeant agréé. Monsieur Marx informe le Conseil de sa décision de se retirer de la

gestion journalière de la Société.

Sous réserve de l’approbation ministérielle requise, il recommande au Conseil de nommer Monsieur Marc Lauer nou-

veau dirigeant agréé.

Le Conseil se rallie à l’unanimité à cette proposition et décide que M. Lauer assumera la fonction de dirigeant agréé,

en lieu et place de H. Marx, à compter de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 mars 2005,
sinon à compter de la date de l’approbation ministérielle, si celle-ci est postérieure à la date de la prédite Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07568. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064057.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

STROUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 46.693. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG06975, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064031.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

STROUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 46.693. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG06973, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064030.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Senningerberg, le 27 juillet 2005.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme 
<i>FOYER RE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A.
F. Hélias / A. Birget
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

63836

COMPAGNIE DE CONSEILS ET DE SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 88.637. 

<i>Réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1

<i>er

<i> décembre 2004

L’an deux mille quatre, le 1

er

 du mois de décembre.

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Jean-François Remy de son poste d’administrateur-

délégué.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Jean-François Remy, administrateur de société, demeurant professionnel-

lement à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume, en tant qu’administrateur. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer Monsieur Michel Vandevijver au poste d’administrateur-délégué.

<i>Cinquième résolution

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s’est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06257. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064267.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

TRIDEX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.871. 

Avec effet au 10 juin 2005, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée par voie de
cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter, administrateur démission-
naire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064166.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PARC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4605 Differdange, 23, rue Adolphe Krieps.

R. C. Luxembourg B 46.677. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06475, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 21 juillet 2005.

(063917.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature / Signature / Signature 
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Ch. Agata / G. Birchen

PARC-IMMO, S.à r.l.
Signature

63837

CST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 94.707. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juin 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de un an.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Marino Di Pietro, administrateur A, domicilié au 37, Via Marinada, Montagnola, Suisse;
- Filippo Merlo, administrateur A, domicilié au 42/A, Via Motta, Lugano, Suisse;
- Luca Jermini, administrateur A, domicilié à Via Roncaccio, Ponte Capriasca, Suisse;
- Jean Hoffmann, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg;
- Marc Koeune, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg;
- Nicole Thommes, administrateur B, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg;
- Andrea Dany, administrateur B, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064963.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

LUXOR CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

R. C. Luxembourg B 71.329. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en

date du 30 juin 2005 que:

1. L’Assemblée a décidé de renouveler aux fonctions d’administrateur: Monsieur Edgar Bisenius, Monsieur Dieter

Kundler et Monsieur Jean-Paul Balsamo.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2010.

2. L’Assemblée a décidé de renouveler aux fonctions d’administrateur-délégué: Monsieur Jean-Paul Balsamo.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels au 31 dé-

cembre 2010.

3. L’Assemblée a décidé de renouveler aux fonctions de commissaire aux comptes la société CD-SERVICES, S.à r.l.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels au 31 dé-

cembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG06992. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064856.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

PIED-PLUME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 11, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 98.779. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06480, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Petange, le 21 juillet 2005.

(063921.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

PIED-PLUME, S.à r.l.
Signature

63838

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) M&amp;H LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 108.932. 

In the year two thousand five, on the fourteenth day in the month of July. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA), L.P., a Delaware limited partnership with its principal place of business at Cor-

poration Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.;

(the «Shareholder»),
hereby represented by Maître Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13 July

2005.

Said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

the société à responsabilité limitée J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) M&amp;H LUXEMBOURG, S.à r.l., a company gov-
erned by the laws of Luxembourg, with registered office at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary of 13 May 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial and entered in the Trade and Companies Register of Luxembourg, Section B, under the number
108.932. The articles of incorporation have not been amended since this date.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda.

<i>Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of seventy-six thousand fifty Pounds Sterling (GBP 76,050.-) so as

to raise it from its present amount of eight thousand nine hundred fifty Pounds Sterling (GBP 8,950.-) to eighty-five thou-
sand Pounds Sterling (GBP 85,000.-).

2) To issue three thousand forty-two (3,042) new shares with a nominal value of twenty-five Pounds Sterling (GBP

25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of
the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3) To accept subscription for these new shares, without payment of a share premium, by J.P. MORGAN PARTNERS

(BHCA) L.P. and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.

4) To amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions: 

<i>First resolution

The Shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of seventy-six thousand

fifty Pounds Sterling (GBP 76,050.-) so as to raise it from its present amount of eight thousand nine hundred fifty Pounds
Sterling (GBP 8,950.-) to eighty-five thousand Pounds Sterling (GBP 85,000.-). 

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to issue three thousand forty-two (3,042) new shares with a nominal value of twenty-five

Pounds Sterling (GBP 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to divi-
dends as from the day of these resolutions.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared Maître Nicolas Gauzès, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact

of J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) L.P., prenamed by virtue of the pre-mentioned proxy (the «Subscriber»).

The Subscriber declares to subscribe for three thousand forty-two (3,042) new shares having each a nominal value

of twenty-five Pounds Sterling (GBP 25.-), without payment of any share premium, and to make payment for such new
shares by a contribution in kind consisting of «PIK notes» constituted by an instrument dated 30 April 2004 (as amended
and restated) by MAYNARD &amp; HARRIS PLASTICS (UK) LIMITED, a company incorporated under the laws of England
and Wales and having its registered office at London Road, Beccles, Suffolk NR34 8TS in a principal amount of seventy-
six thousand fifty Pounds Sterling (GBP 76,050.-) (the «PIK Notes»), without however any right to the interests accrued
on the PIK Notes to date (the «Contribution»). 

The Subscriber further stated that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that

there subsist no impediments to the free transferability of such consideration to the Company.

The Subscriber stated that the total value of the Contribution of seventy-six thousand fifty Pounds Sterling (GBP

76,050.-) has been certified by a group internal special report issued on 14 July 2005, which special report signed ne
varietur by the proxy holder and the notary will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Subscriber states together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid trans-

fer to the Company of the Contribution.

Thereupon, the Shareholder resolves to accept the said subscription and payment and to allot the three thousand

forty-two (3,042) new shares to the Subscriber.

63839

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of

incorporation, which will from now on read as follows:

«Art. 5. Subscribed capital. First paragraph. The subscribed capital of the Company is set at eighty-five thou-

sand Pounds Sterling (GBP 85,000.-) divided into three thousand four hundred (3.400) shares, with a nominal value of
twenty-five Pounds Sterling (GBP 25.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-

crease are estimated at thousand eight hundred fifty Euro.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) L.P., un Limited Partnership constitué selon le droit du Delaware, ayant son siège

social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A. (l’«As-
socié»),

représentée aux fins des présentes par Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une

procuration donnée le 13 juillet 2005.

La prédite procuration restera annexée aux présentes. 
L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de la société à respon-

sabilité limitée J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) M&amp;H LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée
suivant acte du notaire soussigné le 13 mai 2005, non encore publié, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 108.932. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis cette date.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de soixante-seize mille cinquante livres sterling (GBP

76.050,-) pour le porter de son montant actuel de huit mille neuf cent cinquante livres sterling (GBP 8.950,-) à quatre-
vingt- cinq mille livres sterling (GBP 85.000,-).

2) Emission de trois mille quarante-deux (3.042) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq livres

sterling (GBP 25,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bé-
néfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée. 

3) Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, sans paiement d’une prime d’émission, par J.P. MOR-

GAN PARTNERS (BHCA) L.P. et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par apport en
nature.

4) Modification de l’article 5, alinéa premier, des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus.
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Associé décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de soixante-seize mille cinquante livres

sterling (GBP 76.050,-) pour le porter de son montant actuel de huit mille neuf cent cinquante livres sterling (GBP
8.950,-) à quatre-vingt-cinq mille livres sterling (GBP 85.000,-).

<i>Deuxième résolution

L’Associé décide d’émettre trois mille quarante-deux (3.042) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-

cinq livres sterling (GBP 25,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant
aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, Maître Nicolas Gauzès précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de J.P.

MORGAN PARTNERS (BHCA) L.P., précitée, en vertu de la procuration prémentionnée (le «Souscripteur»).

Le Souscripteur déclare souscrire trois mille quarante-deux (3.042) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de

vingt-cinq livres sterling (GBP 25,-) chacune, sans paiement d’une prime d’émission et de libérer intégralement ces parts
sociales nouvelles par un apport en nature consistant en PIK notes créées par un instrument en date du 30 avril 2004
(tel que modifié) par MAYNARD &amp; HARRIS PLASTICS (UK) LIMITED une société constituée selon le droit anglais et
ayant son siège social à London Road, Beccles, Suffolk NR34 8TS d’un montant principal de soixante-seize mille cinquan-

63840

te livres sterling (GBP 76.050,-) (les «PIK Notes»), sans toutefois aucun droit sur les intérêts accrus sur les PIK Notes
à ce jour (les «Apports»).

Le Souscripteur déclare encore que les Apports sont libres de tout privilège ou gage et qu’il ne subsiste aucune res-

triction à la cessibilité des Apports.

Le Souscripteur déclare que la valeur totale de l’Apport de soixante-seize mille cinquante livres sterling (GBP 76.050)

a été établi par un rapport interne du groupe émis le 14 juillet 2005, lequel rapport signé ne varietur par le comparant
et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour être enregistré avec elles.

Le Souscripteur déclare avec la Société qu’ils accompliront toutes les formalités concernant le transfert effectif à la

Société de l’Apport.

Ensuite, l’Associé décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’allouer les trois mille quarante-deux

(3.042) parts sociales nouvelles au Souscripteur.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé décide de modifier l’article 5, alinéa premier, des statuts

qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille livres sterling (GBP 85.000)

représenté par trois mille quatre cents (3.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (GBP
25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille huit cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzès, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2005, vol. 895, fol. 56, case 10. – Reçu 1.107,31 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067001.3/239/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) M&amp;H LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 108.932. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067003.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

POTYKA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 32, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 85.392. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06478, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 21 juillet 2005.

(063925.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

POTYKA, GmbH
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Tref Investments S.A.

Tref Investments S.A.

Texfina S.A.

International Wear Parts S.A.

International Wear Parts S.A.

Ad Hoc Consulting S.A.

Ad Hoc Consulting S.A.

Euro Port S.A.

Direct-Locations / Agence Royal Business

Direct-Locations / Agence Royal Business

Immobilière Drai Eechelen, S.à r.l.

Immobilière Drai Eechelen, S.à r.l.

Immobilière Drai Eechelen, S.à r.l.

Immobilière Drai Eechelen, S.à r.l.

Vital Center International S.A.

Vital Center International S.A.

Belfry Limited Partner, S.à r.l.

Civalux S.A.

AMF International Holding S.A.

Kertes S.A.

Grand Bazar Schirtz, S.à r.l.

Locations Privées / Agence Aldringen, S.à r.l.

Locations Privées / Agence Aldringen, S.à r.l.

S.C.I. Drai Eechelen

S.C.I. Drai Eechelen

S.C.I. Drai Eechelen

S.C.I. Drai Eechelen

Colony Sardegna, S.à r.l.

Colony Sardegna, S.à r.l.

Thanatos Participations S.A.

Demo Solutions S.A.

MP Business S.A.

Sieg Holding S.A.

Sieg Holding S.A.

Atlantis, S.à r.l.

Chinese King, S.à r.l.

Golden Entertainment Productions Holding S.A.

Golden Entertainment Productions Holding S.A.

Integrated Network Solutions (Luxembourg) S.A.

Belfry Managing Partner, S.à r.l.

BCM Holding S.A.

Dorian Hellenic Holdings S.A.

Hubble Holding S.A.

Space S.A.

Chauffage Entringer, S.à r.l.

Safag

Corspi S.A.

Grandex Promotion S.A.

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Entreprise de Transports Micolino et Fils, S.à r.l.

Florinvest Holding S.A.H.

Florinvest Holding S.A.H.

Distribution et Consulting S.A.

Med Lease S.A.

Rommels Maschinn, S.à r.l.

Talpa, S.à r.l.

Sifolux S.A.

VCM Golding Mezzanine SICAV

VCM Golding Mezzanine SICAV

Nylof S.A.

Florinvest Holding S.A.H.

Iberian Foods, S.à r.l.

FOYER RE, Compagnie Luxembourgeoise de Réassurance S.A.

Stroud S.A.

Stroud S.A.

Compagnie de Conseils et de Services S.A.

Tridex A.G.

Parc-Immo, S.à r.l.

CST Investment Holding S.A.

Luxor Consulting S.A.

Pied-Plume, S.à r.l.

J.P. Morgan Partners (BHCA) M&amp;H Luxembourg, S.à r.l.

J.P. Morgan Partners (BHCA) M&amp;H Luxembourg, S.à r.l.

Potyka, GmbH