logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

63457

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1323

3 décembre 2005

S O M M A I R E

Agharti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63489

Henderson   Indirect   Property   Fund   (Europe) 

Agharti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63490

Management, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . . . 

63461

Alba Master Holding Company S.A., Luxembourg.

63498

Hifitel S.A., Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63469

Alimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63493

Holcim Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg

63458

All-Sport International Holding S.A., Luxembourg

63501

J. Hirsch & Co International, S.à r.l., Luxembourg 

63491

Alu-Fer, S.à r.l., Noerdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63471

Jafer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63502

Anin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63472

Janek Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

63501

Atlas Telecom Interactive S.A., Luxembourg. . . . .

63494

Jofad Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

63498

Barclays Investment Funds (Luxembourg), Sicav, 

Leco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63504

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63500

Lion Capital Markets S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

63498

Bay-Rum Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .

63499

Lux-Lorraine Invest Holding S.A., Luxembourg . . 

63491

Bergasa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63503

Marfinco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63494

C.A.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63493

NLG Acquisition Holdings S.C.A., Luxembourg . . 

63475

Caspan Equity S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

63472

Odyssey Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63468

Clarins Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

63492

Parabole S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

63503

COFINORD,   Compagnie   Financière   du   Nord

Plastichem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

63500

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63499

Provincial Capital Securities S.A., Luxembourg . . 

63472

Cogenaf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63499

Provincial Capital Securities S.A., Luxembourg . . 

63473

Ecomin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63502

Provincial Capital Securities S.A., Luxembourg . . 

63473

FBL,  Fortis  Banque  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Provincial Capital Securities S.A., Luxembourg . . 

63473

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63470

Provincial Capital Securities S.A., Luxembourg . . 

63473

FBL,  Fortis  Banque  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Provincial Capital Securities S.A., Luxembourg . . 

63474

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63471

Provincial Capital Securities S.A., Luxembourg . . 

63474

Financière de la Vallée S.A., Luxembourg. . . . . . . .

63493

Provincial Capital Securities S.A., Luxembourg . . 

63474

Financière Epeios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63495

Reality S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63504

Financière Galates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63495

RXP Service S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

63503

Financière Osinius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63497

S.C.P.,  Security  Consulting  Professionnals  S.A., 

Financière Themisto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

63491

Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63492

Financière Thero S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63496

Sailux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63472

Financière Zelos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63496

Sainternational S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63472

Finbourg Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63495

(Les) Sens du Vin, S.à r.l., Redange-sur-Attert  . . . 

63469

Finluxinfo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

63474

Spring Financial Investment S.A., Luxembourg  . . 

63504

Finsai International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

63472

(The)  UBK  French  Property  Company  (No  2), 

Fontanina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63502

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63471

Frazil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63501

Univest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63458

Gem-World, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

63502

Urbaninvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

63498

Gotam Umbrella Fund (Lux) Advisory Company 

Vive les Mariés, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . 

63469

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63458

White Eagle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

63497

63458

GOTAM UMBRELLA FUND (LUX) ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding,

(anc. GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) MANAGEMENT COMPANY).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.460. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(062566.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

UNIVEST, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de UNIVEST du 21 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf.

LSO-BK06263, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2005.

The management regulations of UNIVEST, registered in Luxembourg on 23 November 2005, ref. LSO-BK06263,

were deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg on 24 November 2005.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 22nd November 2005.

(102068.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 92.528. 

In the year two thousand and five, on the seventeenth of November.
Before us the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company («société anonyme»), HOLCIM

FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxem-
bourg section B number 92.528, incorporated by deed of the undersigned notary on the 27th of March 2003, published
in the Mémorial C number 431 on the 19th of April 2003, and its articles have been modified by deeds of the undersigned
notary:

- on the 16th of June 2003, published in the Mémorial C number 780 of the 24th of July 2003;
- on the 25th of March 2005, published in the Mémorial C number 298 of the 5th of April 2005.
The meeting is presided by Mr Thierry Grosjean, maître en droit privé, professionally residing at L-1931 Luxembourg,

25, avenue de la Liberté.

The chairman appoints as secretary Miss Cindy Gabriele, maître en droit, professionally residing at L-1931 Luxem-

bourg, 25, avenue de la Liberté.

The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, professionally residing at L-1931 Lux-

embourg, 25, avenue de la Liberté.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Modification of article 4 of the Articles of Association which have the following content:
«The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or

abroad.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indi-

rectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.»

2. Miscellaneous.

J. Elvinger
<i>Notaire

NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature

63459

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides to modify article 4 of the Articles of Association which will have the following content:
«Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or

abroad.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indi-

rectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at eight hundred and fifty euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed. 

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille cinq, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLCIM FINANCE

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 92.528, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mars 2003, publié au Mémorial
C numéro 431 du 19 avril 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 16 juin 2003, publié au Mémorial C numéro 780 du 24 juillet 2003;
- en date du 25 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 298 du 5 avril 2005.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Cindy Gabriele, maître en droit, demeurant professionnelle-

ment à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-

nellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que se soit, dans toutes sociétés luxembour-

geoises et étrangères, ou dans d’autres sociétés financières, ainsi que l’acquisition par achat, souscription, ou de toute
autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange, ou autrement de titres de toutes sortes, d’emprunts,
d’obligations, de valeurs et autres portefeuilles titres de tous genres, ainsi que la propriété, l’administration, le dévelop-
pement et la gestion de ses portefeuilles.

63460

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés et gérer ses activités au travers de succur-

sales à Luxembourg ou à l’étranger.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que se soit et procéder à l’émission d’emprunts et d’obligations.
De façon générale pouvoir accorder assistance (par voie de prêt, avances, garanties, titres ou autres) aux sociétés ou

autres entreprises dans lesquelles la Société détient un intérêt ou dans les filiales de groupe de sociétés dans lesquelles
la Société a des participations, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’el-
le jugera nécessaire à la réalisation et à la mise en valeur dé ses objectifs.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, techniques, financières ou autres, rattachées directe-

ment ou indirectement à tous secteurs d’activités afin de faciliter la réalisation de son objet.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

2. Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que se soit, dans toutes sociétés

luxembourgeoises et étrangères, ou dans d’autres sociétés financières, ainsi que l’acquisition par achat, souscription, ou
de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange, ou autrement de titres de toutes sortes, d’em-
prunts, d’obligations, de valeurs et autres portefeuilles titres de tous genres, ainsi que la propriété, l’administration, le
développement et la gestion de ses portefeuilles.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés et gérer ses activités au travers de succur-

sales à Luxembourg ou à l’étranger.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que se soit et procéder à l’émission d’emprunts et d’obligations.
De façon générale pouvoir accorder assistance (par voie de prêt, avances, garanties, titres ou autres) aux sociétés ou

autres entreprises dans lesquelles la Société détient un intérêt ou dans les filiales de groupe de sociétés dans lesquelles
la Société a des participations, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’el-
le jugera nécessaire à la réalisation et à la mise en valeur de ses objectifs.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, techniques, financières ou autres, rattachées directe-

ment ou indirectement à tous secteurs d’activités afin de faciliter la réalisation de son objet.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Th. Grosjean, C. Gabriele, J.-H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 2005, vol. 534, fol. 61, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102127.3/231/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Junglinster, le 23 novembre 2005.

J. Seckler.

63461

HENDERSON INDIRECT PROPERTY FUND (EUROPE) MANAGEMENT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 111.966. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventeenth day of November.
Before us Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

HENDERSON GLOBAL INVESTORS (INTERNATIONAL HOLDINGS) BV, having its registered office in J.W.

Brouwersstraat 12, 1071 LJ Amsterdam, The Netherlands, 

here represented by Mr Olivier Lambertyn, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given on 14 November 2005, 
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its above-mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

articles of incorporation of a societé à responsabilité limitee, which is herewith established as follows: 

Art. 1. Form. There is established by the appearing party of a société à responsabilité limitée, (the «Company»)

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial compa-
nies, as amended (the «1915 Law») and by the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment as
amended and by these articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is to be composed of a single shareholder and thus the owner of the entire issued share capital of the

Company. The Company may however at any time be composed of several shareholders, as a result of the transfer of
shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of HENDERSON INDIRECT PROPERTY FUND (EUROPE)

MANAGEMENT, S.à.r.l.

Art. 3. Form. The sole purpose of the Company is the creation, administration and management of HENDERSON

INDIRECT PROPERTY FUND (EUROPE) a mutual investment fund (Fonds Commun de Placement) organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Fund»).

The Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promotion of the

Fund. It may, on behalf of the Fund, enter into any contract, purchase, sell, exchange and deliver any securities, property
and more generally assets constitutive of authorised investments of the Fund proceed to or initiate any registrations
and transfers in its name or in third parties name in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign
companies and exercise on behalf of the Fund and holders of units of the Fund, all rights and privileges, especially all
voting rights attached to the securities constituting the assets of the Fund. The foregoing powers shall not be considered
as exhaustive, but only as declaratory.

The Company may also manage its own assets on an ancillary basis, carry out any activities deemed useful for the

accomplishment of its object remaining however within the limitations set forth by the Fund’s constitutional documents
and the applicable Luxembourg laws and regulations.

The Company shall be subject to Chapter 14 of the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective

investment.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered Office. The registered Office is established in Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within Schuttrange by decision of the board of managers.
The Company may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

 Art. 6. Capital. The corporate capital of the Company is set at hundred twenty-five thousand euros (EUR 125.000)

represented by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one thousand euros (EUR 1.000,-) each.

Art. 7. Variation of the corporate capital. The corporate capital may at any time be increased, respectively,

decreased by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders de-
ciding in the form foreseen for amendment of the articles of incoporation, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a single shareholder the latter shall exercise all powers which are granted by the 1915

Law and the Articles of incorporation to the general meeting of shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the decisions of the single share-

holder or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered

63462

by court; they must for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single
shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact whether appointed

amongst them or not. 

Art. 10. Transfer of shares. When the Company is composed of a single shareholder, that single shareholder may

transfer freely its shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst the existing

shareholders.

When the Company is composed of several shareholders, the shares can be transferred by living persons to non-

shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least 75 per cent of the
capital of the Company.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Unless duly notified to the Company or accepted by the Company in pursuance of article 1690 of the Civil Code, any

such transferred is not binding upon the Company and upon third parties.

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of

the 1915 Law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar

event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation. 

Art. 14. Board of managers. The Company is managed and administrated by a board of managers consisting of at

least three (3) managers, whether shareholders or not.

Each manager is appointed for a limited or an unlimited duration by the single shareholder or by the general meeting

of shareholders.

Any manager may be removed at any time by the single shareholder or the general meeting of shareholders by an

affirmative vote representing at least 75 per cent of the corporate capital of the Company. Any manager may resign at
any time.

The single shareholder or the general meeting of shareholders decides upon the compensation of each manager (if

any).

The board of managers shall appoint from among its members a chairman of the board of managers. The board of

managers shall choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of managers.

The board of managers may also appoint officers of the Company which it considers necessary for the operation and

management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of managers. Officers
need not be managers nor shareholders of the Company. The officers appointed shall have the powers and duties en-
trusted to them by the board of managers.

Art. 15. Meetings of the board of managers. The board of managers shall meet at the place indicated in the

notice of the meeting.

Written notes of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 hours in advance of

the time set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. The notice may be waived by the consent in writing, by cable, telegram, telex
or telefax of each manager.

Any manager may act at any meeting of the board of the managers by appointing in writing, by cable, telegram, telex

or telefax another manager as his proxy. Managers may also cast their vote in writing, by cable, telegram, telex or telefax.
Meetings of the board of managers may be held by way of conference call, video conference or any similar means of
communication, in which case the managers participating by such means shall be deemed to be present in Luxembourg.

The board of managers shall deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present
or represented at such meeting. The chairman of the board of managers shall have a casting vote.

Resolutions may also be passed in the form of a consent resolution which is signed on one or more counterparts by

all the managers. 

Art. 16. Powers of representation. In dealing with third parties, any manager shall have most extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent
with the Company’s purpose. The Company is bound in any circumstances by the single signature of any manager.

Art. 17. Board of Managers’ Committees. The board of managers may, by a majority vote of the whole board,

set up one or more committees to deal with specific matters under its supervision and responsibility, each committee
to consist of one or more managers of the Company. The board of managers may designate one or more managers as
alternate members of any committee who may replace any absent or disqualified member at a meeting of such commit-
tees. 

Art. 18. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a manager. The death, incapacity, bankruptcy, insol-

vency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put
the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

63463

Art. 19. Liability of a manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation

in relation to the commitments taken on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or

is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending completed action, suit or
proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or was
a manager or officer of the Company or a subsidiary or (2) is or was serving at the request of the Company or a sub-
sidiary of the Company as a manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership,
joint venture, trust, committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the board of managers, the Company may indemnify, to the fullest extent per-

mitted by applicable law, any person who was a party or is threatened to be made a party, or is involved in any manner
in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investiga-
tive) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a manager or officer) of the Com-
pany or a subsidiary.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a man-

ager, officer, employee or agent of the Company or a subsidiary, or is or was serving at the request of the Company or
a subsidiary as a manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, join ven-
ture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by
him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have
the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal, modification or amendment of, or adoption of any provision inconsistent with, this article 19, nor to the

fullest extent permitted by applicable law, any modification of law shall adversely affect any right or protection of any
person granted pursuant hereto existing at, or with respect to events that occurred prior to, the time of such repeal,
amendment, adoption or modification.

The right to indemnification conferred in this article 19 also includes, to the fullest extent permitted by applicable

law, the right to be paid the expenses (including attorney’s fees) incurred in connection with any such proceeding in
advance of its final disposition. The payment of any amounts to any manager, officer, partner, member, employee or
agent pursuant to this article 19 shall subrogate the Company to any right such manager, officer, partner, member, em-
ployee or agent may have against any other person or entity. The right conferred in this article 19 shall be contract
rights. 

Art. 20. General meeting of shareholders. When the Company is composed of one single shareholder, the lat-

ter exercises the power granted by the 1915 Law to the general meeting of shareholders.

Art. 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
When the company is composed of less than 25 shareholders, the decisions of the shareholders may be taken in a

general meeting or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted under the terms and conditions as
foreseen in the 1915 Law.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of

the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

When the Company is composed of several shareholders, unless otherwise specified in these articles, decisions of

the shareholders are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the
corporate capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be
taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s corporate capital. 

Art. 21. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the shareholders or of the general meeting of

shareholders are documented in writing, recorded in a register and kept at the registered office of the Company.

The votes of the shareholders and the power of attorneys are attached to the decision or minutes.

Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December

of that year.

Art. 23. Independent auditor. The single shareholder or general meeting of shareholders shall appoint an inde-

pendent auditor (réviseur d’enterprises agréé) who shall fulfil the duties prescribed by applicable laws. 

Art. 24. Balance-sheet. Each year, on 31 December, the accounts are closed, the board of managers draws up an

inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the 1915 Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may consult the financial documents at the registered office of the Company

within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of shareholders. 

Art. 25. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-

tion and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.

The remaining net profit is allocated by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general

meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 26. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the single shareholder
or by the general meeting of shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liqui-
dator(s).

63464

Art. 27. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance

with applicable laws.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter: 

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who stated conditions provided for in article 183

of the 1915 Law have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately three thousand seven hundred and fifty euros (EUR 3,750.00).

<i>Transitory Provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2005.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing party in its capacity as sole Shareholder of the Company has passed the following resolutions:
1. Resolved to set the number of managers at three (3) and further resolved to elect the following in their respective

capacity as manager of the Company for an unlimited period of time:

- Mr Rodney Alexander Bysh, Director, having his domicile at 61440, Oberursel, Römerstraße 8, Germany; 
- Mr Michael Sales (HENDERSON UK), Director, having his domicile at 42, Beacon Way, Rickmansworth, Herts,

England WD3 7PE;

- Mr Jeremy Vickerstaff, Director, having his domicile at 52, Rue du Chateau, Berg, L-6922 Luxembourg.
2. The registered office shall be at 64 rue Principale, Schuttrange, L-5367 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
3. ERNST &amp; YOUNG S.A., a company having its registered office at 6, Rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg, is

appointed as independent auditor of the Company. The term of office of the Independent auditor shall end at the date
of approval of the accounts of the year 2006.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with

Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

HENDERSON GLOBAL INVESTORS (INTERNATIONAL HOLDINGS) BV, ayant son siège social à J.W. Brouwers-

straat 12, 1071 LJ Amsterdam, Pays-Bas, 

ici représentée par Monsieur Olivier Lambertyn, juriste, demeurant a Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée le 14 novembre 2005, 
laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Le comparant, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d´une société à responsabilité limitée qui est constituée comme suit: 

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la légis-

lation luxembourgeoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (la «Loi de 1915»), et par la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placements collectifs, tel que modifiée,
ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comportera initialement un associé unique qui sera par conséquent propriétaire de l’intégralité du capital

social de la Société. La Société peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés suite à, notamment, la
cession d’actions ou l’émission de nouvelles actions. 

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de HENDERSON INDIRECT PROPERTY FUND

(EUROPE) MANAGEMENT, S.à.r.l. 

Art. 3. Objet. L’objet unique de la Société est la constitution, l´administration et la gestion de HENDERSON

INDIRECT PROPERTY FUND (EUROPE), un Fonds Commun de Placement soumis aux lois du Grand-Duché de
Luxembourg (le «Fonds»).

Shareholder

Subscribed Number of

Amount

capital

shares

paid in

HENDERSON GLOBAL INVESTORS (INTERNATIONAL HOLDINGS) BV. .

 EUR

125,000.-

125

EUR

125,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 EUR

125,000.-

125

EUR

125,000.-

63465

La Société se chargera de toutes les actions en rapport avec la gestion, l’administration et la promotion du Fonds.

Elle pourra, pour compte du Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobi-
lières, propriétés et, plus généralement, tout avoir constituant des investissements autorisés du Fonds, procéder ou ini-
tier à toutes inscriptions et tout transfert en son nom ou au nom de tiers dans le registre d’actions ou d’obligations de
toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et exercer pour compte du Fonds et des détenteurs de parts du
Fonds, tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux titres constituant les avoirs du Fonds,
cette énumération n’étant pas limitative, mais simplement exemplative.

La Société pourra également gérer ses propres actifs à titre accessoire et entreprendre toute autre activé qui est

jugée utile à l’accomplissement de son objet social, en restant toutefois dans le limites imposées par les documents cons-
titutifs du Fonds et les lois et règlements luxembourgeois applicables.

La Société sera soumise au Chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siége social est établi à Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de Schuttrange en vertu d´une décision du conseil de gérance. 
La Société pourra établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. 

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par cent

vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit moyen-

nant décision de l’associé unique ou moyennant résolution adoptée par l´assemblée générale des associés, selon le cas,
décidant selon la forme prévue à cet effet pour modifier les statuts.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux actions. Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans

les bénéfices de la Société et une voix aux assemblées générales des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exercera tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi de 1915

et les Statuts aux assemblées générales des associés. 

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé

unique ou de l’assemblée des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des actions. Chaque action est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun

choisi parmi eux ou en dehors d’eux. 

Art. 10. Cession d’actions. Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique pourra librement

céder ses actions.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les actions sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que

moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant 75% du capital social de la Société. 

Art. 11. Formalités. La cession d´actions doit être formalisée par acte notarial ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou

acceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil. 

Art. 12. Rachat des actions. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales

de la Loi de 1915. 

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d´un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la Société. 

Art. 14. Conseil de gérance. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance comprenant au moins

trois (3) gérants, associés ou non.

Chaque gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés en vertu d’une résolution favorable représentant 75% du capital

social de la Société, pourra décider la révocation d’un gérant à tout moment. Chaque gérant peut se démettre de ses
fonctions à tout moment.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décidera, le cas échéant, de la rémunération de chaque gérant.
Le conseil de gérance élira en son sein un président du conseil de gérance. Le conseil de gérance choisira un secrétaire

qui ne doit pas être un gérant et qui sera responsable de la garde des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra nommer des fondés de pouvoirs de la Société qu’il jugera nécessaire pour la conduite

des affaires de la Société. Pareilles nominations pourront être révoquées à tout moment par le conseil de gérance. Les
fondés de pouvoirs ne doivent pas être gérant ou associé de la Société. Les fondés de pouvoirs auront les pouvoirs et
obligations qui leur seront conférés par le conseil de gérance. 

63466

Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunira au lieu indiqué dans l’avis de convo-

cation.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins 24 heures avant l’heure

prévue pour celle-ci, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation par l’assentiment écrit ou par câble, télégramme,
télex ou message télécopié de chaque gérant.

Tout gérant pourra se faire représenter lors d’une réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, câble, télé-

gramme, télex ou message télécopié un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou message télécopié. Les réunions du conseil de gérance peuvent être tenues au
moyen de conférences téléphoniques ou conférences par images interposées ou tout autre moyen similaire de commu-
nications, auxquels cas les gérants participant par le biais de ces moyens de communications, seront réputés être pré-
sents à Luxembourg.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants sont présents

ou représentés à une réunion du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou repré-
sentés à la réunion. Le Président du conseil de gérance aura une voix prépondérante.

Les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par des résolutions circulaires signées sur un ou

plusieurs documents par tous les gérants. 

Art. 16. Pouvoirs de représentation. Vis-à-vis des tiers, tout gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir

au nom de la Société en toutes circonstances ainsi que pour accomplir et autoriser tous les actes et opérations relatifs
à l’objet social de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant.

Art. 17. Comités du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, par un vote à la majorité de tout le conseil,

constituer un ou plusieurs comités afin de traiter sous son contrôle et sa responsabilité de sujets particuliers, chaque
comité comprenant un ou plusieurs gérants de la Société. Le conseil de gérance peut designer un ou plusieurs gérants
comme membres suppléants susceptibles de remplacer tout membre absent ou exclu à toute réunion de ces comités. 

Art. 18. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture d’un gérant. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfi-

ture d`un gérant ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou révocation pour quelque
motif que soit, n’entrainent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants droits d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens

et documents de la Société. 

Art. 19. Responsabilité d`un gérant. Un gérant ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n`est responsable que de
l`exécution de son mandat.

La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute per-

sonne qui a été ou est partie, ou est menacée d`être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute
action, procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou a l`occasion d`une procédure d`instruction) du
fait que cette personne (1) a été ou est gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou d`une filiale ou (2) rend
ou a rendu service à la demande de la Société ou d`une filiale de la Société en tant que gérant, directeur ou fondé de
pouvoir, associé, membre, employé ou agent d`une autre société, association, joint venture, trust, comité ou toute autre
entreprise.

Dans la mesure où le conseil d`administration l`estime souhaitable, la Société peut indemniser, dans toute la mesure

du possible en vertu des dispositions légales en vigueur toute personne qui a été partie, ou est partie ou est menacée
d`être partie à ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d`être
entamé, en cours d`instance ou terminé (de nature civile, pénale, administrative ou à l’occasion d`une procédure d’ins-
truction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou est un agent (autre que gérant, directeur ou fondé de
pouvoir) de la Société ou d’une filiale.

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d`assurance pour le compte de cette personne qui

est ou a été gérant, ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou d´ une filiale, ou qui a rendu ou rend des
services à la demande de la Société ou d`une filiale comme gérant, directeur ou fondé de pouvoir associé, membre, em-
ployé ou agent d`une autre société, association, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute
dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son
statut que la Société ou une filiale ait ou non le pouvoir de l`indemniser du fait d`une telle dépense, responsabilité ou
perte en vertu des dispositions légales applicables.

Toute abrogation, modification, avenant ou adoption d`une disposition en contradiction avec cet article 19, ainsi que

dans la mesure ou cela serait permis en vertu des dispositions légales en vigueur, toute modification du droit n`entravera
pas les droits ou la protection accordés à toute personne en vertu du présent article tels qu`ils sont ou étaient en vigueur
au moment ou antérieurement à de tels abrogation, avenant, adoption ou modification.

Le droit à l’indemnisation conféré en vertu de cette article 19 comporte également, dans la mesure où cela est permis

par les dispositions légales en vigueur, le droit d’être remboursé des dépenses (y compris les honoraires d`avocat) en-
courues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d`un gérant,
directeur, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 19 subrogera la Société dans les droits que peuvent
avoir de tels gérants, directeurs ou autres fondés de pouvoir, membre, employés ou agents contre toute autre personne
ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 19 seront des droits contractuels. 

63467

Art. 20. Assemblées générales des associés 
Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la Loi de 1915 à

l’assemblée générale des associés.

Dans ce cas, les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi de 1915 ne sont pas applicables.
Lorsque la Société comporte moins de 25 associés, les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera soumis aux termes et conditions prévus par la Loi de 1915.

Dans ce cas les associé ont l`obligation d´émettre leur vote par écrit et de l’envoyer à la Société dans un délai de quinze

jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions des associés ne sont valablement prises qu`avec l`accord

des associés représentant plus de la moitié du capital social sauf dispositions contraires contenues dans ces statuts. Ce-
pendant, des décisions portant modification des présents Statuts et notamment celle de liquider la Société ne peuvent
être valablement prises qu`avec l`accord de la majorité des associés représentant trois quarts du capital social de la So-
ciété. 

Art. 21. Assemblées générales des associés. Les décisions de l´associé unique ou de l´assemblée générale des

associés seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu au siège social de la Société. Les pièces constatant
par écrit et consignées dans un registre seront tenu au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des
associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions ou procès-verbaux. 

Art. 22. Année sociale. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le denier jour

du mois de décembre de cette même année.

Art. 23. Réviseur d’entreprise agréé. L’associé unique ou l’assemblée générale des associés nommera un

réviseur d’entreprises agréé qui accomplira les obligations prescrites par les lois applicables.

Art. 24. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil d´administration dresse un

inventaire des avoirs et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la Loi de 1915.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas à l’assemblée générale des asso-

ciés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut consulter les documents financiers au siège social de la société, au cours

d´une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale des associés. 

Art. 25. Répartition des bénéfices. L’excédent du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est levé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d´’être

obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice net recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale

des associés.

Art. 26. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l´associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 27. Matières non envisagées. Tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts sera soumis aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre d’actions et a libéré en espèces

le montant ci-après énoncé: 

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article

183 de la Loi de 1915 ont été respectées. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ trois mille sept cent cinquante euros (EUR 3.750,00).

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Décisions de l’Associé Unique

L’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale de la Société, a pris immédiatement les résolutions

suivantes:

1. L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre des Gérants et nomme les personnes suivantes aux fonctions

de gérants de la Société pour un période indéterminée:

Associé

Capital

Nombre

Montant

souscrit

de parts

libéré

sociales

HENDERSON GLOBAL INVESTORS (INTERNATIONAL HOLDINGS) BV . .

EUR

125.000,-

125

EUR

125.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

125.000,-

125

EUR

125.000,-

63468

- M. Rodney Alexander Bysh, Directeur, ayant son domicile à 61440, Oberursel, Römerstraße 8, Allemagne;
- M. Michael Sales (HENDERSON UK), Directeur, ayant son domicile à 42, Beacon Way, Rickmansworth, Herts,

Angleterre WD3 7PE;

- M. Jeremy Vickerstaff, Directeur, ayant son domicile à 52, Rue du Chateau, Berg, L-6922 Luxembourg.
2. Le siège social est fixé (Grand-Duché de Luxembourg) au 64, rue Principale, Schuttrange, L-5367 Luxembourg.
3. ERNST &amp; YOUNG S.A. une société ayant son siège établi à 6, Rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg est nommée

en tant que réviseur d´ entreprise agréé de la Société. Le mandat du réviseur d’entreprise agréé expirera à la date de
l’approbation des comptes de l’année 2006.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire

de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d´une version française, et qu’à la demande du même
mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: O. Lambertyn, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 29, case 6. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102111.3/230/452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

ODYSSEY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 50.331. 

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ODYSSEY GROUP S.A.,

ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, Espace Kirchberg - Eolis Bât. C, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro 50.331, constituée sous la dénomination de O.D.C. HOLDING S.A. suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 9 février 1995, publié au Mémorial C, numéro 263 du 15 juin 1995, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 84
du 17 février 1996, dans lequel acte a été entre autres changé la dénomination de la société en ODYSSEY TREASURY
SYSTEMS S.A., suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 mars 1998, publié au Mémorial C, numéro 457
du 24 juin 1998, dans lequel acte a été entre autres changé la dénomination de la société en ODYSSEY GROUP S.A.,
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 503 du 1

er

 juillet 1999,

suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 31 du 17 janvier 2001,
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 novembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 470 du 21 juin
2001, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin 2001, publié au Mémorial C, numéro 1234 du 27
décembre 2001, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro 102
du 18 janvier 2002, suivant six actes reçus par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2001, publiés au Mémorial
C, numéro 602 du 18 avril 2002, suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 27 mars 2002, publié au
Mémorial C, numéro 973 du 26 juin 2002 et suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 15 décembre 2004,
publié au Mémorial C, numéro 343 du 16 avril 2005 et en date du 10 juin 2005, publié au Mémorial C, numéro 656 du
6 juillet 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Eggermont, directeur financier, demeurant à Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I.- Cette assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des lettres recommandées adressées à tous

les actionnaires en date du 16 novembre 2005.

II.- L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Renouvellement du capital autorisé pour une durée de cinq (5) ans, et ce jusqu’à un montant de vingt-cinq millions

d’euros (EUR 25.000.000,-) et modification subséquente du troisième alinéa de l’article 5 des statuts.

III.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

IV.- Il résulte de la prédite liste de présence que sur les vingt-neuf millions quatre cent cinquante-quatre mille huit

cent cinquante-deux (29.454.852) actions représentant l’intégralité du capital social, dix-neuf millions huit cent
cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (19.852.458) actions sont dûment présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée.

V.- Conformément à l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la présente assemblée

générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

63469

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé de vingt-cinq millions d’euros (EUR 25.000.000,-).
L’assemblée entend le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales proposant de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires dans le
cadre du capital autorisé.

L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans

le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera avec la faculté de supprimer ou de limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l’assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article 5 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 5. (Troisième alinéa). Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq

ans, prenant cours à dater de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre
2005.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Eggermont, P. Pierrard, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2005, vol. 433, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(103279.2/236/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.

HIFITEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, Galerie du Pall Center.

R. C. Luxembourg B 108.119. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06989, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902417.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

VIVE LES MARIES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 14, rue Dr Herr.

R. C. Luxembourg B 104.833. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2005, réf. DSO-AG00254, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902420.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

LES SENS DU VIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.

R. C. Luxembourg B 103.027. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05305, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902416.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

Bascharage, le 28 novembre 2005.

A. Weber.

Signature.

Ettelbruck, le 21 juillet 2005.

Signature.

Signature.

63470

FBL, FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG).
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481. 

L’an deux mille cinq, le dix-sept novembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE GENERALE DU

LUXEMBOURG, avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 6 481, constituée suivant acte reçu par Maître Jules Hamelius, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 1935, publié au Recueil Spécial du Mémorial, numéro 51 du 3
juillet 1935, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant décisions du conseil d’ad-
ministration du 28 juin 2001 et du 15 novembre 2001, publiées par extrait au Mémorial C, numéro 1170 du 14 décembre
2001. 

La séance est ouverte à 11.45 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Meyer, président du Conseil d’adminis-

tration de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, demeurant à Oberanven.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Louis Margue, secrétaire général de la BANQUE GE-

NERALE DU LUXEMBOURG, demeurant à Contern.

L’assemblée choisit comme scrutateurs: 
- Monsieur Fernand Simon, ancien membre du Comité de direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,

demeurant à Strassen,

- Monsieur Marc Meyer, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter: 
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, publiés dans les

journaux suivants:

a) au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C» numéro 1094 du 25 octobre 2005 et numéro 1157 du 5

novembre 2005, 

b) au «D’Wort» numéro 248 du 25 octobre 2005 et numéro 257 du 5 novembre 2005,
c) au «La Voix» numéro 249 du 26 octobre 2005 et numéro 257 du 5 novembre 2005,
d) au «Tageblatt» numéro 248 du 25 octobre 2005 et numéro 257 du 5 novembre 2005, 
d) au «Quotidien» numéro 248 du 25 octobre 2005 et numéro 257 du 5 novembre 2005.
e) au «Lëtzebuerger Journal» numéro 206 du 25 octobre 2005 et numéro 214 du 5 novembre 2005. 
Les justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau.
En outre des convocations contenant l’ordre du jour ont été adressées aux actionnaires en nom, en date du 24

octobre 2005.

II) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les man-
dataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire. 

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur

par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les treize millions sept cent trente-deux mille trente-cinq

(13.732.035) actions, représentatives de l’intégralité du capital social de trois cent cinquante millions d’euros
(350.000.000,-), treize millions sept cent dix-huit mille six cent cinquante-six (13.718.656) actions, soit plus de la moitié,
sont représentées à la présente assemblée.

IV) Que dès lors la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement dé-

libérer sur l’ordre du jour, conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale.
2. Modification de l’article 1

er

 (1), de l’article 13 (1), de l’article 19 (1), de l’article 5 (2) et de l’article 13 (2) des statuts

de la banque.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, et après avoir entendu les explications du Président sur les

points portés à l’ordre du jour, cette dernière, après délibérations, prend les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

 (1) des statuts de la banque pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

Art. 1

er

 (1) relatif à la dénomination sociale:

(1) «Il existe entre les propriétaires des actions émises en vertu de l’article cinq ci-après, et de celles qui pourront

être créées à l’avenir, une société anonyme qui, initialement dénommée BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,
portera dorénavant la dénomination de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG en abrégé FBL.»

Cette résolution a été adoptée par 13.718.646 voix, un actionnaire représentant 10 actions s’étant abstenu.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 (1), l’article 19 (1), l’article 5 (2) et l’article 13 (2) des statuts de

la banque pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 13 (1) relatif à l’émission d’obligations:
«La société peut émettre des obligations de toute nature par décision du conseil d’administration.»

63471

Art. 19 (1) relatif aux procès-verbaux:
(1) «Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont

signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes; les mandataires signent en outre
pour les membres qu’ils représentent. Les procurations ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex,
téléfax, ou tout autre moyen de reproduction d’un écrit y sont annexés.»

Art. 5 (2) relatif au capital autorisé:
L’article 5 (2) est supprimé.

Art. 13 (2) relatif à l’émission d’obligations dans les limites du capital autorisé.
L’article 13 (2) est supprimé.
Cette résolution a été adoptée par 13.718.606 voix, un actionnaire représentant 50 actions ayant voté contre la

résolution.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: J. Meyer, J.-L. Margue, F. Simon, M. Meyer, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(102357.3/212/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

FBL, FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG).
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102360.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

ALU-FER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8551 Noerdange, 5, Nidderpallenerstrooss.

R. C. Luxembourg B 99.538. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 11 juillet 2005, réf. DSO-BG00064, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 20 juillet 2005.

(902425.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (No 2), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.785. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06167, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063090.3/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

P. Frieders.

FIDUCIAIRE UNTERREGIONALE S.A.
Signature

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (No 2), S.à r.l.
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
C. Schmitz / G. Hornick 
<i>Gérant - catégorie «A» / <i>Gérant - catégorie «B» 

63472

ANIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.312. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-

BG05861, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063015.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CASPAN EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 94.838. 

Les comptes annuels au 30 juin 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-

BG02393, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063017.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SAINTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 49.849. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-

BG03524, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063019.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FINSAI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 84.679. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-

BG03567, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063020.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SAILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 44.793. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-

BG03577, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063021.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PROVINCIAL CAPITAL SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. DEUTSCHE BEAMTEN-VORSORGE DBV AG).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.889. 

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05058, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

63473

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062320.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

PROVINCIAL CAPITAL SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. DEUTSCHE BEAMTEN-VORSORGE DBV AG).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.889. 

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05062, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062323.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

PROVINCIAL CAPITAL SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. DEUTSCHE BEAMTEN-VORSORGE DBV AG).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.889. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05065, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062329.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

PROVINCIAL CAPITAL SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. DEUTSCHE BEAMTEN-VORSORGE DBV AG).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.889. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05067, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062333.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

PROVINCIAL CAPITAL SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. DEUTSCHE BEAMTEN-VORSORGE DBV AG).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.889. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05070, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062334.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

63474

PROVINCIAL CAPITAL SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. DEUTSCHE BEAMTEN-VORSORGE DBV AG).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.889. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05073, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062335.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

PROVINCIAL CAPITAL SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. DEUTSCHE BEAMTEN-VORSORGE DBV AG).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.889. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05076, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062336.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

PROVINCIAL CAPITAL SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. DEUTSCHE BEAMTEN-VORSORGE DBV AG).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.889. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05094, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(062338.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

FINLUXINFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.337. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 6 septembre 2004

L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Mme Sandrine Klusa et décide de nommer en son rem-

placement Mme Frédérique Vigneron.

Les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M. Xavier Justo, M. Roger Palma, Mme Frédérique Vigneron

et Mme Patricia Jupille ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD étant échus, l’assemblée géné-
rale décide de le renouveler avec date d’effet au 12 mai 2004, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2010.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02816. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063784.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour <i>FINLUXINFO HOLDING S.A.
Signature

63475

NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.526. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twelfth day of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) NLG ACQUISITIONS HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l., a private limited liability company («Gesellschaft mit

beschränkter Haftung») governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

incorporated by a deed of today by the undersigned notary, not yet registered at the R.C.S. Luxembourg,
represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

2) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of

Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United
States of America) and registration number 3857012,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

3) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of

Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United
States of America) and registration number 3857013,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

4) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR-15065,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

5) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number MC-15340,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

6) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws

of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE
19801 (United States of America) and registration number 3876917,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

7) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws

of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE
19801 (United States of America) and registration number 3876915,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

8) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws

of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE
19801 (United States of America) and registration number 3876912,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

9) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws

of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town,
Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15189,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

10) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., a limited partnership governed by

the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15585,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

11) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., a limited partnership governed by

the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15582,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

63476

12) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P., a limited partnership governed by

the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15580,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005;

13) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P., a limited partnership governed by

the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15579,

represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on

8 July 2005; and

14) FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P., a company incorporated under the laws of Delaware, having its regis-

tered office at 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (United States of America), registered under number
3820415.

The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons or their proxyholder(s) and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have drawn up the following articles of association of a company which they declared organ-

ized among themselves:

Chapter I. - Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established among NLG ACQUISITION HOLDINGS MAN-

AGEMENT, S.à r.l., a private limited liability company («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») incorporated under the
laws of Luxembourg, as unlimited partner («Komplementär») and the founding limited partners («Kommanditisten»)
and all those who may become owners of shares following its incorporation, a company (the «Company») in the form
of a partnership limited by shares («Kommanditgesellschaft auf Aktien») which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg (the «Laws») and by the present articles of association (the «Articles of Association»).

The Company will exist under the corporate name of NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager.

In the event that, in the view of the Manager, extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any inter-
ested parties by the Manager.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-)

divided into twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) class A shares (the «Class A Shares»), which shall
be held by the limited partners («Kommanditisten») and one (1) class B share (the «Class B Share»), which shall be held
by the unlimited partner («Komplementär»), in representation of its unlimited partnership interest in the Company.
Each issued share of each class has a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in the Articles of Association, shall be iden-

tical except to the extend otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the pay-
ment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Form of Shares. The Class A Shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares,

at the option of the shareholders, with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form.
The Class B Share will be in the form of a registered share only.

63477

The Class A Shares are freely transferable. The Class B Share may only be transferred subject to the shareholders (i)

approving the transfer in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the
case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association and (ii) resolving that the Class B share-
holder shall act as Manager of the Company after the relevant transfer. Any transfer of the Class B Share not approved
by the shareholders shall be unenforceable against the Company.

With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates in the form and with the indi-

cations prescribed by the Laws to the relevant shareholders. The Company may issue multiple bearer share certificates.

The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).
With respect to the registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number and class of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares
and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered
letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Own-
ership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register. Certificates reflecting the
recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders. The Company may issue multiple regis-
tered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered

into the shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as
well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the

general meeting of shareholders.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued and/or authorized capital of the Company may be increased

or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of these Articles of Association.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing sharehold-

ers, first of the same class, then to the other shareholders, in proportion to the part of the capital which those share-
holders are holding. The Manager shall determine the period within which the preferred subscription right shall be
exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting in compliance with the quorum and majority rules set by

these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association
may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Manager to do so.

Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own Class A Shares, but not its Class B Share.

The acquisition and holding of its own Class A Shares will be in compliance with the conditions and limits established
by the Laws.

Chapter III. - Manager, Supervisory board

Art. 9. Management. The Company shall be managed by NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à

r.l., prenamed (the «Manager»), in its capacity as unlimited partner and holder of the Class B Share of the Company.

The Manager may be removed for cause and must be immediately replaced by a new manager, who must be an un-

limited partner, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and
majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these
Articles of Association. The Manager to be removed shall however have no veto right in his capacity as unlimited partner
of the Company on any resolution relating to his removal.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Manager. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Articles of Association or
by the Laws to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are in the competence of the Manager.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Manager may receive a management fee in respect of the carrying

out of its management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred
by the Manager in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.

Art. 12. Liability of the Manager. The Manager shall be jointly and severally liable with the Company for all lia-

bilities of the Company which cannot be met out of the Company’s assets.

The shareholders other than the Manager shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or ca-

pacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings or otherwise, and, consequent-
ly, they shall only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share (and share premium if
any) in the Company owned by them.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager may delegate the daily man-

agement of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons
or committees of its choice.

The Manager may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary

functions to persons or committees of its choice.

63478

The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager (acting, in case the Manager

is a legal entity, through one or more duly authorised signatories, such as designated by the Manager at its sole discre-
tion).

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons

to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint sig-
natures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Manager, within
the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any oth-

er company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of its directors,
managers, officers or employees, the officers or employees of the Company or the members of the Supervisory Board
have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other company or firm.
Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business.

The Company shall indemnify the Manager or any one or more of its directors, managers, officers or employees, the

officers or employees of the Company or the members of the Supervisory Board and, if applicable, their successors,
heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably incurred by them in connection
with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them being or having been directors,
managers, officers or employees of the Manager, or officers or employees of the Company or members of the Super-
visory Board, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or cred-
itor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
present Articles of Association may be entitled. 

Art. 15. Dissolution-Incapacity of the Manager. In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or

where for any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company will not be dissolved.

In that event, the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be shareholders, until

such time as the general meeting of shareholders shall convene for purposes of appointing a new Manager.

Within fifteen days of their appointment, the administrator(s) shall convene the general meeting of shareholders in

the manner provided for by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws.

The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the

general meeting of shareholders shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate. 

Art. 16. Supervisory Board. The business of the Company and its financial situation, including more in particular

its books and accounts, shall be reviewed by a Supervisory Board composed of not less than three members, who need
not be shareholders.

The members of the Supervisory Board will be elected by the shareholders, who will determine their number, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the said

Supervisory Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally
replace them until they are able to resume their functions. In the event of the total number of members of the Super-
visory Board falls permanently below three, the Manager shall forthwith convene a general meeting of shareholders in
order to fill such vacancies.

The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by the general meeting of shareholders.
In the fulfilment of its duties, the Supervisory Board may be assisted by an independent auditor who shall be an inde-

pendent public accountant («réviseur d’entreprises») who shall be affiliated with a reputable firm of auditors.

The independent auditor, if any, shall be elected by resolution of the general meeting of shareholders for a period

ending at the date of the first annual general meeting of the shareholders following his appointment and he will hold
office until his successor is elected. He is re-eligible and he may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution adopted by the general meeting of shareholders.

Art. 17. Advisory Powers of the Supervisory Board. In addition to its statutory audit functions, the Supervisory

Board shall be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine from time to time.

Art. 18. Meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Board (the «Secretary»). 

The Supervisory Board will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Supervisory Board must be convened

if any two of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, except that in his absence the Supervisory Board

may appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at
such meeting.

63479

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

Supervisory Board meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the
transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and
the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any
means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Supervisory Board. No
separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Supervisory Board.

Every Supervisory Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Supervisory Board may from

time to time determine. Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by
appointing in writing another member of the Supervisory Board as his proxy.

A quorum of the Supervisory Board shall be the presence or the representation of a majority of the members of the

Supervisory Board holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Supervisory
Board present or represented at such meeting.

One or more members of the Supervisory Board may participate in a meeting by means of a conference call or by

any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Supervisory Board, is proper and valid as

though it had been adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Supervisory Board.

Art. 19. Minutes of meetings of the Supervisory Board. The minutes of any meeting of the Supervisory Board

will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Supervisory Board.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

Art. 20. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders

pursuant to these Articles of Association and the Laws.

Art. 21. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held at the registered office

of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on 31 March at 2:00 p.m.

If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 22. Other General Meetings. The Manager or the Supervisory Board may convene general meetings of

shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if sharehold-
ers representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting of shareholders, may be held abroad if, in the judgement

of the Manager, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 23. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publi-

cation) of a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws. The convening notice sent
to the shareholders will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business
to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for an extraordinary general meeting shall
also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text
of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 24. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting

of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, to be transmitted by any means

of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder him-
self. The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated
by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a shareholder, may execute
a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its
representative at any general meeting of shareholders, subject to the production of such evidence of authority as the
Manager may require. The Manager may determine any other conditions that must be fulfilled in order to take part in
a general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.

Art. 25. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by one of the Managers or by a person

designated by the Manager.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or rep-

resented.

63480

The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 26. Adjournment. The Manager may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four weeks.

The Manager must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Company’s issued cap-
ital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly

deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 27. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they

vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders. 

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt

another voting procedure.

At any general meeting of shareholders other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of

amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and
majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted, irrespective of the
number of shares represented, by a simple majority of votes cast. Save as otherwise stated in the present Articles of
Association, no resolution may be adopted without the consent of the Manager.

At any extraordinary general meeting of shareholders, convened in accordance with these Articles of Association or

the Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption
is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, the quorum shall
be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second meeting may be
convened at which there shall be no quorum requirement.

In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/

3) majority of the votes of the shareholders present or represented is required at any such general meeting. Save as
otherwise stated in the present Articles of Association, no resolution may be adopted without the consent of the Man-
ager.

Art. 28. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meet-

ing, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any shareholders or proxies
of shareholders, who so request.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager.

Chapter V. - Financial year, Distribution of earnings

Art. 29. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in each year and ends on

the last day of December in the same year.

Art. 30. Adoption of financial statements. The Manager shall prepare, for approval by the shareholders, annual

accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice. The annual accounts
are submitted to the general meeting of shareholders, which shall consider and, if thought fit, adopt these annual ac-
counts.

Art. 31. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall

each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will
cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder

of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a pro-
vision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits,
distributable reserves or share premium to the holders of Class A Shares and to the holder of the Class B Share, each
share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager may pay

out an advance payment on dividends to the holders of Class A Shares and the holder of the Class B Share. The Manager
fixes the amount and the date of payment of any such advance payment. 

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 32. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the

present Articles of Association, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of these Articles of Association.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager or such other person (who may

be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers
and their compensation.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the holders of Class A Shares and the holder of the Class B Share in con-

63481

formity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set our for
dividend distributions.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accord-

ance with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

articles 26 and 103 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2005.

The first annual general meeting will thus be held in the year 2006.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to set at three (3) the number of members of the Supervisory Board and further resolved to elect the

following as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be
held in the year 2006:

- Mr Randal A. Nardone, Investment Manager, born on 22 June 1955 in New York, New York (United States of Amer-

ica), with professional residence at 1251, avenue of the Americas, 16TH Floor, New York, NY 10020 (United States of
America);

- Mr Wesley R. Edens, Investment Manager, born on 30 October 1961 in Salem, Washington (United States of Amer-

ica), with professional residence at 1251, avenue of the Americas, 16TH Floor, New-York, NY 10020 (United States of
America); and

- Mr Jeffrey Rosenthal, Investment Manager, born on 22 February 1951 in Chicago, Illinois (United States of America),

with professional residence at 1251, avenue of the Americas, 16TH Floor, New York, NY 10020 (United States of Amer-
ica).

2. Resolved to establish the registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg).

Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary in Luxembourg, on the day named at the begin-

ning of this document.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.

Shareholders

Subscribed and

Number

paid-in capital

 and class

(EUR)

 of shares

NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT S. à r.l.   . . . . . . . . . . . . .

1,250.-

1 B Share

FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,385.- 1,908 Class A Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,385.- 1,908 Class A Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,385.- 1,908 Class A Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,385.- 1,908 Class A Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2,385.- 1,908 Class A Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P.. . . . .

2,385.- 1,908 Class A Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. . . . . .

 2,385.- 1,908 Class A Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P.  . . . .

 2,385.- 1,908 Class A Shares

FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P.  . . . .

2,383.75 1,907 Class A Shares

FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCH-LAND (FUND A) L.P.

 2,383.75 1,907 Class A Shares

FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCH-LAND (FUND B) L.P.

 2,383.75 1,907 Class A Shares

FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCH-LAND (FUND C) L.P.

 2,383.75 1,907 Class A Shares

FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCH-LAND (FUND D) L.P.

 2,383.75 1,907 Class A Shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 31,000.-24,799 Class A Shares

1 Class B Share

63482

The document having been read to the persons appearing, who are known to the undersigned notary by their sur-

name, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the undersigned notary this original
deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am zwölften Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg).

Sind erschienen:

1) NLG ACQUISITIONS HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l., eine Société à responsabilité limitée - Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Gesellschaftssitz in 5, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

gegründet gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars vom heutigen Tag, die noch nicht beim Luxemburger Han-

dels- und Gesellschaftsregister eingetragen worden ist;

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

2) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates

Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801
(Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3857012,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

3) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates

Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801
(Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3857013,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

4) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der

Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer CR-15065,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

5) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kayma-

ninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Kaymaninseln) und Registernummer MC-15340,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

6) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den

Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilming-
ton DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3876917,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

7) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den

Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilming-
ton DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3876915,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

8) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den

Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilming-
ton DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3876912,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

9) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den

Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15189,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

10) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß

den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15585,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

11) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß

den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15582,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005;

63483

12) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß

den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15580,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005; und 

13) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß

den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15579,

vertreten durch Maître Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in

New York am 8. Juli 2005.

Die oben genannten Vollmachten, welche von allen erschienenen Personen und dem unterzeichnenden Notar unter-

zeichnet wurden, bleiben der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die erschienenen Personen haben für die zwischen ihnen zu gründende Gesellschaft die nachfolgende Satzung aufge-

setzt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Zwischen NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l., als Aktionär unbe-

schränkter Haftung (Komplementär), den übrigen Gründungsaktionären mit beschränkter Haftung (Kommanditisten)
und all jenen, die zukünftig infolge der Gesellschaftsgründung Aktionäre werden, besteht eine Kommanditgesellschaft
auf Aktien (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (die «Gesetze») und den Bestim-
mungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Die Gesellschaft existiert unter dem Namen NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A. 

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführers an jeden anderen Ort innerhalb Stadt

Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Büros der Gesellschaft können durch einen Beschluss des Geschäftsführers im

Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Sollte der Geschäftsführer der Auffassung sein, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder

sozialer Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am
Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen dem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur
völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehende Massnahme hat
keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung ihres Sitzes
weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Diese vorübergehende Massnahme ist vom Geschäftsführer zu be-
schliessen und hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Ziel. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in luxem-

burgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligun-
gen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen oder Schuldscheine

ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt einundreißigtausend Euro (EUR

31.000,-), aufgeteilt in zwei Aktienkategorien, vierundzwanzigtausendsiebenhundert-neunundneunzig (24.799) Aktien
der Kategorie A (die «A-Aktien»), die von den Kommanditisten gehalten werden, und eine (1) Aktie der Kategorie B
(die «B-Aktie»), die von dem Komplementär im Gegenzug für seine unbegrenzte, komplementäre Beteiligung in der Ge-
sellschaft gehalten wird. Jede Aktie der einzelnen Kategorien hat einen Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig
Cent (EUR 1,25) und ist vollständig eingezahlt.

Jede Aktie der einzelnen Kategorien, welche in den Statuten definiert sind, ist vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmun-

gen der vorliegenden Satzung oder des Gesetzes mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital, kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einer Aktien zusätzlich zu ihrem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Aktien, die die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, zum Ausgleich von
realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Aktionäre in Form von Dividenden oder zur Bereitstellung der ge-
setzlichen Rückstellungen genutzt werden.

Art. 6. Aktien. Die A-Aktien werden, je nach der Wahl der Aktionäre, entweder in Form von Namensaktien oder

in Form von Inhaberaktien, ausgegeben, mit Ausnahme jedoch solcher Aktien die von Gesetzes wegen Namensaktien
sein müssen. Die B-Aktie hat ausschließlich die Form einer Namensaktie.

63484

Die A-Aktien sind frei übertragbar. Die Übertragung der B-Aktie erfordert, dass die Aktionäre, (i) der Übertragung

nach den gemäss dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen erforderlichen Quorum
und Mehrheiten zustimmen und (ii) bestimmen, dass der B-Aktionär nach der Übertragung Geschäftsführer der Gesell-
schaft sein soll. Jegliche Übertragungen der B-Aktie, der die Aktionäre nicht zugestimmt haben, ist gegenüber der
Gesellschaft undurchsetzbar.

Hinsichtlich der Inhaberaktien, entsprechen die von der Gesellschaft an die Aktionäre ausgegebenen Inhaberzertifi-

kate in ihrer Form und ihren weiteren Angaben den von den Gesetzen geforderten Angaben. Die Gesellschaft kann In-
haberzertifikate, welche mehrere Aktien darstellen, ausstellen.

Die Übertragung der Inhaberaktien findet durch die blosse Übertragung der Inhaberzertifikate statt.
Hinsichtlich der Namensaktien, wird am Gesellschaftssitz ein Register über die Namensaktien geführt, dass von jedem

Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Aktienregister enthält Angaben über die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs
und über die Anzahl und die Kategorie der jeweils gehaltenen Aktien, über die auf jede Aktie geleisteten Zahlungen
sowie über die Daten der Übertragungen von Aktien. Jeder Aktionnär muss der Gesellschaft mittels eingeschriebenem
Brief seine Adresse und jegliche Änderung derselben mitteilen. Die Gesellschaft darf sich für jegliche Zwecke auf die ihr
zuletzt mitgeteilte Adresse verlassen. Das Eigentum an den Namensanteilen bestimmt sich nach den Eintragungen in dem
Aktienregister. Den Aktionären werden Zertifikate ausgestellt, die die Eintragungen des Aktienregisters wiedergeben.
Die Gesellschaft kann Namenszertifikate, welche Eintragungen betreffend mehrere Aktien darstellen, ausstellen.

Jede Übertragung von Namensaktien wird im Aktienregister mittels einer dahinein gegebenen, datierten und vom

Übertragenden und Übertragungsempfänger oder seinem/ihren Vertreter(n) unterzeichneten Erklärung sowie im Ein-
klang mit den in Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Luxemburgs über die Forderungsübertragung festgelegten
Regelneingetragen. Ferner darf die Gesellschaft jede Übertragung, auf die in jeglicher Art von Korrespondenz oder in
einem jeden anderen Dokument Bezug genommen wird und die die Zustimmung vom Übertragenden und Übertra-
gungsempfänger enthält zur Kenntnis nehmen und in das Aktienregister eintragen.

Das Eigentum an einer Aktie beinhaltet zugleich implizit das Einverständnis mit der Satzung und den von der

Hauptversammlung angenommenen Beschlüssen.

Art. 7. Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals. Das ausgegebene und/oder das genehmigte Kapital der

Gesellschaft können einmalig oder mehrfach durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung
mit den nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen erforderlichen Quorum und
Mehrheiten, angenommen wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die neuen mittels Geldeinlage zu zeichnenden Aktien werden den vorhandenen Aktionären, zuerst derselben Kate-

gorie Aktien, dann aller anderen Kategorien, in dem Verhältnis, zu welchem diese an dem Gesellschaftskapital beteiligt
sind, bevorzugt angeboten. Der Geschäftsführer wird den Zeitraum bestimmen, innerhalb dessen das Vorzugsrecht bei
der Aktienzeichnung ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf dreissig Tage nicht unterschreiten.

Unbeschadet des Vorstehenden, kann die Generalversammlung, die in Übereinstimmung mit den nach dieser Satzung

oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen erforderlichen Quorum und Mehrheiten, abstimmt, das
Vorzugsrecht bei der Aktienzeichnung begrenzen oder ausschließen oder den Geschäftsführer hierzu ermächtigen. 

Art. 8. Erwerb von eigenen Aktien. Die Gesellschaft darf ihre eigenen A-Aktien erwerben, nicht jedoch ihre B-

Aktie. Der Erwerb und das Halten der eigenen A-Aktien vollzieht sich in Übereinstimmung mit den durch die Gesetze
festgelegten Bedingungen und Begrenzungen.

Kapitel III. - Geschäftsführung, Aufsichtsrat

Art. 9. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch die vorgenannte NLG ACQUISITION HOLDINGS MA-

NAGEMENT, S.à r.l. (der «Geschäftsführer»), in seiner Eigenschaft als unbeschränkt haftender Partner und B-Aktionär
geführt.

Der Geschäftsführer kann begründet abberufen werden und, falls nach einer solchen Abberufung kein weiterer

Geschäftsführer existiert, muss er sofort durch einen neuen Geschäftsführer ersetzt werden, der ebenfalls ein unbe-
schränkt haftender Partner ist und der durch einen in Übereinstimmung mit den nach dieser Satzung oder den zur Än-
derung dieser Satzung ergangenen Gesetzen, erforderlichen Quorum und Mehrheiten gefassten Beschluss der
Hauptversammlung, bestimmt worden ist. Dem abzuberufenden Geschäftsführer steht in seiner Stellung als unbe-
schränkt haftender Partner der Gesellschaft kein Vetorecht gegen jene Beschlüsse zu, die sich auf seine Ablösung bezie-
hen.

Die übrigen Aktionäre sollen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch sich in diese einmi-

schen.

Art. 10. Befugnisse des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle zur

Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die
die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat übertragen haben, fallen
in die Zuständigkeit des Geschäftsführers.

Art. 11. Kosten der Geschäftsführung und Ausgaben. Der Geschäftsführer darf zur Ausführung der Geschäfts-

führung eine Vergütung erhalten und ferner einen Ersatz aller Aufwendungen, die er bei der Geschäftsführung der
Gesellschaft oder bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks gemacht hat, erhalten.

Art. 12. Haftung des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer haftet gesamtverbindlich zusammen mit der

Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft, welche nicht durch die Aktiva der Gesellschaft gedeckt werden
können.

Mit Ausnahme der Geschäftsführer dürfen die Aktionäre, in welcher Art und Weise auch immer, nur im Rahmen der

Ausübung ihrer Aktionärsrechte bei der Hauptversammlung oder anderweitig, handeln und haften deshalb der Gesell-

63485

schaft nur für Beträge in Höhe des Nennwerts jeder Aktie (und, wenn vorgesehen, des Aufgeldes der Aktien), die sie
an der Gesellschaft besitzen.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Der Geschäftsführer kann die tägliche

Verwaltung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft innerhalb dieser täglichen Verwaltung einer oder meh-
reren Personen oder Ausschüssen seiner Wahl überlassen.

Der Geschäftsführer kann einer oder mehreren Personen oder Ausschüssen seiner Wahl ebenfalls besondere Befug-

nisse oder Vollmachten übertragen oder letztere mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers (im Falle der Ge-

schäftsführung durch eine juristische Person, durch die Unterschrift einer oder mehrerer ordnungsgemäß ermächtigter
Unterzeichner, wie sie durch eine Ermessensentscheidung des Geschäftsführers bestimmt worden sind) vertreten.

Die Gesellschaft wird im Rahmen der täglichen Geschäftsführung Dritten gegenüber ferner durch die gemeinschaft-

liche Unterschrift oder die alleinige Unterschrift derjenigen Person(en) vertreten, denen die tägliche Verwaltung der
Gesellschaft übertragen worden ist, oder durch die gemeinschaftliche oder die alleinige Unterschrift derjenigen Per-
son(en), der/denen von dem Geschäftsführer eine besondere Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber immer nur
im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.

Art. 14. Interessenkonflikte - Entschädigungen. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der

Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Firma soll in ihrer Wirksamkeit dadurch beeinflusst
werden, dass der Geschäftsführer, eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer, Angestellte oder
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder die Mitglieder des Aufsichtsrates ein persönliches Interesse bezüglich der anderen
Gesellschaft oder Firma haben oder ein Anteilsinhaber, Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Angestellter oder
Arbeitnehmer der anderen Gesellschaft oder Firma sind. Jede Person, die in der zuvor beschriebenen Weise mit einer
Gesellschaft oder einer Firma verbunden ist und mit denen die Gesellschaft vertraglich oder in anderer Weise in
Geschäftsbeziehungen treten wird, soll nicht alleine wegen dieser Verbindung, an der Abstimmung oder der Vornahme
anderer Handlungen in Bezug auf einen solchen Vertrag oder sonstigen Geschäftstätigkeit gehindert sein.

Die Gesellschaft wird den Geschäftsführer oder jeden von seinen Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern, An-

gestellten oder Arbeitnehmern, oder die Aufsichtsratsmitglieder und, wo dies der Fall ist, deren Nachkommen, Erben,
Erbvollstrecker und Verwalter für sämtlichen Schadensersatz und vernünftige Auslagen, die sie in ihrer Eigenschaft als
Anteilsinhaber, Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Angestellter oder Arbeitnehmer der Geschäftsführer oder als
Angestellter oder Arbeitnehmer der Gesellschaft oder als Verwaltungsratsmitglieder, oder, auf Verlangen der Gesell-
schaft, jeder anderen Gesellschaft, deren Anteilsinhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, zahlen mussten und für die
sie keine anderweitige Entschädigung bekommen, entschädigen. Diese Entschädigung spielt nur mit Ausnahme der An-
gelegenheiten, deretwegen die vorgennanten Personen in besagter Handlung, Klage oder Verfahren wegen grober Fahr-
lässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wurden. Im Falle einer Einigung bezieht sich die Entschädigung nur auf jene
Punkte der Einigung, zu denen der Gesellschaft von ihrem Rechtsberater dargelegt wurde, dass die zu entschädigende
Person sich keiner groben Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft schuldig gemacht hat. Das vorgenannte Recht auf Entschä-
digung schließt keine anderen Entschädigungsansprüche, zu welchen die Satzung berechtigt, aus.

Art. 15. Auflösung-Rechtliche Handlungsunfähigkeit des Geschäftsführers. Die Ablösung oder die rechtli-

che oder sonstige Handlungsunfähigkeit des Geschäftsführers bedeutet nicht die Auflösung der Gesellschaft. 

In diesem Fall, und falls es keinen anderen Geschäftsführer gibt, wird der Aufsichtsrat einen oder mehrere Verwalter,

die nicht Aktionär sein müssen, bis dass die Hauptversammlung zum Zwecke der Ernennung eines neuen Geschäftsfüh-
rers zusammengetreten ist, benennen.

Innerhalb von fünfzehn Tagen nach ihrer Ernennung soll(en) der/die Verwalter die Hauptversammlung, nach den in

dieser Satzung oder in den Gesetzen festgelegten Regeln, einberufen.

Die Aufgaben der Verwalter bestehen bis zum Zusammenkunft der Hauptversammlung in der Vornahme unaufschieb-

barer Handlungen und solcher Handlungen, die zur gewöhnlichen Geschäftsführung gehören. 

Die Verwalter sind nur für die Ausführung ihres Auftrags verantwortlich.

Art. 16. Aufsichtsrat. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Lage, einschließlich insbesondere der

Geschäftsbücher und Konten, werden von einem Aufsichtsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die jedoch
nicht Aktionär sein müssen, überwacht.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Aktionären, die ihre Anzahl festlegen, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren gewählt. Sie verbleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind erneut wählbar und können zu jeder
Zeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden.

Sollten ein oder mehrere Mitglieder des Aufsichtsrates zeitweise an der Teilnahme an den erwähnten Sitzungen des

Aufsichtsrates verhindert sein, können die übrigen Mitglieder bis zur Wiederaufnahme des Amtes durch dieses/diese
Aufsichtsratsmitglied(er) eine Ersatzperson aus den Reihen der Aktionäre ernennen. Sinkt die absolute Zahl der Auf-
sichtsratsmitglieder dauerhaft unter drei, soll der Geschäftsführer nunmehr die Hauptversammlung der Gesellschaft ein-
berufen, um die freien Sitze besetzen zu können.

Die Hauptversammlung legt die Entlohnung der Aufsichtsratsmitglieder fest. 
Zur Unterstützung seiner Aufgabenerfüllung kann sich der Aufsichtsrat eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers bedie-

nen, der unabhängig sein soll und mit einer namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammenarbeitet.

Der unabhängige Wirtschaftsprüfer, wenn ein solcher bestellt werden soll, wird durch einen Beschluss der Haupt-

versammlung für einen Zeitraum, der bis zum Abhalten der ersten jährlichen Hauptversammlung nach seiner Ernennung
dauert, ernannt und wird so lange im Amt bleiben bis ein Nachfolger ernannt ist. Er ist erneut wählbar und kann zu jeder
Zeit durch einen von der Hauptversammlung angenommenen Beschluss, mit oder Angabe von Gründen, abberufen wer-
den.

63486

Art. 17. Konsultativrechte des Aufsichtsrates.  Zusätzlich zu seinen satzungsrechtlichen Prüfungsbefugnissen

kann der Aufsichtsrat von dem Geschäftsführer bei jenen Angelegenheiten hinzugezogen werden, die der Geschäftsfüh-
rer von Zeit zu Zeit festlegt.

Art. 18. Sitzungen des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ernennt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der

«Vorsitzende»). Der Aufsichtsrat kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein
muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Aufsichtsrats verantwortlich ist (der «Schriftführer»).

Der Aufsichtsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Sitzung des Aufsichtsrats muss

ferner auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Aufsichtsrats vor, es sei denn, dass der Aufsichtsrat wegen der Abwesen-

heit des Vorsitzenden ein anderes Mitglied als Vorsitzenden auf Zeit durch Mehrheitswahl in dieser Sitzung ernannt hat.

Ausser in Dringlichkeitsfällen oder bei einer vorher erteilten Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die

Sitzungen des Aufsichtsrats eine Woche vor ihrem Termin schriftlich durch ein, die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tages-
ordnung und die Eigenart des zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann schrift-
lich durch ein, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium, auf die Benachrichtigung verzichten. Für
Sitzungen, deren Veranstaltungsort und Zeit in einem zuvor angenommenen Beschluss des Aufsichtsrats festgelegt
worden sind, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Jede Aufsichtsratssitzung findet in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Aufsichtsrat hierfür bestimmt hat,

statt. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich bei den Aufsichtsratssitzungen durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied ver-
treten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats erfordert die Anwesenheit einer Mehrheit von Aufsichtsratsmitglieder. Ent-

schlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder ge-
fasst.

Ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung oder durch

ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende Mittel teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der tatsächlichen Anwesenheit an einer Sitzung gleich gestellt.

In Dringlichkeitsfällen steht eine vom Aufsichtsrat schriftlich festgehaltene und von allen Aufsichtsratsmitgliedern un-

terzeichnete Entscheidung einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Auf-
sichtsratssitzung gefasst worden wäre. Diese Entscheidung kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren
getrennten Dokumenten desselben Inhalts, die jeweils von einem oder mehreren Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet
sind, festgehalten sein.

Art. 19. Protokoll der Aufsichtsratssitzungen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden von dem

Vorsitzenden unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, unter-

zeichnen der Vorsitzende und, soweit vorhanden, der Schriftführer oder zwei sonstige Mitglieder des Aufsichtsrates.

Kapitel IV. - Hauptversammlung

Art. 20. Befugnisse der Hauptversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt die

Gesamtheit der Aktionäre (die «Hauptversammlung»).

Die Hauptversammlung besitzt die nach dieser Satzung und nach den Gesetzen zukommenden Befugnisse.

Art. 21. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird am Sitz der Gesellschaft

oder an jedem anderen, im Einberufungsschreiben angeführten Platz am 31. März um 14.00 Uhr abgehalten.

Fällt dieser Tag auf eine gesetzliche Feiertag, auf einen Samstag oder einen Sonntag, wird die Versammlung am nächst-

folgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 22. Weitere Hauptversammlungen. Der Geschäftsführer oder der Aufsichtsrat können zusätzlich zu der

Jahreshauptversammlung weitere Hauptversammlungen einberufen. Diese Versammlung sind einzuberufen, wenn es
eine Anzahl von Aktionären, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitalsvertreten, so verlangt. 

Hauptversammlungen sowie die Jahreshauptversammlung können ausser Landes abgehalten werden, wenn dies nach

dem endgültigen Urteil des Geschäftsführers durch die Umstände höherer Gewalt angebracht ist.

Art. 23. Einberufungsschreiben zu Hauptversammlungen. Die Aktionäre treten auf Einberufungsschreiben,

welches in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung und den Gesetzen mitgeteilt und erforderlichenfalls
auch veröffentlicht wird, zusammen. Das an die Aktionäre versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit
sowie die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Hauptversammlung an. Die
Tagesordnung einer ausserordentlichen Hauptversammlung muss, insofern angebracht, die vorzunehmenden Änderun-
gen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den Wortlaut der Änderungen ausführen, die Auswirkungen
auf Gesellschaftszweck und -form der Gesellschaft haben.

Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Tagesordnung

der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden. 

Art. 24. Teilnahme und Vertretung. Alle Aktionäre besitzen bei jeder Hauptversammlung ein Teilnahme- und

ein Rederecht.

Ein Aktionär kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit wahrende Übertragung-

weise übermittelt wurde, bei jeder Hauptversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Aktionär sein muss,
vertreten lassen. Der Geschäftsführer kann die Form der Vertretungserklärung sowie deren Hinterlegung mindestens
fünf Tage vor Sitzungsbeginn festlegen. Jede juristische Person, die Aktionär ist, kann ihre Vertretungserklärung durch

63487

einen ordnungsgemäß ernannten Vertreter erstellen oder eine ihr geeignet erscheinende Person zur Vertretung bei ei-
ner Hauptversammlung ernennen, jedoch unter der Bedingung des Ermächtigungnachweises auf Verlangen des Ge-
schäftsführers. Der Geschäftsführer kann weitere Bedingungen, die zur Teilnahme an einer Hauptversammlung erfüllt
sein müssen, aufstellen.

In Bezug auf die Gesellschaft ist jede Aktie unteilbar. Die Miteigentümer, die Niessbraucher und die blossen Eigentü-

mer von Aktien sowie die Pfandgläubiger und die Pfandschuldner von Aktien müssen einen einzigen Vertreter zu ihrer
Vertretung bei der Hauptversammlung bestimmen.

Art. 25. Verfahren. Einer der Geschäftsführer oder eine von diesem bestimmte Person steht jeder Hauptversamm-

lung vor.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung wird einen Schriftführer ernennen.
Die Hauptversammlung wird aus den anwesenden oder vertretenen Aktionären einen Stimmenzähler wählen.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden zusammen den Vorstand der Hauptversammlung.

Art. 26. Vertagung. Der Geschäftsführer kann jede Hauptversammlung für vier Wochen vertagen. Der Geschäfts-

führer ist zur Vertagung verpflichtet, wenn es die Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des von der Gesellschaft ausge-
gebenen Kapitals vertreten, so verlangen.

Eine derartige Vertagung macht automatisch jeden zuvor angenommenen Beschluss gegenstandslos.
Die so vertagte Hauptversammlung hat dieselbe Tagesordnung wie die ursprünglich angesetzte. Die im Hinblick auf

die ursprünglich einberufene Hauptversammlung ordnungsgemäss hinterlegten Aktien und Vollmachten behalten ihre
Gültigkeit auch für die vertagte Versammlung.

Art. 27. Abstimmung. Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Aktionäre und die Anzahl ihrer zur Abstimmung

berechtigenden Aktien angibt, wird von den Aktionären oder von ihren Vertretern vor der Eröffnung der Hauptver-
sammlung unterzeichnet.

Die Hauptversammlung darf nur über solche Punkte beraten und abstimmen, die auf der Tagesordnung aufgeführt

sind.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme, vorbehaltlich der durch die Gesetze auferlegten Beschränkungen.
Die Abstimmungen finden per Handzeichen oder durch Namensaufruf statt, falls nicht die Hauptversammlung ein an-

deres Abstimmungsverfahren anzunehmen beschlossen hat.

Bei jeder Hauptversammlung, mit Ausnahme der ausserordentlichen, die zum Zwecke der Abänderung der Satzung

oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung
der Satzung unterliegt, werden die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und ungeachtet der Anzahl der vertretenen Aktien
angenommen. Beschlüsse werden, mangels anderslautender, ausdrücklicher Festlegung in dieser Satzung, nur mit dem
Einverständnis des Geschäftsführers angenommen.

Bei jeder Hauptversammlung, die zum Zwecke der Abänderung der Satzung oder zur Abstimmung über Beschlüsse,

deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung der Satzung unterliegt, einberufen wur-
de, entspricht das Quorum mindestens der Hälfte aller ausgegebenen und noch ausstehenden Aktien. Sollte das genann-
te Quorum nicht anwesend sein, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, welche keinem
Quorumerfordernis unterliegt.

In einer solchen ausserordentlichen Hauptversammlung ist zur Annahme eines vorgeschlagenen Beschlusses eine

Zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre erforderlich. Beschlüsse werden,
mangels anderslautender, ausdrücklicher Festlegung in dieser Satzung nur mit dem Einverständnis des Geschäftsführers
angenommen.

Art. 28. Protokoll. Das Sitzungsprotokoll der Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden der Versammlung, dem

Schriftführer und dem Stimmenzähler der Versammlung unterzeichnet. Es kann auf Verlangen ferner von jedem Aktionär
oder Vertreter eines Aktionärs unterzeichnet werden.

Kopien oder Auszüge dieses Protokolls, die in rechtlichen Verfahren übermittelt werden sollen, sind von dem Ge-

schäftsführer zu unterzeichnen.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnverwendung

Art. 29. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am

31. Dezember desselben Jahres.

Art. 30. Annahme der Finanzberichte. Der Geschäftsführer bereitet in Übereinstimmung mit den gesetzlichen

Bestimmungen und den luxemburgischen Buchhaltungsvorschriften den Jahresabschluss hinsichtlich der Zustimmung der
Aktionäre vor. Der Jahresabschluss wird der Hauptversammlung unterbreitet, die hierüber beraten und, im Falle der
Zustimmung, diesen annehmen wird.

Art. 31. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens 5% der gesetzlich

vorgesehenen Rückstellungen (die «gesetzliche Rückstellung») zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die ge-
setzliche Rückstellung die Höhe von 10% des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Bereitstellung der gesetzlichen Rückstellung wird die Hauptversammlung festlegen, wie der verbleibende

Überschuss an Reingewinn verteilt werden soll; ob durch vollständige oder teilweise Bildung einer Rückstellung oder als
Zuweisung zu einer Provisionszahlung; durch Übernahme bis in das nächste Geschäftsjahr oder durch Ausschüttung ge-
meinsam mit den übernommenen Gewinnen, den ausschüttungsfähigen Rückstellungen oder den Ausgabeprämien, an
die A- und B-Aktionäre, wobei jede Aktie zu einer gleich grossen Berücksichtigung bei der Verteilung berechtigt.

63488

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestim-

mungen, kann der Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die A-und B-Aktionäre vornehmen. Der Geschäftsführer
legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel - VI. Auflösung, Abwicklung

Art. 32. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann zu einem früheren als dem in Artikel 4 dieser Satzung

vorgesehenen Zeitpunkt durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach dieser
Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen, erforderlichen Quorum und Mehrheiten gefasst
worden ist, aufgelöst werden.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von dem Geschäftsführer oder jeder anderen natürlichen oder

juristischen Person ausgeführt werden, deren Befugnisse und deren Vergütung von der Hauptversammlung festgelegt
wurde.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehender Ansprüche wird der Reinerlös aus

der Abwicklung an die A- und B-Aktionäre so verteilt, dass ihre Grundlage insgesamt der wirtschaftlich anvisierten
Ausschüttung der Dividenden entspricht.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 33. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind,

bestimmen sich den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in
seiner zuletzt geltenden Fassung.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung ist somit von den erschienenen Parteien erstellt worden, welche nachstehende Anzahl und Kategorie

von Aktien gezeichnet sowie folgende Beträge in bar eingezahlt haben: 

Beweis über alle diese Zahlungen wurde dem unterzeichnenden Notaren überbracht, der die Beachtung der Artikel

26 und 103 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 feststellt.

<i>Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-

hen, werden auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2005.

Die erste Jahreshauptversammlung wird folglich im Jahr 2006 abgehalten.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung

Die erschienen Personen, die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals vertreten und sich selbst als ordnungsgemäss

einberufen betrachten, sind unverzüglich dazu übergegangen, eine ausserordentliche Hauptversammlung abzuhalten.

Nachdem sie zunächst überprüft haben, dass die Versammlung regelgerecht zusammengetreten ist, haben sie, jeweils

mittels einstimmiger Wahl, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Es wird beschlossen, die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates auf drei (3) festzulegen, und weiterhin wird be-

schlossen, folgende Personen für einen Zeitraum, der mit der ordentlichen Hauptversammlung, die in 2006 abgehalten
wird, endet, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen:

- Herr A. Nardone, Investment Manager, geboren am 22. Juni 1955 in New York, New York (Vereinigte Staaten von

Amerika), berufsansässig in 1251, avenue of the Americas, 16TH Floor, New York, NY 10020 (Vereinigte Staaten von
Amerika);

Aktionäre

Gezeichnetes

Anzahl

und eingezahltes

und Kategorie

Kapital (EUR)

 von Aktien

NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

1,250.-

1 B Aktie

FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.385,-

1.908 A-Aktien

FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.385,-

1.908 A-Aktien

FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.385,-

1.908 A-Aktien

FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.385,-

1.908 A-Aktien

FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.385,-

1.908 A-Aktien

FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P. . . . . . .

2.385,-

1.908 A-Aktien

FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. . . . . . .

2.385,-

1.908 A-Aktien

FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P. . . . . . .

2.385,-

1.908 A-Aktien

FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P. . . . . . .

2.383,75

1.907 A-Aktien

FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCH-LAND (FUND A) L.P.  .

2.383,75

1.907 A-Aktien

FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCH-LAND (FUND B) L.P. . .

2.383,75

1.907 A-Aktien

FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCH-LAND (FUND C) L.P.  .

2.383,75

1.907 A-Aktien

FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCH-LAND (FUND D) L.P.  .

2.383,75

1.907 A-Aktien

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 31.000,-

24.799 A-Aktien

1 B-Aktie

63489

- Herr Wesley R. Edens, Investment Manager, geboren am 30. Oktober 1961 in Salem, Washington (Vereinigte

Staaten von Amerika), berufsansässig in 1251, avenue of the Americas, 16TH Floor, New York, NY 10020 (Vereinigte
Staaten von Amerika); und

- Herr Jeffrey Rosenthal, Investment Manager, geboren am 22. Februar 1951 in Chicago, Illinois (Vereinigte Staaten

von Amerika), berufsansässig in 1251, avenue of the Americas, 16TH Floor, New York, NY 10020 (Vereinigte Staaten
von Amerika).

2. Es wird beschlossen, dass sich der Gesellschaftssitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg befindet.

Woraufhin vorliegende, Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxembourg

aufgenommen wurde.

Der unterzeichnende Notar, der des Englischen mächtig ist, erklärt hiermit, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der

weiter oben erwähnten Parteien in englischer Sprache verfasst ist und von einer Fassung in deutscher Sprache gefolgt
wird; auf Antrag derselben Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
gilt der englische Text.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort

bekannten, erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem
unterzeichnenden Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 18. Juli 2005, Band. 895, Blatt. 49, Feld 12. – 310 Euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen. 

(066270.3/239/902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

AGHARTI S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.136. 

In the year two thousand and five, on the nineteenth day of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replace-

ment of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depos-
itary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AGHARTI S.A., a société anonyme which was in-

corporated by deed of notary Jean-Joseph Wagner, on 15 April 2002, published in the Mémorial C N

°

 1062 of 11 July

2002, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 87.136 and having
its registered office at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (the «Company»).

The extraordinary general meeting is opened in the chair by M

e

 Nicki Kayser, avocat, with professional address in

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Brendan D. Klapp, employee, with professional address in

Belvaux (Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer M

e

 Delphine Horn avocat, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
to add a new paragraph between article 4 paragraph 2 and paragraph 3 of the articles of incorporation of the Com-

pany as follows:

«The Company may directly or indirectly through its branches established either in the Grand Duchy of Luxembourg

or abroad, provide services, advice and assistance to affiliated enterprises or third parties».

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned no-

tary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of one hundred thousand

Euro (100,000 EUR) are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may
validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting resolve to add a new paragraph between article 4 paragraph 2 and paragraph 3 of the articles of

incorporation of the Company as follows:

«The Company may directly or indirectly through its branches established either in the Grand Duchy of Luxembourg

or abroad, provide services, advice and assistance to affiliated enterprises or third parties.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Beles, den 25. Juli 2005.

 J.-J. Wagner.

63490

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.
Par-devant Nous Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant

en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel
dernier nommé restera dépositaire de la présente minute. 

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGHARTI S.A., constituée

suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, le 15 avril 2002, publié au Mémorial C n

°

 1062 du 11 juillet 2002, enregis-

trée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 87.136 et ayant son siège social
à 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Nicki Kayser, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé, avec adresse professionnelle à Belvaux

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Maître Delphine Horn, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
- l’ajout d’un nouveau paragraphe entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l’article 4 comme suit: «La société pour-

ra, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l’étranger, fournir des services, conseils ou assistance à des sociétés affiliées ou à des tierces parties.»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les personnes présentes et le notaire ins-

trumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de cent mille

euros (100.000 EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée
et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’ajouter un nouveau paragraphe entre les paragraphes

2 et 3 de l’article 4 qui aura la teneur suivante:

«La société pourra, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses succursales établies au Grand-Duché

de Luxembourg ou à l’étranger, fournir des services, conseils ou assistance à des sociétés affiliées ou à des tierces par-
ties.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Kayser, B. D. Klapp, D. Horn, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2005, vol. 895, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066445.3/239/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

AGHARTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.136. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066447.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

63491

FINANCIERE THEMISTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.438. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue en date du 13 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE THE-

MISTO S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L’assemblée a décidé de nommer, la société RUSHBURY
INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en Fran-

ce, avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Les différents mandats s’achèveront lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
2. L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Olivier Wusarczuc,

demeurant à Luxembourg, avec effet à ce jour. L’assemblée a décidé de nommer en son remplacement la société à res-
ponsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47,
route d’Arlon, pour une période de 3 ans.

Le mandat s’achèvera avec l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064219.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

LUX-LORRAINE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 48.550. 

Messieurs,
Par la présente je démissionne de mon poste d’administrateur de la société référencée sous rubrique et ceci avec

effet immédiat.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063985.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

J. HIRSCH &amp; CO INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 102.323. 

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l’associée unique en date du 7 juillet 2005

1. L’Associé unique prend acte de la démission avec effet immédiat, de Monsieur Jean-Pierre Verlaine de son mandat

de gérant de la société.

L’Associée unique décide de nommer gérant, avec effet immédiat, Monsieur Christophe Blondeau, employé privé,

demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle à tenir en 2006 statuant sur l’exercice arrêté au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063862.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

R. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
R. Thillens / C. Blondeau
<i>Gérant / <i>Gérant

63492

CLARINS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.210. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 juin 2005 a appelé aux fonctions d’admi-

nistrateur Monsieur Elmar Steiger, Königsberger Strasse 41, D-82319 Starnberg, et MONTEREY SERVICES S.A., 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de Monsieur Pierre Milet et de Monsieur
Bastiaan Schreuders. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
- Monsieur Edward Bruin, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enfin cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Edward Bruin, Administrateur,
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- Monsieur Elmar Steiger, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063996.3/029/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

S.C.P., SECURITY CONSULTING PROFESSIONNALS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 105.467. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille et cinq (2005), le 30 juin, à 15 heures, Messieurs les actionnaires de la société anonyme SECURITY

CONSULTING PROFESSIONNALS S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg.

La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Pranzetti Bernard, demeurant à L-7450 Lintgen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Tatjana Goergen, demeurant professionnellement à L-Luxem-

bourg, et comme scrutateur, Monsieur Jean Joel Ansart, demeurant à F-91720 Maisse.

Monsieur le président constate que:
I. Que les actionnaires sont présents ou représentés, et se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la pré-

sente assemblée

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Démission de Monsieur Jean-Joel Ansart du mandat d’administrateur-délégué,
- Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement.

<i>Résolution

Les actionnaires, à l’unanimité décident:
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-Joel Ansart, né le 17 juillet 1955 à F-Veigné, demeurant à 53, rue de la

Ferté Allais, F-91720 Maisse du mandat d’administrateur-délégué et d’administrateur,

- de nommer comme administrateur en remplacement la société ESTORIA S.A. avec siège social à Akara Bldg., 24

De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town Tortola, British Virgin Islands.

L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et

faire toutes formalités s’il y a lieu.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h30.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03825. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063853.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour CLARINS LUXEMBOURG S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

63493

C.A.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.429. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005

- Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2006:

Mr. Peter Wodtke, banquier, demeurant à Londres, Angleterre;
Mr. Salim Meouchi, lawyer, demeurant à Beyrouth, Liban;
Mr. David Sambar, business consultant, demeurant à Londres, Angleterre;
Mrs. Myrna Bustani, administrateur de sociétés, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur A;
Sh. Fouad El-Khazen, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur A;
Mr. Fady A. El-Khoury, company director, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur B en remplacement

de Mrs. Mia El-Khoury Ayoub, administrateur B démissionnaire;

Mr. Nabil Iskandar A. El-Khoury, company director, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur B en rem-

placement de Mr. Camille A. El-Khoury, administrateur B démissionnaire;

Mr. Issam Shammas, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur C;
Mr. Nizam Shammas, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur C.
- Est nommée commissaire aux comptes pour le contrôle des comptes annuels et réviseur d’entreprises pour le con-

trôle des comptes consolidés, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2005:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06377. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063981.3/534/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ALIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 44.168. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2005 que:
- La démission de Madame L. Zenners de son poste d’administrateur de la société est acceptée et est élue comme

nouvel administrateur FIDIGA S.A., son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2010.

- Sont réélues aux postes d’administrateur, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 2010:

- Madame M.P. Van Waelem, demeurant à Luxembourg;
- Madame M.J. Renders, demeurant professionnellement à Luxembourg. 
- Est réélue au poste de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire sta-

tuant sur l’exercice 2010:

- EWA REVISION S.A., avec siège social à Bertrange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05722. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063854.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINANCIERE DE LA VALLEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.142. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06165, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063087.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Signature.

FINANCIERE DE LA VALLEE S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

63494

ATLAS TELECOM INTERACTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 53.802. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 4 juillet 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- décision a été prise d’accepter la révocation de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., siégeant au

2, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en tant que Commissaire et Réviseur d’Entreprises, et
ce avec effet rétroactif au 26 mai 2004;

- décision a été prise d’accepter la nomination de Monsieur Philippe Bednarek, né le 16 avril 1960 à Tourcoing (Fran-

ce) et résidant au 29A New Cavendish Street, W1G 9XA Londres, en tant que nouveau Commissaire, et ce avec effet
rétroactif au 26 mai 2004;

- décision a été prise d’accepter la nomination de la société DELOITTE S.A., enregistrée sous le numéro B 67.895 au

Registre du Commerce de Luxembourg et siégeant au 560, rue de Neudorf, L-1330 Luxembourg, en tant que nouveau
Réviseur d’Entreprises, et ce avec effet rétroactif au 26 mai 2004;

- décision a été prise de renouveler le mandat des administrateurs de la société, et ce jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07820. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063789.3/1005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

MARFINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 60.516. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires tenue le 10 juin 2005

1. L’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717

Luxembourg, au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg avec effet à la date de l’assemblée.

2. L’Assemblée Générale a accepté la démission des administrateurs suivants:
- Maître Simone Retter, Maître en droit, demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Madame Catherine Koch, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg;

- Madame Rita Goujon, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-

bourg.

3. L’Assemblée Générale a décidé de nommer les administrateurs suivants en remplacement des administrateurs dé-

missionnaires:

- Monsieur Steeve Simonetti, employé privé, avec adresse professionnelle au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxem-

bourg,

- Monsieur Guy Frisch, gérant de sociétés, avec adresse professionnelle au 5, rue Jules Fischer, L-1522 Luxembourg,
- Monsieur Patrick Sganzerla, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 17, rue des Jardiniers, L-1835

Luxembourg,

avec effet à la date de l’assemblée et pour une durée d’une année expirant lors de la prochaine assemblée générale

annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2005.

4. L’Assemblée Générale a décidé de reconduire le mandat du Commissaire, LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à

r.l., société établie et ayant son siège social au 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

pour une nouvelle période d’une année expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer

sur les comptes de la société au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05192. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063791.3/1005/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour ATLAS TELECOM INTERACTIVE S.A.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

MERCURIA SERVICES
Signature

63495

FINANCIERE GALATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.928. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue en date du 13 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE GA-

LATES S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L’assemblée a décidé de nommer, la société RUSHBURY
INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en Fran-

ce, avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Les différents mandats s’achèveront lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
2. L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Olivier Wusarczuc,

demeurant à Luxembourg, avec effet à ce jour. L’assemblée a décidé de nommer en son remplacement la société à res-
ponsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47,
route d’Arlon, pour une période de 3 ans.

Le mandat s’achèvera avec l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064236.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 56.512. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société FINBOURG FINANCE S.A. qui s’est tenue en date du 15

juin 2005 au siège social que:

1. Suite à la démission de Monsieur Gert Jan Pieters et à la ratification de la nomination de Monsieur Rob Smeele

comme administrateur, ainsi qu’à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2005, le Conseil d’administration se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg,

282, route de Longwy, Président du Conseil,

- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Switzerland,
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire.

2. A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale qui se pro-

noncera sur les comptes de l’exercice 2005:

- ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à L-5635 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063787.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINANCIERE EPEIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.837. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue en date du 13 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE

EPEIOS S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

63496

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L’assemblée a décidé de nommer, la société RUSHBURY
INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en Fran-

ce, avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Les différents mandats s’achèveront lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
2. L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Olivier Wusarczuc,

demeurant à Luxembourg, avec effet à ce jour. L’assemblée a décidé de nommer en son remplacement la société à res-
ponsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47,
route d’Arlon, pour une période de 3 ans.

Le mandat s’achèvera avec l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064237.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINANCIERE ZELOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.840. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue en date du 13 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE ZE-

LOS S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L’assemblée a décidé de nommer, la société RUSHBURY
INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en Fran-

ce, avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Les différents mandats s’achèveront lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
2. L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Olivier Wusarczuc,

demeurant à Luxembourg, avec effet à ce jour. L’assemblée a décidé de nommer en son remplacement la société à res-
ponsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47,
route d’Arlon, pour une période de 3 ans.

Le mandat s’achèvera avec l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064255.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINANCIERE THERO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.839. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue en date du 13 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE

THERO S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L’assemblée a décidé de nommer, la société RUSHBURY
INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en Fran-

ce, avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

63497

Les différents mandats s’achèveront lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
2. L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Olivier Wusarczuc,

demeurant à Luxembourg, avec effet à ce jour. L’assemblée a décidé de nommer en son remplacement la société à res-
ponsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47,
route d’Arlon, pour une période de 3 ans.

Le mandat s’achèvera avec l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064258.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINANCIERE OSINIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.929. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue en date du 13 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE OSI-

NIUS S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L’assemblée a décidé de nommer la société RUSHBURY
INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en Fran-

ce, avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Les différents mandats s’achèveront lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
2. L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Olivier Wusarczuc,

demeurant à Luxembourg, avec effet à ce jour. L’assemblée a décidé de nommer en son remplacement la société à res-
ponsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47,
route d’Arlon, pour une période de 3 ans.

Le mandat s’achèvera avec l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07142. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064260.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

WHITE EAGLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 65.807. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1

er

 juin 2005 que:

- Madame Meriel Ceridwen Jones-Avanzi et Madame Nicoletta Avanzi ont démissionné de leur fonction d’adminis-

trateur.

- Le nombre d’administrateurs a été réduit de 5 à 3.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07234. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063812.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

Pour extrait conforme
Signature

63498

JOFAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 56.714. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 janvier 2006 à 11.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2005 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,

le quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
I (04615/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALBA MASTER HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.640. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 janvier 2006 à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2005 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
I (04614/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LION CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.869. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>January 6th, 2006 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg

law on commercial companies of August 10th, 1915.

The Postponed Annual General Meeting of November 7th, 2005 could not deliberate in due form on this item of the

agenda as the quorum required by law was not attained.
I (04471/795/14) 

<i>The Board of Directors.

URBANINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.932. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>23 décembre 2005 à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004

63499

3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (04605/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COFINORD, COMPAGNIE FINANCIERE DU NORD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 7.377. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>23 décembre 2005 à 11.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04582/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BAY-RUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.691. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 décembre 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (04583/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COGENAF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 23.085. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>23 décembre 2005 à 15.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes

63500

6. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (04606/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLASTICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.457. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 janvier 2006 à 9.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2005 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
I (04613/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.439. 

The shareholders of the Company are hereby informed that the quorum of 50% of the outstanding shares required

to transfer the registered office of BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) (the «Company») to Sennin-
gerberg was not reached at the extraordinary general meeting («EGM») held on Wednesday 30 November 2005.

The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

has therefore been reconvened and will take place on Tuesday <i>3 January 2006 at 11.30 a.m. at the same place, being in
the offices of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., European Bank and Business Center, 6, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The agenda of the second EGM is the same as the agenda for the first EGM, i.e.:

<i>Agenda:

Transfer of the registered office of the Company to European Bank and Business Center, 6, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect from 3 April 2006 and subsequent amendment of
article 4 of the articles of incorporation of the Company.

In addition the annual general meeting of the Company (the «AGM» which should have been held on 30th November

2005 also had to be reconvened. Indeed, for technical reasons, the financial statements had not been finalised on time
in order for them to be sent to shareholders or be available at the registered office for the statutory period before the
AGM.

The ANNUAL GENERAL MEETING

will now take place on Tuesday <i>3 January 2006 at 11.00 a.m. at the offices of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
to resolve on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the Audited Annual Report of the Company for the financial year ended 31 July 2005.
2. Approval of the Board of Directors’ Report to the Shareholders for the financial year ended 31 July 2005.
3. Note the content of the Independent Auditor’s Report to the Shareholders for the financial year ended 31 July

2005.

4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the financial year

ended 31 July 2005.

5. Note the resignation of Mr. Matthew Payne as Director of the Company effective as of 15 September 2005.
6. Confirm appointment of Mr. Lorcan A. Murphy as Director of the Company effective as of 15 September 2005.
7. Re-election of the following persons as Directors: Mr. Philippe Hoss, Mr. Hugh Paul Shovlin, Mr. Martyn Scriven

and Mr. Marko Van Bergen.

8. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Independent Auditors of the Company to hold office for

the financial year ending 31 July 2006.

9. Allocation of the results in compliance with the proposal(s) of the Board of Directors.

10. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

63501

Shareholders who cannot be personally present at the shareholders’ meetings and wish to be represented may ap-

point a proxy to vote on their behalf. Proxies for the EGM and the AGM are available upon request at the registered
office of the Company.

To be valid, the proxy forms must be completed and sent to the attention of Ms. Marta Kozinska, fax number +352

46 26 85 825 prior to Friday 30 December 2005. The signed original should in addition be sent by mail to J.P. MORGAN
BANK LUXEMBOURG S.A.

Proxies sent for the EGM or the AGM of 30 November 2005 will remain valid. 
For the Board of Directors of BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), on 1st December 2005.

I (04616/755/48) 

JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 15.356. 

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>12. Dezember 2005 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2005
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Annahme des Rücktritts von Verwaltungsratsmitgliedern und Ernennung ihrer Nachfolger
5. Sonderentlastung an die zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates bis zum Da-

tum deren Rücktritts

6. Verschiedenes.

II (04266/795/17) 

<i>Der Verwaltungsrat.

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 décembre 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (04267/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALL-SPORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.673. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 décembre 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (04268/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

63502

FONTANINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.881. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 décembre 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (04269/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GEM-WORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.710. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GEM-WORLD à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>14 décembre 2005 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
– Approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2005
– Affectation des résultats
– Quitus aux Administrateurs
– Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
– Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (04440/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ECOMIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 20.043. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le lundi <i>12 décembre 2005 à 10.00 heures au siège de la société à Luxembourg, 7, rue du
Fort Rheinsheim avec le seul ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Elections statutaires.

II (04500/832/12) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JAFER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 25.932. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 décembre 2005 à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

63503

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04442/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RXP SERVICE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.901. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 décembre 2005 à 14.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04458/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BERGASA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.590. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 décembre 2005 à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04459/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARABOLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 18.513. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 décembre 2005 à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

63504

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04460/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LECO S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.969. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>14 décembre 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Lecture du rapport intermédiaire du liquidateur,
– Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 30 septembre 2005.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04506/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SPRING FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.901. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue Extraordinairement, qui aura lieu le <i>13 décembre 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

II (04537/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REALITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.756. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06188, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063105.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

REALITY S.A., Société Anonyme
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Gotam Umbrella Fund (Lux) Advisory Company

Univest

Holcim Finance (Luxembourg) S.A.

Henderson Indirect Property Fund (Europe) Management, S.à r.l.

Odyssey Group S.A.

Hifitel S.A.

Vive les Mariés

Les Sens du Vin, S.à r.l.

FBL, Fortis Banque Luxembourg

FBL, Fortis Banque Luxembourg

Alu-Fer, S.à r.l.

The UBK French Property Company (No 2), S.à r.l.

Anin S.A.

Caspan Equity S.A.

Sainternational S.A.

Finsai International S.A.

Sailux S.A.

Provincial Capital Securities S.A.

Provincial Capital Securities S.A.

Provincial Capital Securities S.A.

Provincial Capital Securities S.A.

Provincial Capital Securities S.A.

Provincial Capital Securities S.A.

Provincial Capital Securities S.A.

Provincial Capital Securities S.A.

Finluxinfo Holding S.A.

NLG Acquisition Holdings S.C.A.

Agharti S.A.

Agharti S.A.

Financière Themisto S.A.

Lux-Lorraine Invest Holding S.A.

J. Hirsch &amp; Co International

Clarins Luxembourg S.A.

S.C.P., Security Consulting Professionnals S.A.

C.A.T. Holding S.A.

Alimmo S.A.

Financière de la Vallée S.A.

Atlas Telecom Interactive S.A.

Marfinco S.A.

Financière Galates S.A.

Finbourg Finance S.A.

Financière Epeios S.A.

Financière Zelos S.A.

Financière Thero S.A.

Financière Osinius S.A.

White Eagle Holding S.A.

Jofad Holding S.A.

Alba Master Holding Company S.A.

Lion Capital Markets S.A.

Urbaninvest S.A.

COFINORD, Compagnie Financière du Nord

Bay-Rum Immobilière S.A.

Cogenaf S.A.

Plastichem S.A.

Barclays Investment Funds (Luxembourg)

Janek Holding S.A.

Frazil S.A.

All-Sport International Holding S.A.

Fontanina Holding S.A.

Gem-World

Ecomin S.A.

Jafer S.A.

RXP Service S.A.

Bergasa Holding S.A.

Parabole S.A.

Leco S.A.

Spring Financial Investment S.A.

Reality S.A.