This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
62977
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1313
2 décembre 2005
S O M M A I R E
LUXEMBOURG NORTH DISTRIBUTION, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.397.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05023, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063067.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
A.I.J.A., Association Internationale des Jeunes
Island Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
63021
Avocats, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
63021
Island Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
63021
Addison Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
62981
Lagomar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
63018
Addison Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
63000
Luxembourg North Distribution S.A., Luxem-
Aquarelle Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
63018
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62977
Artotal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63020
Luxenergie S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .
63023
B.C. Gesellschaft Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
63022
Luxenergie S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .
63023
Elvira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63019
Luxenergie S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .
63023
Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-
Luxenergie S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .
63023
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63011
Mobile Signal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
63000
Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-
North Line Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
63018
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63013
North Line Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
63018
Fenster Mersch S.A., Brachtenbach . . . . . . . . . . . . .
62981
P.I.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63020
Fipop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63004
PEF V Zelmer Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . .
63017
Fishing und Camping A.G., Luxembourg. . . . . . . . .
63021
Société Financière de l’Energie «SOFINEN»
Fonds de Pension - Députés au Parlement Euro-
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62980
péen, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63022
Société Hôtelière Europe S.A., Luxembourg . . . .
63015
Gamax Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
63022
Telco Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
62978
Great Mountain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
62980
Telco Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
62979
Great Mountain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
62980
Vins Descombe International, S.à r.l., Luxem-
Héraclès S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62978
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63019
Héraclès S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62978
Winrock Resorts and Properties S.A., Luxem-
HIG International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
63020
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63024
I.D.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63013
Winrock Resorts and Properties S.A., Luxem-
I.D.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63015
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63024
Immovacances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
62981
Winrock Resorts and Properties S.A., Luxem-
Investments Novapol S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
63019
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63024
Investments Solapol S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
63019
Luxembourg, le 14 juillet 2005.
Signature.
62978
HERACLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.945.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 28 juin 2005i>
Les mandats de Alain Frechard, administrateur-délégué, Philippe Schneider et Christophe Brayer, administrateurs, et
le mandat de Michel Vacelet, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’As-
semblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2010.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31
décembre 2010 se compose comme suit:
- Alain Frechard, informaticien, demeurant à 8, rue de la Forêt, F-57140 Woippy, administrateur-délégué;
- Philippe Schneider, informaticien, demeurant à 2, impasse Hercule, F-57330 Hettange-Grande;
- Christophe Brayer, informaticien, demeurant à 12, rue Aubertin, F-57000 Metz.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:
- Michel Vacelet, informaticien, demeurant à 13, rue du Petit Arbois, F-54520 Laxou.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06724. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062474.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
HERACLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06750, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062493.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
TELCO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 99.920.
—
EXTRAIT
Il résulte de conventions de transfert de parts sociales prenant effet le 28 juin 2005 que:
- PERMIRA EUROPE III L.P.1, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, a trans-
féré à SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-
bourg, les parts suivantes dans la Société:
- 10.548 parts sociales A;
- 51.366 parts sociales B;
- 77.049 parts sociales C;
- 102.732 parts sociales D.
- PERMIRA EUROPE III L.P.2, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, a trans-
féré à SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., précitée, les parts sociales suivantes dans la Société:
- 30.436 parts sociales A;
- 148.210 parts sociales B;
- 222.315 parts sociales C;
- 296.420 parts sociales D.
- PERMIRA EUROPE III GmbH & Co KG, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guer-
nesey a transféré à SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., précitée, les parts sociales suivantes dans la Société:
- 398 parts sociales A;
- 1.940 parts sociales B;
- 2.910 parts sociales C;
- 3.880 parts sociales D.
- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernesey a transféré à SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., précitée, les parts sociales suivantes dans la
Société:
- 258 parts sociales A;
Pour extrait sincère et conforme
HERACLES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 11 juillet 2005.
Signature.
62979
- 1.254 parts sociales B;
- 1.881 parts sociales C;
- 2.508 parts sociales D.
- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey,
a transféré à SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., précitée, les parts sociales suivantes dans la Société:
- 752 parts sociales A;
- 3.660 parts sociales B;
- 5.490 parts sociales C;
- 7.320 parts sociales D.
- DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS Gbr, ayant son siège social à Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart, Alle-
magne, a transféré à SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., précitée, les parts sociales suivantes dans la Société:
- 3.608 parts sociales A;
- 17.570 parts sociales B;
- 26.355 parts sociales C;
- 35.140 parts sociales D.
Il en résulte, qu’à compter du 28 juin 2005, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02292. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062514.3/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
TELCO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 99.920.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un avis de rachat de parts sociales propres prenant effet le 30 juin 2005 que:
- TELCO HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, a racheté ses
propres parts sociales à SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, avenue Emile Reuter,
L-2420 Luxembourg, comme suit:
- 46.000 parts sociales A
- 224.000 parts sociales B
- 336.000 parts sociales C
- 448.000 parts sociales D
Il en résulte, qu’à compter du 30 juin 2005, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.135 parts sociales A
PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.669 parts sociales A
PERMIRA EUROPE III GmbH & Co KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
572 parts sociales A
PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369 parts sociales A
PERMIRA INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.078 parts sociales A
DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.177 parts sociales A
SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.000 parts sociales A
224.000 parts sociales B
336.000 parts sociales C
448.000 parts sociales D
Total parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112.000
Total parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224.000
Total parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336.000
Total parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.120.000
S. Michel
<i>Gérantei>
PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.135 parts sociales A
PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.669 parts sociales A
PERMIRA EUROPE III GmbH & Co KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
572 parts sociales A
PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369 parts sociales A
PERMIRA INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.078 parts sociales A
DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.177 parts sociales A
TELCO HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.000 parts sociales A
224.000 parts sociales B
336.000 parts sociales C
448.000 parts sociales D
62980
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02295. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062516.3//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
GREAT MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.402.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 16 juin 2005 i>
Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31
décembre 2009 se compose comme suit:
* Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg;
* Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg;
* Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
* Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06725. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062476.3/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
GREAT MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.402.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06754, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062495.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
SOCIETE FINANCIERE DE L’ENERGIE «SOFINEN» S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 17.682.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2005i>
L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur René Schlim en remplacement de Monsieur Robert
Reckinger. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2009.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03914. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(062653.3/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
Total parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112.000
Total parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224.000
Total parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336.000
Total parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.120.000
S. Michel
<i>Gérantei>
GREAT MOUNTAIN S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 11 juillet 2005.
Signature.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
62981
FENSTER MERSCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9641 Brachtenbach, Maison 2A.
R. C. Luxembourg B 101.438.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2005i>
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.,
et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Septième résolutioni>
En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, l’assemblée générale décide de nommer:
SOFINTER GESTION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activité
Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.316.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2006.
Brachtenbach, le 9 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05148. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062647.3/820/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
IMMOVACANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 62.463.
—
MORGANE INTERTRADE LTD démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec effet im-
médiat au jour de la présente.
Le 29 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05289. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(062722.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
ADDISON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 108.506.
—
In the year two thousand five, on the seventeenth day of the month of June.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ADDISON LUXEMBOURG S.A., a société
anonyme - Aktiengesellschaft governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-
1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under section B, number 108.506 (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary of
May 27, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is declared open at 06.50 p.m. with Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the purpose of the meeting is record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To create three classes of shares, the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares, having the rights
and privileges attached thereto following a restatement of the articles, and to convert twenty-four thousand seven hun-
dred ninety-nine (24,799) existing shares, each with a nominal value of one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25), into
twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) Class A Shares and one (1) existing share into one (1) Class
B Share having a nominal value of one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25).
2. To increase the corporate capital by an amount of two million three hundred forty-one thousand five hundred
Euro (EUR 2,341,500.-) so as to raise it from its amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to two million three
hundred seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 2,372,500.-).
3. To issue six hundred ninety-five thousand two hundred and one (695,201) new Class A Shares, so that the amount
of Class A Shares is increased from currently twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) Class A Shares
to seven hundred twenty thousand (720,000) Class A Shares, forty-one thousand nine hundred ninety-nine (41,999)
Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
<i>Pour MORGANE INTERTRADE LTD
i>A. Lorang
62982
Class B Shares, so that the amount of Class B Shares is increased from currently one (1) Class B Share to forty-two
thousand (42,000) Class B Shares, and one million one hundred thirty-six thousand (1,136,000) Class C Shares, with a
nominal value of one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each.
4. To accept subscription
(i) for six hundred ninety-five thousand two hundred and one (695,201) new Class A Shares by ROWAN NOMINEES
LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at One Canada
Square, London E14 5AL, United Kingdom, as nominee of:
- HG INVESTMENT MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of England, with registered office at
Third Floor, Minerva House, 3-5 Montague Close, London SE 9BB, United Kingdom, in its capacity as a duly authorised
representative of MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED and on behalf of MERRILL LYNCH INVEST-
MENT MANAGERS LIMITED’s discretionary fund management clients, the latter one being the economic beneficiary of
one hundred and thirty-five thousand seven hundred eighty-five (135,785) new Class A Shares to be subscribed by
ROWAN NOMINEES LIMITED,
- HGT L.P., a company governed by the laws of England, with registered office at Third Floor, Minerva House, 3-5
Montague Close, London SE 9BB, United Kingdom, being the economic beneficiary of one hundred fifteen thousand
eight hundred fifty-nine (115,859) new Class A Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- HG CAPITAL CO-INVESTMENT PLAN, with its office at Third Floor, Minerva House, 3-5 Montague Close, London
SE 9BB, United Kingdom, being the economic beneficiary of five thousand four hundred sixty-five (5,465) new Class A
Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- MUST 4 GmbH & CO. KG, a company governed by the laws of Germany, with registered office at Maria Theresia
Straße 5, 81675 Munich, Federal Republic of Germany, being the economic beneficiary of twenty-five thousand nine hun-
dred fifty-nine (25,959) new Class A Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- MUST 4 L.P., a company governed by the laws of the Channel Islands, with registered office at 13-15 Victoria Road,
St. Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, Channel Islands, being the economic beneficiary of two hundred ninety-two thou-
sand four hundred sixty-one (292,461) new Class A Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- MUST 4 «B» L.P., a company governed by the laws of the Channel Islands, with registered office at 13-15 Victoria
Road, St. Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, Channel Islands, being the economic beneficiary of thirty-seven thousand two
hundred thirty-one (37,231) new Class A Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- GKN SPLP 2 L.P., a company governed by the laws of the Channel Islands, with registered office at Alexander House,
13-15 Victoria Road, St. Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, Channel Islands, being the economic beneficiary of twenty-
four thousand two hundred forty-seven (24,247) new Class A Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIM-
ITED, and
- RR SPLP 2 L.P., a company governed by the laws of the Channel Islands, with registered office at Alexander House,
13-15 Victoria Road, St. Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, Channel Islands, being the economic beneficiary of fifty-eight
thousand one hundred ninety-four (58,194) new Class A Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
(ii) for thirty-two thousand (32,000) Class B Shares by Mr Michael Röchner, residing at Stuttgarter Straße 35, 71638
Ludwigsburg, Federal Republic of Germany, for six thousand (6,000) new Class B Shares by Mr Brian Cook, residing at
85 Fairway avenue, Rye, New York 10580, United States of America, for three thousand nine hundred ninety-nine
(3,999) new Class B Shares by Mr Richard P. W. Donner, residing at Tudor Lodge, Hendon Wood Lane, Mill Hill, Lon-
don NW7, United Kingdom,
(iii) for one million one hundred thirty-six thousand (1,136,000) Class C Shares by ROWAN NOMINEES LIMITED,
prenamed, as nominee for
- HG INVESTMENT MANAGERS LIMITED, prenamed, in its capacity as a duly authorised representative of MERRILL
LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED and on behalf of MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMIT-
ED’s discretionary fund management clients, the latter one being the economic beneficiary of two hundred fourteen
thousand two hundred thirty-eight (214,238) Class C Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- HGT L.P., prenamed, being the economic beneficiary of two hundred twenty-one thousand nine hundred twenty-
eight (221,928) Class C Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- HG CAPITAL CO-INVESTMENT PLAN, prenamed, being the economic beneficiary of eight thousand six hundred
twenty-three (8,623) Class C Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- MUST 4 GmbH & CO. KG, prenamed, being the economic beneficiary of forty thousand nine hundred fifty eight
(40,958) Class C Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- MUST 4 L.P., prenamed, being the economic beneficiary of four hundred sixty-one thousand four hundred thirty-
nine (461,439) Class C Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- MUST 4 «B» L.P., prenamed, being the economic beneficiary of fifty-eight thousand seven hundred forty-one
(58,741) Class C Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
- GKN SPLP 2 L.P., prenamed, being the economic beneficiary of thirty-eight thousand two hundred fifty-seven
(38,257) Class C Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED, and
- RR SPLP 2 L.P., prenamed, being the economic beneficiary of ninety-one thousand eight hundred sixteen (91,816)
Class C Shares to be subscribed by ROWAN NOMINEES LIMITED,
to accept payment in full for such new shares by contributions in cash by the respective economic beneficiaries and
individuals, to allot these new shares to the subscribers in consideration for such contributions in cash and to acknowl-
edge the effectiveness of the capital increase.
5. To fully restate the articles of incorporation of the Company, which restatement shall consist inter alia in adopting
the following corporate object:
62983
«3. Object
3.1 The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/
or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the
direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members
of its group of companies.
3.2 The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner
any stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or issue any subscription rights (including share warrants) and/or debt in-
struments in any form whatsoever and (v) carry out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or
financial, with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with its object.»
6. To grant full discharge to Mr Franz Schaefer, Mr Stephan Morsch and Mr Timo Engelhardt for the fullfilment of
their duties as Directors of the Company, to acknowledge their resignation as Directors, and to appoint each of Ms Lisa
Stone, Mr Richard P.W. Donner, Mr Kai Romberg, Mr Michael Röchner and Mr Brian Cook as new Directors of the
Company, each time for a period expiring at the annual general meeting to be held in 2006.
7. To grant full discharge to Mr Wolfgang Essler for the fullfilment of his duties as statutory auditor of the Company,
to acknowledge his resignation as statutory auditor and to appoint DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, as new stat-
utory auditor of the Company for a period expiring at the annual general meeting to be held in 2006.
8. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders meeting resolves to create three classes of shares, the Class A Shares, the Class B Shares and the
Class C Shares, having the rights and privileges attached thereto following a restatement of the articles, and to convert
twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) existing shares, each with a nominal value of one Euro and
twenty-five cent (EUR 1.25), into twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) Class A Shares and one (1)
existing share into one (1) Class B Share having a nominal value of one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25).
<i>Second resolutioni>
The shareholders meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of two million three hundred for-
ty-one thousand five hundred Euro (EUR 2,341,500.-) so as to raise it from its amount of thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-) to two million three hundred seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 2,372,500.-).
<i>Third resolutioni>
The shareholders meeting resolves to issue six hundred ninety-five thousand two hundred and one (695,201) new
Class A Shares, so that the amount of Class A Shares is increased from currently twenty-four thousand seven hundred
ninety-nine (24,799) Class A Shares to seven hundred twenty thousand (720,000) Class A Shares, forty-one thousand
nine hundred ninety-nine (41,999) Class B Shares, so that the amount of Class B Shares is increased from currently one
(1) Class B Share to forty-two thousand (42,000) Class B Shares, and one million one hundred thirty-six thousand
(1,136,000) Class C Shares, with a nominal value of one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each.
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared Maître Manfred Müller, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of
(i) ROWAN NOMINEES LIMITED, acting in its capacity as nominee of HG INVESTMENT MANAGERS LIMITED, pre-
named, HgT L.P., prenamed, HGCAPITAL CO-INVESTMENT PLAN, prenamed, MUST 4 L.P., prenamed, MUST 4 «B»
L.P., prenamed, MUST 4 GmbH & CO. KG, prenamed, GKN SPLP 2 L.P., prenamed, RR SPLP 2 L.P., prenamed, (ii) Mr
Michael Röchner, prenamed, (iii) Mr Brian Cook, prenamed, and (iv) Mr Richard P. W. Donner, prenamed (the «Sub-
scribers»), by virtue of the same proxies as mentioned above.
62984
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscribers for the number and class
of shares mentioned hereafter and to make payment in full for each such new share thus subscribed by contributions in
cash (the «Contributions»), for the amounts mentioned hereafter:
The Contributions thus represent a contribution in an aggregate amount of two million three hundred forty-one
thousand five hundred Euro (EUR 2,341,500).
In addition, twenty-three thousand two hundred and fifty Euro (EUR 23,250) have been paid-in on the twenty-four
thousand eight hundred (24,800) shares issued and paid-up to twenty-five percent (25%) at incorporation of the Com-
pany, so that these shares, which have been converted into twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799)
Class A Shares and one (1) Class B Share pursuant to the above first resolution, are now also fully paid-in.
Proof of such payments has been given to the undersigned notary and the amount of two million three hundred sixty-
four thousand seven hundred fifty Euro (EUR 2,364,750) is now at the disposal of the Company.
Thereupon, the shareholders meeting resolves (i) to accept the said subscriptions and payments by the Subscribers,
(ii) to allot the six hundred ninety-five thousand two hundred and one (695,201) new Class A Shares, the forty-one
thousand nine hundred ninety-nine (41,999) Class B Shares and the one million one hundred thirty-six thousand
(1,136,000) Class C Shares to the Subscribers as stated above, and (iii) to acknowledge the effectiveness of the capital
increase.
<i>Fourth resolutioni>
On the basis of a report adopted by the Board of Directors with respect to the creation of an authorised capital, a
copy of which shall be attached to the present minutes for registration purposes, the shareholders meeting resolves to
fully restate the articles of incorporation of the Company, which restatement, next to reflecting the above changes to
the issued capital, shall consist inter alia in creating an authorised capital with the capacity of the Board of Directors to
limit or cancel any preferential subscription rights upon the issue of shares under the authorised share capital.
The articles of incorporation shall consequently forthwith read as follows:
«I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form, Name
1.1 There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
created a company (the «Company») in the form of a Société anonyme - Aktiengesellschaft which will be governed by
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles (the «Articles of Incorporation»).
1.2 The Company will exist under the name of ADDISON LUXEMBOURG S.A.
2. Registered Office
2.1 The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
Shareholders
subscribed and
paid-in capital
(EUR)
number of shares and
class of shares
ROWAN NOMINEES LIMITED, in its capacity as nominee of
HG INVESTMENT MANAGERS LIMITED the latter one in its
capacity as duly authorized representative of MERRILL LYNCH
INVESTMENT MANAGERS LIMITED and on behalf of MER-
RILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED’s discre-
tionary fund management clients
169,731.25
267,797.5
135,785 Class A Shares
214,238 Class C Shares
ROWAN NOMINEES LIMITED, in its capacity as nominee of
HGT L.P.
144,823.75
277,410
115,859 Class A Shares
221,928 Class C Shares
ROWAN NOMINEES LIMITED, in its capacity as nominee of
HG CAPITAL CO-INVESTMENT PLAN
6,831.25
10,778.75
5,465 Class A Shares
8,623 Class C Shares
ROWAN NOMINEES LIMITED, in its capacity as nominee of
MUST 4 GmbH & CO. KG
32,448.75
51,197.5
25,959 Class A Shares
40,958 Class C Shares
ROWAN NOMINEES LIMITED, in its capacity as nominee of
MUST 4 L.P.
365,576.25
576,798.75
292,461 Class A Shares
461,439 Class C Shares
ROWAN NOMINEES LIMITED, in its capacity as nominee of
MUST 4 «B» L.P.
46,538.75
73,426.25
37,231 Class A Shares
58,741 Class C Shares
ROWAN NOMINEES LIMITED, in its capacity as nominee of
GKN SPLP 2 L.P.
30,308.75
47,821.25
24,247 Class A Shares
38,257 Class C Shares
ROWAN NOMINEES LIMITED, in its capacity as nominee of
RR SPLP 2 L.P.
72,742.5
114,770
58,194 Class A Shares
91,816 Class C Shares
Michael Röchner
40,000
32,000 Class B Shares
Brian Cook
7,500
6,000 Class B Shares
Richard P.W. Donner
4,998.75
3,999 Class B Shares
Total
869,001.25
695,201 Class A Shares
52,498.75
41,999 Class B Shares
1,420,000
1,136,000 Class C Shares
2,341,500
62985
2.2 The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Directors.
2.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the Board of Directors.
2.4 In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will
be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of
the Company.
3. Object
3.1 The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/
or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the
direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members
of its group of companies.
3.2 The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner
any stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any subscription rights (including share warrants) and/or
debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial
or financial, with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with its object.
4. Duration
4.1 The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 It may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the quorum and majority rules provided by
law.
II. Capital, Shares
5. Corporate Capital
5.1 The subscribed capital of the Company is set at two million three hundred seventy-two thousand five hundred
Euro (EUR 2,372,500.-) divided into seven hundred and twenty thousand (720,000) class A shares (the «Class A Shares»)
with a nominal value of one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, forty-two thousand (42,000) class B shares
(the «Class B Shares») with a nominal value of one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, and one million one
hundred and thirty-six thousand (1,136,000) class C shares (the «Class C Shares») with a nominal value of one Euro and
twenty-five cent (EUR 1.25) per share. All the shares are fully paid up.
5.2 The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in the Articles of Incorporation, shall
be identical except to the extend otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.
5.3 The authorised capital of the Company is set at one million one hundred eighty-six thousand two hundred fifty
Euro (EUR 1,186,250.-) divided into three hundred sixty thousand (360,000) Class A Shares, twenty-one thousand
(21,000) Class B Shares and five hundred sixty-eight thousand (568,000) Class C Shares. Each authorised share has a
nominal value of one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25).
5.4 The Board of Directors is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any
increase of the corporate capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of
the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorised capital
under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar in-
struments), convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of
new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company
or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms
and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential sub-
scription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a
period ending 5 (five) years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial
and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum
and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these
Articles of Association.
5.5 The Board of Directors may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and
receiving payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.
5.6 Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in
the form provided for by the Laws, this Section will be modified so as to reflect the actual increase. Such modification
will be recorded in authentic form by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by the
Board of Directors for this purpose.
62986
5.7 In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for
the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses,
to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
6. Shares
6.1 The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.
6.2 If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will
be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication
of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and
the dates thereof.
6.3 Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Com-
pany will be entitled to rely on the last address thus communicated.
6.4 Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
6.5 The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated
and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.
6.6 Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
6.7 The Company may issue multiple share certificates.
7. Dividend and Liquidation Preference
7.1 Each holder of Class C Shares shall be entitled to an annual dividend preference to the amount of eight percent
(8%) of the amounts paid by the respective shareholder for the acquisition of the Class C Shares in the course of their
issuance.
7.2 In case of liquidation of the Company, each holder of Class C Shares shall be entitled to a liquidation preference
equalling to the amounts paid by the respective shareholder for the acquisition of the Class C Shares in the course of
their issuance plus the cumulative dividend preference referred to in Section 7.1 (in so far as not yet paid according to
Section 7.1).
8. Sale and Disposal of Shares
8.1 Each holder of the Class B Shares undertakes to the Class A shareholders not to, nor to agree to, do any of the
following without the prior written consent of the Class A shareholders:
(i) pledge, charge or otherwise encumber any of his shares in the Company or any interest in any of his shares in the
Company;
(ii) sell, transfer or otherwise dispose of, or grant any option over, any of his shares in the Company or any interest
in his shares in the Company to a person which is not a Permitted Transferee as defined below; or
(iii) enter into any agreement in respect of the votes attached to any of his shares in the Company.
8.2 Except if otherwise agreed between the shareholders, each Class B shareholder shall be entitled to transfer his
shares in the Company in whole or in part without the consent of the Class A shareholders to the following permitted
transferees («Permitted Transferees»):
(i) his spouse;
(ii) his adult children or adult step children; or
(iii) to the a company set up wholly for his benefit, or that of his spouse, children or step children, whereby the shares
in such company may only be transferred upon prior approval by all shareholders of the Company.
8.3 The Class A shareholders shall be entitled to freely dispose of their shares in the Company.
9. Pre-emption Right
9.1 In the event of the sale of shares by a Class B shareholder to which the Class A shareholders shall have consented,
the Class A shareholders are entitled to pre-emption.
9.2 The pre-emption right shall be allocated to the Class A shareholders in the proportion, in which the nominal
amounts of their shares in the Company relate to each other. Where a Class A shareholder fails to exercise his pre-
emption right or fails to do so by the due date, this pre-emption right shall accrue to the other Class A shareholders in
accordance with the ratio to which the nominal amounts of their shares relate to each other.
9.3 In case the Class B shareholder intends to sell his shares, he shall immediately notify the Class A shareholders of
the complete content of the contract entered into with the respective purchaser by delivery of a copy. The pre-emption
right may only be exercised within one month after receipt of such notification and only by written declaration vis-à-vis
the Class B shareholder. The pre-emption right accruing pursuant to Section 9.2, sentence 2, may only be exercised
within one month after receipt of the notification of accretion by the Class B shareholder and only by written declaration
vis-à-vis the Class B shareholder.
9.4 A Class A shareholder may exercise his pre-emption right only with respect to the entire shares to which he is
entitled from the outset pursuant to Section 9.2, sentence 1, and all shares accruing to him subsequently pursuant to
Section 9.2, sentence 2. If two or more Class A shareholders should exercise their pre-emption rights, the shares shall
be divided accordingly. Non-divisible fractions of shareholdings shall be allocated to the Class A shareholder first to
exercise his pre-emption right.
9.5 The provisions of this Section 9 shall not apply to the cases dealt with in Section 8.2, Section 10 and in such cases
the shareholders may from time to time agree on.
62987
9.6 For the avoidance of doubt, it shall be clarified, that the Class A shareholders may exercise their pre-emption
right under this Section 9 also in case they have granted their consent to the respective share transfer in accordance
with Section 8.1.
10. Drag-Along Right, Tag-Along Right
10.1 If one or more of the Class A shareholders, collectively entitled to more than fifty percent (50%) of the votes
in the Company receive an offer from a third party/third parties which is neither a shareholder nor an affiliated company
of a shareholder nor another fund managed or advised by one of the Class A shareholders («Third Party» or «Third
Parties») for the purchase of more than fifty percent (50%) of the entire share capital of the Company and if such Class
A shareholders decide to accept such an offer, or, in case the Class A shareholders make such offer to a Third Party or
to Third Parties, and the Third Party/Third Parties decide(s) to accept such offer, the other shareholders shall, upon
request of these Class A shareholders, be obliged to sell the same percentage of their shares in the Company as such
Class A shareholders (the determination of the percentage shall be calculated on the basis of the total amount of shares
in the Company collectively held by such Class A shareholders and the total amount of shares which shall be collectively
sold by such Class A shareholders) together with these Class A shareholders on the same terms as agreed between the
Third Party/Third Parties and the respective Class A shareholder(s) («Drag-Along Right»). The request by the share-
holder(s) shall be made in writing vis-à-vis the respective other shareholders.
10.2 If one or more of the Class A shareholders decide to sell all or parts of their shares in the Company to a Third
Party/Third Parties which would thereby acquire more than fifty percent (50%) of the entire share capital of the Com-
pany, such Class A shareholders shall agree with the Third Party/Third Parties interested in acquiring the shares, that
such Third Party/Third Parties must offer to the other Shareholders to acquire the same percentage of shares held by
them as they intend to acquire from the respective Class A shareholders (the determination of the percentage shall be
calculated on the basis of the total amount of shares in the Company collectively held by such Class A shareholders and
the total amount of shares which shall be collectively acquired from such Class A shareholders by the Third Party/Third
Parties) on the same terms as offered by the Class A shareholders who decided to sell their shares («Tag-Along Right»).
The Tag-Along Right has to be exercised within a period of thirty (30) calendar days following the receipt of such offer
from the Third Party/Third Parties by written notice to the Third Party/Third Parties and to the respective Class A
shareholders or shall otherwise be forfeited.
10.3 The Drag-Along Right and the Tag-Along Right shall apply accordingly to cases of exchange, contribution, merg-
ers as well as comparable share transfers.
11. Increase and Reduction of Capital
11.1 The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the General
Meeting voting with the quorum and majority rules set out by these Articles of Incorporation for any amendment there-
of, unless otherwise provided by law.
11.2 The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing share-
holders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall de-
termine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than
thirty (30) days.
11.3 Notwithstanding the above, the General Meeting, voting with the quorum and majority rules set out by these
Articles of Incorporation for any amendment thereof, unless otherwise provided by law, may limit or withdraw the pref-
erential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.
12. Acquisition of Company’s Own Shares
12.1 The Company may acquire its own shares.
12.2 The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by
the law.
III. Board of directors, Statutory auditors
13. Board of Directors
13.1 The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least
three (3) and up to six (6) members who need not be shareholders (the «Directors»).
13.2 The Directors will be elected by the General Meeting, which will determine their number, for a period not ex-
ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
13.3 In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority
vote a Director to fill such vacancy until the next General Meeting.
14. Meetings of Board of Directors
14.1 The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint
a secretary, who need not be a Director and who will among others be responsible for keeping the minutes of the meet-
ings of the Board of Directors and of the General Meetings.
14.2 The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be con-
vened if any four Directors so require.
14.3 The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and at General Meetings, except that in his
absence the Board of Directors may appoint another Director and the General Meeting may appoint any other person
as chairman pro tempore by vote of the majority of the Directors or, as the case may be, of the shareholders present
or represented at such meeting.
62988
14.4 Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least ten (10) days’ advance
notice of each meeting of the Board of Directors and of each committee (if any) of the Board of Directors shall be given
to each Director, such notice to be accompanied by a written agenda specifying the business to be transacted at such
meeting and, at least five (5) days prior to the meeting, all papers to be circulated or presented to the same shall be sent
to each Director. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature
of the business to be transacted.
14.5 The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice
is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board
of Directors.
14.6 Every meeting of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Di-
rectors may from time to time determine.
14.7 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram
another Director as his proxy.
14.8 A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors
holding office.
14.9 Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
14.10 In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been
adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or sev-
eral Directors.
15. Minutes of Meetings of Board of Directors
15.1 The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting. Any proxies
will remain attached thereto.
15.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.
16. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved
by law to the General Meeting) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All pow-
ers not expressly reserved by law to the General Meeting are in the competence of the Board of Directors.
17. Delegation of Powers
17.1 The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Com-
pany within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who
may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or tem-
porary functions to persons or agents chosen by it.
17.2 Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by
the General Meeting.
18. Conflict of Interests
18.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or
is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter,
any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.
18.2 Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal
interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and
shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein
shall be reported to the next General Meeting.
18.3 The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against ex-
penses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
19. Representation of Company
19.1 The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors or by the single
signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily manage-
ment, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated
by the Board of Directors, but only within the limits of such power.
62989
20. Statutory Auditors
20.1 The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not be share-
holders.
20.2 The auditors will be elected by the General Meeting, which will determine the number of such auditors, for a
period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term
as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a res-
olution of the General Meeting.
IV. Meeting of shareholders
21. Powers of Meeting of Shareholders
21.1 Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders
(the «General Meeting»).
21.2 It has the powers conferred upon it by law.
22. Annual General Meeting
22.1 The annual General Meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday of May of each calendar year, between 8 a.m.
and 5 p.m. (local time).
22.2 If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
23. Other General Meetings
23.1 The Board of Directors may convene other General Meetings. Such meetings must be convened if shareholders
representing at least one fifth of the Company’s capital so require.
23.2 General Meetings, including the annual General Meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of
Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
24. Procedure, Vote
24.1 Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance
with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place
of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
24.2 If all the shareholders are present or represented at a General Meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
24.3 A shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing, by fax or by telegram as his proxy an-
other person who need not be a shareholder.
24.4 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Gen-
eral Meeting.
24.5 Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a
simple majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the General Meeting.
24.6 One vote is attached to each share.
24.7 Copies or extracts of the minutes of the General Meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise
will be signed by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.
V. Financial year, Distribution of profits
25. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and ac-
counting practice.
26. Appropriation of Profits
26.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.
26.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may
decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the
next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
26.3 Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends.
The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
VI. Dissolution, Liquidation
27. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting voting with the quorum and majority rules
set out by these Articles of Incorporation for any amendment thereof, unless otherwise provided by law. Should the
Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting,
which will determine their powers and their compensation.
VII. Applicable Law
28. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.»
62990
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders meeting resolves to grant full discharge to Mr Franz Schaefer, Mr Stephan Morsch and Mr Timo
Engelhardt for the fulfillment of their duties as Directors of the Company, to acknowledge their resignation as Directors,
to fix the number of Directors at five (5) and to appoint each of the following as new Directors of the Company, each
time for a period expiring at the annual general meeting to be held in 2006:
- Ms Lisa Stone, Investment Manager, with business address at Minerva House, 3-5 Montague Close, London, SE1
9BB, United Kingdom;
- Mr Richard P. W. Donner, Investment Banker, residing at Tudor Lodge, Hendon Wood Lane, Mill Hill, London
NW7, United Kingdom;
- Mr Kai Romberg, Investment Manager, with business address at Minerva House, 3-5 Montague Close, London, SE1
9BB, United Kingdom;
- Mr Michael Röchner, Managing Director, residing at Stuttgarter Straße 35, 71638 Ludwigsburg, Germany; and
- Mr Brian Cook, Corporate Finance Advisor, residing at 12, Lyndhurst Road, London NW3 5NL, United Kingdom.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders meeting resolves to grant full discharge to Mr Wolfgang Essler for the fulfillment of his duties as
statutory auditor of the Company, to acknowledge his resignation as statutory auditor, to fix the number of statutory
auditors at one (1) and to appoint the following as new statutory auditor of the Company for a period expiring at the
annual general meeting to be held in 2006:
- DELOITTE S.A., Luxembourg, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 7.30 p.m.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at twenty-six thousand five hundred Euro.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, said persons signed together with us notary this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünf, am siebzehnten Tag des Monats Juni,
vor Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der ADDISON LUXEMBOURG S.A. statt, einer
Société anonyme - Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen ins Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 108.506 (die «Gesellschaft»), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden
Notar am 27. Mai 2005, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Die Hauptversammlung wird eröffnet um 18.50 Uhr durch den Vorsitzenden, Herrn Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt,
wohnhaft in Luxemburg,
der Herrn Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.
Die Versammlung wählt Herrn Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmzähler.
Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
(i) Zielsetzung der Hauptversammlung ist, Beschlüsse aufzunehmen, die aufgrund folgender Tagesordnung zu treffen
sind:
<i>Tagesordnung:i>
1. Schaffung dreier Kategorien von Aktien, und zwar der Kategorien der A-Aktien, der B-Aktien und der C-Aktien,
die mit den Rechten und Privilegien gemäß einer Neufassung der Satzung ausgestattet sind, Umwandlung von vierund-
zwanzigtausend-siebenhundertneunundneunzig (24.799) bestehenden Aktien mit einem Nennwert von jeweils einem
Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) in vierundzwanzigtausend-siebenhundertneunundneunzig (24.799) A-Aktien,
und Umwandlung einer (1) bestehenden Aktie in eine (1) B-Aktie mit einem Nennwert von einem Euro und fünfund-
zwanzig Cent (EUR 1,25).
2. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundvierzigtausendfünf-
hundert Euro (EUR 2.341.500,-), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR
31.000,-) auf zwei Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendfünfhundert Euro (EUR 2.372.500,-) erhöht wird.
3. Ausgabe von sechshundertfünfundneunzigtausendzweihundertundeins (695.201) neuen A-Aktien, sodass die An-
zahl A-Aktien von derzeit vierundzwanzigtausendsieben-hundertneunundneunzig (24.799) A-Aktien auf siebenhundert-
zwanzigtausend (720.000) A-Aktien erhöht wird, von einundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig (41.999) B-
Aktien, sodass die Anzahl der B-Aktien von derzeit einer (1) B-Aktie auf zweiundvierzigtausend (42.000) B-Aktien er-
höht wird, und von einer Million einhundertsechsunddreißigtausend (1.136.000) C-Aktien, mit einem Nennwert von je-
weils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
4. Annahme der Zeichnung
62991
(i) von sechshundertfünfundneunzigtausendzweihundertundeins (695.201) neuen A-Aktien durch ROWAN
NOMINEES LIMITED, einer Gesellschaft englischen Rechts mit Gesellschaftssitz in One Canada Square, London E14
5AL, Vereinigtes Königreich, in deren Eigenschaft als nomineller Aktieninhaber von
- HG INVESTMENT MANAGERS LIMITED, einer Gesellschaft englischen Rechts mit Gesellschaftssitz in Third Floor,
Minerva House, 3-5 Montague Close, London SE 9BB, Großbritannien, in deren Eigenschaft als ordnungsgemäß berech-
tigter Vertreter der MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED und für Rechnung der nach MERILL
LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED’S Ermessensentscheidung ausgewählten Fondsmanagementkunden, wo-
bei letztere die wirtschaftlichen Berechtigten von einhundertfünfunddreißigtausend-siebenhundertfünfundachtzig
(135.785) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende neuen A-Aktien sind,
- HGT L.P., einer Gesellschaft englischen Rechts mit Gesellschaftssitz in Third Floor, Minerva House, 3-5 Montague
Close, London SE 9BB, Großbritannien, als wirtschaftliche Berechtigte von einhundertfünfzehn-tausendachthundert-
neunundfünfzig (115.859) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende neue A-Aktien,
- HG CAPITAL CO-INVESTMENT PLAN, einer Gesellschaft englischen Rechts mit Gesellschaftssitz in Third Floor,
Minerva House, 3-5 Montague Close, London SE 9BB, Großbritannien, als wirtschaftlich Berechtigter von fünftausend-
vierhundertfünfundsechzig (5.465) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende neue A-Aktien,
- MUST 4 GmbH & CO. KG, einer Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in Maria Theresia Straße 5,
81675 München, Bundesrepublik Deutschland, als wirtschaftliche Berechtigte von fünfundzwanzigtausend-neunhundert-
neunundfünfzig (25.959) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende neue A-Aktien,
- MUST 4 L.P., einer Gesellschaft, die dem Recht der Kanalinseln unterliegt, mit Gesellschaftssitz in 13-15 Victoria
Road, St. Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, Kanalinseln, als wirtschaftliche Berechtigte von zweihundertzweiund-neun-
zigtausend-vierhunderteinundsechzig (292.461) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende neue A-Aktien,
- MUST 4 «B» L.P., einer Gesellschaft, die dem Recht der Kanalinseln unterliegt, mit Gesellschaftssitz in 13-15 Victoria
Road, St. Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, Kanalinseln, als wirtschaftliche Berechtigte von siebenunddreißig-tausend-
zweihunderteinunddreißig (37.231) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende neue A-Aktien,
- GKN SPLP 2 L.P., einer Gesellschaft, die dem Recht der Kanalinseln unterliegt, mit Gesellschaftssitz in Alexander
House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, Kanalinseln, als wirtschaftliche Berechtigte von vier-
undzwanzigtausendzweihundertsiebenundvierzig (24.247) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende neue A-
Aktien,
- RR SPLP 2 L.P., einer Gesellschaft, die dem Recht der Kanalinseln unterliegt, mit Gesellschaftssitz in Alexander
House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, GY1 3ZD Guernsey, Kanalinseln, als wirtschaftliche Berechtigte von acht-
undfünfzigtausendeinhundertvierundneunzig (58.194) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende neue A-Ak-
tien,
(ii) von zweiunddreißigtausend (32.000) B-Aktien durch Herrn Michael Röchner, wohnhaft in der Stuttgarter Straße
35, 71638 Ludwigsburg, Bundesrepublik Deutschland, von sechstausend (6.000) B-Aktien durch Herrn Brian Cook,
wohnhaft in 85, Fairway avenue, Rye, New York 10580, Vereinigte Staaten von Amerika, von dreitausendneunhundert-
neunundneunzig (3.999) B-Aktien durch Herrn Richard P. W. Donner, wohnhaft in Tudor Lodge, Hendon Wood Lane,
Mill Hill, London NW7, Vereinigtes Königreich,
(iii) von einer Million einhundertsechsunddreißigtausend (1.136.000) C-Aktien durch die ROWAN NOMINEES
LIMITED, vorgenannt, in ihrer Eigenschaft als nomineller Aktieninhaber von
- HG INVESTMENT MANAGERS LIMITED, vorgenannt, in deren Eigenschaft als ordnungsgemäß berechtigter Ver-
treter der MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED und für Rechnung der nach MERILL LYNCH
INVESTMENT MANAGERS LIMITED’S Ermessensentscheidung ausgewählten Fondsmanagementkunden, wobei letz-
tere die wirtschaftlichen Berechtigten von zweihundertvierzehntausendzweihundertachtunddreißig (214.238) durch
ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende C-Aktien sind,
- HGT L.P., vorgenannt, als wirtschaftliche Berechtigte von zweihunderteinundzwanzigtausendneunhundertachtund-
zwanzig (221.928) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende C-Aktien,
- HG CAPITAL CO-INVESTMENT PLAN, vorgenannt, als wirtschaftlicher Berechtigter von achttausendsechshun-
dertdreiundzwanzig (8.623) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende C-Aktien,
- MUST 4 GmbH & CO. KG, vorgenannt, als wirtschaftliche Berechtigte von vierzigtausendneunhundertachtundfünf-
zig (40.958) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende C-Aktien,
- MUST 4 L.P., vorgenannt, als wirtschaftliche Berechtigte von vierhunderteinundsechzigtausendvierhundertneunund-
dreißig (461.439) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende C-Aktien,
- MUST 4 «B» L.P., vorgenannt, als wirtschaftliche Berechtigte von achtundfünfzigtausendsiebenhunderteinundvierzig
(58.741) durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende C-Aktien,
- GKN SPLP 2 L.P., vorgenannt, als wirtschaftliche Berechtigte von achtunddreißigtausendzweihundertsiebenundfünf-
zig (38.257) durch Rowan Nominees Limited zu zeichnende C-Aktien, und
- RR SPLP 2 L.P., vorgenannt, als wirtschaftliche Berechtigte von einundneunzigtausendachthundertsechzehn (91.816)
durch ROWAN NOMINEES LIMITED zu zeichnende C-Aktien,
Annahme der vollständigen Einzahlung jeder dieser Aktien durch Bareinlagen der jeweiligen wirtschaftlichen Berech-
tigten und natürlichen Personen, Zuteilung dieser neu ausgegebenen Aktien an die einbringenden Parteien als Gegenlei-
stung für die obengenannten Bareinlagen und Bestätigung der Gültigkeit der Kapitalerhöhung.
5. Vollständige Neufassung der Gesellschaftssatzung, die unter anderem die Annahme folgenden Gesellschaftsgegen-
stands beinhaltet:
«3. Gegenstand der Gesellschaft
3.1 Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der Ankauf und das Halten von Darlehens- und/oder Kapitalbeteiligungen in
jeder Art oder Form an luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung, Entwicklung und
62992
Betreuung solcher Instrumente sowie (iii) die mittelbare und/oder unmittelbare finanzielle Unterstützung der Unterneh-
men, an denen sie Anteile hält oder welche der Gesellschaftsgruppe angehören.
3.2 Die Gesellschaft kann insbesondere (i) mittels Zeichnung, Ankauf, Tausch oder auf jede andere Weise Aktien,
Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, Hinterlegungsscheine und andere Schuldtitel und
ganz allgemein jegliche Wert- und Handelspapiere, die Eigentumsrechte, Forderungen oder von öffentlichen oder pri-
vaten Emittenten ausgestellte übertragbare Wertpapiere verkörpern, erwerben; (ii) alle Rechte ausüben, die mit diesen
Wert- und Handelspapieren verbunden sind; (iii) den Unternehmen, an denen sie Anteile hält oder welche der Gesell-
schaftsgruppe angehören, mittelbare und/oder unmittelbare finanzielle Unterstützung zukommen lassen, insbesondere
mittels der Gewährung von Darlehen, Kreditlinien und Sicherheiten in jeglicher Form und für jegliche Dauer, und ihnen
Rat und Betreuung in jeder Form gewähren; (iv) Darlehen in jeglicher Form aufnehmen und/oder Zeichnungsrechte (in-
klusive Aktienbezugsscheine) gewähren und/oder Schuldtitel in jeglicher Form ausgeben und (v) jegliche Geschäfte ver-
richten, ob wirtschaftlicher, industrieller oder finanzieller Natur, mit Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter, die
mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesellschaftsgegenstand verbunden sind.»
6. Gewährung der Entlastung an Herrn Franz Schaefer, Herrn Stephan Morsch und Herrn Timo Engelhardt für ihre
Amtsausübung als Verwaltungsratsmitglieder, Annahme ihres Rücktritts als Verwaltungsratsmitglieder und Ernennung
von Frau Lisa Stone, Herrn Richard P. W. Donner, Herrn Kai Romberg, Herrn Michael Röchner und Herrn Brian Cook
zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft, jeweils für einen Zeitraum, der am Tag der Jahreshauptversamm-
lung im Jahre 2006 endet.
7. Gewährung der Entlastung an Herrn Wolfgang Essler für seine Amtsausübung als Kommissar, Annahme seines
Rücktritts als Kommissar und Ernennung von DELOITTE & TOUCHE, Luxemburg, zum Kommissar der Gesellschaft für
einen Zeitraum, der am Tag der Jahreshauptversammlung im Jahre 2006 endet.
8. Sonstiges.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegen-
stand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der
vertretenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit der-
selben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.
(iii) Die durch die erscheinenden Parteien ne varietur abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben
vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.
(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten und da die anwe-
senden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden
zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.
(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetre-
ten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.
Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse ge-
fasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Schaffung dreier Kategorien von Aktien, und zwar der Katego-
rien der A-Aktien, der B-Aktien und der C-Aktien, die mit den Rechten und Privilegien gemäß einer Neufassung der
Satzung ausgestattet sind, sowie die Umwandlung von vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (24.799)
bestehenden Aktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) in vierundzwan-
zigtausendsiebenhundertneunundneunzig (24.799) A-Aktien, und die Umwandlung einer (1) bestehenden Aktie in eine
(1) B-Aktie mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von
zwei Millionen dreihunderteinundvierzigtausendfünfhundert Euro (EUR 2.341.500,-), sodass das Kapital von seinem jet-
zigen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf zwei Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendfünf-
hundert Euro (EUR 2.372.500,-) erhöht wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ausgabe von sechshundertfünfundneunzigtausendzweihundert-
undeins (695.201) neuen A-Aktien, sodass die Anzahl A-Aktien von derzeit vierundzwanzigtausendsiebenhundertneun-
undneunzig (24.799) A-Aktien auf siebenhundertzwanzig-tausend (720.000) A-Aktien erhöht wird, von
einundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig (41.999) B-Aktien, sodass die Anzahl der B-Aktien von derzeit einer
(1) B-Aktie auf zweiundvierzigtausend (42.000) B-Aktien erhöht wird, und von einer Million einhundertsechsunddreißig-
tausend (1.136.000) C-Aktien, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Daraufhin ist erschienen, Herr Manfred Müller, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als ordnungsmäßig er-
mächtigter Bevollmächtigter (i) der ROWAN NOMINEES LIMITED, handelnd in ihrer Eigenschaft als nomineller
Aktieninhaber der HG INVESTMENT MANAGERS LIMITED, vorgenannt, HGT L.P., vorgenannt, HGCAPITAL CO-
INVESTMENT PLAN, vorgenannt, MUST 4 L.P., vorgenannt, MUST 4 «B» L.P., vorgenannt, MUST 4 GmbH & CO. KG,
vorgenannt, GKN SPLP 2 L.P., vorgenannt, RR SPLP 2 L.P., vorgenannt, (ii) des Herrn Michael Röchner, vorgenannt, (iii)
des Herrn Brian Cook, vorgenannt, und (iv) des Herrn Richard P. W. Donner, vorgenannt (die «Zeichner»), aufgrund
derselben Vollmachten wie eingangs erwähnt.
62993
Der Komparent erklärt, im Namen und für Rechnung der Zeichner die neu ausgegebenen Aktien der Gesellschaft
wie folgt zu zeichnen und jede dieser neuen Aktien vollständig mittels Bareinlagen (die «Bareinlagen») wie folgt einzu-
zahlen:
Die Summe der Bareinlagen bildet eine Gesamteinlage von zwei Millionen dreihunderteinundvierzigtausendfünfhun-
dert Euro (EUR 2.341.500,-).
Außerdem sind im Vorfeld vorliegender Kapitalerhöhung dreiundzwanzigtausendzweihundertundfünfzig Euro (EUR
23.250,-) auf die vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien eingezahlt worden, die während der Gründung der
Gesellschaft zu fünfundzwanzig Prozent (25%) eingezahlt worden waren, sodass ebenfalls diese Aktien, die gemäß dem
ersten Beschluss weiter oben in vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (24.799) A-Aktien und eine (1)
B-Aktie umgewandelt worden sind, nunmehr voll eingezahlt sind.
Der Nachweis dieser Einzahlungen ist dem amtierenden Notar erbracht worden und der Betrag von zwei Millionen
dreihundertvierundsechzigtausendsieben-hundertundfünfzig Euro (EUR 2.364.750) steht der Gesellschaft nun zur Ver-
fügung.
Daraufhin beschließt die Hauptversammlung der Aktionäre (i) die besagten Zeichnungen und Einzahlungen anzuneh-
men, (ii) den Zeichnern die sechshundertfünfundneunzigtausendzweihundertundeins (695.201) neuen A-Aktien, die ein-
undvierzigtausendneunhundertneunundneunzig (41.999) neuen B-Aktien und die eine Million
einhundertsechsunddreißigtausend (1.136.000) neuen C-Aktien wie weiter oben beschrieben zuzuteilen, und (iii) die
Gültigkeit der Kapitalerhöhung zu bestätigen.
<i>Vierter Beschlussi>
Auf der Grundlage eines Berichts des Verwaltungsrates bezüglich der Schaffung eines genehmigten Kapitals, von dem
eine Abschrift vorliegender Urkunde zwecks Einregistrierung beigefügt bleibt, beschließt die Hauptversammlung der Ak-
tionäre die Satzung der Gesellschaft vollständig neuzufassen, wobei diese Neufassung neben der Wiedergabe der weiter
oben erwähnten Änderungen betreffend das Gesellschaftskapital unter anderem die Schaffung eines genehmigten Kapi-
tals umfasst, mit der Möglichkeit für den Verwaltungsrat, das Recht auf vorzugsweise Zeichnung im Rahmen der Ausgabe
von Aktien unter dem genehmigten Kapital zu beschränken oder aufzuheben.
Die Satzung nimmt nunmehr folgenden Wortlaut an:
«I. Kapitel I.- Form, Name, Gesellschaftssitz, Gegenstand, Dauer
1. Gesellschaftsform, Name
1.1 Es wird hiermit zwischen den unterzeichnenden Parteien und all denjenigen, die Eigentümer der hiernach geschaf-
fenen Aktien werden, eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in Form einer Société anonyme - Aktiengesellschaft gegrün-
Aktionäre
gezeichnetes und
eingezahltes Kapital
(EUR)
Anzahl und Kategorie
der Aktien
ROWAN NOMINEES LIMITED as nomineller Aktieninhaber
der HG INVESTMENT MANAGERS LIMITED, handelnd als ord-
nungsgemäß berechtigter Vertreter der MERRILL LYNCH IN-
VESTMENT MANAGERS LIMITED und für Rechnung der nach
MERILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED’S Ermes-
sensentscheidung ausgewählten Fondsmanagementkunden
169.731,25
267.797,5
135.785 A-Aktien
214.238 C-Aktien
ROWAN NOMINEES LIMITED in der Eigenschaft des nomi-
nellen Aktieninhabers der HGT L.P.
144.823,75
277.410
115.859 A-Aktien
221.928 C-Aktien
ROWAN NOMINEES LIMITED in der Eigenschaft des nomi-
nellen Aktieninhabers der HG CAPITAL CO-INVESTMENT
PLAN
6.831,25
10.778,75
5.465 A-Aktien
8.623 C-Aktien
ROWAN NOMINEES LIMITED in der Eigenschaft des nomi-
nellen Aktieninhabers der MUST 4 GmbH & CO. KG
32.448,75
51.197,5
25.959 A-Aktien
40.958 C-Aktien
ROWAN NOMINEES LIMITED in der Eigenschaft des nomi-
nellen Aktieninhabers der MUST 4 L.P.
365.576,25
576.798,75
292.461 A-Aktien
461.439 C-Aktien
ROWAN NOMINEES LIMITED in der Eigenschaft des nomi-
nellen Aktieninhabers der MUST 4 «B» L.P.
46.538,75
73.426,25
37.231 A-Aktien
58.741 C-Aktien
ROWAN NOMINEES LIMITED in der Eigenschaft des nomi-
nellen Aktieninhabers der GKN SPLP 2 L.P.
30.308,75
47.821,25
24.247 A-Aktien
38.257 C-Aktien
ROWAN NOMINEES LIMITED in der Eigenschaft des nomi-
nellen Aktieninhabers der RR SPLP 2 L.P.
72.742,5
114.770
58.194 A-Aktien
91.816 C-Aktien
Michael Röchner
40.000
32.000 B-Aktien
Brian Cook
7.500
6.000 B-Aktien
Richard P.W. Donner
4.998,75
3.999 B-Aktien
Summe
869.001,25
695.201 A-Aktien
52.498,75
41.999 B-Aktien
1.420.000
1.136.000 C-Aktien
2.341.500
62994
det, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt (der
«Gesellschaftsvertrag»).
1.2 Die Gesellschaft trägt den Namen ADDISON LUXEMBOURG S.A.
2. Gesellschaftssitz
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.
2.2 Der Gesellschaftssitz kann durch einen Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb dieses Stadtge-
bietes verlegt werden.
2.3 Durch einen Verwaltungsratsbeschluss können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Län-
dern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gegründet werden.
2.4 Sollte der Verwaltungsrat der Ansicht sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder
sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesell-
schaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwischen dem Gesellschafts-
sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann er den Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur
völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen ha-
ben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen
Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, weiterhin den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegt. Diese vor-
übergehenden Maßnahmen werden von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft beauftragt sind, angeordnet und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.
3. Gegenstand der Gesellschaft
3.1 Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der Ankauf und das Halten von Darlehens- und/oder Kapitalbeteiligungen in
jeder Art oder Form an luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung, Entwicklung und
Betreuung solcher Instrumente sowie (iii) die mittelbare und/oder unmittelbare finanzielle Unterstützung der Unterneh-
men, an denen sie Anteile hält oder welche der Gesellschaftsgruppe angehören.
3.2 Die Gesellschaft kann insbesondere (i) mittels Zeichnung, Ankauf, Tausch oder auf jede andere Weise Aktien,
Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, Hinterlegungsscheine und andere Schuldtitel und
ganz allgemein jegliche Wert- und Handelspapiere, die Eigentumsrechte, Forderungen oder von öffentlichen oder pri-
vaten Emittenten ausgestellte übertragbare Wertpapiere verkörpern, erwerben; (ii) alle Rechte ausüben, die mit diesen
Wert- und Handelspapieren verbunden sind; (iii) den Unternehmen, an denen sie Anteile hält oder welche der Gesell-
schaftsgruppe angehören, mittelbare und/oder unmittelbare finanzielle Unterstützung zukommen lassen, insbesondere
mittels der Gewährung von Darlehen, Kreditlinien und Sicherheiten in jeglicher Form und für jegliche Dauer, und ihnen
Rat und Betreuung in jeder Form gewähren; (iv) Darlehen in jeglicher Form aufnehmen und/oder Zeichnungsrechte (in-
klusive Aktienbezugsscheine) gewähren und/oder Schuldtitel in jeglicher Form ausgeben und (v) jegliche Geschäfte ver-
richten, ob wirtschaftlicher, industrieller oder finanzieller Natur, mit Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter, die
mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesellschaftsgegenstand verbunden sind.
4. Dauer
4.1 Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
4.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Regeln be-
züglich Quorum und Mehrheit getroffenen Hauptversammlungsbeschluss aufgelöst werden.
II. Gesellschaftskapital, Aktien
5. Gesellschaftskapital
5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf zwei Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendfünfhundert Euro (EUR
2.372.500,-) festgesetzt. Es ist eingeteilt in siebenhundertzwanzigtausend (720.000) Aktien der Kategorie A (die «A-Ak-
tien») mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie, zweiundvierzigtau-
send (42.000) Aktien der Kategorie B (die «B-Aktien») mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig
Cent (EUR 1,25) pro Aktie, und eine Million einhundertsechsunddreißigtausend Aktien der Kategorie C (die «C-Ak-
tien») mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie. Alle Aktien sind
voll eingezahlt.
5.2 Die Aktien jeder Kategorie sind vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder der vorliegenden
Satzung mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet.
5.3 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million einhundertsechsundachtzigtausendzweihundertfünf-
zig Euro (EUR 1.186.250,-), aufgeteilt in dreihundertsechzigtausend (360.000) Aktien der Kategorie A, einundzwanzig-
tausend (21.000) Aktien der Kategorie B und fünfhundertachtundsechzigtausend (568.000) Aktien der Kategorie C. Jede
Aktie unter dem genehmigten Kapital hat einen Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
5.4 Der Verwaltungsrat ist in den Grenzen des genehmigten Kapitals dazu ermächtigt, (i) jede, eventuell auf einer
Ausübung, gemäss den Bedingungen der ausgegebenen Zeichnungsoptionen, Wandelanleihen, Schuldscheinen oder ähn-
lichen, von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft ausgebebenen Wertpapieren, der von ihm, im Rahmen des genehmigten
Kapitals, gewährten Zeichnungs- und/oder Umwandlungsrechte (die entweder gesondert von den Aktien, Anleihen,
Schuldscheinen oder anderen Wertpapieren oder diesen beigefügt ausgegeben wurden) beruhende, Erhöhung des Ge-
sellschaftskapitals, in einer oder in mehreren Phasen durch die Ausgabe neuer Aktien, entweder mit oder ohne Emissi-
onsaufgeld, gegen eine Geld- oder eine Sacheinlage, durch eine Umwandlung von Ansprüchen gegenüber der
Gesellschaft oder auf jede andere Weise, vorzunehmen; (ii) den Ort und den Zeitpunkt der Aktienausgabe oder der
aufeinander folgenden Aktienausgaben, den Ausgabepreis, die Bedingungen der Zeichnung und der Einzahlung der neuen
Aktien festzulegen; und (iii) das bevorzugte Zeichnungsrecht der Aktieneigner im Falle einer Aktienausgabe gegen Bar-
zahlung auszuschließen oder zu begrenzen. Diese Ermächtigung gilt bis zum Ende eines Zeitraums von fünf (5) Jahren
62995
nach der Veröffentlichung der notariellen Gründungsurkunde der Gesellschaft im Mémorial und kann durch einen Be-
schluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach dieser Satzung erforderlichen Quorum- und
Mehrheitsregeln oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen angenommen worden ist, erneuert wer-
den.
5.5 Der Verwaltungsrat kann jeder ordnungsgemäß ermächtigten Person, die Annahme der Zeichnung und der Ein-
zahlung der anteilig oder vollständig unter dem genehmigten Kapital ausgegebenen neuen Aktien überlassen.
5.6 Nach jeder Erhöhung des ausgegebenen Kapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals, deren Ausführung und
Durchführung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form festgehalten ist, wird dieser Artikel dergestalt abgeändert, dass
er die gegebene Erhöhung widerspiegelt. Diese Änderung wird in notarieller Form von dem Verwaltungsrat oder jeder
anderen, ordnungsgemäß von dem Verwaltungsrat zu diesem Zweck ermächtigten Person, vorgenommen.
5.7 Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das sämtliche Emissions-
aufgelder, die auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses
Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Aktien, die die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Aktionäre in Form von Dividenden oder zur Bereitstellung der
gesetzlichen Rückstellungen genutzt werden.
6. Aktien
6.1 Die Aktien werden nach Wahl der Aktionäre Namensaktien oder Inhaberaktien sein.
6.2 Gibt die Gesellschaft Namensaktien aus, so ist am Gesellschaftssitz ein Aktienregister zu führen, das jeder Aktio-
när einsehen darf. In dem Register werden die genaue Namensbezeichnung jedes Aktionärs und die Anzahl gehaltener
Aktien, die auf die Aktien eingezahlten Beträge sowie die Aktienübertragungen zusammen mit deren Datum vermerkt.
6.3 Jeder Aktionär teilt der Gesellschaft per Einschreiben seine Anschrift und jedwede diesbezügliche Änderung mit.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich auf die zuletzt mitgeteilte Anschrift zu berufen.
6.4 Das Eigentum der Namensaktien ergibt sich aus den Eintragungen in das Aktienregister.
6.5 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch eine in das Aktienregister eingetragene Übertragungserklärung, die
vom Veräußerer und vom Erwerber oder von deren Vertreter(n) unterzeichnet wird. Aktienübertragungen können
ebenfalls gemäß den in Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches vorgesehenen Bestimmungen betreffend die
Übertragung von Forderungen erfolgen. Außerdem ist die Gesellschaft befugt, jede Übertragung in das Aktienregister
einzutragen, auf die sich ein Briefwechsel oder ein anderes Schriftstück bezieht, aus dem das Einverständnis des Veräu-
ßerers und des Erwerbers hervorgeht.
6.6 Den Aktionären werden die Eintragung in das Aktienbuch dokumentierende Zertifikate ausgestellt.
6.7 Die Gesellschaft kann multiple Aktienzertifikate ausstellen.
7. Vorzugsdividende und Liquidationserlös
7.1 Jeder Eigentümer von C-Aktien hat Anspruch auf eine jährliche Vorzugsdividende in Höhe von acht Prozent (8%)
der Beträge, die von den jeweiligen Aktionären zum Erwerb der C-Aktien nach deren Ausgabe gezahlt worden sind.
7.2 Bei Abwicklung der Gesellschaft hat jeder Eigentümer von C-Aktien einen Anspruch auf einen Vorzugsliquidati-
onserlös in Höhe der Beträge, die von den jeweiligen Aktionären zum Erwerb der C-Aktien nach deren Ausgabe gezahlt
worden sind, zuzüglich der kumulierten Vorzugsdividende, die in Sektion 7.1wähnt ist (insoweit diese noch nicht gemäß
Sektion 7.1 ausgezahlt worden ist).
8. An- und Verkauf von Aktien
8.1 Jeder Eigentümer von B-Aktien verpflichtet sich gegenüber den Eigentümern von A-Aktien, folgende Geschäfte
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der A-Aktionäre weder zu tätigen, noch ihnen Zustimmung zu leisten:
(i) seine Aktien an der Gesellschaft oder deren Nießbrauch ganz oder teilweise verpfänden, mit Sicherheiten belegen
oder in einer anderen Form belasten;
(ii) seine Aktien an der Gesellschaft oder deren Nießbrauch ganz oder teilweise an eine Person verkaufen, übertragen
oder in einer anderen Form an sie abtreten oder diesbezügliche Kaufoptionen gewähren, die nicht ein Befugter Erwer-
ber im Sinne der untenstehenden Definition sind; oder
(iii) jegliche Vereinbarung bezüglich der Stimmrechte seiner Aktien, insgesamt oder teilweise, an der Gesellschaft tref-
fen.
8.2 Vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung zwischen den Aktionären ist jeder B-Aktionär dazu berechtigt, seine Ak-
tien an der Gesellschaft ganz oder teilweise ohne die Zustimmung der A-Aktionäre an folgende befugte Erwerber (die
«Befugten Erwerber») zu übertragen:
(i) seinen Ehepartner;
(ii) seine volljährigen Kinder beziehungsweise Stiefkinder; oder
(iii) ein Unternehmen, das er ausschließlich in seinem eigenen Interesse oder in dem seines Ehepartners, seiner Kinder
oder seiner Stiefkinder gegründet hat, wobei die Aktien an einem solchen Unternehmen lediglich nach vorheriger Zu-
stimmung aller Aktionäre der Gesellschaft übertragbar sind.
8.3 Eigentümer von A-Aktien dürfen ihre Aktien an der Gesellschaft frei übertragen.
9. Vorkaufsrecht
9.1 Im Falle des Verkaufs von Aktien durch einen Aktionär der Kategorie B, dem die Aktionäre der Kategorie A zu-
gestimmt haben, besitzen die Aktionäre der Kategorie A ein Vorkaufsrecht.
9.2 Das Vorkaufsrecht besteht zugunsten der Aktionäre der Kategorie A in dem Verhältnis, in dem die jeweiligen
Nennwerte ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft zueinander stehen. Nimmt ein Aktionär der Kategorie A sein Vor-
kaufsrecht nicht wahr beziehungsweise übt er es bis zum Fälligkeitstermin nicht aus, so verfällt sein Vorkaufsrecht zu-
gunsten der übrigen Aktionäre der Kategorie A in Übereinstimmung mit dem Verhältnis in dem die jeweiligen
Nennwerte ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft zueinander stehen.
62996
9.3 Erwägt ein Aktionär der der Kategorie B, seine Aktien zu verkaufen, so setzt er die Aktionäre der Kategorie A
unverzüglich über gesamten Inhalt der Vereinbarung, die er mit dem entsprechenden Käufer getroffen hat, in Kenntnis,
indem der eine Abschrift davon übermittelt. Das Vorkaufsrecht darf lediglich binnen eines Monats nach Erhalt des Be-
nachrichtigungsschreibens und ausschließlich mittels schriftlicher Erklärung gegenüber dem Aktionär der Kategorie B
erfolgen. Das gemäß Sektion 9.2, Satz 2, erhöhte Vorkaufsrecht darf lediglich binnen eines Monats nach Erhalt der Zu-
wachsbenachrichtigung durch den Aktionär der Kategorie B und ausschließlich mittels schriftlicher Erklärung gegenüber
dem Aktionär der Kategorie B erfolgen.
9.4 Ein Aktionär der Kategorie A darf sein Vorkaufsrecht lediglich hinsichtlich der gesamten Aktien ausüben, zu denen
er ursprünglich gemäß Sektion 9.2, Satz 1, berechtigt ist, zuzüglich aller Aktien, die ihm infolge von Sektion 9.2, Satz 2,
zugewachsen sind. Sollten zwei oder mehr Aktionäre der Kategorie A ihre Vorkaufsrechte ausüben, werden die Aktien
dementsprechend aufgeteilt. Unteilbare Beteiligungsanteile werden demjenigen der Aktionäre der Kategorie A zugeteilt,
der als erster sein Vorkaufsrecht ausgeübt hat.
9.5 Die Bestimmungen vorliegender Sektion 9 finden keine Anwendung auf die Fälle, die in Sektion 8.2 und Sektion
10 vorgesehen sind sowie auf Fälle, auf die die Aktionäre sich in von Zeit zu Zeit einigen.
9.6 Zwecks Vermeidung jeglichen Zweifels sei klargestellt, dass die Aktionäre der Kategorie A ihr Vorkaufsrecht ge-
mäß Sektion 9 ebenfalls ausüben dürfen, falls sie ihr Einverständnis zu der betreffenden Aktienübertragung in Überein-
stimmung mit Sektion 8.1 abgegeben haben.
10. Recht auf Durchsetzung des Mitverkaufs, Mitverkaufsrecht
10.1 Erhalten ein oder mehrere Aktionäre der Kategorie A, die zusammen mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte an der Gesellschaft auf sich vereinen, ein Angebot einer/mehrerer Drittpartei(en), die weder ein Aktionär noch
eine Gesellschaft sind, die der Gruppe eines Aktionärs angehört, noch ein anderer Fonds, der von einem der Aktionäre
der Kategorie A verwaltet oder beraten wird («Drittpartei» oder «Drittparteien»), zwecks Erwerbs von mehr als fünfzig
Prozent (50%) des gesamten Aktienkapitals der Gesellschaft, und entscheiden sich diese Aktionäre der Kategorie A, die-
ses Angebot anzunehmen, oder, falls diese Aktionäre der Kategorie A einer Drittpartei oder Drittparteien ein solches
Angebot unterbreiten, und entscheidet/entscheiden sich die Drittpartei(en) dazu, dieses Angebot anzunehmen, so sind
die übrigen Aktionäre, auf Antrag besagter Aktionäre der Kategorie A, dazu verpflichtet, denselben Prozentsatz ihrer
Aktien an der Gesellschaft wie besagte Aktionäre der Kategorie A (der Prozentsatz wird berechnet auf der Grundlage
der Gesamtzahl der Aktien, die von besagten Aktionären der Kategorie A gemeinsam an der Gesellschaft gehalten wer-
den sowie der Gesamtzahl der Aktien, die von besagten Aktionären der Kategorie A gemeinsam verkauft werden) zu-
sammen mit den besagten Aktionären der Kategorie A gemäß den Geschäftsbedingungen, die die Drittpartei(en) mit
dem/den besagten Aktionär(en) der Kategorie A vereinbart hat/haben, zu verkaufen (das «Mitverkaufsdurchsetzungs-
recht»). Der Antrag des Aktionärs beziehungsweise der Aktionäre erfolgt den übrigen Aktionären gegenüber schriftlich.
10.2 Entscheiden ein oder mehrere Aktionäre der Kategorie A sich dazu, ihre Aktien an der Gesellschaft ganz oder
teilweise an eine/mehrere Drittpartei(en) zu verkaufen, die dadurch mehr als fünfzig Prozent (50%) des gesamten Akti-
enkapitals der Gesellschaft erwerben, so vereinbaren diese Aktionäre der Kategorie A mit der/den Drittpartei(en), die
den Erwerb der Aktien in Erwägung ziehen, dass diese Drittpartei(en) den übrigen Aktionären anbieten, denselben Pro-
zentsatz der von ihnen gehaltenen Aktien (der Prozentsatz wird berechnet auf der Grundlage der Gesamtzahl der Ak-
tien, die von besagten Aktionären der Kategorie A gemeinsam an der Gesellschaft gehalten werden sowie der
Gesamtzahl der Aktien, die den besagten Aktionären der Kategorie A gemeinsam von der/den Drittpartei(en) abgekauft
werden) zu denselben Geschäftsbedingungen zu erwerben, die von den Aktionären der Kategorie A, die sich zum Ver-
kauf ihrer Aktien entschlossen haben, angeboten worden sind (das «Mitverkaufsrecht»). Das Mitverkaufsrecht ist binnen
eines Zeitraums von dreißig (30) Kalendertagen ab Erhalt eines solchen Angebots seitens der/den Drittpartei(en) aus-
zuüben, und zwar mittels schriftlicher Benachrichtigung der Drittpartei(en) und der besagten Aktionäre der Kategorie
A; anderenfalls verwirkt das Mitverkaufsrecht.
10.3 Das Mitverkaufsdurchsetzungsrecht und das Mitverkaufsrecht finden analog Anwendung auf Tausch, Einbringung,
Verschmelzung und vergleichbare Übertragungen von Aktien.
11. Kapitalerhöhung und -verringerung
11.1 Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrfach durch einen Hauptversammlungsbeschluss erhöht bezie-
hungsweise verringert werden, der gemäß den Bestimmungen betreffend Quorum und Mehrheit getroffen wird, die vor-
behaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen in vorliegendem Gesellschaftsvertrag für jede Abänderung desselben
vorgesehen sind.
11.2 Die neuen mittels Geldeinlage zu zeichnenden Aktien werden den bestehenden Aktionären im Verhältnis zu dem
von diesen Aktionären gehaltenen Anteil am Kapital bevorzugt angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum,
während dessen das Vorkaufsrecht auszuüben ist. Dieser Zeitraum darf dreißig (30) Tage nicht unterschreiten.
11.3 Unbeschadet des Vorrangehenden ist die Hauptversammlung dazu befugt, das Vorkaufsrecht gemäß den Bestim-
mungen betreffend Quorum und Mehrheit, die vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen in vorliegendem
Gesellschaftsvertrag für jede Abänderung desselben vorgesehen sind, zu begrenzen oder zu entziehen beziehungsweise
den Verwaltungsrat diesbezüglich zu ermächtigen.
12. Erwerb eigener Aktien
12.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien erwerben.
12.2 Der Erwerb und das Halten ihrer eigenen Aktien erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Be-
dingungen und innerhalb des gesetzlichen Rahmens.
62997
III. Verwaltungsrat, Kommissare
13. Verwaltungsrat
13.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat (der «Verwaltungsrat»), der sich aus mindestens
drei (3) und höchstens sechs (6) Mitgliedern zusammensetzt, die nicht notwendigerweise Aktionäre sind (die «Verwal-
tungsratsmitglieder»).
13.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung, welche deren Anzahl festlegt, für eine Dauer
von höchstens sechs Jahren gewählt und bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind wiederwählbar, können
jedoch jederzeit durch einen Hauptversammlungsbeschluss mit oder ohne Grund abberufen werden.
13.3 Wird im Verwaltungsrat ein Sitz frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten
und durch einen Mehrheitsbeschluss ein Verwaltungsratsmitglied wählen, um den freigewordenen Sitz bis zur nächsten
Hauptversammlung zu besetzen.
14. Sitzungen des Verwaltungsrates
14.1 Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Verwaltungsrat kann
ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der
Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen verantwortlich ist.
14.2 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Verwaltungsratssitzung ist einzube-
rufen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies fordern.
14.3 Der Vorsitzende führt bei allen Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen den Vorsitz, mit der Aus-
nahme, dass der Verwaltungsrat beziehungsweise die Hauptversammlung befugt sind, in dessen Abwesenheit mit einfa-
cher Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder beziehungsweise der bei besagter Versammlung anwesenden oder
vertretenen Aktionäre ein anderes Verwaltungsratsmitglied beziehungsweise eine andere Person zum zeitweiligen Vor-
sitzenden zu ernennen.
14.4 Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein
schriftlicher Einberufungsbescheid zu den Sitzungen des Verwaltungsrats oder jedes Ausschusses (falls solche bestehen)
mindestens zehn (10) Tage vor dem für sie vorgesehenen Datum an alle Verwaltungsratsmitglieder entsendet; diesem
Einberufungsbescheid ist eine schriftliche Tagesordnung beigefügt, die die während der Sitzung zu verrichtenden Ge-
schäfte beschreibt, und, mindestens fünf (5) Tage vor der Sitzung, werden den Verwaltungsratsmitgiedern jegliche Do-
kumente zugesandt, die an sie zu richten oder ihnen zu unterbreiten sind. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide
enthalten Angaben über Sitzungsort und -datum, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte.
14.5 Liegt die schriftliche Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in
einem früheren Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
14.6 Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Verwaltungsrat von
Zeit zu Zeit festlegen kann.
14.7 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in Verwaltungsratssitzungen vertreten lassen, indem es hierzu ein ande-
res Verwaltungsratsmitglied per Brief, Telefax oder Telegramm zu seinem Bevollmächtigen ernennt.
14.8 Der Verwaltungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner amtierenden Mitglieder an-
wesend oder vertreten sind.
14.9 Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertre-
tenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.
14.10 In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneter Beschluss gültig
und rechtsverbindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasst worden
wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten
werden, wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben wird.
15. Sitzungsprotokolle
15.1 Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet. Vollmachten bleiben
dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
15.2 Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig
vorgelegt werden, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
16. Befugnisse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist mit den weitreichendsten Befugnissen (mit Ausnahme derer, die aufgrund des Gesetzes aus-
drücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind) ausgestattet, um jedwede Handlung vorzunehmen, die zur Erfüllung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder von Nutzen sind. Sämtliche Befugnisse, die nicht aufgrund des Gesetzes aus-
drücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Verwaltungsrats.
17. Übertragung von Befugnissen
17.1 Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen einer solchen täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Be-
vollmächtigten, Angestellten oder sonstigen Personen übertragen, die Aktionäre sein können doch nicht sein müssen,
oder Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen beziehungsweise dauerhafte oder zeitweilige Handlungsbefugnisse
auf Personen oder Beauftragte seiner Wahl übertragen.
17.2 Für die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf ein Verwaltungsratsmitglied ist die vorherige Zustim-
mung der Hauptversammlung erforderlich.
62998
18. Interessenkonflikte
18.1 Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft
oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/sind oder Direk-
tor(en), Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma ist/sind. Vorbehalt-
lich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Direktor oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, der als
Direktor, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma, mit der die Gesellschaft ver-
tragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit solch einer anderen
Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte betreffende Ange-
legenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.
18.2 Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Ver-
waltungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder dar-
über abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Verwaltungsratsmitglieds oder Bevollmächtigten sind
bei der nächsten Hauptversammlung offenzulegen.
18.3 Die Gesellschaft entschädigt jedes Verwaltungsratmitglied oder jeden Bevollmächtigten und deren Erben, Testa-
mentvollstrecker und -verwalter, für alle Kosten, die sie vernünftigerweise im Zusammenhang mit irgendeinem Rechts-
streit, einer Klage oder einem Gerichtsverfahren aufgewandt haben, in die sie einbezogen worden ist aufgrund ihrer
Eigenschaft als aktives oder ehemaliges Verwaltungsratsmitglied beziehungsweise Bevollmächtigter der Gesellschaft
oder, auf Verlangen der Gesellschaft, einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft beteiligt ist oder deren Gläu-
biger sie ist und durch die sie nicht entschädigt werden können, wobei Vorkommnisse ausgenommen sind, zu deren
Haftung sie im Rahmen einer Klage, eines Rechtsstreits oder eines Gerichtsverfahrens wegen grober Fahrlässigkeit oder
schlechter Geschäftsführung verurteilt werden; im Falle eines Vergleichs wird Schadenersatz lediglich hinsichtlich sol-
cher Angelegenheiten geleistet, die durch den Vergleich gedeckt sind und hinsichtlich derer die Gesellschaft von ihren
Rechtsanwälten eine Bestätigung erhält, dass die entschädigungsberechtigte Person keine Pflichtverletzung begangen hat.
Das vorerwähnte Recht auf Entschädigung schließt sonstige Rechte nicht aus, auf die sie unter Umständen einen An-
spruch haben.
19. Vertretung der Gesellschaft
19.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unterschrift
von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der Person, der die tägliche Geschäftsführung
der Gesellschaft übertragen wurde, jedoch nur innerhalb dieser täglichen Geschäftsführung. Sie wird weiterhin durch
die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen rechtsverbindlich verpflichtet, denen
solche Zeichnungsbefugnisse durch den Verwaltungsrat übertragen wurden, wobei dies jedoch lediglich innerhalb dieser
Befugnisse gilt.
20. Kommissare
20.1 Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut, welche keine
Aktionäre sein müssen.
20.2 Die Kommissare werden von der Hauptversammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der
sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Man-
dats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Hauptversamm-
lungsbeschluss abberufen werden.
IV. Hauptversammlung
21. Befugnisse der Hauptversammlung
21.1 Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Hauptversammlung der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Ak-
tionäre (die «Hauptversammlung»).
21.2 Sie hat die Befugnisse, die gesetzlich festgelegt sind.
22. Jahreshauptversammlung
22.1 Die Jahreshauptversammlung tritt jedes Jahr am ersten Mittwoch des Monats mai zwischen 8 und 17 Uhr (Orts-
zeit) am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.
22.2 Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahreshauptversammlung am darauffolgenden Werktag abge-
halten.
23. Andere Hauptversammlungen
23.1 Der Verwaltungsrat kann andere Hauptversammlungen einberufen. Diese müssen einberufen werden, wenn Ak-
tionäre, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, dies verlangen.
23.2 Hauptversammlungen, die Jahreshauptversammlung inbegriffen, können jedes Mal dann im Ausland abgehalten
werden, wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Veraltungsrats liegen, dies er-
forderlich machen.
24. Verfahren, Wahl
24.1 Hauptversammlungen treten nach in Übereinstimmung mit luxemburgischen Recht erfolgter Einberufung durch
den Verwaltungsrat oder die Kommissare zusammen. Der den Aktionären in Übereinstimmung mit dem Gesetz über-
mittelte Einberufungsbescheid enthält Angaben zu Zeitpunkt und Ort der Versammlung sowie zur Tagesordnung und
Art der zu tätigen Geschäfte.
62999
24.2 Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die der Ver-
sammlung zugrunde liegenden Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, kann die Versammlung auch ohne vor-
herige Einberufung abgehalten werden.
24.3 Ein Aktionär kann an den Hauptversammlungen teilnehmen, indem er per Brief, Telefax oder Telegramm, eine
andere Person, die nicht notwendigerweise Aktionär ist, zu seinem Bevollmächtigten ernennt.
24.4 Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, die zwecks Teilnahme an einer Hauptversamm-
lung zu erfüllen sind.
24.5 Vorbehaltlich gegenteiliger Anforderungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrags werden
Beschlüsse ungeachtet der Anzahl bei der Hauptversammlung anwesender oder vertretener Aktien durch einfache
Mehrheit gefasst.
24.6 Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.
24.7 Kopien von oder Auszüge aus Hauptversammlungsprotokollen, die im Rahmen von Gerichtsverfahren oder an-
derweitig vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unter-
zeichnet.
V. Geschäftsjahr, Gewinnverwendung
25. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißigsten Tag des Monats Dezem-
ber desselben Jahres. Der Verwaltungsrat bereitet gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes und den
Buchhaltungsregeln den Jahresabschluss vor.
26. Gewinnverwendung
26.1 Vom jährlichen Reingewinn werden fünf Prozent (5%) den gesetzlichen Rücklagen zu gewiesen. Die Verpflichtung
zu dieser Zuweisung entfällt, sobald und solange die gesetzliche Reserve zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
darstellt.
26.2 Die Hauptversammlung entscheidet über die Verwendung des Saldos des jährlichen Reingewinns. Sie kann ent-
scheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen, ihn auf neue Rechnung zu übertragen
oder ihn in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.
26.3 Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen eine Abschlagsdividende auszah-
len. Der Verwaltungsrat bestimmt den Betrag und das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.
VI. Auflösung, Liquidation
27. Auflösung, Liquidation
Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft durch einen Hauptversammlungsbe-
schluss aufgelöst werden, der gemäß den Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die in vor-
liegendem Gesellschaftsvertrag für Abänderungen desselben vorgesehen sind. Bei Auflösung der Gesellschaft wird die
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen, die von der Hauptversammlung ernannt werden,
welche deren Befugnisse und Bezüge festlegt.
VII. Anwendbares Recht
28. Anwendbares Recht
Sämtliche Angelegenheiten, die vorliegendem Gesellschaftsvertrag nicht unterliegen, werden in Übereinstimmung mit
dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, geregelt.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, den Herren Franz Schaefer, Stephan Morsch und Timo Engelhardt
für ihre Amtsausübung als Verwaltungsratsmitglieder Entlastung zu erteilen, ihren Rücktritt als Verwaltungsratsmitglie-
der anzunehmen, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf fünf (5) festzulegen und folgende Personen zu neuen Ver-
waltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zu bestellen, jeweils für einen Zeitraum, der am Tag der Jahres-
hauptversammlung im Jahre 2006 endet:
- Frau Lisa Stone, Investmentmanager, geschäftsansässig in Third Floor, Minerva House, 3-5 Montague Close, London
SE1 9BB, Vereinigtes Königreich;
- Herrn Richard P. W. Donner, Investmentbanker, wohnhaft in Tudor Lodge, Hendon Wood Lane, Mill Hill, London
NW7, Vereinigtes Königreich;
- Herrn Kai Romberg, Investmentmanager, geschäftsansässig in Third Floor, Minerva House, 3-5 Montague Close,
London SE1 9BB, Vereinigtes Königreich;
- Herrn Michael Röchner, geschäftsführender Direktor, wohnhaft in Stuttgarter Straße 35, 71638 Ludwigsburg,
Deutschland; und
- Herrn Brian Cook, Unternehmensfinanzberater, wohnhaft in 12, Lyndhurst Road, London NW3 5NL, Vereinigtes
Königreich.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, Herrn Wolfgang Essler für seine Amtsausübung als Kommissar Ent-
lastung zu gewähren, seinen Rücktritt als Kommissar anzunehmen, die Anzahl der Kommissare auf einen (1) Kommissar
festzulegen und folgende Person zum Kommissar der Gesellschaft für einen Zeitraum zu bestellen, der am Tag der Jah-
reshauptversammlung im Jahre 2006 endet:
- DELOITTE S.A., Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg.
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist wurde die Sitzung um 19.30 Uhr geschlossen.
63000
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf sechsundzwanzigtausendfünfhundert Euro geschätzt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch ver-
fasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Ab-
weichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.
Aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten
Komparenten haben dieselbe zusammen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J.-P. Spang, L. Schummer, M. Müller, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 27. Juni 2005, Band. 895, Blatt. 17, Feld 6. – Erhalten 23.647,50 Euro.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(064440.3/239/1173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
ADDISON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 108.506.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 13 juillet 2005.
(064441.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
MOBILE SIGNAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 109.478.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fifteenth of July.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. MAUNDER INVESTMENTS CORPORATION, a company duly organized under the law of the British Virgin
Islands, having its registered office at P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the
Companies’ Registrar of Tortola under N
o
IBC 451.957,
here represented by Ms Sabine Perrier, Corporate Director, with residence address at 5, chemin du Colombier,
57100 Thionville, France,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 6, 2005.
2. Ms Sabine Perrier, Corporate Director, with residence address at 5, chemin du Colombier, 57100 Thionville,
France, acting in her own name.
Such proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the above named qualities, have decided to form amongst themselves a company in
accordance with the following Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a limited company (Société Anonyme) under the name of MOBILE SIGNAL S.A.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy
of Luxembourg by a resolution of the Shareholders and to any other place within Luxembourg Town by a resolution of
the board of Directors.
If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the company which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.
The company is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the company is the holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies or foreign companies specialized in computer systems (hard and software) and in new technologies and any
other form of investment, the acquisition, by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by
sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.
Beles, den 13. Juli 2005.
J.-J. Wagner.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
63001
The Company may take interests, by any means, in any businesses, undertakings or companies having the same, analo-
gous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in
accomplishment of its purposes in accordance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amend-
ed.
Art. 3. The corporate capital of the company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into ten
thousand (10,000) shares of stock having a par value of three Euro and ten Cent (EUR 3.10) each.
Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder, except those shares for
which the law prescribes the registered form.
The company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single share or two or more
shares.
The company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of
the amended Law of August 10tn, 1915 on commercial companies.
Art. 5. The company shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not
to be shareholders.
The directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible, they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting.
Art. 6. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of
the company.
All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
The board of directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another director may preside over
the meeting.
The board of directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors which may be given by letter, telegram, telefax or telex, being permitted.
In case of urgency, directors may vote by letter, telegram, telefax or telex or in form of circular resolution.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has the casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day to day management and the repre-
sentation of the company in connection therewith to one or more directors, managers or other officers, they need not
be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The company is bound by the joint signatures of any two directors or by the sole signature of the managing director.
Art. 7. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty first of December of
the same year.
Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-
dicated in the convening notices on the fourth Tuesday of June at 4 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted
to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Art. 11. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the company.
It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the amended Law of August 10th, 1915, the board of
directors is authorised to distribute interim dividends.
Art. 13. The Law of August 10th, 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply providing these Articles
of Incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2006.
2) The first annual general meeting shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The above-named parties have subscribed the shares as follows:
1. MAUNDER INVESTMENTS CORPORATION, prenamed, six thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,000
2. Ms Sabine Perrier, prenamed, four thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,000
Total: ten thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000
63002
All these shares have been paid up to the extent of one hundred percent in cash, so that the sum of thirty-one
thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commer-
cial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about two thousand one hundred (2,100.-)
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Joël Ake, named Dan-Joël Ake, company manager, residing at 7, rue Nicolas Wester, L-5836 Alzingen, born on
December 11, 1960 in Nancy, France;
b) Ms Emmanuelle Didion, management controller, residing at 3, rue Sturel Paigné, L-57000 Metz, born on February
23, 1970 in Nancy, France;
c) Mr Bertrand Gerard, administration director, residing in 25, rue Jouffroy d’Abbans, F-75017 Paris, born on January
1st, 1968 in Paris, France.
3) The following is appointed Auditor:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg n
o
58.155, 134, route d’Arlon, B.P. 18, L-
8001 Strassen.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
5) The company shall have its registered office in 1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
6) The board of directors is authorised to appoint a managing director, according to Article 60 of the Law on
Commercial Companies.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing persons, said
mandatory signed together with us, the Notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. MAUNDER INVESTMENTS CORPORATION, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège
social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée au Registre des Sociétés de Tortola sous
le n
o
IBC 451.957,
ici representée par Madame Sabine Perrier, Administrateur de Sociétés, demeurant 5, chemin du Colombier, F-57100
Thionville,
en vertu d’un procuration établie à Luxembourg, le 6 juillet 2005.
2. Madame Sabine Perrier, Administrateur de Sociétés, demeurant 5, chemin du Colombier, F-57100 Thionville,
agissant en son nom personnel.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte, pour être enregistrée en même temps.
Les comparantes, agissant dans leurs qualités décrites ci-dessus, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société
anonyme qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de MOBILE SIGNAL S.A.
Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par décision des décisions des associés prise suivant les conditions exigées pour la modification des statuts et
dans toute autre endroit de la Commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés Luxem-
bourgeoises ou étrangères spécialisées dans les domaines informatiques (hard & software) ainsi que dans le domaines
63003
des nouvelles technologies et toutes autres formes de placements, l’acquisition par l’achat, la souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille. La Société peut s’intéresser, par toutes voies, dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés ayant le même objet analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le déve-
loppement de son entreprise ou à le lui faciliter.
En général, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utile
à l’accomplissement de son objet, selon les dispositions de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en dix mille (10.000) actions de valeur
nominale trois euros et dix cents (3,10 EUR).
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, sauf celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les
dispositions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou télex ou sous forme de résolutions
circulaires.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La Société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de
l’administrateur délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à 16 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, com-
me modifiée, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1. MAUNDER INVESTMENTS CORPORATION, préqualifiée, six mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
2. Madame Sabine Perrier, préqualifiée, quatre mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
63004
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (EUR
31.000,-) est la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille cent
(2.100,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Joël Ake, dit Dan-Joël Ake, dirigeant de société, demeurant à 7, rue Nicolas Wester, L-5836 Alzingen,
né le 11 décembre 1960 à Nancy, France;
b) Madame Emmanuelle Didion, contrôleur de gestion, demeurant à 3, rue Sturel Paigné, F-57000 Metz, née le 23
février 1970 à Nancy, France;
c) Monsieur Bertrand Gerard, directeur administratif, demeurant à 25, rue Jouffroy d’Abbans, F-75017 Paris, né le 6
janvier 1968 à Paris, France.
3) Est appelé à la fonction de commissaire-aux-comptes:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg n
o
58.155, 134, route d’Arlon, B.P. 18, L-
8001 Strassen.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5) Le siège social est fixé à 1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
6) Le conseil d’administration est autorisé à élire en son sein, un administrateur délégué, en vertu de l’article 60 de
la Loi régissant les sociétés commerciales.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes
comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée la mandataire des comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la
présente minute.
Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 1, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065537.3/230/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.
FIPOP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 109.470.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the eighteenth day of July.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
1) Mr. Declan Harrington, financial advisor, residing in Ballingeary, Macroom, Co Cork, Ireland,
duly represented by M
e
Samia Rabia, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on July 15, 2005;
2) Mr Richard Pratt, property developer, residing in Ardfallen House, Sundays Well, Co Cork, Ireland,
duly represented by Maître Samia Rabia, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal, given on July 15, 2005.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as here above stated, have requested the notary to state the following articles
of incorporation of a limited liability corporation («société anonyme») governed by the relevant laws and the present
Articles:
Luxembourg, le 22 juillet 2005.
A. Schwachtgen.
63005
Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares in
the future, a Luxembourg corporation in the form of a «société anonyme», under the name of FIPOP S.A. (hereafter
called «the Corporation»).
Art. 2. The Corporation is established for an undetermined period.
Art. 3. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City.
It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of directors of the Cor-
poration.
It may also be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
general meeting of its shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.
Art. 4. The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,
financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, option or in any other way.
The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as
they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.
Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:
- Acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,
bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes there-
fore, as well as the lending of money;
- Acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-
marks or other similar interests;
- Rendering of technical assistance;
- Participation in and management of other companies;
- Borrowing of monies;
- Creation of mortgages and charges over the assets of the Corporation including over any of its property assets;
- entering into any ISDA master agreements and generally, entering into any, derivatives and similar transactions.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, notes, securities, debentures and cer-
tificates.
In general, the Corporation may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and de-
velopment of its purposes.
Title II. Capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) represented by
1.000 (one thousand) shares with a nominal value of EUR 31.- (thirty-one Euro) each, which have been entirely paid up.
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-
ner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. Each share entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Cor-
poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Corporation.
Art. 7. The shareholders’ meeting shall be convened by the President of the board of directors or by any two direc-
tors.
Notices for general meetings shall be given by cable, telex, telegram, telefax or by e-mail and shall be deemed to be
given when sent as aforesaid.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders
of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of
the Corporation.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of those present or represented.
63006
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax
or by email another person who need not be a shareholder.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of share-
holders representing at least two third (2/3) of the capital. The shareholders may change the nationality of the Corpo-
ration by unanimous decision.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Cor-
poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice on the last Wednesday in
the month of June of each year at 2.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.
Art. 9. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents
of the Corporation.
Title III. Administration
Art. 10. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least 3 (three) directors, who
need not be shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period of one year and they
shall hold office until their successors are elected.
Art. 11. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet as may be required and at least quarterly upon call by the chairman, or two (2)
directors, at Luxembourg.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.
This notice may be waived by the consent in writing by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previ-
ously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may give power of attorney to another director who will represent him at any meeting of the board of
directors. Such power of attorney may be given in writing by cable, telegram, telex or telefax, or by email.
The board of directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the directors is present or repre-
sented at the meeting.
Resolutions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at a meeting
of directors.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two directors.
Art. 13. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the Corporation’s interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the
board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation and the rep-
resentation of the Corporation for such management, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any
member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors), under such
terms and with such powers as the board shall determine.
It may also confer all powers and special mandates to any person(s), who need not be directors, appoint and dismiss
all officers and employees, and fix their compensation.
Art. 14. The Corporation will be bound by the joint signature any two directors, provided however that, in case one
or several Luxembourg resident director(s) has/have been appointed by the shareholders, at least one Luxembourg res-
ident director be one of the two.
The Corporation will also be bound by the single or joint signature of any such person to whom such signatory power
shall have been delegated by the board of directors.
Art. 15. In the execution of their mandate, the directors are not held personally responsible for the obligations of
the Corporation. As agents of the Corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 16. The operations of the Corporation shall be supervised by one or several auditors. The general meeting of
shareholders shall appoint the auditors for a period of one year, and shall determine their number and remuneration.
The term of office of the auditors shall end at the end of each annual general meeting of shareholders; they may be
re-elected.
63007
Art. 17. The accounting year of the Corporation shall begin on January first (January 1st) of each year and shall ter-
minate on December thirty-first (December 31st).
Art. 18. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each fiscal year and will be at
the disposal of the shareholders at the registered office of the Corporation.
Out of the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Corpo-
ration.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual
net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Title IV. Winding-up - Liquidation
Art. 19. In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders resolving such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 20. All matters not expressly governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on commercial companies, such as amended.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the appearing parties, here represented as stated here above, declare to subscribe to the shares as fol-
lows:
The 1.000 (one thousand) shares of the Corporation have been entirely subscribed by the subscribers and entirely
paid in, in cash, so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) is at the free disposal of the Corporation,
as was certified to the notary executing this deed.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year begins today and it will end on December 31, 2005.
The first annual general meeting of shareholders will be held in 2006.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves
as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the extraordinary general meeting of shareholders has passed
the following resolutions by unanimous vote:
1. The registered office of the Corporation is set at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of auditors at 1 (one).
3. The following persons are appointed as directors:
- Mr. Michael McDonald, director of companies, born in Manchester (England) on January 10, 1948, residing profes-
sionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Mr. Declan Harrington, financial advisor, born in Cork (Ireland) on May 5, 1964, residing in Ballingeary, Macroom,
Co Cork, Ireland;
- Mr. Olivier Ferrer, auditor, born in Orange (France) on May 5, 1969, residing professionally in L-2320 Luxembourg,
69, boulevard de la Pétrusse.
4. Has been appointed to assume the role as auditor: KPMG AUDIT, S.à r.l., with registered office at L-2520 Luxem-
bourg, 31, allée Scheffer, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 103.590.
5. The term of office of the directors and of the auditor shall end at the end of the annual general meeting of share-
holders to be held in two thousand and six (2006).
6. The board of directors is authorised to delegate the daily management of the Corporation and the representation
of the Corporation in connection therewith to any member or members of the board or to any committee (the mem-
bers of which need not be directors).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
Shareholders Subscribed
Paid-in Number
of
capital
capital
shares
(in EUR) (in EUR)
- Mr. Declan Harrington, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,500.-
15,500.-
500
- Mr. Richard Pratt, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000.-
15,000.-
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000.-
31,000.-
1,000
63008
appearing persons and in case of divergences between the French and the English text, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The deed having been read in the language of the proxyholder, known to the notary by surname, Christian name, civil
status and residence, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Declan Harrington, conseiller financier, demeurant à Ballingeary, Macroom, Co Cork, Irlande,
dûment représenté par Maître Samia Rabia, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 juillet 2005.
2) Monsieur Richard Pratt, property developer, demeurant à Ardfallen House, Sundays Well, Co Cork, Irlande,
dûment représenté par Maître Samia Rabia, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 juillet 2005.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une
société anonyme régie par les lois applicables et les présents Statuts:
Titre I
er
. Nom - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Il est crée entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires à l’avenir, une Société anonyme
de droit luxembourgeois sous le nom de FIPOP S.A. (ci-après «la Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré dans la municipalité de Luxembourg-Ville par une résolution du conseil administration de la
Société.
Il pourra aussi être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de l’assem-
blée générale de ses actionnaires.
La Société peut avoir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil
d’administration.
Si des évènements politiques, économiques ou sociaux de nature à interférer sur l’activité normale de la Société en
son siège, ou encore sur la communication entre ce siège et les personnes se trouvant à l’étranger, comme prévu par
la gérance de la Société, se sont produits ou bien sont sur le point de se produire, le siège social sera temporairement
transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n’auront
aucune incidence sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège demeurera une Société
luxembourgeoise. De telles mesures seront prises et notifiées à toutes les parties intéressées par le conseil d’adminis-
tration de la Société.
Art. 4. L’objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute société com-
merciale, industrielle, financière ou autres, luxembourgeoise ou étrangères; l’acquisition de toutes actions et droits par
le biais de participation, apport, option ou tout autre moyen.
La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier, établir, gérer, développer et disposer de ses actifs
dans l’état dans lequel ils se trouveront, entre autre, mais non limité à son portefeuille de titres de quelque origine que
ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir, par le biais d’investisse-
ment, de souscription, ou option, titres, et tous droits de propriété intellectuelle, les réaliser par la vente, transfert,
échange ou autre, recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder à ou au profit
de sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe, toute assis-
tance, y compris toute assistance financière, prêts, avances ou garanties.
Sans préjudice à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- Acquisition, possession, administration, vente, échange, transfert, commerce et investissement ou aliénation d’ac-
tions, obligations, fonds, notes, titres de créances et autres titres, emprunt de fonds et émission d’emprunt y relatif, ainsi
que le prêt;
- Acquisition de ressources provenant de la disposition ou l’exploitation de droits d’auteur, brevet, conceptions, se-
cret de fabrication, marque de fabrique ou autres intérêts similaires;
- Assistance technique;
- Participation dans l’administration d’autres sociétés;
- Emprunt d’argent;
- Création d’hypothèques et de sûretés sur les actifs de la Société, y inclus sur toutes les propriétés de la Société;
- Conclusion de tout contrat ISDA master agreement et généralement conclusion de tout instrument dérivatif et
transactions similaires.
La Société pourra contracter des emprunts sous toute forme et émettre des obligations, notes, valeurs mobilières,
reconnaissance de dette et certificats.
63009
D’une manière générale, la Société est autorisée à faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et
au développement de son objet social.
Titre II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des actionnaires adoptée de la façon exigée
pour la modification des statuts de la Société.
La Société pourra racheter ses propres actions dans la mesure autorisée par la loi.
Art. 6. Chaque action donne droit à une voix lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaît qu’une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la So-
ciété a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a
pas été désignée comme en étant le seul propriétaire en relation avec la Société.
Art. 7. L’assemblée générale des actionnaires sera convoquée par le Président du conseil d’administration ou par
deux administrateurs.
Les convocations aux assemblées générales des actionnaires pourront être faites par câble, télex, télégramme, téléfax
ou par e-mail et devront être considérées comme accomplies quand elles auront été effectuées comme précité.
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l’intégralité des actionnaires
de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les
activités de la Société.
Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d’une assemblée des actionnaires régulièrement convo-
quée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Un actionnaire pourra agir à toutes les assemblées d’actionnaires en nommant par écrit ou câble, télégramme, télex
ou téléfax ou par e-mail toute autre personne, qui n’a pas besoin d’être actionnaire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou pu-
blication préalable si l’assemblée constate qu’elle a bien été informée de l’ordre du jour de l’assemblée.
Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par une ma-
jorité des actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) du capital social. Les actionnaires pourront changer la
nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.
Art. 8. L’assemblée générale ordinaire de la Société se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg comme il peut être indiqué dans la convocation, le dernier mercredi de juin de chaque
année à 14 (quatorze) heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale a lieu le prochain jour ouvrable.
Art. 9. Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir
des actifs ou des documents de la Société.
Titre III. Administration
Art. 10. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois (3) administrateurs
qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période d’une
année et ils continueront d’être en exercice jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et est autorisé à choisir parmi
ses membres un vice-président. Le conseil d’administration pourra également choisir un(e) secrétaire qui n’a pas besoin
d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira à Luxembourg autant que de besoin et au moins tous les trois mois sur con-
vocation du Président ou de deux (2) administrateurs.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration devra être adressée à tous les administrateurs
au moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des
circonstances d’urgence devra être mentionnée dans la convocation.
Cette convocation pourra être écartée de l’accord écrit par câble, télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail de
chaque administrateur.
Une convocation séparée ne sera pas nécessaire pour les réunions ponctuelles tenues aux lieux et place prévus par
le calendrier précédemment adopté par une résolution du conseil d’administration.
Chaque administrateur pourra donner mandat à un autre administrateur qui le représentera à toute réunion du con-
seil d’administration. Un tel mandat pourra être donné par écrit par câble, télégramme, télex ou téléfax ou par e-mail.
Le conseil d’administration pourra délibérer et agir valablement à la condition qu’au moins la majorité des adminis-
trateurs soit présente ou représentée à la réunion.
Les décisions devront être prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion.
Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration, auront le
même effet que les résolutions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en son ab-
sence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.
63010
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront
signés par le président, le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration
et de disposition dans l’intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des actionnaires seront de la compé-
tence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la repré-
sentation de la Société pour ses affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à tout
(tous) membre(s) du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs), aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration.
Il pourra également conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui n’a pas besoin d’être admi-
nistrateur, engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.
Art. 14. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, sous réserve que, dans le cas
où les actionnaires ont nommé un ou plusieurs administrateur(s) résidant au Luxembourg, l’un au moins des signataires
soit un administrateur résident luxembourgeois.
La Société sera également engagée par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir
de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 15. Dans l’exécution de leur mandat, les administrateurs ne seront pas responsables personnellement des en-
gagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l’exercice correct de leurs
obligations.
Art. 16. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires. L’assemblée générale des
actionnaires procèdera à la nomination des commissaires pour une année, et déterminera leur nombre et leur rémuné-
ration.
La durée des fonctions des commissaires prendra fin lors de chaque assemblée générale ordinaire annuelle; ils sont
rééligibles.
Art. 17. L’année sociale de la Société commencera le premier janvier (1
er
janvier) de chaque année et se terminera
le trente et un décembre (31 décembre).
Art. 18. A la fin de chaque exercice, le conseil d’administration préparera les comptes annuels qui seront à la dispo-
sition des actionnaires au siège social de la Société.
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société sera affecté à la réserve légale. Cette déduction
cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera l’affectation des
bénéfices nets annuels.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les termes et conditions de la loi.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront
être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant
de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Art. 20. Tout ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance
avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés ainsi qu’il a été dit, déclarent souscrire
au capital comme suit:
Les mille (1.000) actions de la Société ont été entièrement souscrites par les souscripteurs et entièrement libérées
par des versements en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre dispo-
sition de la Société, comme certifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et déclare expressément que ces conditions sont
remplies.
Actionnaires Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré d’actions
(en EUR)
(en EUR)
- M. Declan Harrington, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500,-
15.500,-
500
- M. Richard Pratt, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000,-
15.000,-
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,-
31.000,-
1.000
63011
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000).
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires i>
Les personnes pré-qualifiées, dûment représentées, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considé-
rant comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
3. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d’administrateurs:
- Monsieur Michael McDonald, administrateur de sociétés, né à Manchester (Angleterre) le 10 janvier 1948, demeu-
rant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Monsieur Declan Harrington, conseiller financier, né à Cork (Irlande) le 5 mai 1964, demeurant professionnellement
à Ballingeary, Macroom, Co Cork (Irlande);
- Monsieur Olivier Ferrer, expert comptable, né le 5 mars 1969 à Orange (France), demeurant professionnellement
à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
4. Est nommée commissaire aux comptes: la société KPMG AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxem-
bourg, 31, allée Scheffer, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 103.590.
5. Les administrateurs et le commissaire sont nommés jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle des actionnaires
qui se tiendra en deux mille six (2006).
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation
à cet égard à l’un ou plusieurs de ses membres ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs).
Le notaire instrumentant, lequel comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, dûment repré-
sentés, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé
avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Rabia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 37, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(065174.3/222/422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. ESPIRITO SANTO FINANCIAL HOLDING S.A.).
Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.
—
In the year two thousand and five, on the twentieth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Laurent Schummer, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as special attorney in fact of the board of directors of ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP
S.A., a société anonyme, having its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, incor-
porated on 28 November 1984 pursuant to a deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, published
in the Mémorial C number 2 of 3 January 1985 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des So-
ciétés under number B 22.232, whose articles of associations have been amended for the last time pursuant to a deed
of the undersigned notary of 8 July 2005, not yet published (the «Company»),
by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the board of directors of the Company on 12
July 2005, and in consideration of the decisions adopted by the special attorney of the board of directors on 14 July 2005
and on 19 July 2005, a copy of which resolutions by the board of directors and decisions by the special attorney, signed
ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which
it shall be formalised.
The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I. That the issued share capital of the Company is presently set at four hundred seventy-nine million eighty-five thou-
sand five hundred fifty Euro (EUR 479,085,550.-), divided into forty-seven million nine hundred eight thousand five hun-
dred fifty-five (47,908,555) shares, each of a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) fully paid up.
II. That pursuant to Article 5 of the Company’s articles of association, the authorised capital of the Company has been
fixed at one billion Euro (EUR 1,000,000,000.-) represented by one hundred million (100,000,000) shares of ten Euro
Luxembourg-Bonnevoie, le 22 juillet 2005.
T. Metzler.
63012
(EUR 10.-) each and that pursuant to the same Article 5, the board of directors of the Company has been authorised
to increase the issued share capital of the Company, such article of the articles of association then to be amended so as
to reflect the increase of capital.
III. That the board of directors of the Company, in its meeting of 12 July 2005 and in accordance with the authority
conferred on it pursuant to Article 5 of the Company’s articles of association, has decided to issue up to eight million
five hundred thousand (8,500,000) new shares plus one million five hundred thousand (1,500,000) new shares on exer-
cise of the over-allotment option and to cancel the preferential subscription rights of the Company’s existing sharehold-
ers to subscribe for the new shares and has appointed Mr Manuel Villas-Boas, director of the Company, as the special
attorney in fact of the board of directors to decide, upon consultation with the Chairman of the board of directors of
the Company, on the actual number of new shares to be issued, including any new shares to be issued on the exercise
of the over-allotment option and on the actual issue price of the new shares including any new shares to be issued on
the exercise of the over-allotment option.
IV. That Mr Manuel Villas-Boas, in his capacity as special attorney in fact of the board of directors has decided on 14
July 2005 to set the actual number of shares to be issued at seven million eight hundred ninety-four thousand seven
hundred thirty-six (7,894,736) new shares and to set the actual issue price of the new shares at nineteen Euro (EUR 19).
V. That Mr Manuel Villas-Boas, in its capacity as special attorney in fact of the board of directors having acknowledged
that the Company had received for value 19 July 2005 an amount of one hundred forty-nine million nine hundred ninety-
nine thousand nine hundred eighty-four Euro (EUR 149,999,984.-), has decided on 19 July 2005 to issue seven million
eight hundred nine-four thousand seven hundred thirty-six (7,894,736) new shares with a par value of ten Euro (EUR
10.-) with payment of a share premium of nine Euro (EUR 9.-) per share.
VI. That the amount of one hundred forty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-four
Euro (EUR 149,999,984.-) has been on 19 July 2005 at the free disposal of the Company, as was evidenced to the un-
dersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.
VII. That as a consequence of the above mentioned issue of shares, with effect as of 19 July 2005, paragraph one of
Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:
«Art. 5, paragraph 1. The authorised capital is fixed at one billion (1,000,000,000.-) Euro (EUR) represented by
one hundred million (100,000,000) shares of ten (10.-) Euro (EUR) each, of which fifty-five million eight hundred three
thousand two hundred ninety-one (55,803,291) shares have been issued, subscribed and fully paid in, representing an
issued capital of five hundred fifty-eight million thirty-two thousand nine hundred ten (558,032,910.-) Euro (EUR).»
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the
present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP
S.A., une société anonyme ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, consti-
tuée le 28 novembre 1984 suivant acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, numéro 2 du 3 janvier 1985 et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 22.232, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 8
juillet 2005, non encore publié (la «Société»),
en vertu du pouvoir qui lui a été conféré par résolutions adoptées par le conseil d’administration de la Société en
date du 12 juillet 2005 et compte tenu des décisions adoptées par le mandataire spécial du conseil d’administration les
14 juillet 2005 et 19 juillet 2005, une copie desdites résolutions du conseil d’administration et décisions adoptées par le
mandataire spécial, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et
constatations suivantes:
I. Que le capital social de la société s’élève actuellement à quatre cent soixante dix-neuf millions quatre-vingt-cinq
mille cinq cent cinquante euros (EUR 479.085.550,-), divisé en quarante-sept millions neuf cent huit mille cinq cent
cinquante-cinq (47.908.555) actions, chacune ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) entièrement libérées.
II. Qu’en vertu de l’article 5 des statuts de la société, le capital autorisé de la société a été fixé à un milliard d’euros
(EUR 1.000.000.000,-) représenté par cent millions (100.000.000) d’actions de dix euros (EUR 10,-) chacune et que
conformément au même article 5, le conseil d’administration de la Société a été autorisé à augmenter le capital émis de
la Société, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter l’augmentation de capital.
III. Que le conseil d’administration de la Société, lors de sa réunion du 12 juillet 2005 et conformément au pouvoir
qui lui a été conféré en vertu de l’article 5 des statuts de la Société, a décidé d’émettre au maximum huit millions cinq
cent mille (8.500.000) nouvelles actions plus au maximum un million cinq cent mille (1.500.000) nouvelles actions lors
de l’exercice de l’option de sur-allocation et d’annuler le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
63013
de la Société pour la souscription des nouvelles actions et a nommé Monsieur Manuel Villas-Boas, administrateur de la
Société, comme mandataire spécial du conseil d’administration pour décider, après consultation avec le président du
conseil d’administration de la Société, du nombre total de nouvelles actions à émettre, y compris toutes nouvelles ac-
tions à émettre lors de l’exercice de l’option de sur-allocation, ainsi que le prix d’émission définitif de ces nouvelles ac-
tions, y compris les nouvelles actions devant être émises lors de l’exercice de l’option de sur-allocation.
IV. Que Monsieur Manuel Villas-Boas, en sa capacité de mandataire spécial du conseil d’administration a décidé le 14
juillet 2005 de fixer le nombre définitif des actions à émettre à sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille sept
cent trente-six (7.894.736) nouvelles actions et de fixer le prix définitif d’émission des nouvelles actions à dix-neuf euros
(EUR. 19,-).
V. Que Monsieur Manuel Villas-Boas, en sa capacité de mandataire spécial du conseil d’administration, ayant pris acte
que la Société a reçu avec date de valeur le 19 juillet 2005 un montant de cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre vingt-quatre euros (EUR. 149.999.984,-), a décidé le 19 juillet 2005 d’émettre sept
millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent trente-six (7.894.736) nouvelles actions avec une valeur nomi-
nale de dix euros (EUR. 10,-) et paiement d’une prime d’émission de neuf euros (EUR. 9,-) par action.
VI. Que le montant de cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre
euros (EUR. 149.999.984,-) est à compter du 19 juillet 2005 à la libre disposition de la société, comme prouvé au notaire
instrumentant par présentation des documents concernant lesdits paiements.
VII. Qu’en conséquence de l’émission d’actions mentionnée ci-dessus, avec effet au 19 juillet 2005, le premier para-
graphe de l’article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5, alinéa 1
er
. Le capital social autorisé est fixé à un milliard (1.000.000.000,-) d’euros (EUR), représenté par
cent millions (100.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix (10) euros (EUR) chacune, dont cinquante-cinq
millions huit cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze (55.803.291) actions ont été émises, souscrites et entièrement
libérées, représentant un capital émis de cinq cent cinquante-huit millions trente-deux mille neuf cent dix (558.032.910)
euros (EUR).»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-
sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Schummer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, vol. 149S, fol. 31, case 9. – Reçu 1.499.999,84 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064492.3/230/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. ESPIRITO SANTO FINANCIAL HOLDING S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1172 du 20 juillet 2005 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064494.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
I.D.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 13, rue de Thionville.
R. C. Luxembourg B 73.924.
—
L’an deux mille cinq, le treize juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.D.S. S.A., ayant son siège
social à L-2611 Luxembourg, 13, rue de Thionville, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la
section B et le numéro 73.924, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à
Hesperange, en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 19 avril 2000,
numéro 292.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 février 2004,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 22 avril 2004, numéro 429.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlos Marques, employé privé, demeurant professionnel-
lement au 81, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Carmo Pedroso, employée privée, demeurant professionnellement au 81,
avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 juillet 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
63014
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Soumois, employé privé, demeurant professionnellement au
81, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social souscrit et versé de la société, à concurrence de EUR 13,31 pour porter le capital
social à EUR 31.000 sans création d’actions; suppression de la désignation de la valeur nominale des actions; libération
en espèces par les actionnaires actuels;
2. Modification du nombre d’actions pour le porter à 531;
3. Augmentation du capital social souscrit et versé de la société, à concurrence de EUR 500.000,- pour porter le
capital social souscrit à EUR 531.000,- sans création d’actions nouvelles et en augmentant le pair comptable de chaque
action;
4. Souscription et libération intégrale en espèces par les actionnaires actuels de la Société;
5. Modification afférente du paragraphe 1
er
de l’article 5 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-
bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit et versé de la société à concurrence de treize euros et
trente et un centimes (EUR 13,31) de manière à le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-
six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sans création d’actions
nouvelles.
<i>Libérationi>
Le montant de treize euros et trente et un centimes (EUR 13,31) en espèces est à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de modifier le nombre d’actions
de sorte que le capital social se divise en cinq cent trente et une (531) actions sans désignation de valeur nominale.
Les cinq cent trente et une (531) actions sont réparties entre les actionnaires proportionnellement aux actions
détenues avant modification de leur nombre.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit et versé de la société de cinq cent mille euros (EUR
500.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cinq cent trente
et un mille euros (EUR 531.000,-) sans création d’actions nouvelles en augmentant le pair comptable de chaque action.
<i>Libérationi>
Le montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) en espèces est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration afin de
procéder à l’échange des anciennes actions contre cinq cent trente et une (531) actions sans désignation de valeur
nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’Article 5 des statuts conformément aux décisions précé-
dentes, lequel aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
paragraphe. Le capital souscrit est fixé à cinq cent trente et un mille euros (EUR 531.000,-) représenté
par cinq cent trente et une (531) actions sans désignation de valeur nominale.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’Article 26, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de six mille neuf cents euros (EUR 6.900,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
63015
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: C. Marques, C. Pedroso, R. Soumois, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 100, case 5. – Reçu 500,13 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064726.3/202/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
I.D.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 13, rue de Thionville.
R. C. Luxembourg B 73.924.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064744.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
SOCIETE HOTELIERE EUROPE S.A., Société Anonyme,
(anc. SOCIETE HOTELIERE EUROPE, S.à r.l.).
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 27.918.
—
L’an deux mille cinq, le vingt juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société anonyme XILUX IMMOBILIERE S.A., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 33.940,
ici dûment représentée par Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, L-8070 Bertrange, Atrium Business Park,
31, Zone d’Activités Bourmicht, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SOCIETE HOTELIERE EUROPE, S.à r.l. avec siège social à L-2212 Luxem-
bourg, 6, place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
27.918, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 mars 1988, publié au Mémorial C
numéro 181 du 4 juillet 1988,
que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg,
en date du 26 mai 1989, publié au Mémorial C numéro 343 du 23 novembre 1989,
et que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par
l’assemblée générale des associés tenue en date du 10 avril 2002, l’extrait afférent ayant été publié au Mémorial C
numéro 1296 du 6 septembre 2002.
- Que le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cents euros (495.800,- EUR), représenté
par deux mille (2.000) parts sociales de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix cents (247,90 EUR).
- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et
qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, accorde décharge au gérant, Monsieur Eric Lux, administrateur
de sociétés, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 31, Zone d’Activité Bourmicht, pour l’exercice de son
mandat jusqu’à la date de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide de transformer la société à responsabilité limitée SOCIETE
HOTELIERE EUROPE, S.à r.l. en une société anonyme qui sera dorénavant dénommée SOCIETE HOTELIERE EUROPE
S.A.
L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide en outre de transformer les parts sociales de la société à
responsabilité limitée en actions et le capital social sera représenté dorénavant par deux mille (2.000) actions nouvelles
d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix cents (247,90 EUR).
Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est
créée; la société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existée jusqu’à présent,
avec la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de
cette société.
Senningerberg, le 21 juillet 2005.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 21 juillet 2005.
P. Bettingen.
63016
<i>Rapport du réviseur d’entreprisesi>
Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur d’entreprises, Monsieur Guy Schosseler de la société à responsa-
bilité limitée S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, avec siège social à L-2546
Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, et dont les conclusions sont établies comme suit:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
transformation de la Société en société anonyme et sur la valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à
la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, à la suite de la transformation d’un nombre équivalent de parts
sociales de société à responsabilité limitée.
Luxembourg, le 16 juin 2005.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:
STATUTS
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE HOTELIERE EUROPE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un hôtel-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcoo-
liques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales financières ou civiles, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chent directement u indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation
ou l’extension.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cents euros (495.800,- EUR), représenté
par deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix cents (247,90
EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
63017
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
mercredi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
Décision est prise de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer aux fonctions d’administrateurs, leur
mandat expirant lors de l’assemblée générale de 2011:
a) Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés né à Luxembourg, le 19 décembre 1967, L-8070 Bertrange, Atrium
Business Park, 31, Zone d’Activités Bourmicht;
b) Monsieur Edouard Lux, administrateur de sociétés, né à Greisch, le 15 juin 1938, demeurant professionnellement
à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert;
c) Monsieur Romain Bontemps, associé, FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, né à Dudelange, le 27 décembre 1960,
demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
<i>Cinquième résolutioni>
Décision est prise de nommer la société à responsabilité limitée ABAX AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-
2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 27.761), comme commissaire aux comptes
de la société, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de 2010.
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de huit cent cinquante
euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Lux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2005, vol. 532, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065957.3/231/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.
PEF V ZELMER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 280.000,-.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.235.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05596, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063016.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Junglinster, le 18 juillet 2005.
J. Seckler.
Luxembourg, le 14 juillet 2005.
Signature.
63018
LAGOMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.868.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 6 juin 2005 à 10.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen
Lozie et COSAFIN S.A. en fonction et mandat du Commissaire aux Comptes, HRT REVISION, S.à r.l.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06808. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062897.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
AQUARELLE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 95.826.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 mars 2005i>
La société W@rm. UP S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, inscrite au Registre de Com-
merce à Luxembourg, numéro B 87.248, seul et unique associé de la société, déclarait son intention de vendre toutes
les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de la société à Madame Michelle Calevoi, née le 1
er
juillet 1955 à
Liège, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue Jean Chapelié, 27.
Le nouvel associé unique déclare accepter la cession de parts prémentionnée pour la société conformément à l’article
1690 du code civil, avec dispense de signification.
La répartition des parts sociales est donc dès maintenant comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06251. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062913.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
NORTH LINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 78.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06086, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063144.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
NORTH LINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 78.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, ée 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06090, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063149.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Michelle Calevoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts
AQUARELLE EUROPE, S.à r.l.
Signature
Signature.
Signature.
63019
ELVIRA S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 200.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.548.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2005 a approuvé les résolutions suivantes:
- Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Bart Zech et M. Markus Hugelshofer, est renouvelé
pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS & Co. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est
renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07406. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062944.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
INVESTMENTS NOVAPOL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 35.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.508.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2005 a approuvé les résolutions suivantes:
- Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Bart Zech et M. Markus Hugelshofer, est renouvelé
pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS & Co. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est
renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07407. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062953.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
INVESTMENTS SOLAPOL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 35.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.509.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2005 a approuvé les résolutions suivantes:
- Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Bart Zech et M. Markus Hugelshofer, est renouvelé
pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS & Co. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est
renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062955.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
VINS DESCOMBE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 102.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06954, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063045.3/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Luxembourg, le 10 juin 2005.
R.P. Pels.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
R.P. Pels.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
B. Zech.
Luxembourg, 11 juillet 2005.
Signature.
63020
ARTOTAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.250,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 45.463.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2005 a approuvé les résolutions suivantes:
3. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Bart Zech et Mme Anne Compère, est renouvelé
pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
4. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS Co. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est
renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07411. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062956.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
P.I.I. S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 260.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.883.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2005 a approuvé les résolutions suivantes:
- Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Bart Zech et Mme Anne Compère, est renouvelé
pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société Galina Incorporated est renouvelé pour une période de
six ans. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07412. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062959.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
HIG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 82.601.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 juin 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2004:
<i>Signataires catégorie A:i>
- Monsieur Ezio Tavasso, administrateur de société, demeurant à I-25100 Brescia (BS), Italie, Via Corfù n.55, Prési-
dent,
- Madame Germana Congiu, administrateur de société, demeurant à I-25100 Brescia (BS), Italie, Via S. Orsola n.62.
<i>Signataires catégorie B:i>
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re à Luxembourg,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2004:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Luxembourg, le 24 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06372. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(063706.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Luxembourg, le 22 juin 2005.
R.P. Pels.
Luxembourg, le 23 juin 2005.
R.P. Pels.
Pour extrait conforme
Signature
63021
A.I.J.A., ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
—
Il résulte d’un jugement rendu sur requête le 25 mai 2005 que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, pre-
mière chambre, a homologué la décision de l’assemblée générale du 28 août 2004 de l’association sans but lucratif AS-
SOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS ASBL, portant modification des statuts de la prédite
association.
A la suite de ladite modification, votée par l’assemblée générale extraordinaire, homologuée comme dit ci-avant, les
statuts de l’association ont été modifiés comme suit:
«Art. 7.
...
2) Peuvent devenir membres individuels les personnes physiques qui s’engagent à respecter les buts et les statuts de
l’association et remplissant toutes les autres conditions suivantes:
a) ...
b) être avocat, membre d’un barreau ou d’une institution officielle similaire dans les pays où il n’existe pas de barreau
ou être titulaire d’un diplôme universitaire en droit permettant l’accession à un barreau et exercer l’activité de juriste
d’entre prise;
c) ...»
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08397. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(063653.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
FISHING UND CAMPING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 29.928.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Mme
Marie-Claire Zehren, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.
Luxembourg, le 11 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05109. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(063432.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
ISLAND CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 246.004.350.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07413, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063134.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
ISLAND CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 246.004.350.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07414, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063136.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour extrait conforme
M. Kerger
<i>Pouri> <i>FISHING UND CAMPING A.G., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
B. Zech.
B. Zech.
63022
FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 46.910.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2005i>
En date du 5 juillet 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de ratifier les démissions de M. Roberto Felice Bigliardo, M. James Provan et de M. Christian Rovsing en date du 1
er
décembre 2004;
- de ratifier la cooptation de Mme Mia De Vits, M. James Nicholson et M. Terence Wynn en date du 1
er
décembre
2004, en qualité d’Administrateurs, en remplacement de M. Roberto Felice Bigliardo, M. James Provan et M. Christian
Rovsing, démissionnaires;
- de reconduire les mandats de Mme Mia De Vits, M. James Nicholson et de M. Terence Wynn en qualité d’Adminis-
trateurs pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006;
- de reconduire les mandats de M. Richard Balfe, M. Joan Colom I Naval, M. Manuel Carlos Porto, Mme Astrid Lulling,
M. Anthony Simpson, M. Eddie Thomas en qualité d’Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2006;
- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant fin
lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10979. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072768.3/1024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.
B.C. GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 82.733.
—
HRT REVISION, S.à r.l., auprès de laquelle la Société Anonyme Holding B.C. GESELLSCHAFTHOLDING S.A. a établi
son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg en date du 3 avril 2003, ayant constaté que ladite société domi-
ciliée a manqué à ses obligations, décide de dénoncer avec effet immédiat tout office de domiciliation et ce, sur base de
la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07670b. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068504.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.
GAMAX HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 73.325.
—
Par décision du Conseil d’administration du 1
er
juillet 2005, M. Roberto de Mari a été coopté au Conseil d’adminis-
tration, en remplacement de M. Pierluigi Vergari, démissionnaire.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: M. Roberto de Mari, Holbeinstrasse 11, D-81679
München, M. Giuseppe Lalli, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, I-20080 Basiglio, Milano 3 et M. Antonio Maria Penna, Palazzo
Meucci, Via F. Sforza, I-20080 Basiglio, Milano 3.
Luxembourg, le 11 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(063443.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour B.C. GESELLSCHAFT HOLDING S.A.
Le domiciliataire
i>HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin
<i>Pouri> <i>GAMAX HOLDING AG, Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
63023
LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 23, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.538.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2005 que Monsieur Pierre Kieffer a donné sa démission
du poste qu’il occupait en tant qu’administrateur de LUXENERGIE.
L’assemblée générale nomme administrateur Monsieur Mil Kieffer en remplacement de Monsieur Pierre Kieffer.
Son mandat en tant que membre du conseil d’administration expirera à l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 4 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071884.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.
LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 23, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.538.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2005 que Monsieur Ady Kieffer a donné sa démission
du poste qu’il occupait en tant qu’administrateur et président du comité de direction de LUXENERGIE.
L’assemblée générale nomme administrateur Monsieur Pierre-Emile Kieffer en remplacement de Monsieur Ady
Kieffer.
Son mandat en tant que membre du conseil d’administration expirera à l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 4 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01691. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071885.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.
LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 23, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.538.
—
EXTRAIT
Conformément à l’article 13 des statuts, l’assemblée générale nomme administrateur-délégué Monsieur Paul Weis.
Luxembourg, le 4 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01693. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071886.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.
LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 23, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.538.
—
EXTRAIT
Suite à la nomination d’un administrateur-délégué lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2005, le Comité
de Direction a été dissout.
Les membres suivants sont à rayer:
Monsieur Kieffer Ady, Président du Comité de Direction,
Monsieur Baldauff André, Membre du Comité de Direction,
Monsieur Steinhauser Jürgen, Membre du Comité de Direction,
Monsieur Jungels Jean-Pierre, Membre du Comité de Direction.
P. Weis
<i>Administrateur-déléguéi>
P. Weis
<i>Administrateur-déléguéi>
P. Weis
<i>Administrateur-déléguéi>
63024
Luxembourg, le 8 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02728. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071887.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.
WINROCK RESORTS AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.936.
—
Je soussigné Bernard Felten, demeurant à Luxembourg, déclare démissionner de mon poste d’administrateur au sein
de la société WINROCK RESORTS AND PROPERTIES S.A. avec effet au 16 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07000. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(063621.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
WINROCK RESORTS AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.936.
—
Je soussigné Frédéric Collot, demeurant à Luxembourg, déclare démissionner de mon poste d’administrateur au sein
de la société WINROCK RESORTS AND PROPERTIES S.A. avec effet au 16 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07001. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(063623.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
WINROCK RESORTS AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.936.
—
Nous soussignés CD-SERVICES, S.à r.l., ayant notre siège social à Luxembourg, déclarons démissionner de notre
poste de commissaire aux comptes au sein de la société WINROCK RESORTS AND PROPERTIES S.A. avec effet au
16 juin 2003.
Luxembourg, le 26 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(063626.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
P. Weis
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 26 avril 2005.
B. Felten.
Luxembourg, le 26 avril 2005.
F. Collot.
CD-SERVICES, S.à r.l.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Luxembourg North Distribution
Héraclès S.A.
Héraclès S.A.
Telco Holding, S.à r.l.
Telco Holding, S.à r.l.
Great Mountain S.A.
Great Mountain S.A.
Société Financière de l’Energie «SOFINEN» S.A.
Fenster Mersch S.A.
Immovacances S.A.
Addison Luxembourg S.A.
Addison Luxembourg S.A.
Mobile Signal S.A.
Fipop S.A.
Espirito Santo Financial Group S.A.
Espirito Santo Financial Group S.A.
I.D.S. S.A.
I.D.S. S.A.
Société Hôtelière Europe S.A.
PEF V Zelmer Holdings, S.à r.l.
Lagomar S.A.
Aquarelle Europe, S.à r.l.
North Line Holding S.A.
North Line Holding S.A.
Elvira S.A.
Investments Novapol S.A.
Investments Solapol S.A.
Vins Descombe International, S.à r.l.
Artotal S.A.
P.I.I. S.A.
HIG International S.A.
A.I.J.A., Association Internationale des Jeunes Avocats
Fishing und Camping A.G.
Island Capital, S.à r.l.
Island Capital, S.à r.l.
Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen, Sicav
B.C. Gesellschaft Holding S.A.
Gamax Holding AG
Luxenergie S.A.
Luxenergie S.A.
Luxenergie S.A.
Luxenergie S.A.
Winrock Resorts and Properties S.A.
Winrock Resorts and Properties S.A.
Winrock Resorts and Properties S.A.