logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

61105

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1274

25 novembre 2005

S O M M A I R E

A la Petite Marmite, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . .

61111

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61141

A.I.S., Architectes Ingénieurs Services, S.à r.l., Lu-

Exxonmobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . 

61141

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61108

Exxonmobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . 

61141

Audio Concept, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

61152

Exxonmobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange  . . . . 

61115

Avanza Immobilia, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . .

61144

Exxonmobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange  . . . . 

61115

B.F.B.,  Bois  et  Forêts  du  Brabant  S.A.,  Luxem-

Faja S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61112

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61146

Finance Technology Systems «Fitech Systems» 

Balspeed Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

61152

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61150

Basic Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

61114

Formica  Luxembourg  Holding,  S.à r.l.,  Luxem-

BMS Building Maintenance Service, S.à r.l., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61107

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61152

Globus Real Estate Invest S.A., Luxembourg  . . . . 

61113

Bodycontrol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61113

Hobell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61145

Bodycontrol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61113

Horfut S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61147

Bonaria Frères S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

61112

Indus-Net S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61112

Bonaria Frères S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

61112

Institut Mary’Anna, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

61145

BW & Partner, GmbH, Grevenmacher . . . . . . . . . .

61109

International Locations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

61113

(Le) Chiringuito, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61111

International  Masters  Publishers  Nihon,  S.à r.l., 

Citeg S.A., Wecker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61112

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61108

Cofinatrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61111

KOM MKT LUX, Komoditis MKT Luxembourg S.A.,

(Le)  Cordon  Bleu  International,  S.à r.l.,  Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61144

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61107

KSM Participations Mobilières et Immobilières 

Covéa Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61150

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61148

Credit  Suisse  Asset  Management  Fund  Service 

Lansan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61112

(Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

61149

Locapress S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61114

Credit Suisse Asset Management Holding Europe 

LSFAP Euro-Asian Holding, S.à r.l., Luxembourg. 

61115

(Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

61151

LSFAP  Indonesian  Investments,  S.à r.l.,  Luxem-

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Sicav, Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61116

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61148

Lux   Euro-Asian   Investments   I,   S.à r.l.,   Luxem-

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Sicav, Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61108

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61148

Lux  Euro-Asian  Investments  II,  S.à r.l.,  Luxem-

Decatec S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61114

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61109

Dijou-Zune, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . .

61111

Mains d’Or, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

61111

Eremis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

61148

Mawashi Geri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

61107

Eurafrica S.A., Meispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61147

Modern Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61151

European Paper Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

61150

Moewe Holding S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . 

61114

ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l., Bertrange  . . . . .

61116

Monorosa Holdings LTD, Luxembourg  . . . . . . . . . 

61149

ExxonMobil Asia International, S.à r.l., Bertrange .

61116

Mouwannes, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . 

61109

ExxonMobil Luxembourg International Finance 1, 

Nippon Capital TMK Investments, S.à r.l., Luxem-

S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61116

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61115

ExxonMobil Luxembourg UK Holdings, S.à r.l., Ber-

Noble Equities Trust - Asset & Investment Mana-

61106

STAMER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.721. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03428, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060386.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

STAMER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.721. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03418, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060385.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

STAMER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.721. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03421, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060383.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

STAMER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.721. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03424, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060379.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

gement S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61110

Société   de   Gestion   Internationale,   S.à r.l., 

Noble Equities Trust - Asset & Investment Mana-

Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61151

gement S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61110

Soparad Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

61147

Noble Equities Trust Financial Holdings S.A., Lu-

Soparad Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

61147

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61108

Special Risk Insurance of Reinsurance Luxembourg

Noble Equities Trust Financial Holdings S.A., Lu-

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61116

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61108

Stamer Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61106

Noble Equities Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

61110

Stamer Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61106

Noble Equities Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

61110

Stamer Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61106

Noble Equities Trust Securities S.A., Luxembourg

61110

Stamer Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61106

Noble Equities Trust Securities S.A., Luxembourg

61110

Sunotel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61145

Odagon S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61146

Svenska Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61152

Prispa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61148

Teddy-House, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61114

Quilvest Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61147

Thekla Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

61142

Ristorante C.N.M., S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . 

61109

Topdanmark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

61151

Smile Invest Holding S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . 

61113

Torride S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61149

SOFITRA S.A., Société de Financement pour les 

UNICO Asset Management S.A., Luxembourg . . .

61144

Transports, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61145

Westchester S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

61117

Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M»

Yak, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61107

Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61146

Yak, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61107

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

61107

MAWASHI GERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 32.114. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09313, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059848.3/813/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

FORMICA LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 100.944. 

Il résulte de la décision de l’associé unique tenue en date du 30 juin 2005 que:
1. Paul van Baarle a démissionné de sa fonction de Gérant B.
2. Marcus Jacobus Dijkerman est élu nouveau Gérant B pour la Société pour une durée illimitée.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02765. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059856.3/683/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LE CORDON BLEU INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.808. 

En date du 30 juin 2005 Paul van Baarle et Robert-Jan Schol ont démissionné de leur fonction de Gérant A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02737. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059864.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

YAK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 19, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 90.586. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02800, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059879.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

YAK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 19, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 90.586. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02804, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059877.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MAWASHI GERI S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FORMICA LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.
L. Denys
<i>Gérant B

LE CORDON BLEU INTERNATIONAL, S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant A

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

61108

INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS NIHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.372. 

En date du 30 juin 2005 Paul van Baarle a démissionné de sa fonction de Gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059872.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

A.I.S., ARCHITECTES INGENIEURS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 23.313. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02768, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059882.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

NOBLE EQUITIES TRUST FINANCIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.933. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02808, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059884.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

NOBLE EQUITIES TRUST FINANCIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.933. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02828, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059891.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 115.000.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 81.404. 

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059970.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS NIHON, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS I, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

61109

MOUWANNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser.

R. C. Luxembourg B 69.810. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04488, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(059885.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

RISTORANTE C.N.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4640 Differdange, 39, avenue d’Obercorn.

R. C. Luxembourg B 93.587. 

<i>Extrait du contrat de cession de parts en date du 6 juillet 2005

Art. 3. Réparation des parts après cession. Le capital de la société est de 12.500,- euro divisé en 100 parts so-

ciales de 125,- euro chacune, intégralement libérées en espèces. La propriété des parts se répartit comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059887.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BW &amp; PARTNER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

R. C. Luxembourg B 56.933. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG01915, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(059896.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 115.000.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 81.405. 

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059971.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature

M. José Carlos Sousa Da Cunha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts sociales

<i>Pour la société
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS II, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

61110

NOBLE EQUITIES TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.295. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02832, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059893.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

NOBLE EQUITIES TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.295. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02836, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059894.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

NOBLE EQUITIES TRUST - ASSET &amp; INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.088. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02893, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059897.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

NOBLE EQUITIES TRUST - ASSET &amp; INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.088. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02894, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

NOBLE EQUITIES TRUST SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.087. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02898, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059898.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

NOBLE EQUITIES TRUST SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.087. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02897, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059899.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

61111

MAINS D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 36, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.448. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01922, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(059905.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LE CHIRINGUITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 51, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 87.271. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02700, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(059909.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

A LA PETITE MARMITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 16, rue de Hagen.

R. C. Luxembourg B 35.911. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02729, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(059912.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

DIJOU-ZUNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 38, Cité Loppert.

R. C. Luxembourg B 97.008. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01912, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(059915.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

COFINATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 58.140. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059926.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

Signature.

61112

INDUS-NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 74.981. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04302, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059928.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

FAJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 71.139. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04297, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059930.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CITEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R. C. Luxembourg B 81.124. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059931.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BONARIA FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 67, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 8.567. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04290, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059934.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BONARIA FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 67, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 8.567. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04287, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059933.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 86.241. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01540, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059937.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

61113

GLOBUS REAL ESTATE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 89.902. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01032, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059935.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SMILE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 72.052. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01033, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059936.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BODYCONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 68.386. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01035, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059940.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BODYCONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 68.386. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01036, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059943.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

INTERNATIONAL LOCATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 59.207. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01532, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059942.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour GLOBUS REAL ESTATE INVEST S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour SMILE INVEST HOLDING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour BODYCONTROL, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour BODYCONTROL, S.à r.l.
Signature

Signature.

61114

DECATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 39, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.502. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01037, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059944.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MOEWE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Louis Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.251. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01047, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059946.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

TEDDY-HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 5, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.106. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01040, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059959.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BASIC INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 98.262. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059961.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LOCAPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 64.987. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01038, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059963.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour DECATEC S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour MOEWE HOLDING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour <i>TEDDY-HOUSE, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour BASIC INVEST HOLDING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour LOCAPRESS S.A.
Signature

61115

NIPPON CAPITAL TMK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.184.750.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 90.991. 

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04808. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059986.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LSFAP EURO-ASIAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 77.579. 

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04809. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059990.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 449.723,20.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.559. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 28 juin 2005

L’Assemblée décide:
- de confirmer comme administrateurs de la société Messieurs Gilbert Wirtz, Curt Le Van et Carlo Ranucci. Leur

mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060051.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.559. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02719, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060014.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

NIPPON CAPITAL TMK INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

LSFAP EURO-ASIAN HOLDING, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
G. Wirtz

Leudelange, le 12 juillet 2005.

Signature.

61116

LSFAP INDONESIAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 77.580. 

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059995.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SPECIAL RISK INSURANCE OF REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.964. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01062, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060003.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ExxonMobil ASIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 76.554. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02696, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060018.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ExxonMobil LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.736. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02724, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060019.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 76.503. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02689, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060032.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LSFAP INDONESIAN INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

P. Antony.

Leudelange, le 12 juillet 2005.

Signature.

Leudelange, le 12 juillet 2005.

Signature.

Leudelange, le 12 juillet 2005.

Signature.

61117

WESTCHESTER S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R. C. Luxembourg B 108.625. 

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.

Was held a general meeting of shareholders of WESTCHESTER S.C.A., a société en Commandite par Actions, having

its registered office at L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Reg-
ister under section B, number 108.625, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, acting in
replacement of the undersigned notary, on 10 June 2005, not yet published (hereafter the «Company»).

The meeting was opened at 8.00 a.m. with Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety-eight thousand seven hundred

ten Euro and ten cents (EUR 198,710.10), in order to increase it from its current value of thirty-one thousand Euro
(EUR 31,000) up to a value of two hundred twenty-nine thousand seven hundred ten Euro and ten cents (EUR
229,710.10), through the issue of thirty-nine thousand seven hundred forty-two shares and two fractional shares of one
hundredth of a share (39,742.02), the whole shares with a par value of five Euro (EUR 5) each and payment of the new
shares in cash.

2. Further increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-seven thousand six hundred ninety

Euro and seventy cents (EUR 77,690.70), in order to increase it up to a value of three hundred seven thousand four
hundred Euro and eighty cents (EUR 307,400.80), through the issue of fifteen thousand five hundred thirty-eight new
shares and fourteen fractional shares of one hundredth of a share (15,538.14), the whole shares with a par value of five
Euro (EUR 5) each and payment of the new shares through assignment and contribution in kind of receivables in the
aggregate nominal amount of seventy seven thousand six hundred ninety Euro and seventy cents (EUR 77,690.70) owed
to the contributors by the Company.

3. Further increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred twenty-three thousand five

hundred ninety-nine Euro and twenty cents (EUR 223,599.20), in order to increase it up to a value of five hundred thirty-
one thousand Euro (EUR 531,000), through the issue of forty-four thousand seven hundred nineteen new shares and
eighty-four fractional shares of one hundredth of a share (44,719.84), the whole shares with a par value of five Euro
(EUR 5) each and payment of the new shares through assignment and contribution in kind of receivables owed to the
contributors by iesy Hessen GmbH &amp; Co. KG, a Kommanditgesellschaft existing under the laws of Germany, with reg-
istered address at Kleyerstrasse 88, D-60326 Frankfurt am Main, Germany, registered with the commercial register of
the local court at Frankfurt under the number HRA 31043 (hereinafter the «iesy KG Receivables») and of rights in an
escrow account distributed to the contributors by KABELNETZ NRW LIMITED, a company limited by shares, incor-
porated under the laws of Jersey, with registered address at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8XP Channel Is-
lands with registered number 84707 (hereinafter the «Kabelnetz Ltd Escrow Rights») in the aggregate nominal amount
of two hundred twenty-three thousand five hundred ninety-nine Euro and twenty cents (EUR 223,599.20). 

4. Reduction of the share capital by an amount of thirty thousand nine hundred ninety-five Euro (EUR 30,995) through

the cancellation of six thousand one hundred ninety-nine (6,199) shares in order to arrive at a share capital of five hun-
dred thousand and five Euro (EUR 500,005) consisting of one hundred thousand and one (100,001) shares with a par
value of five Euro (EUR 5) each. 

5. Restatement of the articles of association of the Company.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That all the shares of the Company are present or represented at this meeting.
IV. That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agen-

da prior to this meeting and that thus no convening notices were necessary.

V. That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders’ meeting decides to increase the share capital from its current value of thirty one thousand Euro

(EUR 31,000) up to a value of two hundred twenty-nine thousand seven hundred ten Euro and ten cents (EUR
229,710.10), through the issue of thirty-nine thousand seven hundred forty-two shares and two fractional shares of one
hundredth of a share (39,742.02), with a par value of five Euro (EUR 5) for each whole share.

All such new shares have been subscribed at a price of five Euro (EUR 5) per whole share by AP CABLE LLC, c/o

Apollo Management, L.P., Two Manhattanville Road, Purchase, NY 10577 U.S.A. and said shares have been paid entirely
in cash.

AP CABLE LLC is here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of proxies

given on 24 June 2005.

The proof of the existence of the cash payment has been produced to the undersigned notary.

61118

The shareholders’ meeting and OAKBROOK S.A., in its capacity as general partner and shareholder of the company,

hereby expressly approve the capital increase, the issuance of the new shares, the subscription of all of the new shares
as described above and the payment of the new shares in cash and all the existing shareholders waive their preferential
subscription right.

These new shares are deemed to be issued immediately following the signing of this deed.

<i>Second resolution

The shareholders’ meeting decides to further increase the share capital up to a value of three hundred seven thousand

four hundred Euro and eighty cents (EUR 307,400.80), through the issue of fifteen thousand five hundred thirty-eight
new shares and fourteen fractional shares of one hundredth of a share (15,538.14), with a par value of five Euro (EUR
5) for each whole share.

All such new shares have been subscribed at a price of five Euro (EUR 5) per whole share, as follows:
1. CONCERTO I B.V., c/o AXA Investment Managers UK, Newgate Street, London EC1A 7NX, United Kingdom,

has subscribed for 319 new shares and 45 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and
contribution in kind of receivables in an amount of EUR 1,597.25 owed to it by the Company;

2. CAF EUROPEAN HIGH YIELD BOND., c/o Credit Agricole Asset Management, 90, boulevard Pasteur, 75015 Par-

is, France, has subscribed for 34 new shares and 8 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment
and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 170.40 owed to it by the Company;

3. GRD 5-OD-HY EUROPE, c/o Credit Agricole Asset Management, 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France, has

subscribed for 29 new shares and 82 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and con-
tribution in kind of a EUR 149.10 receivable owed to it by the Company;

4. ALPHA US SUBFUND II LLC, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, 25th Floor, New York, NY

10022, U.S.A., has subscribed for 188 new shares and 62 fractional shares of one hundredth of a share, paid through
assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 943.10 owed to it by the Company;

5. B&amp;W MASTER RETIREMENT TRUST, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New York, NY

10022, U.S.A., has subscribed for 73 new shares and 77 fractional shares of one hundredth of a share, paid through as-
signment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 368.85 owed to it by the Company;

6. DB STRUCTURED PRODUCTS INC, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New York, NY

10022, U.S.A., has subscribed for 486 new shares and 5 fractional shares of one hundredth of a share, paid through as-
signment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 2,430.25 owed to it by the Company;

7. GOLDEN TREE HIGH YIELD VALUE MASTER FUND, LP, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue,

New York, NY 10022, U.S.A., has subscribed for 105 new shares and 62 fractional shares of one hundredth of a share,
paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 528.10 owed to it by the Company;

8. GOLDEN TREE HIGH YIELD MASTER FUND, Ltd, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New

York, NY 10022, U.S.A., has subscribed for 5,965 new shares and 86 fractional shares of one hundredth of a share, paid
through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 29,829.30 owed to it by the Company;

9. GOLDEN TREE HIGH YIELD MASTER FUND II, Ltd, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New

York, NY 10022, U.S.A., has subscribed for 635 new shares and 58 fractional shares of one hundredth of a share, paid
through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 3,177.90 owed to it by the Company;

10. GOLDEN TREE HIGH YIELD OPPORTUNITIES II, LP, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue,

New York, NY 10022, U.S.A., has subscribed for 547 new shares and 84 fractional shares of one hundredth of a share,
paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 2,739.20 owed to it by the Com-
pany;

11. GKW UNIFIED HOLDINGS LLC, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New York, NY 10022,

U.S.A., has subscribed for 135 new shares and 53 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment
and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 677.65 owed to it by the Company;

12. The university of Chicago, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, U.S.A.,

has subscribed for 22 new shares and 81 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and
contribution in kind of receivables in an amount of EUR 114.05 owed to it by the Company;

13. Andrew Booth, c/o Jefferies &amp; Company, INC, 520 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10022, U.S.A.,

has subscribed for 27 new shares and 69 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and
contribution in kind of receivables in an amount of EUR 138.45 owed to it by the Company;

14. Andrew Whittaker, c/o Jeffries &amp; Company INC., 11100 Santa Monica Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, CA

90025, U.S.A., has subscribed for 27 new shares and 69 fractional shares of one hundredth of a share, paid through as-
signment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 138.45 owed to it by the Company;

15. Chris Kanoff, c/o Jeffries &amp; Company INC., 11100 Santa Monica Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, CA 90025,

U.S.A., has subscribed for 27 new shares and 69 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment
and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 138.45 owed to it by the Company;

16. Craig Zaph, c/o Jeffries &amp; Company INC., 11100 Santa Monica Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, CA 90025,

U.S.A., has subscribed for 2 new shares and 13 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment
and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 10.65 owed to it by the Company;

17. OZ MASTER FUND, Ltd., c/o Och-Ziff Management L.L.C., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York, NY

10019, U.S.A., has subscribed for 1,165 new shares and 16 fractional shares of one hundredth of a share, paid through
assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 5,825.80 owed to it by the Company;

18. OZ EUROPE MASTER FUND Ltd., c/o Och-Ziff Management L.L.C., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York,

NY 10019, U.S.A., has subscribed for 624 new shares and 69 fractional shares of one hundredth of a share, paid through
assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 3,123.45 owed to it by the Company;

61119

19. FLEET MARITIME INC., c/o Och-Ziff Management L.L.C., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York, NY 10019,

U.S.A., has subscribed for 17 new shares and 72 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment
and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 88.60 owed to it by the Company;

20. CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND Ltd., c/o Cyprus Capital Partners Europe LLP, Buchanan House, 3 St.

James’s Square, London SW1Y 4JU, United Kingdom, has subscribed for 259 new shares and 31 fractional shares of one
hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 1,296.55
owed to it by the Company;

21. CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND II, Ltd., c/o Cyprus Capital Partners Europe LLP, Buchanan House, 3

St. James’s Square, London SW1Y 4JU, United Kingdom, has subscribed for 373 new shares and 63 fractional shares of
one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 1,868.15
owed to it by the Company;

22. COLONY eKabel PARTNERS, LP, 1999 Avenue of the Stars, Los Angeles, CA 90067, U.S.A., has subscribed for

62 new shares and 39 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind
of receivables in an amount of EUR 311.95 owed to it by the Company;

23. STANFIELD ARBITRAGE CDO Ltd., 430 Park Avenue, New York, NY 10022, U.S.A., has subscribed for 253 new

shares and 49 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receiv-
ables in an amount of EUR 1,267.45 owed to it by the Company;

24. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA, Avda. Fernandez Ladreda 8, 40001 Segovia, Spain,

has subscribed for 85 new shares and 19 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and
contribution in kind of receivables in an amount of EUR 425.95 owed to it by the Company;

25. FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL LIMITED, c/o Franklin Templeton Investments, The Adelphi, 1-11 John

Adam Street, London WC2N 6HT, United Kingdom, has subscribed for 76 new shares and 67 fractional shares of one
hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 383.35 owed
to it by the Company;

26. INVESCO PERPETUAL MONTHLY INCOME PLUS FUND, 30 Finsbury Square, London EC2A 1 AG, has sub-

scribed for 553 new shares and 72 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contri-
bution in kind of receivables in an amount of EUR 2,768.60 owed to it by the Company;

27. Jeffrey D. Benjamin, 133 East 64th Street, New York, NY 10021, U.S.A., has subscribed for 106 new shares and

14 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an
amount of EUR 530.70 owed to it by the Company;

28. JP MORGAN CHASE, 14201 Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, U.S.A., has subscribed for 1,254 new shares and

79 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an
amount of EUR 6,273.95 owed to it by the Company;

29. MORGAN STANLEY &amp; CO. INTERNATIONAL LIMITED, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,

United Kingdom, has subscribed for 194 new shares and 65 fractional shares of one hundredth of a share, paid through
assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 973.25 owed to it by the Company;

30. MORGAN STANLEY &amp; CO INCORPORATED, 1585 Broadway, New York, NY 10036, U.S.A., 1585 Broadway,

New York, NY 10036, U.S.A., has subscribed for 40 new shares and 14 fractional shares of one hundredth of a share,
paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 200.70 owed to it by the Company;

31. PERSHING, DIVISION OF DONALDSON, LUFKIN &amp; JENRETTE SECURITIES CORP, One Pershing Plaza 9th

Floor, Jersey City, NJ 07399, U.S.A., has subscribed for 9 new shares and 55 fractional shares of one hundredth of a
share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 47.75 owed to it by the
Company;

32. SOUND BEACH CAPITAL L.P., 201 Main Street, Suite 3200, Fort Worth, TX 76102, U.S.A., has subscribed for

85 new shares and 19 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind
of receivables in an amount of EUR 425.95 owed to it by the Company;

33. STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, P.O. Box 575, 2501 CN The Hague, The Netherlands, has subscribed

for 85 new shares and 19 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in
kind of receivables in an amount of EUR 425.95 owed to it by the Company;

34. UBS AG, 100 Liverpool Street, London EC2M 2RH, United Kingdom, has subscribed for 3 new shares and 06

fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an
amount of EUR 15.30 owed to it by the Company;

35. ATLANTIC SECURITY BANK, c/o Torre Banco Continental, Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Piso 29, Panama

Rep. De Panama, has subscribed for 92 new shares and 52 fractional shares of one hundredth of a share, paid through
assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 462.60 owed to it by the Company;

36. DEUTSCHE BANK AG, Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, has subscribed for 26

new shares and 19 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of
receivables in an amount of EUR 130.95 owed to it by the Company;

37. RAB GLOBAL MACRO FUND LIMITED, c/o RAB Capital plc, 1 Adam Street, London WC2N 6LE, United King-

dom, has subscribed for 8 new shares and 52 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment
and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 42.60 owed to it by the Company;

38. Mario Rebba, Via Broggi 14, 20129 Milano, Italy, has subscribed for 21 new shares and 30 fractional shares of one

hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 106.50 owed
to it by the Company;

61120

39. Jami B. Gertz IRA Rollover, 21 Beverly Park Terrace, Beverly Hills, CA 90210, U.S.A., has subscribed for 97 new

shares, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 485 owed to it by the
Company;

40. Antony P. Ressler IRA, 1999 Avenue of the Stars, Suite 1900, Los Angeles, CA 90067, U.S.A., has subscribed for

4 new shares and 39 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of
receivables in an amount of EUR 21.95 owed to it by the Company;

41. DILMUN CAPITAL II, Ltd., c/o AIG Global Investment Group, Corporate Legal Department, 2929 Allen Parkway,

36th Floor, Houston, TX 77019, U.S.A., has subscribed for 84 new shares and 50 fractional shares of one hundredth of
a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 422.50 owed to it by the
Company;

42. IESY HESSEN (US) L.P., c/o DLA Piper Rudnick Gray Cary, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020,

U.S.A., has subscribed for 424 new shares and 31 fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment
and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 2,121.55 owed to it by the Company;

43. Bruno Claude, 19 Moenchhofstrasse, Kilchberg, 8802-ZH, Switzerland, has subscribed for 449 new shares and 25

fractional shares of one hundredth of a share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an
amount of EUR 2,246.25 owed to it by the Company;

44. BLUEWATER COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED, Nautilus House, La Cour des Casernes, St. Heller,

Jersey JE13NH, United Kingdom, has subscribed for 449 new shares and 25 fractional shares of one hundredth of a
share, paid through assignment and contribution in kind of receivables in an amount of EUR 2,246.25 owed to it by the
Company.

All such subscribers are represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of prox-

ies given on 24 June 2005.

All such subscribers hereby certify with respect to their respective contributions and assignments in kind, that:
- each subscriber is the legal and beneficial owner of the receivable contributed and assigned by it;
- there are no security, pre-emptive rights, nor any other rights attached to the contributed and assigned receivable

by virtue of which any person may be entitled to demand that this contributed and assigned receivable be transferred
to him;

- that all authorizations or waivers necessary to transfer the receivable contributed and assigned to the Company

have been duly obtained, where applicable.

The proof of the existence and of the value of the above described contributed and assigned receivables has been

produced to the undersigned notary.

The value of the assets contributed and assigned has been described and confirmed in a report from KPMG AUDIT,

external auditor (réviseur d’entreprises), with registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, in accordance
with articles 32-1 and 26-1 of the Luxembourg law governing commercial companies dated 10 August 1915, which re-
port will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The conclusion of the report was the following: «Based on the verification carried out as described above, we have

no observation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value
of the ordinary shares to be issued as consideration.»

The shareholders’ meeting and OAKBROOK S.A., in its capacity as general partner and shareholder of the company,

hereby expressly approve the capital increase, the issuance of the new shares, the subscription of all of the new shares
as described above and the payment of the new shares through assignment and contribution in kind as described.

These new shares are deemed to be issued immediately following the signing of this deed.

<i>Third resolution

The shareholders’ meeting decides to further increase the share capital up to a value of five hundred thirty-one thou-

sand Euro (EUR 531,000), through the issue of forty-four thousand seven hundred nineteen new shares and eighty-four
fractional shares of one hundredth of a share (44,719.84), with a par value of five Euro (EUR 5) for each whole share.

All such new shares have been subscribed at a price of five Euro (EUR 5) per whole share, as follows:
1. ALPHA US SUBFUND II LLC, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue, 25th Floor, New York,

NY 10022, U.S.A., subscribes for 19 new shares and 29 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid through
assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 96.45 comprising of Receivables and Escrow Rights
of such Subscriber;

2. DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N

2DB, United Kingdom, subscribes for 5,212 new shares and 78 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid
through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 26,063.90 comprising of Receivables and
Escrow Rights of such Subscriber;

3. FINAKABEL HOLDINGS LIMITED, CIE MANAGEMENT II LIMITED, P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques,

St. Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, Channel Islands, subscribes for 15,994 new shares and 46 fractional shares of one
hundredth of a share, to be paid through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 79,972.30
comprising of Receivables and Escrow Rights of such Subscriber;

4. GOLDENTREE HIGH YIELD MASTER FUND, Ltd., c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., subscribes for 682 new shares and 25 fractional shares of one hundredth of
a share, to be paid through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 3,411.25 comprising of
Receivables and Escrow Rights of such Subscriber;

5. GOLDENTREE HIGH YIELD MASTER FUND II, Ltd., c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., subscribes for 870 new shares and 35 fractional shares of one hundredth of

61121

a share, to be paid through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 4,351.75 comprising of
Receivables and Escrow Rights of such Subscriber;

6. GOLDENTREE HIGH YIELD OPPORTUNITIES I, LP, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., subscribes for 931 new shares and 31 fractional shares of one hundredth of
a share, to be paid through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 4,656.55 comprising of
Receivables and Escrow Rights of such Subscriber;

7. GOLDENTREE HIGH YIELD OPPORTUNITIES II, LP, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., subscribes for 426 new shares and 13 fractional shares of one hundredth of
a share, to be paid through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 2,130.65 comprising of
Receivables and Escrow Rights of such Subscriber;

8. CITI GOLDEN TREE LIMITED, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue, 25th Floor, New York,

NY 10022, U.S.A., subscribes for 382 new shares and 33 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid
through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 1,911.65 comprising of Receivables and
Escrow Rights of such Subscriber;

9. SAFETY NATIONAL CASUALTY CORPORATION, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., subscribes for 90 new shares and 99 fractional shares of one hundredth of a
share, to be paid through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 454.95 comprising of
Receivables and Escrow Rights of such Subscriber;

10. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ,

United Kingdom, subscribes for 1,543 new shares and 56 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid
through assignment and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 7,717.80 comprising of Receivables and
Escrow Rights of such Subscriber;

11. OZ MASTER FUND, Ltd., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York, NY 10019, U.S.A., subscribes for 4,146

new shares and 69 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid through assignment and contribution in kind
in the aggregate amount of EUR 20,733.45 comprising of Receivables and Escrow Rights of such Subscriber;

12. CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND II Ltd., 390 Park Avenue, 21st Floor, New York, NY 10022, U.S.A.,

subscribes for 1,245 new shares and 92 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid through assignment
and contribution in kind in the aggregate amount of EUR 6,229.60 comprising of Receivables and Escrow Rights of such
Subscriber;

13. CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND Ltd., 390 Park Avenue, 21st Floor, New York, NY 10022, U.S.A., sub-

scribes for 556 new shares and 15 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid through assignment and
contribution in kind in the aggregate amount of EUR 2,780.75 comprising of Receivables and Escrow Rights of such Sub-
scriber;

14. OZ EUROPE MASTER FUND, LTD., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York, NY 10019, U.S.A., subscribes

for 1,507 new shares and 45 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid through assignment and contri-
bution in kind in the aggregate amount of EUR 7,537.25 comprising of Receivables and Escrow Rights of such Subscriber;

15. SCOGGIN CAPITAL MANAGEMENT LP II, 660 Madison Avenue, 20th Floor, New York, NY 10021 U.S.A., sub-

scribes for 4,284 new shares and 23 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid through assignment and
contribution in kind in the aggregate amount of EUR 21,421.15 comprising of Receivables and Escrow Rights of such
Subscriber;

16. SPCP GROUP, LLC, 2 Greenwich Plaza, 1st Floor, Greenwich, CT 06830, U.S.A., subscribes for 6,825 new shares

and 95 fractional shares of one hundredth of a share, to be paid through assignment and contribution in kind in the
aggregate amount of EUR 34,129.75 comprising of Receivables and Escrow Rights of such Subscriber.

All such subscribers are represented by Mr Jean-Michel Schmit, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of proxies

given on 24 June 2005.

All such subscribers hereby certify with respect to their respective assignments and contributions in kind, that:
- each subscriber is the legal and beneficial owner of the receivable and the escrow right contributed and assigned by

it;

- there are no security, pre-emptive rights, nor any other rights attached to the contributed and assigned receivable

and escrow right by virtue of which any person may be entitled to demand that this contributed and assigned receivable
and escrow right be transferred to him;

- that all authorizations or waivers necessary to transfer the receivable and escrow right contributed and assigned to

the Company have been duly obtained, where applicable.

The proof of the existence and of the value of the above described contributed and assigned receivables has been

produced to the undersigned notary.

The value of the assets contributed and assigned has been described and confirmed in a report from KPMG AUDIT,

external auditor (réviseur d’entreprises), with registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, in accordance
with articles 32-1 and 26-1 of the Luxembourg law governing commercial companies dated 10 August 1915, which re-
port will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The conclusion of the report was the following: «Based on the verification carried out as described above, we have

no observation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value
of the ordinary shares to be issued as consideration.»

The shareholders’ meeting and OAKBROOK S.A., in its capacity as general partner and shareholder of the company,

hereby expressly approve the capital increase, the issuance of the new shares, the subscription of all of the new shares
as described above and the payment of the new shares through assignment and contribution in kind as described.

These new shares are deemed to be issued immediately following the signing of this deed.

61122

<i>Fourth resolution

The shareholders’ meeting resolves to reduce the share capital of the Company from its amount of five hundred thir-

ty-one thousand Euro (EUR 531,000) by an amount of thirty thousand nine hundred ninety-five Euro (EUR 30,995)
through the cancellation of six thousand one hundred ninety-nine (6,199) shares numbered 2 to 6200 and the reim-
bursement to the registered shareholder of the amount of thirty thousand nine hundred ninety-five Euro (EUR 30,995).

These shares are deemed to be cancelled immediately following the signing of this deed.
As a consequence of the above resolutions, article 6 of the articles of association is amended and now reads as fol-

lows:

«Art. 6. The Company has a subscribed capital of five hundred thousand and five Euro (EUR 500,005) consisting of

one hundred thousand and one (100,001) shares with a par value of five Euro (EUR 5) each.»

<i>Fifth resolution

The shareholders’ meeting resolve to restate the Articles of Association of the Company, in order to give them the

following wording:

A. Name - Definitions - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société en commandite par actions, under the name of WESTCHESTER S.C.A.

Affiliate, when used with reference to a Person (for such purposes, the «First Person»), shall mean any other Person

that directly or indirectly (i) is Controlled by such First Person, (ii) Controls such First Person, or (iii) which is under
common Control with such First Person;

Articles means the articles of association of the Company;
As-Converted Basis, with respect to outstanding securities of a company, shall mean as if all CPECs (and all other

securities convertible into or exercisable or exchangeable for equity securities of such company) outstanding were con-
verted, exercised or exchanged into or for shares comprising such company’s share capital pursuant to the terms of
such CPECs and such other convertible, exercisable or exchangeable securities (i.e., in the case of the SCA, the number
of SCA Shares outstanding, plus the additional number of SCA Shares that would be outstanding assuming such conver-
sion, exercise or exchange);

Business Days means any day other than a Saturday, Sunday or legal holiday on which banking institutions in Luxem-

bourg and the United Kingdom are open for business;

Company means WESTCHESTER S.C.A, a société en commandite par actions;
Concert Parties means parties that have agreed to act collectively in exercising Control of the Group, however, an

agreement among all Securityholdes shall not in itself render the Securityholders or any Group of Securityholders Con-
cert Parties;

Control (including the terms «Controlled» and «Controlling») means, in respect of any Person, the possession of, or

the entitlement and ability to currently possess and exercise, the power to manage or direct the management of such
Person, or to appoint the managing and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

CPEC means (i) the convertible preferred equity certificates issued by the SCA and (ii) any securities issued or issu-

able (other than SCA Shares issued or issuable upon redemption or conversion of the CPECs in accordance with their
terms) directly or indirectly with respect to the securities referred to in clause (i) (or their successors pursuant to this
clause (ii)) by way of a dividend, split or other transaction or in connection with a combination of securities, recapitali-
zation, merger, consolidation, exchange, conversion, redemption, repurchase or other reorganization transaction, and
any securities (other than SCA Shares) into which any of the foregoing may be converted;

Drag-Along Sale has the meaning ascribed hereto in Article 10(a);
Drag-Along Sale has the meaning ascribed hereto in Article 10(a);
Drag-Along Notice has the meaning ascribed hereto in Article 10(a)(i);
Drag-Along Seller has the meaning ascribed hereto in Article 10(a)(i);
Exempted Reorganization means a merger, consolidation, exchange, reorganization or sale of all or substantially all

of the assets or businesses of the GP or the SCA (i) solely among the GP, the SCA or any SCA Subsidiaries, (ii) in con-
nection with a Public Listing;

GP means the manager and General Partner of the Company being OAKBROOK S.A.;
GP Board of Directors means the Board of Directors of the GP;
GP Shares means (i) the ordinary shares in the capital of the GP in registered form and having the rights set out in

the GP’s articles of association and (ii) any securities issued or issuable directly or indirectly with respect to the secu-
rities referred to in clause (i) (or their successors pursuant to this clause (ii)) by way of a dividend, split or other trans-
action or in connection with a combination of securities, recapitalization, merger, consolidation, exchange, conversion,
redemption, repurchase or other reorganization transaction, and any securities into which any of the foregoing may be
converted;

Group means the SCA and the SCA Subsidiaries;
Person means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock com-

pany, a trust, a joint venture, an unincorporated organization, any other business or non-profit entity and a governmental
entity or any department, agency or political subdivision thereof;

Potential Tag-Along Seller has the meaning ascribed hereto in Article 9;
Proposed Sale Securities has the meaning ascribed hereto in Article 9;
Public Listing means a public registration, listing, qualification or acceptance for trading or quotation of equity secu-

rities of the SCA and/or any SCA Subsidiary (or any other entity or entities created through any Exempted Reorgani-

61123

zation) on an internationally recognized securities exchange or listing, reporting or quotations system in the United
States, United Kingdom, Luxembourg, Germany, or any other jurisdiction;

Qualified Public Sale means any sale or offering or series of sales or offerings of equity securities through a Public

Listing, where after the consummation of such sale or offering or series of sales or offerings more than 20% of the out-
standing equity securities of the SCA (or any SCA Subsidiary) are sold or transferred;

Regulatory Extension means, with respect to any time period and applicable transaction, an extension of such time

period until such time as any requisite or material regulatory, governmental or contractual approval (from a third party
that is not a party to such applicable transaction), required in connection with such transaction is obtained, so long as
the applicable parties are undertaking reasonable efforts to obtain such approval and such approval may reasonably be
expected to be obtained;

Relevant Percentage has the meaning ascribed hereto in Article 9;
Sale of the Business means a merger, consolidation, exchange, reorganization or sale of all or substantially all of the

assets or businesses of the GP or the SCA;

SCA means the Company;
SCA Securities means the SCA Shares and the CPECs;
SCA Shares means (i) the ordinary shares in the capital of the SCA in registered form and having the rights set out

in the SCA’s articles of association and (ii) any securities issued or issuable directly or indirectly with respect to the
securities referred to in clause (i) (or their successors pursuant to this clause (ii)) by way of a dividend, split or other
transaction or in connection with a combination of securities, recapitalization, merger, consolidation, exchange, conver-
sion, redemption, repurchase or other reorganization transaction, and any securities (other than CPECs) into which any
of the foregoing may be converted;

SCA Subsidiary means the Subsidiaries of the SCA from time to time;
Securities means the shares in the Company, the GP Shares and the CPEC’s issued by the Company;
Securityholder means the holder of Securities;
Securityholder Seller has the meaning ascribed hereto in Article 9;
Security Strip means a package (or any pro rata portion thereof) of GP Shares, SCA Shares and CPECs issued to a

single shareholder at the same time (with appropriate adjustments in the event of any event described in clause (ii) of
the definition of GP Shares, SCA Shares or CPECs, or other adjustments as may be approved by the GP Board of Di-
rectors to remedy errors made in previous issuances or any of the events described in clause (ii) of the definition of GP
Shares, SCA Shares or CPECs), it being the intent that the GP Shares, SCA Shares and CPECs forming a part of a Se-
curity Strip shall be stapled to each other;

Tag-Along Election Period has the meaning ascribed hereto in Article 9;
Tag-Along Notice has the meaning ascribed hereto in Article 9;
Tag-Along-Rights has the meaning ascribed hereto in Article 9;
Tag-Along Sale has the meaning ascribed hereto in Article 9;
Tag-Along Seller has the meaning ascribed hereto in Article 9(d);
Terms and Conditions means the terms and conditions of the CPECs.;
Transfer has the meaning ascribed hereto in Article 8(a);
Transferee has the meaning ascribed hereto in Article 8(a)(ii);
Transferring Securityholder has the meaning ascribed hereto in Article 8(a)(i).

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited shareholder with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar corporate structures.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the

registered office of the Company may be transferred by resolution of the manager. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager.

Art. 5. The GP being general partner of the Company is liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets

of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the general partner), shall refrain
from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders
in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company has a subscribed capital of five hundred thousand and five Euro (EUR 500,005) consisting of

one hundred thousand and one (100,001) shares with a par value of five Euro (EUR 5) each. 

The authorised capital, including the subscribed capital of five hundred thousand and five Euro (EUR 500,005), is fixed

at six hundred twenty-eight million nine hundred nine thousand six hundred Euro (EUR 628,909,600), consisting of five
hundred seventy-one million two hundred thirty-six thousand Euro (EUR 571,236,000) for a conversion of CPECS in

61124

one hundred fourteen million two hundred forty-seven thousand two hundred (114,247,200) redeemable shares with
a par value of five Euro (EUR 5) each, fifty-seven million one hundred twenty-three thousand six hundred Euro (EUR
57,123,600) for a conversion of CPECS in eleven million four hundred twenty-four thousand seven hundred twenty
(11,424,720) redeemable shares with a par value of five Euro (EUR 5) each and fifty thousand Euro (EUR 50,000) for the
issuance of ten thousand (10,000) shares with a par value of five Euro (EUR 5) each. During the period of five years,
from the date of the publication of these articles of association, the manager be and is hereby authorised to issue shares
and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit (and specifically to
proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares
issued).

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The
Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 7. The shares of the Company are in registered form.
A shareholders’ register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any share-

holder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by the manager upon request of the relevant shareholder.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been des-
ignated as the sole owner in relation to the Company.

For the avoidance of doubt and notwithstanding anything to the contrary herein, fractional shares shall have the same

rights (on a fractional basis) as whole shares, provided that shares shall only have voting rights when the appropriate
number of fractional shares are aggregated into one or more whole shares and if there are fractions that do not aggre-
gate to a whole share, such fractions shall have no voting rights.

The Company is entitled to redeem its own shares, which are subscribed and fully paid-in, in accordance with the

provisions of Article 49-8 of the law on commercial companies, as amended, it being understood that this acquisition
may only be made pro rata by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the
funds received by the Company as an issue of its shares or by means of the proceeds of a new issue made to the purpose
of the redemption and provided that this redemption does not cause the Company’s share capital to fall below the min-
imum required by the law. The redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the
liquidation proceeds. The redemption price of the redeemable shares is calculated on the basis of the company’s net
assets determined in accordance with the following provisions. The redemption price of the shares, which the Company
intends to redeem in accordance with 49-8 of the law on commercial companies will equal the net asset value per share,
as this value will be determined by the GP Board of Directors on the valuation day which shall be the day on which the
GP Board of Directors decides to redeem any shares in accordance with the terms and conditions set out here below.
The net asset value of the Company’s shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect
of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value of the Company’s assets less its liabilities
at close of business on that day, by the number of shares of the Company on an As-Converted Basis at such close of
business, all in accordance with the valuation regulations set out hereunder or should any event not be provided for by
these regulations, in accordance with the rules the GP Board of Directors shall regard as fair and equitable. All these
valuation rules and provisions comply with generally accepted accounting principles. In the absence of any bad faith, gross
negligence or overt error, any decision taken by the GP Board of Directors with respect to the calculation of the re-
demption price shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future shareholders.

Art. 8. Transfer of Securities
(a) Requirements for Transfer of Securities.
Prior to a Qualified Public Sale at the level of the SCA, no Securityholder may sell, transfer, assign, pledge, hypothe-

cate or otherwise dispose of any of its Securities (or any beneficial interest therein), directly or indirectly, to any Person
(a «Transfer»), other than pursuant to a transaction in compliance with Article 10 or pursuant to a Sale of the Business
or an Exempted Reorganization, without the prior written consent of the GP. To the extent that the GP’s prior written
consent has not been obtained, or if compliance with the conditions set forth in Article 8(a) cannot be assured with
respect to any given Transfer, the GP shall have the right to prevent the registration of such contemplated Transfer and
any such purported Transfer will be null and void ab initio and disregarded by the SCA.

(b) Concurrent Transfer of GP Shares and SCA Securities.
Except as expressly provided otherwise in the Articles, no Securityholder shall Transfer any SCA Securities under

this Article 8 without concurrently transferring to the same Person in the same transaction and the same proportion
(as nearly as practicable in the event of inability to Transfer in such proportion), each and every type and class of GP
Shares that are part of the same Security Strip (it being the intent that the GP Shares, SCA Shares and CPECs in the
same Security Strip shall be «stapled» to each other by virtue of this sentence).

(c) Transfers in Violation of the Articles.
Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any provision of the Articles shall be null and

void ab initio, and disregarded by the SCA, and neither shall give any effect to such purported Transfer nor record such
purported Transfer on its share register or treat any purported Transferee of such Securities as the owner of such Se-
curities for any purpose hereunder or otherwise.

61125

Art. 9. Tag-Along Rights
(a) Application of Tag-Along Rights.
The parties agree that in the event any Securityholder that, together with its Affiliates and Concert Parties, holds in

excess of 50% of the SCA Shares on an As-Converted Basis desires to sell or otherwise dispose of for value more than
5% of the SCA Shares on an As-Converted Basis in one transaction or series of related transactions (other than in con-
nection with or following a Public Listing or in connection with a Drag-Along Sale and other than to an Affiliate) (a «Tag-
Along Sale»), such Securityholder or Securityholders may only do so in compliance with this Article 9.

(b) Delivery of Tag-Along Notice.
Subject to Article 9(a), in the event that a Securityholder desires to effect a Tag-Along Sale, prior to consummating

any such Tag-Along Sale, the holder proposing to sell or dispose for value (the «Securityholder Seller») shall deliver a
written notice (a «Tag-Along Notice») to the GP and the SCA, and the GP shall, within three Business Days of receipt
thereof, provide such notice to each other Securityholder (each, a «Potential Tag-Along Seller»). The Tag-Along Notice
shall disclose in reasonable detail the proposed type and number of Securities to be acquired by the proposed transferee
(the «Proposed Sale Securities»), and, with respect to each type of Security proposed to be acquired, the percentage of
the total number of outstanding Securities of such type on an As-Converted Basis proposed to be transferred by the
Securityholder Seller in the Tag-Along Sale, (the «Relevant Percentage»), the proposed total amount and form of con-
sideration to be offered for the Proposed Sale Securities and the price for each type of Proposed Sale Security, the other
material terms and conditions of the proposed Transfer, an estimate of the anticipated costs and expenses to be in-
curred to complete the Tag-Along Sale, and the identity or identities of the prospective or proposed transferee(s); pro-
vided that the Tag-Along Notice must provide that each Potential Tag-Along Seller may only participate in the Tag-Along
Sale through sales of the same type of Security Strips as the Securityholder Seller and provided, further, that all Securi-
tyholders shall receive the same amount and form of consideration per security, on an As-Converted Basis, in connec-
tion with any Tag-Along Sale.

(c) Election to Participate.
Any of the Potential Tag-Along Sellers may elect to sell such type and number of Proposed Sale Securities as is pro-

vided below at the price and on the terms no less favorable in the aggregate to such Potential Tag-Along Seller than
those specified in the Tag-Along Notice by delivering written notice of such election to the Securityholder Seller, the
SCA and the GP as soon as practical, but in any event not later than the tenth Business Day following the date of dispatch
by the GP of the Tag-Along Notice to such Potential Tag-Along Seller (the «Tag-Along Election Period»). For the avoid-
ance of doubt, any Potential Tag-Along Seller that does not provide written notice by the end of the Tag-Along Election
Period shall forfeit the opportunity to participate, which opportunity shall revert to the Securityholder Seller. Each Po-
tential Tag-Along Seller may elect to sell (i) where the proposed Transfer includes the Transfer of all Securities held by
the Securityholders, all the Securities held by each other Securityholder; or (ii) where the proposed Transfer includes
the Transfer of less than all the Securities held by the Securityholders, up to the Relevant Percentage of each such other
Securityholder’s Securities. If the number of Securities proposed to be transferred by the Securityholder Seller together
with those other Securities that Potential Tag-Along Sellers would be entitled to Transfer pursuant to clause (i) or (ii),
would, if transferred, result in the proposed transferee increasing its holdings of securities of the Group or any member
of the Group above the percentage it is willing to acquire, the number of Securities which shall be Transferred by the
Securityholder Seller and each Potential Tag-Along Seller shall be reduced on a pro rata basis to achieve Transfers which
in the aggregate will result in the proposed transferee achieving the desired percentage holdings specified by such trans-
feree; provided that each Potential Tag-Along Seller may only participate in the Tag-Along Sale through sales of the same
type of Security Strips as the Securityholder Seller.

(d) Transfer of Securities.
If any Potential Tag-Along Seller elects to sell under Article 9(c) (each Potential Tag-Along Seller so electing, a «Tag-

Along Seller»), the Transfer of such Securities from the Tag-Along Seller shall be consummated contemporaneously with
the sale by the Securityholder Seller on the terms and conditions specified in the Tag-Along Notice. The GP Board of
Directors shall make the calculations and prorations as to the number and type of Securities to be transferred by and
price to be paid to the Securityholder Seller and the Tag-Along Sellers and shall be permitted to round to the nearest
whole Security, and consistent with the terms set forth in Article 9(c) and the immediately preceding sentence. Any
such calculations and prorations by the GP Board of Directors taken in good faith shall be final and binding, and the
Securtiyholders can not make any claim that such calculations, prorations or Tag-Along Sale are void or voidable. If there
shall be no Tag-Along Sellers participating in a Tag-Along Sale, then the Securityholder Seller may, within 60 Business
Days (subject to Regulatory Extension) after the expiry of the Tag-Along Election Period, transfer such Proposed Sale
Securities to the proposed transferee(s) upon the other terms and conditions described in the Tag-Along Notice. Any
Proposed Sale Securities not transferred within such time period shall, for the avoidance of doubt, be subject to this
Article 9 again in connection with any subsequent Transfer. To the extent specified in the Tag-Along Notice, a Tag-
Along Seller may be required to deliver (in connection with the delivery of such Tag-Along Seller’s reply notice or oth-
erwise) all items required in connection with his Tag-Along Sale including, without limitation, a power of attorney in
favor of the GP, the SCA or the Securityholder Seller to deliver Securities or to enter into any contract, instrument,
undertaking or obligation reasonably in advance of the consummation of the Transfer in order to more effectively facil-
itate such consummation.

Art. 10. Drag-Along Sale
(a) Drag-Along Sale.
If one or more Securityholders agrees in writing to, directly or indirectly, transfer such holder’s GP Shares, SCA

Shares or CPECs (which may take the form of, without limitation, a merger, consolidation, reorganization, sale or ex-
change) to any Person that would, upon consummation of such Transfer, directly or indirectly, or if upon any Transfer

61126

any Person does, hold (or have written transfer agreements collectively to hold) at least a majority of the outstanding
SCA Shares, on an As-Converted Basis, and the proposed transferee is willing to make a binding written offer (which
may specify conditions) to acquire all of the remaining GP Shares and/or SCA Securities (a «Drag-Along Sale»), the Se-
curityholder(s) initiating the Drag-Along Sale, may, at its option, require the other holders of GP Shares and/or SCA
Securities to Transfer GP Shares and/or SCA Securities, then held by every other holder of such Securities to such pro-
posed transferee.

(i) In the event that a Person desires to effect a Drag-Along Sale, such Person shall deliver a written notice (a «Drag-

Along Notice») to the GP and the SCA with appropriate evidence that such contemplated transaction satisfies the re-
quirements for a Drag-Along Sale hereunder. Within three Business Days of receipt of a Drag-Along Notice, the GP
and the SCA shall provide the Drag-Along Notice to all holders of GP Shares and SCA Shares other than the Security-
holder or Securityholders initiating the Drag-Along Sale. The Drag-Along Notice shall disclose in reasonable detail the
proposed type and number of Securities to be acquired by the transferee, the proposed form and amount of consider-
ation to be offered for the Securities being transferred and the form and amount of consideration to be offered for each
type of Security (on an As-Converted Basis) to be transferred, the identity of the prospective purchaser, the other ma-
terial terms and conditions of the proposed Drag-Along Sale, and an estimate of the anticipated costs and expenses to
be incurred to complete the Drag-Along Sale. A Drag-Along Sale may provide for the unstapling of the SCA Securities
from the GP Shares in the Security Strips but not the unstapling of the SCA Shares from the CPECs. In such event, the
GP Board of Directors will prescribe any amendments to the remaining Securities within the Security Strips that it
deems necessary or appropriate.

(b) Consideration.
The form and value of the consideration per SCA Share shall be identical to the consideration given, whether directly

or indirectly, to the Securityholder(s) initiating the Drag-Along Sale in respect of such Securities. If the proposed Trans-
feree in the Drag-along Sale is an Affiliate or Concert Party of the initiating Securityholder(s) transferor(s), the transac-
tion giving rise to the Drag-Along Sale shall however not in and on itself give rise to Affiliate or Concert Party status,
(x) the consideration per SCA Share, on an As-Converted Basis, shall be no less than the highest price paid per SCA
Share by such proposed Transferee or its Affiliates or Concert Parties within the 180 days immediately preceding the
date of the Drag-Along Notice (and the Securityholder(s) initiating the Drag-Along Sale shall attach a representation
from the proposed Transferee to such effect in its Drag-Along Notice) and (y) the Securityholder(s) initiating the Drag-
Along Sale or the proposed Transferee shall provide attached to the Drag-Along Notice to the GP Board of Directors
an opinion from an internationally recognized, independent investing banking firm as to the fairness, as of such date,
from a financial point of view, of the consideration to be received by the holders of SCA Shares in such Drag-Along Sale.

(c) In the event of a Drag-Along Sale, each Securityholder shall be required to Transfer such Securities held by such

Securityholder as provided in the Drag-Along Notice.

C. General meetings of shareholders

Art. 11. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

The general meeting is convened by the manager or the Board of auditors.
It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the Company’s

share capital.

Art. 12. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 15 June of each year. If such
day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of
shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. The notices
shall be given no less than eight calendar days prior to such meeting. The quorum and time-limits provided by law shall
govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise pro-
vided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. To the extent
permitted under Luxembourg law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with the con-
sent of the majority of the shares present or represented.

The manager may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any

meeting of shareholders.

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

D. Management

Art. 13. The Company shall be managed by the GP in its capacity as general partner (associé commandité) and man-

ager of the Company. The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the
Company.

Art. 14. The manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of share-
holders or to the Board of auditors fall within the powers of the manager.

61127

Art. 15. The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the sole signature of any duly appointed represent-

ative of the manager, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the manager
for specific transactions.

Art. 16. In the event of legal incapacity, liquidation, or other permanent situation preventing the manager from acting

as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the board of au-
ditors appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until
a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen days of his appointment.
At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and ma-
jority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liq-
uidated.

Art. 17. The appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the manager.

E. Board of auditors

Art. 18. The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts,

shall be supervised by a board of auditors composed of not less than three members, who need not be shareholders.
For the carrying out of its supervisory duties, the board of auditors shall have the powers of a statutory auditor, as
provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time.

Art. 19. The members of the board of auditors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period

of one year. The members of the board of auditors are re-eligible for election and may be removed at any time, with
or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

Art. 20. In the event of the total number of members of the board of auditors falling below three or below one half

of the number of members determined by the general meeting of shareholders, the manager shall forthwith convene a
shareholders’ meeting in order to fill such vacancies. If one or more members of the board of auditors are temporarily
prevented from attending meetings of the said board, the remaining members may appoint a person chosen from within
the shareholders to provisionally replace them until they are able to resume their functions. The remuneration of the
members of the board of auditors shall be set by the general meeting of shareholders.

Art. 21. The board of auditors shall meet at the place in Luxembourg as indicated in the notice of meeting. The board

of auditors will choose from among its members a chairman. It will also choose a secretary, who need not be a member
of the board of auditors, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of auditors. 

The board of auditors shall be convened by its chairman or by the manager. A meeting of the board must be convened

if any of its members so requests.

The chairman of the board of auditors will preside at all meetings of such board, but in his absence the board of au-

ditors will appoint another member of the board of auditors as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.

Written notice of any meeting of the board of auditors shall be given by letter, by telefax or by electronic mail (with-

out electronic signature) to all its members at least (8) eight days prior to the date set for such meeting, except in the
case of emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of the meeting. The notice
will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof. The notice may be waived by the consent
in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Special notices shall not be
required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the board of auditors.

Any member of the board of auditors may act at any meeting of the board of auditors by appointing another member

as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A member may
represent several of his colleagues.

The board of auditors can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented. Resolutions are taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting. 

Resolutions of the board of auditors are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Any

proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or else-
where shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

The board of auditors may, unanimously, pass resolutions by written circular, a copy being sufficient to demonstrate

that any such resolution has been duly approved. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of
the resolution.

Any member of the board of auditors may participate in any meeting of the board of auditors by means of a confer-

ence call or by any similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one an-
other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The member(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments reg-

ularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any member of the board of auditors and his heirs, executors and administrators,

against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit, or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a member of the board of auditors of the Company. He shall not be entitled
to be indemnified in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for negligence or misconduct. In the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its counsel that the person to be indem-
nified did not commit a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
he may be entitled.

61128

The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any pro-

ceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding undertaking by
such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to in-
demnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea
of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount incurred by such person and to be indemnified promptly upon noti-
fication of an obligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall
reasonably require.

F. Financial year - Profits

Art. 22. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first of the same year.

Art. 23. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the manager, will determine how the remainder of

the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by the manager by observing the terms and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 24. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the articles of incorporation

Art. 25. Subject to the approval of the manager, these Articles may be amended from time to time by the general

meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for in article 67-1 of the law of 10 Au-
gust 1915 governing commercial companies, as amended.

I. Final clause - Applicable law

Art. 26. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the appearing persons and in
case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary, these persons signed together with

the notary this deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, am vierundzwanzigsten Juni.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, wohnhaft in Luxemburg.

Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der WESTCHESTER S.C.A., Kommanditgesellschaft auf Aktien, mit Ge-

sellschaftssitz in L-1468 Luxemburg, 14, rue Erasme, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B,
Nummer 108.625, gegründet am 10. Juni 2005 durch notarielle, noch nicht veröffentlichte Urkunde von Maître Joseph
Elvinger, Notar, in Ersetzung des unterzeichneten Notars (nachfolgend die «Gesellschaft»), stattgefunden.

Die Versammlung wurde um 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Lu-

xemburg, eröffnet,

welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmenzähler.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes

zu beurkunden:

I. Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat: 
1. Eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von einhundertachtundneunzigtausendsiebenhundertzehn

Euro und zehn Cent (EUR 198.710,10) von gegenwärtig einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) auf einen Betrag von
zweihundertneunundzwanzigtausendsiebenhundertzehn Euro und zehn Cent Euro (EUR 229.710,10), durch Ausgabe
von neununddreissigtausendsiebenhundertzweiundvierzig Aktien und zwei Hundertsteln (39.742,02) neuen Bruchteils-
aktien mit einem Nennwert von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie und Zahlung der neuen Aktien durch Bareinlage.

2. Ferner eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals in Höhe von siebenundsiebzigtausendsechshundertneunzig Euro

und siebzig Cent (EUR 77.690,70) auf einen Betrag von dreihundertsiebentausendvierhundert Euro und achtzig Cent
(EUR 307.400,80), durch Ausgabe von fünfzehntausendfünfhundertachtunddreissig Aktien und vierzehn Hundertstel
(15.538,14) neuen Bruchteilsaktien mit einem Nennwert von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie und Zahlung der neuen
Aktien durch Sacheinlage in Form der Abtretung Forderungen im Gesamtwert von siebenundsiebzigtausendsechshun-
dertneunzig Euro und siebzig Cent (EUR 77.690,70) der Sacheinleger gegenüber der Gesellschaft.

61129

3. Ferner eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals in Höhe von zweihundertdreiundzwanzigtausendfünfhundertneun-

undneunzig Euro und zwanzig Cent (EUR 223.599,20) auf einen Betrag von fünfhunderteinunddreissigtausend Euro (EUR
531.000), durch Ausgabe von vierundvierzigtausendsiebenhundertneunzehn Aktien und vierundachtzig Hundertstel
(44.719,84) neuen Bruchteilsaktien mit einem Nennwert von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie und Zahlung der neuen
Aktien durch Sacheinlage in Form der Abtretung von Forderungen der Sacheinleger gegenüber der iesy Hessen GmbH
&amp; Co. KG, Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, mit Gesellschaftssitz in Kleyerstrasse 88, D-60326 Frankfurt
am Main, Deutschland, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter der Nummer HRA 31043
(nachfolgend die «iesy KG Forderungen»), sowie Ansprüche der Sacheinleger gegenüber eines treuhänderischen Bank-
kontos welche Ansprüche an die Sacheinleger ausgeschüttet wurden durch KABELNETZ NRW LIMITED, Gesellschaft
mit beschränkter Haftung auf Aktien, gegründet unter dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftssitz in 22 Grenville Street,
St. Helier, Jersey JE4 8XP Channel Islands mit der Handelsregisternummer 84707 im Gesamtwert von
zweihundertdreiundzwanzigtausendfünfhundertneunundneunzig Euro und zwanzig Cent (EUR 223.599,20) (nachfolgend
die «Kabelnetz Ltd Treuhanderischen Ansprüche»).

4. Eine Verringerung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von dreißigtausendneunhundertfünfundneunzig Euro

(EUR 30.995) durch Löschung von sechstausendeinhundertneunundneunzig (6.199) Aktien.

5. Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft.
II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die An-

zahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch
die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser regi-
striert zu werden.

III. Dass alle Aktien der Gesellschaft in der Hauptversammlung anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind.
IV. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten

Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und dass daher keine Einladungen erforderlich waren.

V. Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-

nungspunkte beraten kann. 

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals von gegenwärtig einunddreißigtausend

Euro (EUR 31.000) auf einen Betrag von zweihundertneunundzwanzigtausendsiebenhundertzehn Euro und zehn Cent
Euro (EUR 229.710,10), mittels Ausgabe von neununddreissigtausendsiebenhundertzweiundvierzig Aktien und zwei
Hundertsteln (39.742,02) neuen Bruchteilsaktien, mit einem Nennwert von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie.

Alle diese neuen Aktien wurden zu einem Preis von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie von AP CABLE LLC, c/o Apollo

Management, L.P., Two Manhattanville Road, Purchase, NY 10577 U.S.A. gezeichnet und durch Bareinlage vollständig
bezahlt.

AP CABLE LLC wird hier rechtswirksam kraft Vollmacht vom 24. Juni 2005 von Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M.,

wohnhaft in Luxemburg, vertreten.

Der Nachweis der tatsächlich erfolgten Bareinlage wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.
Die Hauptversammlung der Aktionäre und die OAKBROOK S.A., in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Aktio-

när der Gesellschaft, nehmen hiermit die Kapitalerhöhung, die Ausgabe neuer Aktien, die vollständige Zeichnung dieser
oben bezeichneten neuen Aktien sowie die vollständige Zahlung durch Bareinlage ausdrücklich an; alle vorhandenen Ak-
tionäre verzichten auf ihr Zeichnungsvorrecht.

Diese neuen Aktien werden sofort nach Unterzeichnung dieser notariellen Urkunde ausgegeben werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt ferner die Erhöhung des Gesellschaftskapitals auf dreihundertsiebentausendvier-

hundert Euro und achtzig Cent (EUR 307.400,80) durch Ausgabe von fünfzehntausendfünfhundertachtunddreissig Akti-
en und vierzehn Hundertstel neuen Bruchteilsaktien, mit einem Nennwert von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie.

Alle diese neuen Aktien wurden zum Preis von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie wie folgt gezeichnet:
1. CONCERTO I B.V., c/o AXA Investment Managers UK, Newgate Street, London EC1A 7NX, Vereinigtes König-

reich, hat 319 neue Aktien und 45 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch
Sacheinlage im Wert von EUR 1.597,25 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

2. CAF EUROPEAN HIGH YIELD BOND., c/o Credit Agricole Asset Management, 90, boulevard Pasteur, 75015 Pa-

ris, Frankreich, hat 34 neue Aktien und 8 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und
durch Sacheinlage im Wert von EUR 170,40 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

3. GRD 5-OD-HY EUROPE, c/o Credit Agricole Asset Management, 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich,

hat 29 neue Aktien und 82 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sach-
einlage im Wert von EUR 149,10 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

4. ALPHA US SUBFUND II LLC, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, 25th Floor, New York, NY

10022, U.S.A., hat 188 neue Aktien und 62 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet
und durch Sacheinlage im Wert von EUR 943,10 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft
bezahlt;

5. B&amp;W MASTER RETIREMENT TRUST, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New York, NY

10022, U.S.A., hat 73 neue Aktien und 77 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und
durch Sacheinlage im Wert von EUR 368,85 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

6. DB STRUCTURED PRODUCTS INC, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New York, NY

10022, U.S.A., hat 486 neue Aktien und 5 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und

61130

durch Sacheinlage im Wert von EUR 2.430,25 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft be-
zahlt;

7. GOLDEN TREE HIGH YIELD VALUE MASTER FUND, LP, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue,

New York, NY 10022, U.S.A., hat 105 neue Aktien und 62 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer
Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 528,10 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber
der Gesellschaft bezahlt;

8. GOLDEN TREE HIGH YIELD MASTER FUND, Ltd, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New

York, NY 10022, U.S.A., hat 5.965 neue Aktien und 86 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie
gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 29.829,30 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der
Gesellschaft bezahlt;

9. GOLDEN TREE HIGH YIELD MASTER FUND II, Ltd, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New

York, NY 10022, U.S.A., hat 635 neue Aktien und 58 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie
gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 3.177,90 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der
Gesellschaft bezahlt;

10. GOLDEN TREE HIGH YIELD OPPORTUNITIES II, LP, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue,

New York, NY 10022, U.S.A., hat 547 neue Aktien und 84 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer
Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 2.739,20 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber
der Gesellschaft bezahlt;

11. GKW UNIFIED HOLDINGS LLC, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New York, NY 10022,

U.S.A., hat 135 neue Aktien und 53 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch
Sacheinlage im Wert von EUR 677,65 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

12. THE UNIVERSITY OF CHICAGO, c/o Golden Tree Asset Management, 300 Park Avenue, New York, NY 10022,

U.S.A., hat 22 neue Aktien und 81 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch
Sacheinlage im Wert von EUR 114,05 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

13. Andrew Booth, c/o Jefferies &amp; Company, Inc., 520 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10022, U.S.A.,

hat 27 neue Aktien und 69 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sach-
einlage im Wert von EUR 138,45 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

14. Andrew Whittaker, c/o Jeffries &amp; Company Inc., 11100 Santa Monica Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, CA

90025, U.S.A., hat 27 neue Aktien und 69 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und
durch Sacheinlage im Wert von EUR 138,45 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

15. Chris Kanoff, c/o Jeffries &amp; Company Inc., 11100 Santa Monica Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, CA 90025,

U.S.A., hat 27 neue Aktien und 69 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch
Sacheinlage im Wert von EUR 138,45 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

16. Craig Zaph, c/o Jeffries &amp; Company Inc., 11100 Santa Monica Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, CA 90025,

U.S.A., hat 2 neue Aktien und 13 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch
Sacheinlage im Wert von EUR 10,65 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

17. OZ MASTER FUND, Ltd., c/o Och-Ziff Management L.L.C., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York, NY

10019, U.S.A., hat 1.165 neue Aktien und 16 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet
und durch Sacheinlage im Wert von EUR 5.825,80 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft
bezahlt;

18. OZ EUROPE MASTER FUND Ltd., c/o Och-Ziff Management L.L.C., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York,

NY 10019, U.S.A., hat 624 neue Aktien und 69 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet
und durch Sacheinlage im Wert von EUR 3.123,45 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft
bezahlt;

19. FLEET MARITIME INC., c/o Och-Ziff Management L.L.C., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York, NY 10019,

U.S.A., hat 17 neue Aktien und 72 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch
Sacheinlage im Wert von EUR 88,60 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

20. CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND Ltd., c/o Cyprus Capital Partners Europe LLP, Buchanan House, 3 St.

James’s Square, London SW1Y 4JU, Vereinigtes Königreich, hat 259 neue Aktien und 31 Bruchteilsaktien mit dem Wert
eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 1.296,55 in Form der Abtretung
einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

21. CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND II, Ltd., c/o Cyprus Capital Partners Europe LLP, Buchanan House, 3

St. James’s Square, London SW1Y 4JU, Vereinigtes Königreich, hat 373 neue Aktien und 63 Bruchteilsaktien mit dem
Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 1.868,15 in Form der Abtre-
tung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

22. COLONY eKabel PARTNERS, LP, 1999 Avenue of the Stars, Los Angeles, CA 90067, U.S.A., hat 62 neue Aktien

und 39 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von
EUR 311,95 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

23. STANFIELD ARBITRAGE CDO Ltd., 430 Park Avenue, New York, NY 10022, U.S.A., hat 253 neue Aktien und

49 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR
1.267,45 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

24. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA, Avda. Fernandez Ladreda 8, 40001 Segovia, Spanien,

hat 85 neue Aktien und 19 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sach-
einlage im Wert von EUR 425,95 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

25. FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL LIMITED, c/o Franklin Templeton Investments, The Adelphi, 1-11 John

Adam Street, London WC2N 6HT, Vereinigtes Königreich, hat 76 neue Aktien und 67 Bruchteilsaktien mit dem Wert

61131

eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 383,35 in Form der Abtretung einer
Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

26. INVESCO PERPETUAL MONTHLY INCOME PLUS FUND, 30 Finsbury Square, London EC2A 1 AG, Vereinigtes

Königreich, hat 553 neue Aktien und 72 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und
durch Sacheinlage im Wert von EUR 2.768,60 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft be-
zahlt;

27. Jeffrey D. Benjamin, 133 East 64th Street, New York, NY 10021, U.S.A., hat 106 neue Aktien und 14 Bruchteils-

aktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 530,70 in Form
der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

28. JP MORGAN CHASE, 14201 Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, U.S.A., hat 1.254 neue Aktien und 79 Bruchteils-

aktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 6.273,95 in
Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

29. MORGAN STANLEY &amp; CO. INTERNATIONAL LIMITED, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,

Vereinigtes Königreich, hat 194 neue Aktien und 65 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie ge-
zeichnet und durch Sacheinlage in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft im Wert von EUR
973,25 bezahlt;

30. MORGAN STANLEY &amp; CO INCORPORATED, 1585 Broadway, New York, NY 10036, U.S.A., 1585 Broadway,

New York, NY 10036, U.S.A., hat 40 neue Aktien und 14 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie
gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 200,70 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Ge-
sellschaft bezahlt;

31. PERSHING, DIVISION OF DONALDSON, LUFKIN &amp; JENRETTE SECURITIES CORP, One Pershing Plaza 9th

Floor, Jersey City, NJ 07399, U.S.A., hat 9 neue Aktien und 55 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer
Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 47,75 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der
Gesellschaft bezahlt;

32. SOUND BEACH CAPITAL L.P., 201 Main Street, Suite 3200, Fort Worth, TX 76102, U.S.A., hat 85 neue Aktien

und 19 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von
EUR 425,95 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

33. STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, P.O. Box 575, 2501 CN The Hague, Niederlande, hat 85 neue Aktien

und 19 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von
EUR 425,95 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

34. UBS AG, 100 Liverpool Street, London EC2M 2RH, Vereinigtes Königreich, hat 3 neue Aktien und 6 Bruchteils-

aktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 15,30 in Form
der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt; 

35. ATLANTIC SECURITY BANK, c/o Torre Banco Continental, Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Piso 29, Panama,

Republik Panama, hat 92 neue Aktien und 52 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet
und durch Sacheinlage im Wert von EUR 462,60 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft
bezahlt;

36. DEUTSCHE BANK AG, Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich, hat 26 neue Ak-

tien und 19 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert
von EUR 130,95 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

37. RAB GLOBAL MACRO FUND LIMITED, c/o RAB Capital PLC, 1 Adam Street, London WC2N 6LE, Vereinigtes

Königreich, hat 8 neue Aktien und 52 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und
durch Sacheinlage im Wert von EUR 42,60 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

38. Mario Rebba, Via Broggi 14, 20129 Milano, Italien, hat 21 neue Aktien und 30 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines

Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 106.50 in Form der Abtretung einer For-
derung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

39. Jami B. Gertz IRA Rollover, 21 Beverly Park Terrace, Beverly Hills, CA 90210, U.S.A., hat 97 neue Aktien gezeich-

net und durch Sacheinlage im Wert von EUR 485 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft
bezahlt;

40. Antony P. Ressler IRA, 1999 Avenue of the Stars, Suite 1900, Los Angeles, CA 90067, U.S.A., hat 4 neue Aktien

und 39 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von
EUR 21,95 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

41. DILMUN CAPITAL II, Ltd., c/o AIG Global Investment Group, Corporate Legal Department, 2929 Allen Parkway,

36th Floor, Houston, TX 77019, U.S.A., hat 84 neue Aktien und 50 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels
einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 422,50 in Form der Abtretung einer Forderung gegen-
über der Gesellschaft bezahlt;

42. IESY HESSEN (US) L.P., c/o DLA Piper Rudnick Gray Cary, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020,

U.S.A., hat 424 neue Aktien und 31 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch
Sacheinlage im Wert von EUR 2.121,55 in Form der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

43. Bruno Claude, 19 Moenchhofstrasse, Kilchberg, 8802-ZH, Schweiz, hat 449 neue Aktien und 25 Bruchteilsaktien

mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 2.246,25 in Form
der Abtretung einer Forderung gegenüber der Gesellschaft bezahlt;

44. BLUEWATER COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED, Nautilus House, La Cour des Casernes, St. Heller,

Jersey JE13NH, Vereinigtes Königreich, hat 449 neue Aktien und 25 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels
einer Aktie gezeichnet und durch Sacheinlage im Wert von EUR 2.246,25 in Form der Abtretung einer Forderung ge-
genüber der Gesellschaft bezahlt.

61132

Alle Zeichner werden rechtswirksam kraft Vollmacht vom 24. Juni 2005 von Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M.,

wohnhaft in Luxemburg, vertreten.

Jeder Zeichner bestätigt hiermit im Hinblick auf seine jeweilige Sacheinlage, dass:
- er der rechtmäßige wirtschaftliche Eigentümer der als Sacheinlage übertragenen Forderung ist;
- keine Sicherheiten, Vorrechte oder anderen Rechte in Bezug auf die als Sacheinlage übertragene Forderung beste-

hen, kraft welcher irgendeine Person befugt sein könnte, die Übertragung dieser Forderung zu seinen Gunsten zu ver-
langen;

- alle erforderlichen Ermächtigungen oder Verzichtserklärungen zur Übertragung der als Sacheinlage übertragenen

Forderung auf die Gesellschaft, soweit einschlägig, ordnungsgemäß vorliegen.

Der Nachweis des Vorhandenseins und des Wertes der oben beschriebenen Sacheinlagen wurde gegenüber dem un-

terzeichneten Notar erbracht.

Der Wert der als Sacheinlage eingebrachten Vermögenswerte sind im Bericht der KPMG AUDIT, externer Wirt-

schaftsprüfer (réviseur d’entreprises), mit eingetragenem Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer, gemäß den Arti-
keln 32-1 and 26-1 des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 beschrieben und
bestätigt worden; dieser Bericht wird dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser registriert zu wer-
den.

Die Schlussfolgerung des Berichts lautet: «Based on the verification carried out as described above, we have no ob-

servation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the
ordinary shares to be issued as consideration.»

Die Hauptversammlung der Aktionäre und die OAKBROOK S.A., in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Aktio-

när der Gesellschaft, nehmen hiermit die Kapitalerhöhung, die Ausgabe neuer Aktien, die vollständige Zeichnung dieser
oben bezeichneten neuen Aktien sowie die vollständige Zahlung durch Sacheinlage ausdrücklich an.

Diese neuen Aktien werden sofort nach Unterzeichnung dieser notariellen Urkunde ausgegeben werden.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt ferner die Erhöhung des Gesellschaftskapitals auf fünfhunderteinunddreissigtau-

send Euro (EUR 531.000) durch Ausgabe von vierundvierzigtausendsiebenhundertneunzehn Aktien und vierundachtzig
Hundertstel (44.719,84) neuen Bruchteilsaktien mit einem Nennwert von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie.

Alle diese neuen Aktien wurden zum Preis von fünf Euro (EUR 5) pro ganze Aktie wie folgt gezeichnet:
1. ALPHA US SUBFUND II LLC, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue, 25th Floor, New York,

NY 10022, U.S.A., hat 19 neue Aktien und 29 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet
und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 96,45 bestehend aus iesy KG Forde-
rungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

2. DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N

2DB, Vereinigtes Königreich, hat 5.212 neue Aktien und 78 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer
Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 26.063,90 bestehend
aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

3. FINAKABEL HOLDINGS LIMITED, Cie Management II Limited, P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.

Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, Channel Islands, hat 15.994 neue Aktien und 46 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines
Hundertstels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR
79.972,30 bestehend aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

4. GOLDENTREE HIGH YIELD MASTER FUND, Ltd., c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., hat 682 neue Aktien und 25 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundert-
stels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 3.411,25
bestehend aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

5. GOLDENTREE HIGH YIELD MASTER FUND II, Ltd., c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., hat 870 neue Aktien und 35 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundert-
stels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 4.351,75
bestehend aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

6. GOLDENTREE HIGH YIELD OPPORTUNITIES I, LP, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., hat 931 neue Aktien und 31 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundert-
stels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 4.656,55
bestehend aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

7. GOLDENTREE HIGH YIELD OPPORTUNITIES II, LP, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., hat 426 neue Aktien und 13 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundert-
stels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 2.130,65
bestehend aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

8. CITI GOLDEN TREE LIMITED, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue, 25th Floor, New York,

NY 10022, U.S.A., hat 382 neue Aktien und 33 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet
und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 1.911,65 bestehend aus iesy KG For-
derungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

9. SAFETY NATIONAL CASUALTY CORPORATION, c/o Golden Tree Asset Management LP, 300 Park Avenue,

25th Floor, New York, NY 10022, U.S.A., hat 90 neue Aktien und 99 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels
einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 454,95 beste-
hend aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

10. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ,

Vereinigtes Königreich, hat 1.543 neue Aktien und 56 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie

61133

gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 3.858,90 bestehend aus
iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

11. OZ MASTER FUND, Ltd., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York, NY 10019, U.S.A., hat 4.146 neue Aktien

und 69 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form
einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 20.733,45 bestehend aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treu-
händerischen Ansprüche;

12. CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND II Ltd., 390 Park Avenue, 21st Floor, New York, NY 10022, U.S.A.,

hat 1.245 neue Aktien und 92 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und bezahlt
durch Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 6.229,60 bestehend aus iesy KG Forderungen und
KABELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

13. CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND Ltd., 390 Park Avenue, 21st Floor, New York, NY 10022, U.S.A., hat

556 neue Aktien und 15 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch
Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 2.780,75 bestehend aus iesy KG Forderungen und KA-
BELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

14. OZ EUROP E MASTER FUND, Ltd., 9 West 57th Street, 39th Floor, New York, NY 10019, U.S.A., hat 1.507

neue Aktien und 45 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sach-
einlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 7.537,25 bestehend aus iesy KG Forderungen und KABEL-
NETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche;

15. SCOGGIN CAPITAL MANAGEMENT LP II, 660 Madison Avenue, 20th Floor, New York, NY 10021 U.S.A., hat

4.284 neue Aktien und 23 Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch
Sacheinlage in Form einer Abtretung im Gesamtwert von EUR 21.421,15 bestehend aus iesy KG Forderungen und KA-
BELNETZ Ltd Treuhänderischen Ansprüche; 

16. SPCP GROUP, LLC, 2 Greenwich Plaza, 1st Floor, Greenwich, CT 06830, U.S.A., hat 6,825 neue Aktien und 95

Bruchteilsaktien mit dem Wert eines Hundertstels einer Aktie gezeichnet und bezahlt durch Sacheinlage in Form einer
Abtretung im Gesamtwert von EUR 34.129,75 bestehend aus iesy KG Forderungen und KABELNETZ Ltd Treuhände-
rischen Ansprüche.

Alle Zeichner werden rechtswirksam kraft Vollmacht vom 24. Juni von Herrn Jean-Michel Schmit, LL.M., wohnhaft in

Luxemburg, vertreten.

Jeder Zeichner bestätigt hiermit im Hinblick auf seine jeweilige Sacheinlage, dass:
- er der rechtmäßige wirtschaftliche Eigentümer der von ihm als Sacheinlage übertragenen Forderungen und der treu-

händerischen Ansprüche ist;

- keine Sicherheiten, Vorrechte oder anderen Rechte in Bezug auf die als Sacheinlage übertragene Forderungen und

der treuhänderischen Ansprüche bestehen, kraft welcher irgendeine Person befugt sein könnte, die Übertragung dieser
Forderungen oder der treuhänderischen Ansprüche zu seinen Gunsten zu verlangen;

- alle erforderlichen Ermächtigungen oder Verzichtserklärungen zur Übertragung der Forderungen oder der treuhän-

derischen Ansprüche als Sacheinlage auf die Gesellschaft, soweit einschlägig, ordnungsgemäß vorliegen.

Der Nachweis des Vorhandenseins und des Wertes der oben beschriebenen Sacheinlagen wurde gegenüber dem un-

terzeichneten Notar erbracht.

Der Wert der als Sacheinlage eingebrachten Vermögenswerte sind im Bericht der KPMG AUDIT, externer Wirt-

schaftsprüfer (réviseur d’entreprises), mit eingetragenem Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer, gemäß den Arti-
keln 32-1 and 26-1 des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 beschrieben und
bestätigt worden; dieser Bericht wird dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser registriert zu wer-
den.

Die Schlussfolgerung des Berichts lautet: «Based on the verification carried out as described above, we have no ob-

servation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the
ordinary shares to be issued as consideration.»

Die Hauptversammlung der Aktionäre und die OAKBROOK S.A., in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Aktio-

när der Gesellschaft, nehmen hiermit die Kapitalerhöhung, die Ausgabe neuer Aktien, die vollständige Zeichnung dieser
oben bezeichneten neuen Aktien sowie die vollständige Zahlung durch Sacheinlage ausdrücklich an.

Diese neuen Aktien werden sofort nach Unterzeichnung dieser notariellen Urkunde ausgegeben werden.

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Verringerung des Gesellschaftskapitals von fünfhunderteinund-

dreißigtausend Euro (EUR 531.000) um den Betrag von dreißigtausendneunhundertfünfundneunzig Euro (EUR 30.995)
durch Löschung von sechstausendeinhundertneunundneunzig (6.199) Aktien mit der Nummer 2 bis 6200 und durch
Rückzahlung des Betrags in Höhe von dreißigtausendneunhundertfünfundneunzig Euro (EUR 30.995) an die eingetrage-
nen Aktionäre.

Diese Aktien werden sofort nach Unterzeichnung dieser notariellen Urkunde gelöscht werden.
In Folge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet nun wie

folgt:

«Art. 6. Die Gesellschaft hat ein gezeichnetes Aktienkapital von fünfhunderttausendfünf Euro (EUR 500.005), wel-

ches sich aus einhunderttausendeins (100.001) Aktien mit einem Nennwert von jeweils fünf Euro (EUR 5) pro Aktie
zusammensetzt.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, die Satzung der Gesellschaft umzuformulieren und ihr folgenden

Wortlaut zu geben:

61134

A. Name - Begriffsbestimmungen - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Es besteht eine zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestellten

Aktien eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die Bezeichnung WESTCHESTER S.C.A. führt.

«Verbundenes Unternehmen» bezeichnet, wenn hierauf mit Bezug auf eine Person verwiesen wird (zu diesen Zwek-

ken die «Erste Person»), jedweden Dritten, der direkt oder indirekt (i) durch die Erste Person Kontrolliert wird, (ii)
diese Erste Person Kontrolliert oder (iii) sich unter gemeinsamer Kontrolle mit dieser Ersten Person befindet;

«Satzung» bezeichnet die Satzung der Gesellschaft;
«As-Converted-Basis» hat im Hinblick auf die umlaufenden Wertpapiere einer Gesellschaft die Bedeutung, als ob

sämtliche wandelbaren Vorzugsaktienzertifikate oder Convertible Preferred Equity Certificates, CPECs (sowie sämtli-
che sonstigen Wertpapiere, die in Aktien der entsprechenden Gesellschaft wandelbar sind oder gegen bzw. in Aktien
der entsprechenden Gesellschaft ausübbar bzw. konvertierbar sind), in bzw. gegen Aktien umgewandelt, ausgeübt oder
ausgetauscht wären, die das Aktienkapital der entsprechenden Gesellschaft bilden, und zwar gemäß den Bedingungen
für diese CPECs und die entsprechenden wandelbaren, ausübbaren oder konvertierbaren Wertpapiere (d.h. im Fall der
SCA die Anzahl an umlaufenden SCA-Anteilen zuzüglich der zusätzlichen Anzahl an SCA-Anteilen, die umlaufen würden,
wenn eine solche Umwandlung, Ausübung bzw. Konvertierung erfolgt wäre);

«Werktage» bezeichnet jeden anderen Tag als einen Samstag oder Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, an dem Bank-

geschäfte in Luxemburg oder dem Vereinigten Königreich geöffnet sind;

«Gesellschaft» bezeichnet WESTCHESTER S.C.A.;
«Gemeinsam handelnde Parteien» bezeichnet Parteien, die vereinbart haben, bei der Ausübung der Kontrolle über

die Gruppe gemeinsam zu handeln, wobei jedoch ein Vertrag an dem alle Aktionäre beteiligt sind die Aktionäre oder
einen Teil von ihnen zu Gemeinsam handelnden Parteien macht;

«Kontrollmehrheit» (einschließlich der Begriffe «Kontrolliert» und «Kontrollieren») bezeichnet im Hinblick auf jed-

wede Person den Besitz oder die Berechtigung und Befähigung zum derzeitigen Besitz und zur derzeitigen Ausübung des
Rechts, die Leitung dieser Person zu verwalten oder zu steuern oder die leitenden und führenden Gremien dieser Per-
son bzw. die Mehrheit ihrer Mitglieder zu ernennen, sei es aufgrund des Eigentums an den Stimmrechtsaktien gemäß
einem Vertrag oder anderweitig;

«CPEC» bezeichnet (i) die seitens der SCA ausgegebenen wandelbaren Vorzugswandelanleihen sowie (ii) jedwede

Wertpapiere oder sonstigen ausgegebenen bzw. direkt oder indirekt auszugebenden Anteile (die keine SCA-Anteile
darstellen, die bei Rückkauf der CPEC gemäß deren Bedingungen ausgegeben werden oder auszugeben sind) in Bezug
auf die in Satz (i) bezeichneten Wertpapiere (oder deren Nachfolger gemäß diesem Satz (ii)), und zwar durch eine Di-
vidende, einen Split oder eine sonstige Transaktion bzw. in Verbindung mit einer Kombination aus Wertpapieren, Ka-
pitalaufstockung, Zusammenschluss, Konsolidierung, Konvertierung, Umwandlung, Einlösung, Rückkauf oder einer
sonstigen Umstrukturierungstransaktion sowie jedwede Wertpapiere oder sonstigen Anteile (die keine SCA-Anteile
darstellen), in die eines der Vorstehenden umgewandelt werden kann;

«Mitverkauf» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 10(a) zugeschrieben wird;
«Mitverkaufsmitteilung» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 10(a)(i) zugeschrieben wird;
«Mitverkaufs-Verkäufer» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 10(a)(i) zugeschrieben wird;
«GP» bezeichnet OAKBROOK S.A., eine société anonyme, die als General Partner und Manager der SCA tätig ist;
«GP-Vewaltungsrat» bezeichnet den Verwaltungsrat der GP;
«GP-Anteile» bezeichnet (i) die Stammaktien am Kapital der GP in eingetragener Form, die mit den in der Satzung

der GP angeführten Rechten behaftet sind, sowie (ii) jedwede Wertpapiere oder sonstigen durch eine Dividende, einen
Split oder eine sonstige Transaktion bzw. im Zusammenhang mit einer Kombination aus Wertpapieren, Kapitalaufstok-
kung, Zusammenschluss, Konsolidierung, Konvertierung, Umwandlung, Einlösung, Rückkauf oder sonstigen Umstruktu-
rierungstransaktion ausgegebenen oder direkt bzw. indirekt auszugebenden Anteile in Bezug auf die in Satz (i)
bezeichneten Wertpapiere (oder deren Nachfolger entsprechend diesem Satz (ii)), sowie jedwede Wertpapiere, in die
eines der Vorstehenden umgewandelt werden kann;

«Gruppe» bezeichnet SCA und die SCA-Tochtergesellschaften;
«Person» bezeichnet eine natürliche Person, eine Personengesellschaft, eine Corporation, eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, eine Vereinigung, eine Aktiengesellschaft, einen Trust, ein Joint Venture, eine Gelegenheitsgesell-
schaft, jedwede sonstige Gesellschaft oder gemeinnützige Organisation sowie eine staatliche Behörde oder Abteilung
bzw. eine diesbezügliche politische Unterabteilung;

«Potenzieller Mitnahme-Verkäufer» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9 zugeschrieben wird;
«Zulassung zum Öffentlichen Handel» bezeichnet eine öffentliche Registrierung, Kotierung, Qualifikation oder Ge-

nehmigung zum Handel oder zur Notierung von Aktien der SCA bzw. jedweder SCA-Tochtergesellschaften (oder jed-
wedes sonstigen Unternehmens bzw. jedweder sonstigen Unternehmen, das bzw. die durch Unabhängige
Umstrukturierung entstanden ist bzw. sind) an einem international anerkannten Weltpapierhandels- oder Zulassungs-,
Berichts- oder Notierungssystem in den USA, in Großbritannien, in Luxemburg, in Deutschland oder in jedwedem son-
stigen Hoheitsgebiet;

«Qualifizierter Öffentlicher Verkauf» bezeichnet jedweden Verkauf oder eine Reihe von Verkäufen bzw. Angeboten

von Aktien durch Zulassung zum Öffentlichen Handel, im Zusammenhang mit dem bei Abschluss des entsprechenden
Verkaufs oder einer Reihe von Verkäufen bzw. Angeboten über 20% der umlaufenden Aktien der SCA (oder jedweder
SCA-Tochtergesellschaften) in Verbindung mit dem entsprechenden Angebot oder der entsprechenden Angebotsserie
verkauft oder übertragen werden;

«Gesetzliche Verlängerung» bezeichnet in Bezug auf einen Zeitraum und eine betreffende Transaktion eine Verlän-

gerung dieses Zeitraums bis zu dem Datum, an dem eine Bedingung oder wesentliche gesetzliche, staatliche oder ver-
tragliche Genehmigung (von einem Dritten, der keine Partei der betreffenden Transaktion ist), die in Verbindung mit

61135

dieser Transaktion erforderlich ist, erhalten wird, und zwar unter der Voraussetzung, dass die betreffenden Parteien
geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese Genehmigung zu erhalten, und vernünftigerweise davon ausgegangen werden
kann, dass diese Genehmigung erteilt wird;

«Relevanter Prozentsatz» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9 zugeschrieben wird;
«Verkauf der Geschäftstätigkeit» bedeutet eine Verschmelzung, eine Konsolidierung, einen Tausch, eine Reoganisa-

tion oder einen Verkauf sämtlicher oder im wesentlichen sämtlicher Vermögensgegenstände und Geschäftszweige der
GP oder der SCA; 

«SCA» bezeichnet WESTCHESTER S.C.A., eine Société en commandite par actions;
«SCA-Wertpapiere» bezeichnet die SCA-Anteile und die CPECs;
«SCA-Anteile» bezeichnet (i) die Stammaktien am Kapital der SCA in eingetragener Form, die mit den in der Satzung

der SCA angeführten Rechten behaftet sind, sowie (ii) jedwede Wertpapiere oder sonstigen durch eine Dividende, einen
Split oder eine sonstige Transaktion bzw. im Zusammenhang mit einer Kombination aus Wertpapieren, Kapitalaufstok-
kung, Zusammenschluss, Konsolidierung, Konvertierung, Umwandlung, Einlösung, Rückkauf oder sonstigen Umstruktu-
rierungstransaktion ausgegebenen oder direkt bzw. indirekt auszugebenden Anteile in Bezug auf die in Satz (i)
bezeichneten Wertpapiere (oder deren Nachfolger entsprechend diesem Satz (ii)), sowie jedwede Wertpapiere oder
sonstigen Anteile (die keine CPEC darstellen), in die eines der Vorstehenden umgewandelt werden kann;

«SCA-Tochtergesellschaft» bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehenden Tochtergesellschaften der SCA;
«Wertpapiere» bezeichnet die Wertpapiere an der Gesellschaft, die SCA-Anteile und die von der SCA ausgegebenen

CPECs;

«Wertpapierinhaber» (sing.) bezeichnet den Inhaber von Wertpapieren;
«Wertpapierinhaber» (pl.) bezeichnet die Inhaber von Wertpapieren;
«Verkaufender Wertpapierinhaber» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9 zugeschrieben wird;
«Wertpapier-Strip» bezeichnet ein Paket (oder einen jedweden anteiligen diesbezüglichen Teil) aus zum gleichen

Zeitpunkt an einen Wertpapierinhaber ausgegebenen GP-Anteilen, SCA-Anteilen und CPECs (mit angemessenen An-
passungen im Falle eines der in Satz (ii) der Bestimmung der Begriffe «GP-Anteile», «SCA-Anteile» und «CPEC» be-
schriebenen Ereignisses oder sonstigen Anpassungen, wie möglicherweise seitens des GP-Verwaltungsrats zur
Ausräumung von Irrtümern, die bei vorherigen Emissionen oder einem der in Satz (ii) der Bestimmung der Begriffe «GP-
Anteile», «SCA-Anteile» und «CPEC» beschriebenen Ereignisse unterlaufen sind, genehmigt), wobei die Absicht darin
besteht, dass diejenigen «GP-Anteile», «SCA-Anteile» und «CPEC», die einen Bestandteil eines Wertpapier-Strips bil-
den, aneinander «anzuheften» sind;

«Mitnahme-Wahlzeitraum» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9 zugeschrieben wird;
«Mitnahme-Mitteilung» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9 zugeschrieben wird;
«Mitnahmerechte» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9 zugeschrieben wird;
«Mitnahme-Verkauf» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9 zugeschrieben wird;
«Mitnahme-Verkäufer» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9(d) zugeschrieben wird;
«Bedingungen» bezeichnet die Bedingungen, mit denen die CPECs behaftet sind;
«Übertragung» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 8(a) zugeschrieben wird;
«Übernehmender» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 8(a)(ii) zugeschrieben wird;
«Übertragender Wertpapierinhaber» trägt die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 8(a)(i) zugeschrieben wird.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf,

Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie durch die Übertragung von Wertpapieren jeder Art erwerben und jegliche
sonstigen Maßnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wertpapieren
sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen treffen.

Die Gesellschaft kann daneben solchen Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder die zu ihrer

Unternehmensgruppe gehören, Darlehen gewähren, zu ihren Gunsten Bürgschaften abgeben und sie anderweitig unter-
stützen.

Die Gesellschaft kann daneben in Personengesellschaften oder in ähnlichen Gesellschaftsformen Gesellschafter mit

begrenzter oder mit unbegrenzter Haftung werden.

Die Gesellschaft kann daneben in eigenem oder fremdem Namen alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres

Zweckes förderlich sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft inner-

halb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers. Durch einfachen Beschluß des Geschäfts-
führers können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland, gegründet werden.

Art. 5. Die GP als Komplementär haftet für alle Schulden, die nicht aus den Güter der Gesellschaft beglichen werden

können. Die anderen Aktionäre (zum Ausschluss jedes Zweifels, ausschließlich des Komplementärs) sollen jede Hand-
lung im Namen der Gesellschaft, in jeder Art und Funktion unterlassen, außer durch Ausübung Ihrer Rechte als Aktio-
näre bei Hauptversammlungen. Die Kommanditäre haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.

B. Kapital - Aktien

Art. 6. Die Gesellschaft hat ein gezeichnetes Aktienkapital von fünfhunderttausendfünf Euro (EUR 500.005), welches

sich aus einhunderttausendeins (100.001) Aktien mit einem Nennwert von jeweils fünf Euro (EUR 5) pro Aktie zusam-
mensetzt.

61136

Das genehmigte Aktienkapital beträgt einschließlich des gezeichneten Aktienkapitals von fünfhunderttausendfünf Euro

(EUR 500.005) einsechshundertachtundzwanzig Millionen neunhundertneuntausendsechshundert Euro (EUR
628.909.600), bestehend aus fünfhunderteinungsiebzig Millionen zweihundertsechsunddreissigtausend Euro (EUR
571.236.000) zur Umwandlung von Vorzugsaktienzertifikaten in einhundertvierzehn Millionen zweihundertvierundsieb-
zigtausend zweihundert (114.247.200) Aktien mit einem Nennwert von fünf Euro (EUR 5), siebenundfünfzig Millionen
einhundertdreiundzwanzigtausendsechshundert Euro (EUR 57.123.600) zur Umwandlung von Vorzugsaktienzertifikaten
in elf Millionen vierhundertvierundzwanzigtausend siebenhundertzwanzig (11.424.720) Aktien mit einem Nennwert von
fünf Euro (EUR 5) und fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) zur Ausgabe von zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nenn-
wert von fünf Euro (EUR 5).

Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung, ist der Geschäftsführer der Gesellschaft

ermächtigt Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft zu erteilen, zugunsten solcher
Personen und zu solchen Bedingungen wie dies der Geschäftsführer für geeignet hält. (Der Geschäftsführer ist in diesem
Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrech-
te einzuräumen.)

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluß der Hauptversammlung

der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt wer-
den.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Art. 7. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses
Register festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Ein-
tragung im Register bestätigen und von dem Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen

diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.

Um jeden Zeifel auszuschliessen und ungeachtet entgegenstehender Bestimmungen sollen Bruchteile Aktien (auf Basis

des Bruchteils) die gleichen Rechte wie ganze Aktien haben, wobei jedoch Bruchteile von Aktien nur dann Stimmrechte
verleihen sollen, wenn die entsprechende Anzahl von Bruchteilsaktien zusammengerechnet eine oder mehrere ganze
Aktien ergeben und wenn solche Bruchteile zusammengezogen keinen ganzen GP-Anteil und SCA-Wertpapiere sollen
solche Bruchteile kein Stimmrecht haben.

Die Gesellschaft ist dazu berechtigt ihre gezeichneten und voll eingezahlten Aktien in Übereinstimmung mit Artikel

49-8 des Gesetzes über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, pro rata einzuziehen, wobei dieser Erwerb nur aus aus-
schüttbaren Reserven, einschliesslich der ausserordentlichen Reserve, die aus von der Gesellschaft im Zuge der Ausgabe
von Aktien oder aus der Ausgabe von Aktien im Zusammenhang mit der Absicht der Einziehung von Aktien stammen
und vorausgesetzt, dass hierdurch das Kapital nicht unter das gesetzliche Mindestkapital fällt. Die eingezogenen Aktien
verleihen keine Stimmrechte und keine Ansprüche auf Dividenden oder Liquiditationserlöse. Der Einziehungspreis der
eingezogenen Aktien berechnet sich auf der Basis des Nettovermögens der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit
den folgenden Bestimmungen. Der Einziehungspreis der Aktien, die die Gesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 49-
8 des Gesetzes über Handelsgesellschaften einzieht entspricht dem Nettowert pro Aktie, so wie dieser Wert von dem
GP-Verwaltungsrat am Tage der Bewertung, der der Tag sein soll an dem der GP-Verwaltungsrat beschliesst die Aktien
in Übereinstimmung mit den unten angeführten Bestimmungen einzuziehen, festgestzt wird. Der Nettowert pro Aktie
soll pro Aktie berechnet werden und soll unter Berücksichtigung des Nettovermögens der Gesellschaft berechnet wer-
den, bestehend aus dem Wert der Aktiva der Gesellschaft abzüglich der Verbindlichkeiten am Ende des Geschäftstages
an dem Tag, an dem die auf «As-Converted-Basis» Aktien in Übereinstimmung mit den hier angeführten Bewertungs-
regeln oder, soweit von keine hier angeführten Bewertungsregeln einschlägig sind, dem GP-Verwaltungsrat, als fair und
angemessen erachtet werden. Sämtliche dieser Bewertungsregeln müssen allgemein anerkannten Buchführungsregeln
entsprechen. Mit Ausnahme von Arglist, grober Fahrlässigkeit oder offensichtlichem Irrtum seitens des GP-Verwaltungs-
rates im Hinblick auf dessen Berechnung des Einziehungspreises soll dieser endgültig und bindend für die Gesellschaft
sowie ihre gegenwärtigen, früheren und zukünftigen Aktionäre sein.

Art. 8. Übertragung von Wertpapieren
(a) Voraussetzungen für die Übertragung von Wertpapieren.
Vor dem Qualifizierten Öffentlichen Verkauf auf dem Niveau der SCA darf kein Wertpapierinhaber seine Wertpa-

piere (oder jedwedes Nießbrauchsrecht an denselben) ohne vorherige schriftliche Zustimmung der GP direkt oder in-
direkt zugunsten jedweder Person verkaufen, übertragen, abtreten, verpfänden, mit einer Hypothek belasten oder
anderweitig veräußern (eine «Übertragung»), sofern dies nicht im Rahmen einer Transaktion entsprechend Artikel 10
oder im Rahmen eines Verkaufs der Geschäftstätigkeit oder einer Unabhängigen Umstrukturierung geschieht. Sofern
die vorherige schriftliche Zustimmung der GP nicht eingeholt wurde oder die Einhaltung der in Artikel 8(a) dargelegten
Bedingungen in Bezug auf eine gegebene Übertragung nicht gewährleistet werden kann, ist die GP berechtigt, die Regi-
strierung der entsprechenden beabsichtigten Übertragung zu verhindern, und ist jedwede entsprechende angebliche
Übertragung ab initio nichtig und wird nicht von der GP berücksichtigt.

(b) Gleichzeitige Übertragung der GP-Anteile und SCA-Wertpapiere.

61137

Außer in dem Fall, dass in der Satzung oder den Bedingungen ausdrücklich etwas Anderweitiges vorgesehen ist, über-

trägt kein Wertpapierinhaber irgendwelche GP-Anteile gemäß diesem Artikel 8, ohne gleichzeitig derselben Person im
Rahmen derselben Transaktion und im gleichen anteiligen Umfang (bzw. in einem Umfang, der dem gleichen anteiligen
Umfang so nahe wie möglich kommt, falls der gleiche anteilige Umfang nicht übertragen werden kann) jeden Typ und
jede Klasse von SCA-Wertpapieren, die Teil desselben Wertpapier-Strips sind (wobei beabsichtigt ist, dass die GP-An-
teile aufgrund dieses Satzes soweit wie möglich an den SCA-Anteil und die CPECs im selben Wertpapier-Strip «ange-
heftet» werden) zu Übertragen.

(c) Übertragungen in Verletzung der Satzung.
Jedwede Übertragung oder versuchte Übertragung von Wertpapieren in Verletzung einer Bestimmung der Satzung

ist ab initio nichtig und wird nicht von der GP berücksichtigt, und diese lässt die entsprechende angebliche Übertragung
weder in Kraft treten, noch trägt sie diese angebliche Übertragung in ihrem Anteilsregister ein oder behandelt einen
angeblichen Übernehmenden dieser Wertpapiere zu gleich welchem Zweck im Rahmen dieses Dokumentes als Eigen-
tümer dieser Wertpapiere.

Art. 9. Mitnahmerechte
(a) Anwendung der Mitnahmerechte.
Die Parteien vereinbaren, dass in dem Fall, dass ein Wertpapierinhaber, der zusammen mit seinen Verbundenen Un-

ternehmen bzw. Gemeinsam handelnden Parteien mehr als 50% der SCA-Anteile auf «As-Converted-Basis» hält, mehr
als 5% der SCA-Anteile gegen Entgelt im Rahmen einer oder einer Reihe verbundener Transaktionen auf «As-Conver-
ted-Basis» zu verkaufen oder anderweitig zu veräußern wünscht (und dies nicht im Zusammenhang mit oder im An-
schluss an eine Zulassung zum Öffentlichen Handel oder in Verbindung mit einem Mitverkauf geschieht und nicht an ein
Verbundenes Unternehmen, eine Gemeinsam handelnde Partei oder ein Verbundenes Unternehmen der Gemeinsam
handelnden Partei erfolgt) (ein «Mitnahme-Verkauf»), dies dem bzw. den entsprechenden Wertpapierinhaber bzw.
Wertpapierinhabern ausschließlich im Einklang mit diesem Artikel 9 gestattet ist.

(b) Zustellung der Mitnahme-Mitteilung.
In dem Fall, dass ein Wertpapierinhaber einen Mitnahme-Verkauf durchführen möchte, sendet der Inhaber, der den

Verkauf oder die Veräußerung gegen Entgelt vorschlägt (der «Verkaufende Wertpapierinhaber»), gemäß Artikel 9(a) vor
dem Abschluss eines entsprechenden Mitnahme-Verkaufs eine schriftliche Mitteilung (eine «Mitnahme-Mitteilung») an
die GP und die SCA und stellt die GP die entsprechende Mitteilung innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt derselben
jedem sonstigen Wertpapierinhaber (jeweils ein «Potenzieller Mitnahme-Verkäufer») zur Verfügung. Die Mitnahme-Mit-
teilung legt angemessen detailliert Folgendes offen: die voraussichtliche Art und Anzahl der durch den vorgeschlagenen
Übernehmenden (der «Vorgeschlagene Übernehmende») zu erwerbenden Wertpapiere sowie in Bezug auf die jeweilige
voraussichtlich zu erwerbende Wertpapierart den Prozentsatz der Gesamtanzahl der umlaufenden Wertpapiere dieser
Art auf «As-Converted-Basis», bezüglich derer vorgeschlagen wird, dass sie durch den Verkaufenden Wertpapierinha-
ber im Rahmen des Mitnahme-Verkaufs übertragen werden (der «Relevante Prozentsatz»), die vorgeschlagene für die
übertragenen Wertpapiere des Geplanten Verkaufs anzubietende Gesamtgegenleistung und den Preis für die jeweilige
zu übertragende Wertpapierart des Geplanten Verkaufs, die übrigen wesentlichen Bedingungen der vorgeschlagenen
Übertragung, eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten und Ausgaben, die im Rahmen des Abschlusses des Mitnah-
me-Verkaufs entstehen werden, und die Identität bzw. die Identitäten des bzw. der potenziellen oder voraussichtlichen
Übernehmenden; dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Mitnahme-Mitteilung vorsehen muss, dass jeder Poten-
zielle Mitnahme-Verkäufer nur durch Verkäufe der gleichen Art des Wertpapier-Strips wie der Verkaufende Wertpa-
pierinhaber am Mitnahme-Verkauf teilnehmen darf, sowie ferner unter der Voraussetzung, dass sämtliche
Wertpapierinhaber in Verbindung mit jedwedem Mitnahme-Verkauf pro Wertpapier, auf einer «As-Converted-Basis»,
eine Gegenleistung gleichen Umfangs und gleicher Form erhalten.

(c) Beteiligungsentscheidung.
Jeder der Potenziellen Mitnahme-Verkäufer kann wählen, die Art und Anzahl von Wertpapieren des Geplanten Ver-

kaufs gemäß nachstehenden Anführungen zu dem Preis und den Bedingungen zu verkaufen, die für den entsprechenden
Potenziellen Mitnahme-Verkäufer nicht ungünstiger sind als die in der Mitnahme-Mitteilung angeführten, und zwar durch
schnellstmögliche Zustellung einer schriftlichen Mitteilung über diese Wahl an den Verkaufenden Wertpapierinhaber,
die SCA und die GP, spätestens jedoch am zehnten Werktag nach dem Datum des Versands der Mitnahme-Mitteilung
durch die GP an den entsprechenden Potenziellen Mitnahme-Verkäufer (der «Mitnahme-Wahlzeitraum»). Zur Vermei-
dung von Missverständnissen sei erwähnt, dass jeder Potenzielle Mitnahme-Verkäufer, der bis zum Ende des Mitnahme-
Wahlzeitraum keine schriftliche Mitteilung getätigt hat, die Gelegenheit zur Beteiligung verwirkt, die wiederum an den
Verkaufenden Wertpapierinhaber zurückfällt. Jeder Potenzielle Mitnahme-Verkäufer kann wählen, (i) in dem Fall, dass
die vorgeschlagene Übertragung die Übertragung sämtlicher im Besitz der Wertpapierinhaber befindlichen Wertpapiere
beinhaltet, sämtliche im Besitz jedes anderen Wertpapierinhabers befindlichen Wertpapiere zu verkaufen; oder (ii) in
dem Fall, dass die vorgeschlagene Übertragung die Übertragung nicht aller im Besitz dieser Wertpapierinhaber befind-
lichen Wertpapiere beinhaltet, einen Anteil bis zum Relevanten Prozentsatz der im Besitz jedes anderen Wertpapierin-
habers befindlichen Wertpapiere zu verkaufen. Sollte sich aus der Anzahl der Wertpapiere, die zur Übertragung durch
den Verkaufenden Wertpapierinhaber vorgeschlagen werden, zusammen mit denjenigen anderen Wertpapieren, zu de-
ren Übertragung Potenzielle Mitnahme-Verkäufer gemäß Satz (i) oder (ii) berechtigt wären, im Fall der Übertragung er-
geben, dass der vorgeschlagene Übernehmende seinen Besitz an Wertpapieren der Gruppe oder jedwedem Mitglied
der Gruppe über den Prozentsatz, den er erwerben möchte hinaus erhöhen würde, so wird die Anzahl der durch den
Verkaufenden Wertpapierinhaber und den jeweiligen Potenziellen Mitnahme-Verkäufer zu übertragenden Wertpapiere
anteilig reduziert, um Übertragungen zu erhalten, die in ihrer Gesamtheit dazu führen, dass der vorgeschlagene Über-
nehmende die gewünschten, durch diesen Übernehmenden spezifizierten Prozentanteile erhält; dies jedoch unter der

61138

Voraussetzung, dass jeder Potenzielle Mitnahme-Verkäufer nur durch Verkäufe des gleichen Wertpapier-Strips wie der
Verkaufende Wertpapierinhaber am Mitnahme-Verkauf teilnehmen darf.

(d) Übertragung von Wertpapieren.
Entscheidet sich ein Potenzieller Mitnahme-Verkäufer gemäß Artikel 9(c) zum Verkauf (jeder Potenzielle Mitnahme-

Verkäufer, der dies wählt, wird als «Mitnahme-Verkäufer» bezeichnet), so wird die Übertragung der entsprechenden
Wertpapiere vom Mitnahme-Verkäufer gleichzeitig mit dem Verkauf durch den Verkaufenden Wertpapierinhaber zu
den in der Mitnahme-Mitteilung spezifizierten Bedingungen durchgeführt. Der GP-Verwaltungsrat führt die Berechnun-
gen und anteilsmäßigen Aufteilungen hinsichtlich der Anzahl und Art der durch den Verkaufenden Wertpapierinhaber
und die Mitnahme-Verkäufer zu übertragenden Wertpapiere und des an diese zu zahlenden Preises übereinstimmend
mit den in Artikel 9(c) und dem unmittelbar vorhergehenden Satz dargelegten Bestimmungen durch, wobei es ihm er-
laubt ist, zum nächsten ganzen Wertpapier runden. Jedwede entsprechenden Berechnungen und anteilsmäßigen Auftei-
lungen seitens des GP-Verwaltungsrates, die in gutem Glauben erstellt wurden, sind endgültig und bindend, und die
Wertpapierinhaber können keinerlei Behauptung vorbringen, die beinhalten, dass entsprechende Berechnungen oder
anteilsmäßige Aufteilungen oder ein entsprechender Mitnahme-Verkauf nichtig oder anfechtbar wären. Beteiligt sich
kein Mitnahme-Verkäufer an einem Mitnahme-Verkauf, so kann der Verkaufende Wertpapierinhaber die entsprechen-
den Wertpapiere des Geplanten Verkaufs innerhalb von 60 Werktagen (vorbehaltlich einer Gesetzlichen Verlängerung)
nach Ablauf des Mitnahme-Wahlzeitraums an den bzw. die vorgeschlagenen Übernehmenden zu den sonstigen in der
Mitnahme-Mitteilung angeführten Bedingungen übertragen. Jedwede innerhalb dieses Zeitraums nicht übertragenen
Wertpapiere des Geplanten Verkaufs unterliegen, zur Vermeidung von Missverständnissen, in Verbindung mit jedweder
späteren Übertragung erneut diesem Artikel 9. Soweit in der Mitnahme-Mitteilung angegeben, ist ein Mitnahme-Verkäu-
fer möglicherweise verpflichtet, unter Wahrung einer angemessenen Frist vor der Durchführung der Übertragung, um
die entsprechende Durchführung effektiver zu erleichtern, sämtliche in Verbindung mit seinem Mitnahme-Verkauf er-
forderlichen Elemente (in Verbindung mit der Zustellung der Antwortmitteilung des entsprechenden Mitnahme-Verkäu-
fers oder anderweitig) zur Verfügung zu stellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf eine Vollmacht für die GP,
die SCA oder den Verkaufenden Wertpapierinhaber zur Lieferung von Wertpapieren oder zum Eingehen jedweder Ver-
einbarung, jedwedes Instruments oder jedweder Zusicherung oder Verpflichtung.

Art. 10. Mitverkauf
a) Mitverkauf.
Erklärt sich einer oder mehrere Wertpapierinhaber schriftlich bereit, direkt oder indirekt die GP-Anteile, SCA-An-

teile oder CPEC dieses Inhabers (die u.a. die Form einer Fusion, einer Konsolidierung, einer Umstrukturierung, eines
Verkaufs oder Tauschs annehmen können) an jedwede Person zu übertragen, die bei Abschluss dieser Übertragung, di-
rekt oder indirekt, bzw. wenn bei einer jedweden Übertragung eine Person mindestens über die Mehrheit der umlau-
fenden SCA-Anteile auf einer «As-Converted-Basis» verfügt oder diese hält (oder über schriftliche
Übertragungsvereinbarungen verfügt, diese gemeinsam zu halten), und der voraussichtliche Übernehmende sich bereit
erklärt, ein verbindliches schriftliches Angebot zu unterbreiten (in dem die Bedingungen festgelegt sind), einige oder alle
der übrigen GP-Anteile und/oder SCA-Wertpapiere zu erwerben (ein «Mitverkauf»), kann/können der/die Wertpapie-
rinhaber, der/die den Mitverkauf initiiert/initiieren, nach seinem/ihrem Ermessen von den anderen Inhabern der GP-An-
teile und/oder SCA Wertpapiere fordern, die GP-Anteile und/oder SCA-Wertpapiere, die zu diesem Zeitpunkt durch
jeden anderen Inhaber dieser Wertpapiere gehalten werden, an diesen voraussichtlichen Übernehmenden zu Übertra-
gen.

(i) In dem Fall, dass eine Person einen Mitverkauf durchzuführen wünscht, lässt die entsprechende Person der GP und

der SCA eine schriftliche Mitteilung (eine «Mitverkaufsmitteilung») zukommen, die hinreichende Beweise dafür enthält,
dass die entsprechende beabsichtigte Transaktion die Voraussetzungen für einen Mitverkauf gemäß dem vorliegenden
Dokument erfüllt. Innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt einer Mitverkaufsmitteilung lassen die GP und die SCA
allen Inhabern von GP-Anteilen und SCA-Anteilen, mit Ausnahme des Wertpapierinhabers oder der Wertpapierinha-
ber, die den Mitverkauf initiiert haben, die Mitverkaufsmitteilung zukommen. Die Mitverkaufsmitteilung legt angemessen
detailliert Folgendes offen: die vorgeschlagene Art und Anzahl der durch den Übernehmenden zu erwerbenden Wert-
papiere, die vorgeschlagene Form und den vorgeschlagenen Umfang der für die übertragenen Wertpapiere anzubieten-
den Gegenleistung und die Form und den Umfang der für die jeweilige zu übertragende Wertpapierart anzubietenden
Gegenleistung (auf «As-Converted-Basis»), die Identität des potenziellen Käufers, die übrigen wesentlichen Bedingungen
des vorgeschlagenen Mitverkaufs sowie eine Schätzung der übrigen voraussichtlichen Kosten und Ausgaben, die im Rah-
men des Abschlusses des Mitverkaufs entstehen werden. Ein Mitverkauf kann Grundlage für die Entbündelung der SCA-
Wertpapiere von den GP-Anteilen in den Wertpapier-Strips sein, nicht aber für die Loslösung der SCA-Anteile von den
CPECs (es sei denn, der Partner für Steuerangelegenheiten genehmigt etwas Anderweitiges). Im entsprechenden Fall
wird der GP-Verwaltungsrat jedwede Änderungen der verbleibenden Wertpapiere innerhalb des Wertpapier-Strips
vorschreiben, die er für notwendig oder angemessen hält.

(b) Gegenleistung.
Die Form und der Wert der Gegenleistung pro GP-Anteil entspricht der an die/den Wertpapierinhaber gezahlten

Gegenleistung, der/die den Mitverkauf in Bezug auf diese Wertpapiere initiiert hat/haben. Falls der voraussichtlich Über-
nehmende an dem Mitverkauf ein Verbundenes Unternehmen oder Gemeinsam handelnde Parteien des den Mitverkauf
initiierenden ist soll der Mitverkauf selber nicht zur Erlangung eines Status als Gemeinsam handelnde Partei beitragen,
(x) die Gegenleistung pro SCA-Anteil auf einer «As-Converted-Basis», nicht niedriger als der höchste Preis pro GP-
Anteil, der durch diesen voraussichtlichen Übernehmenden oder seine Verbundenen Unternehmen oder Gemeinsam
handelnden Parteien pro GP-Anteil innerhalb der 180 Tage gezahlt wurde, die der Zustellung der Mitverkaufsmitteilung
unmittelbar vorausgehen, und (y) der/die Wertpapierinhaber, der/die den Mitverkauf initiiert hat/haben, wird/werden
dem GP-Verwaltungsrat ein Gutachten von einer international anerkannten, unabhängigen Investmentbankfirma bezüg-

61139

lich der Angemessenheit, aus finanzieller Sicht, der durch die Inhaber der GP-Anteile in diesem Mitverkauf zu erhaltenen
Gegenleistung vorlegen.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 11. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer oder den Aufsichtsrat einberufen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberu-

fen werden.

Art. 12. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils 15. Juni eines jeden Jahres oder, wenn die-
ser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an
den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den

gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestim-
mungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-

simileübertragung oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden nur mit Einstimmigkeit
der anwesenden und vertretenen Stimmen gefaßt.

Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-

nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch OAKBROOK S.A. in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Geschäftsführer

der Gesellschaft verwaltet. Die anderen Aktionäre dürfen an dieser Verwaltung der Gesellschaft weder teilnehmen noch
sich darin einmischen.

Art. 14. Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Geschäftsführer hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre oder
dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Art. 15. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Vertreters des

Geschäftsführers oder durch die Unterschrift jeder vom Geschäftsführer für spezifische Rechtsgeschäfte bevollmächtig-
ten Person(en) verpflichtet.

Art. 16. Im Falle einer rechtlichen Geschäftsunfähigkeit, einer Liquidation, oder einer anderen endgültigen Lage wel-

che den Geschäftsführer verhindert als Geschäftsführer der Gesellschaft zu fungieren, wird die Gesellschaft nicht un-
mittelbar aufgelöst und liquidiert, sofern der Aufsichtsrat einen Verwalter ernennt, welcher nicht Aktionär sein muss,
damit dieser die dringende Geschäftsführung übernimmt, bis eine Hauptversammlung der Aktionäre stattgefunden hat,
die der Verwalter innerhalb von fünfzehn Tagen nach seiner Ernennung, einberuft. Auf dieser Hauptversammlung kön-
nen die Aktionäre, den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen folgend, einen Nachfolger des Ge-
schäftsführers ernennen. Sollte diese Ernennung nicht geschehen, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.

Art. 17. Die Ernennung des Nachfolger des Geschäftsführers benötigt nicht die Zusage des Geschäftsführers.

E. Aufsichtsrat

Art. 18. Die Geschäfte sowie die finanzielle Situation der Gesellschaft, insbesondere ihre Bilanzen und Konten, un-

terliegen der Überwachung des Aufsichtsrats, der aus mindestens drei Mitglieder besteht, die nicht Aktionäre der Ge-
sellschaft sein müssen. Der Aufsichtsrat hat für seine Überwachungsfunktion die in Artikel 62 des Gesetzes des 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehenen Befugnisse eines Rechnungs-
prüfers.

Art. 19. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wählt den Aufsichtsrat für ein Jahr. Die Mitglieder des Auf-

sichtsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden und können jederzeit und unbegründet durch Beschluß
der Hauptversammlung abberufen werden.

Art. 20. Sollte die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates unter drei oder unter die Hälfte der von der Hauptver-

sammlung bestimmten Zahl der Mitglieder fallen, wird durch den Geschäftsführer sofort eine Hauptversammlung ein-
berufen, um die leerstehenden Stellen zu besetzen. Ist ein oder sind mehrere Mitglieder des Aufsichtsrates
vorübergehend unfähig an dessen Versammlungen teilzunehmen, können die restlichen Mitglieder einen oder mehrere
Aktionäre ernennen, um diese bis zur Wiederaufnahme zu ersetzen.

Art. 21. Der Aufsichtsrat kommt an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort innerhalb Luxemburgs zu-

sammen. Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär be-
stellen, welcher nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des
Aufsichtsrates verantwortlich ist.

61140

Der Aufsichtsrat wird von seinen Vorsitzenden oder von dem Geschäftsführer einberufen. Der Aufsichtsrat muss auf

Anfrage einer seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Aufsichtsrates; in seiner Abwesenheit kann der Aufsichtsrat mit

Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig
zu führen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält wenigstens acht Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Fak-

simileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungsschreiben, außer im
Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben an-
gegeben werden müssen. Das Einberufungsschreiben enthält den Ort und die Tagesordnung der Sitzung. Auf schriftliche,
durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene
Einwilligung eines jeden Mitglieds der Aufsichtsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein speziel-
les Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Aufsichtsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort
abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Aufsichtsrates auf dem Kalender festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder

durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des
Aufsichtsrats vertreten lassen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats kann mehrere andere Mitglieder vertreten.

Der Aufsichtsrat ist nut beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten

sind. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Protokollen festgehalten und von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Ver-

tretungsvollmächte werden an dieser angeheftet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder ander-
weitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern unterzeichnet.

Einstimmige Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch durch Rundschreiben gefasst werden, wobeieine Kopie aus-

reichend um zu belegen, dass der Beschluss angenommen wurde. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll,
das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommu-

nikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Die Mitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche sie im Namen der Ge-

sellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft und sind daher aus-
schließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jedes Mitglied des Aufsichtsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Verwalter für

angemessene Kosten die im Zusammenhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen sei-
ner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind.

Das Mitglied hat kein Recht auf Entschädigung, wenn im Zusammenhang mit der Handlung, dem Prozess oder dem

Verfahren gerichtlich festgestellt wurde, dass es wegen Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung haftbar ist. Im
Falle eines Vergleiches wird Entschädigung nur in Bezug auf die im Vergleich einbegriffenen Angelegenheiten gezahlt, bei
denen die Gesellschaft von ihrem Rechtbeistand Bestätigung erhält, dass das betroffene Mitglied seine Pflichten nicht
verletzt hat. Das hiervor aufgeführte Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte die dem Mitglied zustehen sollten
nicht aus.

Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit

jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung
dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf
Entschädigung von der Gesellschaft besteht.

Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines Verfahrens durch ein Urteil, eine Anwei-

sung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Verteidigung, entsteht nicht die Vermutung, dass
die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart, durch den das Entschädigungsrecht entsteht,
nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Entschädigungsberechtigten machen, in gleicher
Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflichtungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer
Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt von den Informationen welche die Gesellschaft
vernünftigerweise fordern kann.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 22. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 23. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen

Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals
oder wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Geschäftsführers über die Verwendung des rest-

lichen Betrages des Reingewinns. Der Geschäftsführer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdivi-
denden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 24. Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen

oder mehrerer Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

61141

H. Satzungsänderung

Art. 25. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausge-

setzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften, wie abgeändert, werden beachtet.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 26. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915,

über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Partei-

en, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-

schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Signé: J.-M. Ueberecken, F. Stolz-Page, C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 83, case 3. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063695.3/230/1575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.200,-.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.859. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 28 juin 2005

L’Assemblée décide:
- de confirmer comme administrateurs de la société Messieurs Curt Le Van, René Kremer et Gilbert Wirtz, leur man-

dat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006. Ils ne sont pas rémunérés pour leur mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060052.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.859. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02707, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060016.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ExxonMobil LUXEMBOURG UK HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 97.995. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02677, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060034.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Pour copie conforme
R. Kremer

Leudelange, le 12 juillet 2005.

Signature.

Leudelange, le 12 juillet 2005.

Signature.

61142

THEKLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.113. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la

Guardia, N

°

 8, (République du Panama).

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social à Tortola,

Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques).

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à

Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de THEKLA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou so-

cial, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-
ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-

ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

61143

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3 mercredi du mois d’avril à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à concurrence d’un montant de vingt-quatre mille euros (24.000,- EUR),

de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. - La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aqui-

lino de la Guardia, N

°

 8, (République du Panama), quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . 15.499

2. - La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social

à Tortola, Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques), une action  . .

1

Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

61144

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Muller, expert-comptable, né à Luxembourg, le 21 août 1951, demeurant professionnellement à L-

1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

b) Madame Pascale Loewen, employée privée, née à Luxembourg, le 19 septembre 1965, demeurant professionnel-

lement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

c) Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5) Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2005, vol. 532, fol. 11, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060033.3/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

AVANZA IMMOBILIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 78.548. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02245, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13 juillet 2005.

(060050.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

KOM MKT LUX, KOMODITIS MKT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.495. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03258, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060166.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.460. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03894, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060079.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Junglinster, le 11 juillet 2005.

J. Seckler.

<i>Pour AVANZA IMMOBILIA, S.à r.l.
J. Reuter

Signature.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
Signatures

61145

INSTITUT MARY’ANNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 96.190. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03291, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060178.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

HOBELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.872. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est le 27 mai 2005 à 9.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs: 
Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A.
L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes: 
Monsieur Pierre Schill,
pour une période qui viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre

2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04125. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060186.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SUNOTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.231. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 3 mars 2005

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Ber-

nard Ewen, Madame Joëlle Lietz et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC. et le mandat de Commissaire aux
Comptes de Monsieur Pierre Schill pour une période de un an.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au

31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060204.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.965. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04431, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

(060264.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signatures.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

61146

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «M» HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.525. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 juin 2005 à 15 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Madame Marleen

Dhont et Monsieur Koen Lozie, Administrateur.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Noël Didier en tant que commis-

saire aux comptes.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060188.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ODAGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.715. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 12 mai 2005 à 14.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs

Koen Lozie et Jean Quintus et de la société COSAFIN S.A. et le mandat de Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sta-

tuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060197.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

B.F.B., BOIS ET FORETS DU BRABANT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.723. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 18 mai 2005 à 11.30 heures

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs:
* Madame Denise Vervaet,
* Monsieur Bernard Ewen,
* LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC.,
et du Commissaire aux Comptes:
* Monsieur Pierre Schill,
pour une période qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes

annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060213.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

61147

HORFUT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.953. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 22 avril 2005 à 11.30 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN

S.A., Administrateurs.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de:
V.O. CONSULTING LUX S.A., 8, route Haute, L-4963 Clemency.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060210.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOPARAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 40.317. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03723, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060215.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOPARAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 40.317. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG03727, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060220.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

QUILVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 36.012. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04969, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060297.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EURAFRICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.

R. C. Luxembourg B 48.456. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04952, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060316.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

61148

PRISPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.196. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03884, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060282.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EREMIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 4.664. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03883, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060284.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

KSM PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 94.138. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03882, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060285.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 69.054. 

Le bilan au 31 décembre 2004 a été enregistré le 11 juillet 2005 à I’Administration de I’Enregistrement, réf. LSO-

BG04438, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(060424.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 69.054. 

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2005 et ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire

des actionnaires qui se tiendra en 2006, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme suit:

- Mario Seris, Zurich, Président;
- Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président;
- Luca Diener, Zurich;
- Ian Chimes, Londres;
- Donald B. Rice, Luxembourg;
- Germain Trichies, Luxembourg.

PRISPA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

EREMIS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

KSM PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
S. Best / D. Breger

61149

<i>Réviseur d’entreprises 

KPMG AUDIT, LUXEMBOURG a été réélue comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée

générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060423.3/736/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.727. 

Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 24 juin 2005, Monsieur Glenn Wellman

a été nommé comme nouveau Membre du Conseil d’Administration, avec effet immédiat. 

Par conséquent, le Conseil d’Administration se présente comme suit : 
- Mario Seris, Zurich, Président;
- Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président;
- Lawrence Haber, New York;
- Glenn Wellman, Londres;
- Karl Huwyler, Zurich; 
- Bernard Wester, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04467. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060421.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MONOROSA HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.718. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03881, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060286.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

TORRIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.839. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03880, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060288.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
S. Best / D. Breger

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
S. Best / D. Breger

MONOROSA HOLDINGS LTD
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

TORRIDE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

61150

EUROPEAN PAPER GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 7.254. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060290.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

COVEA RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.590. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02769, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060306.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

FINANCE TECHNOLOGY SYSTEMS «FITECH SYSTEMS» S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1160 Bruxelles, 1, rue Charles Lemaire.

Succursale: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.388. 

RECTIFICATIF

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 mai 2005

Sont présents ou représentés:
- Monsieur Gautier Bataille de Longprey, Administrateur,
- Madame Anne Winckelmans de Cléty, Administrateur,
- Monsieur Alexis Meeus, Administrateur,
- Madame Anne Fievez, Administrateur.
La séance est ouverte à 12.30 heures, au siège social de la BANQUE DEGROOF, sous la présidence de Madame Anne

Winckelmans de Cléty.

L’ordre du jour comporte les points suivants:
1. Cessation des activités des succursales de Luxembourg, Genève et Londres,
2. Transfert du siège social de la société,
3. Dissolution du comité de direction de la société, 
4. Divers.

1. Cessation des activités des succursales de Luxembourg, Genève et Londres
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité la cessation des activités, dans les meilleurs délais, de ses succursales

à l’étranger, à savoir:

- FINANCE TECHNOLOGY SYSTEMS SUCCURSALE LUXEMBOURGEOISE S.A., route d’Esch 44, LU-1470

Luxembourg;

- FINANCE TECHNOLOGY SYSTEMS S.A., Bruxelles, succursale Genève, Logiciels Informatiques, 19, rue du Rhône

- 1204 Genève, Suisse; 

- FINANCE TECHNOLOGY LONDON, 78 Cannon Street, London EC4N 6NQ, Great Britain.

2. Transfert du siège social de la société
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de transférer, avec effet immédiat, le siège social de FITECH SYS-

TEMS vers le 18, rue Guimard à 1040 Bruxelles.

3. Dissolution du comité de direction de la société 
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de dissoudre, avec effet immédiat, le comité de direction, actuelle-

ment composé des personnes suivantes: Messieurs Michel Renckens, Luc Dekyndt et Mesdames Nicole Sibille ainsi que
Claudia Laeremans.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13.00 h.

EUROPEAN PAPER GROUP, S.à r.l.
K. Prestien / R. Kuhs
<i>Gérant / <i>Gérant

<i>Pour la société <i>COVEA RE
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61151

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02481. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060376.3/034/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.630. 

Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 25 mai 2005, Monsieur Glenn Wellman

a été nommé comme nouveau Membre du Conseil d’Administration, avec effet immédiat.

Par conséquent, le Conseil d’Administration se présente comme suit:
- Mario Seris, Zurich, Président;
- Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président;
- Lawrence Haber, New York;
- Karl Huwyler, Zurich;
- Glenn Wellman, Londres;
- Bernard Wester, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060417.3/736/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MODERN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 34.097. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02773, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060310.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 77.606. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04954, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060319.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

TOPDANMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.382. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00589, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060363.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

<i>Le Conseil
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
S. Best / D. Breger

<i>Pour la société <i>MODERN RE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

 

Signature.

61152

SVENSKA RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 32.053. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02779, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060318.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BALSPEED RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 34.186. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02782, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060320.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

AUDIO CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 6A, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.143. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02919, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060327.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BMS BUILDING MAINTENANCE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 89.610. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02905, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060329.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

<i>Pour la société <i>SVENSKA RE
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société <i>BALSPEED RE
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Stamer Holding S.A.

Stamer Holding S.A.

Stamer Holding S.A.

Stamer Holding S.A.

Mawashi Geri S.A.

Formica Luxembourg Holding, S.à r.l.

Le Cordon Bleu International, S.à r.l.

Yak, S.à r.l.

Yak, S.à r.l.

International Masters Publishers Nihon, S.à r.l.

A.I.S., Architectes Ingénieurs Services, S.à r.l.

Noble Equities Trust Financial Holdings S.A.

Noble Equities Trust Financial Holdings S.A.

Lux Euro-Asian Investments I, S.à r.l.

Mouwannes, S.à r.l.

Ristorante C.N.M., S.à r.l.

BW &amp; Partner, GmbH

Lux Euro-Asian Investments II, S.à r.l.

Noble Equities Trust S.A.

Noble Equities Trust S.A.

Noble Equities Trust - Asset &amp; Investment Management S.A.

Noble Equities Trust - Asset &amp; Investment Management S.A.

Noble Equities Trust Securities S.A.

Noble Equities Trust Securities S.A.

Mains d’Or, S.à r.l.

Le Chiringuito, S.à r.l.

A la Petite Marmite, S.à r.l.

Dijou-Zune, S.à r.l.

Cofinatrans S.A.

Indus-Net S.A.

Faja S.A.

Citeg S.A.

Bonaria Frères S.A.

Bonaria Frères S.A.

Lansan S.A.

Globus Real Estate Invest S.A.

Smile Invest Holding S.A.

Bodycontrol, S.à r.l.

Bodycontrol, S.à r.l.

International Locations S.A.

Decatec S.A.

Moewe Holding S.A.

Teddy-House, S.à r.l.

Basic Invest Holding S.A.

Locapress S.A.

Nippon Capital TMK Investments, S.à r.l.

LSFAP Euro-Asian Holding, S.à r.l.

Exxonmobil Luxembourg

Exxonmobil Luxembourg

LSFAP Indonesian Investments, S.à r.l.

Special Risk Insurance of Reinsurance Luxembourg S.A.

ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l.

ExxonMobil Luxembourg International Finance 1, S.à r.l.

ExxonMobil Asia International, S.à r.l.

Westchester S.C.A.

Exxonmobil Luxembourg UK

Exxonmobil Luxembourg UK

ExxonMobil Luxembourg UK Holdings

Thekla Holding S.A.

Avanza Immobilia, S.à r.l.

KOM MKT LUX, Komoditis MKT Luxembourg S.A.

UNICO Asset Management S.A.

Institut Mary’Anna, S.à r.l.

Hobell S.A.

Sunotel S.A.

SOFITRA S.A., Société de Financement pour les Transports

Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M» Holding S.A.

Odagon S.A.

B.F.B., Bois et Forêts du Brabant S.A.

Horfut S.A.

Soparad Holding S.A.

Soparad Holding S.A.

Quilvest Europe S.A.

Eurafrica S.A.

Prispa Holding S.A.

Eremis Holding S.A.

KSM Participations Mobilières et Immobilières S.A.

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Sicav

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Sicav

Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.

Monorosa Holdings LTD

Torride S.A.

European Paper Group, S.à r.l.

Covéa Re

Finance Technology Systems «Fitech Systems» S.A.

Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.

Modern Re S.A.

Société de Gestion Internationale, S.à r.l.

Topdanmark Holding S.A.

Svenska Re

Balspeed Re

Audio Concept, S.à r.l.

BMS Building Maintenance Service, S.à r.l.