logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

59809

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1247

22 novembre 2005

S O M M A I R E

2 Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59850

r.l., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59845

Agnès Constructions, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . .

59856

Infralux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59822

Ampersand S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

59856

International Wave Holding S.A., Strassen . . . . . . 

59855

Ashantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59852

Lisgo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59849

Auto-Boutique, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59810

Luxembourg Global Asset Management S.A.,  Lu- 

Bastion Limited Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . .

59811

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59822

Bastion Lux Participation, S.à r.l., Luxembourg . . .

59822

Marinelli Immobilière, S.à r.l., Helmsange. . . . . . . 

59846

(The) Bridge Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

59856

Masco Europe SCS, Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . 

59847

Bugs S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59855

MK Gestion & Participation S.A., Herborn . . . . . . 

59855

Charme Investments S.C.A., Luxembourg . . . . . . .

59836

Mulhouse Investissements S.A., Luxembourg . . . . 

59852

Citigroup International Luxembourg Limited,  S.à

Multiple Managers Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

59835

r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59853

Nabeul International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

59849

Citigroup Participation Luxembourg Limited,  S.à

Nakaispa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

59854

r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59854

Para Press S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

59844

Claymore Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

59846

Patris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59855

Compagnie de Réservations, Services et Investisse- 

Peralex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59856

ments Hôteliers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59849

Rally Lux Holding One, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

59849

Compagnie Financière Industrielle S.A., Luxem- 

Rally Lux Holding Two, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

59854

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59850

Reiss Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

59835

Ding International S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . .

59843

Salon Teresa, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59853

Docu Group (Lux 2), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

59832

San Bernardino International Holding S.A.,  Luxem- 

Docu Group (Lux 1), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

59841

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59811

Euroinvest (Poland 2), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

59832

Self Service Vivot, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . 

59853

Euroinvest (Poland 1), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

59846

Self Service Vivot, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . 

59853

Euroview Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

59849

Société d’Investissement des Douze S.A. (S.I.D.),

Financière Esch S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

59811

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59850

Financière Notre-Dame S.A., Luxembourg  . . . . . .

59851

Société de Participations Ricordeau S.A., Luxem- 

Finapol, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59842

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59821

Florida Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

59833

Soft Shoes S.A., Wassserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59853

Forsythia  Management  &  Engineering  (F.M.E.)  

Sogis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59845

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59850

Tetra Laval Finance & Treasury Luxembourg 

Franvest Investissements S.A., Luxembourg  . . . . .

59845

S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59836

Franvest Investissements S.A., Luxembourg  . . . . .

59846

Togo Luxe, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59855

Gaume  Secours  Luxembourg,  S.à r.l.,  Esch-sur-

Wardley Asia Pacific Investments Limited,  Sicav, 

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59850

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59852

Gaume  Secours  Luxembourg,  S.à r.l.,  Esch-sur-

West-El, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59821

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59851

Windpower S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

59851

IBM  Services  Financial  Sector  Luxembourg,  S.à 

59810

AUTO-BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 22.991. 

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AUTO-BOUTI-

QUE, S.à r.l. (en liquidation), ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, constituée suivant acte
reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 14 juin 1985, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 242 du 23 août 1985, modifiée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder,
alors de résidence à Mersch, en date du 26 février 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 343 du 8 août 1992, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Schroeder, en date du 23 octobre 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 228 du 1

er

 avril 1999, modifiée suivant acte reçu

par le notaire instrumentaire, en date du 16 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, nu-
méro 731 du 15 juillet 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B
et le numéro 22.991, au capital social de cent trente-six mille trois cent quarante-et-un virgule quarante-trois euros
(EUR 136.341,43).

L’assemblée est composée de:
1. TRIMLINE HOLDING S.A., société anonyme, avec siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume,
représentée par son président du conseil d’administration, Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à L-6140

Junglinster, 26, rue du Village;

2. INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social

à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Wickhams Cay I, Road Town,

ici représentée par Mademoiselle Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à F-57700 Saint Nicolas en Forêt,

7, rue de la Clairière,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 21 juin 2005,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, déclarent que suivant acte reçu par le notaire instru-

mentaire, en date du 16 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 731 du 15 juillet
2004, ladite société a été mise en liquidation et Monsieur Emile Wirtz, prénommé, a été nommé liquidateur; que suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 mai 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, le rapport du liquidateur a été approuvé et un commissaire-vérificateur a été nommé.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, déclarent être les seules associées de ladite société, se con-

sidérer comme dûment convoquées et délibérer valablement sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le rapport du commissaire-vérificateur, Monsieur Gérard Reis, fonctionnaire euro-

péen, demeurant à L-1870 Luxembourg, 24, Kohlenberg, lequel rapport, contenant les comptes de liquidation, paraphé
ne varietur, restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur de la société, Monsieur Emile Wirtz, prénom-

mé, et au commissaire-vérificateur, Monsieur Gérard Reis, prénommé.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans

à l’ancien siège de la société, que la liquidation de la société est close et que l’existence de la société à responsabilité
limitée AUTO-BOUTIQUE, S.à r.l. a cessé, tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et
inconnu à ce jour étant repris par les associées, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants des comparantes, connus du notaire par nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Wïrtz, C. Giovannacci, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 79, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(059461.3/227/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

E. Schlesser.

59811

FINANCIERE ESCH, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.224. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01600, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058477.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

SAN BERNARDINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.878. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG01384, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058579.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

BASTION LIMITED PARTNER, Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 3,487,650.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.158. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirtieth of June.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

BASTION LUX PARTICIPATION, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourgon 30 June 2005, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, not yet registered in
the Luxembourg company and commercial register,

represented by M

e

 Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg, 

by virtue of a proxy given on June 30, 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the

«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of BASTION LIMITED PARTNER, S.à r.l.

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the municipality of the City of Luxem-

bourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a

resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social

developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may tempo-
rarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tempo-
rary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

59812

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at three million four hundred eighty-seven

thousand six hundred fifty euro (EUR 3,487,650.-) divided into one hundred thirty-nine thousand five hundred six
(139,506) shares, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

The authorized capital of the Company is set at seventy million euro (EUR 70,000,000.-), divided into two million

eight hundred thousand (2,800,000) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share.

The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers is/are authorised and empowered, to (i) realise any

increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the
issuing of new shares with or without share premium, against payment in cash or in kind, following the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers under
the terms of share subscription warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments),
convertible preferred equity certificates, convertible notes or similar instruments issued from time to time by the Com-
pany, by conversion of claims or in any other manner; (ii) issue any rights in whatever form under the terms of share
subscription warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible pre-
ferred equity certificates, convertible notes or similar instruments entitling to the subscription of such shares; and (iii)
determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the sub-
scription of and paying up on the new shares.

This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the

resolutions taken by the Company’s sole shareholder on June 30, 2005 in the Mémorial C and it may be renewed by
the sole shareholder or, as the case may be, by a general meeting of shareholders.

The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may delegate to any duly authorized officer of the

Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares
representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the
legally required form by the the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers within the limits of the au-
thorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

59813

Chapter III. Manager(s), Board of Managers, Statutory auditors

Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers

which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and
who need not be shareholders (the «Manager(s)»).

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Manager(s) and one or

several Class B Manager(s).

Art. 10. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman

(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence
or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A Manager and one
Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such
meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in

case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Man-
ager(s) or of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature

of any single Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.

59814

However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one

or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A
Manager and one Class B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exer-

cises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August
10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by
the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obli-
gation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written
vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in

compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more
subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-

er(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of

Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual general meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on 31 Oktober at 3.30 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Manager.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial year. The Company’s financial year begins on the first day of August in every year and ends on

the last day of July.

Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than twenty-five shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

59815

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on

dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixe the amount and the date of payment of any such advance pay-
ment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law. 

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 39,500.- EUR.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of July 2005.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1. The sole shareholder resolved to set at four (4) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as Class A Managers for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year
ended 31 December 2005:

- Mr Robert Ian Kauffman, Financier, born on 22 October 1963 in New York (United States of America), residing at

39, via della Mercede, 00187 Rome (Italy); and

- Mr Jonathan Ashley, Financier, born on 28 February 1966 in New York (United States of America), residing at 21

Carlton Hill Road, London NW8 0JX (United Kingdom).

The sole shareholder further resolved to appoint the following as Class B Manager for a period ending at the date of

approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005:

- Mr Luc Hansen, chartered accountant, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

- Mr John Seil, chartered accountant, born on 28 September 1948 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

2. The registered office shall be at:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg). 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am 30. Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich (Großherzogtum Luxemburg).

Shareholder

Subscribed

Number

Amount

capital (EUR)

of shares

paid-in (EUR)

BASTION LIMITED PARTNER, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . .  3,487,650.- EUR

139,506

3,487,650.- EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,487,650.- EUR

139,506

3,487,650.- EUR

59816

Ist erschienen:

BASTION LUX PARTICIPATION, S.à r.l., eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht des Grossher-

zogstums Luxemburg am 30. Juni 2005 gegründet worden ist, mit Sitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
noch nicht im Luxemburger Handelsregister eingetragen,

vertreten durch M

e

 Sabine Hinz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 30. Juni 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung erstellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit durch den Alleingesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschafts-
vertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Die Gesellschaft zählt ursprünglich einen Alleingesellschafter, Eigentümer aller Geschäftsanteile. Die Gesellschaft

kann jedoch jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Geschäftsanteilen oder der Ausgabe neuer Geschäfts-
anteile, aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf.

Der Name der Gesellschaft ist BASTION LIMITED PARTNER, S.à r.l.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Ge-

schäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in

anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-

scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vor-
übergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu brin-
gen.

Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in

luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Be-
teiligungen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-

scheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, die gemäss den

Gesetzesbestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden. 

Kapitel II. Kapital, Geschäftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf drei Millionen vierhundertsiebenundachtzigtausend-

sechshundertfünfzig Euro (EUR 3.487.650,-) festgesetzt, eingeteilt in einhundertneununddreissigtausendfünfhundert-
sechs (139,506) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll eingezahlt.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt siebzig Millionen Euro (EUR 70.000.000,-), aufgeteilt in zwei Millionen

achthunderttausend (2.800.000) Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro
(EUR 25,-).

Der/die Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführungsrat ist/sind in den Grenzen des genehmigten Ka-

pitals dazu ermächtigt, (i) jede, eventuell auf einer Ausübung, gemäss den Bedingungen der ausgegebenen Zeichnungs-
optionen, Wandelvorzugszertifikate, Wandelanleihen, Schuldscheinen oder ähnlichen, von Zeit zu Zeit von der
Gesellschaft ausgebebenen Wertpapieren, der von ihm beziehungsweise ihnen, im Rahmen des genehmigten Kapitals,
gewährten Zeichnungs- und/oder Umwandlungsrechte (die entweder gesondert von den Geschäftsanteilen, Schuld-
scheinen oder anderen Wertpapieren oder diesen beigefügt ausgegeben wurden) beruhende Erhöhung des Gesell-
schaftskapitals vorzunehmen, und zwar in einer oder in mehreren Phasen durch die Ausgabe neuer Geschäftsanteile,
entweder mit oder ohne Emissionsaufgeld, gegen eine Geld- oder eine Sacheinlage, durch eine Umwandlung von An-
sprüchen gegenüber der Gesellschaft oder auf jede andere Weise; (ii) Rechte in jedweder Form gemäß den Geschäfts-

59817

bedingungen von Zeichnungsoptionen, Wandelvorzugszertifikaten, Wandelanleihen, Schuldscheinen (die entweder
gesondert von den Geschäftsanteilen, Schuldscheinen oder anderen Wertpapieren oder diesen beigefügt ausgegeben
wurden) zu gewähren, die die Zeichnung von Gesellschaftsanteilen gestatten; und (iii) den Ort und den Zeitpunkt der
Geschäftsanteilausgabe oder der aufeinander folgenden Geschäftsanteilausgaben, den Ausgabepreis, die Bedingungen
der Zeichnung und der Einzahlung der neuen Geschäftsanteile festzulegen.

Diese Ermächtigung gilt bis zum Ende eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung des Protokolls

der durch den Alleingesellschafter am 30. Juni 2005 getroffenen Beschlüsse im Mémorial C und kann durch einen Be-
schluss des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafterversammlung erneuert werden.

Der/die Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführungsrat kann/können jedem befugten Mitarbeiter der

Gesellschaft oder jeder anderen ordnungsgemäß ermächtigten Person die Aufgaben der Annahme der Zeichnung und
der Einzahlung der neuen Geschäftsanteile überlassen, die das erhöhte Kapital ganz oder teilweise vertreten. Nach jeder
Erhöhung des ausgegebenen Kapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form
durch den/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls den Geschäftsführungsrat, wird dieser Artikel dergestalt abgeän-
dert, dass er die vorgenommene Erhöhung wiedergibt.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Geschäftsanteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag
dieses Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Geschäftsanteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurück-
kauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter in Form von Dividenden oder
zur Bereitstellung der gesetzlichen Rückstellungen genutzt werden. 

Art. 6. Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Ver-

mögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum
eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. 
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen

gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft meh-

rere Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen
die Geschäftsanteile lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei
der drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.

Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen

Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder

mehrmals durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabge-
setzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorlie-
gendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden
Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird

weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das
den Alleingesellschafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Kapitel III. Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare

Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern,

die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden können (der «Geschäftsführungs-
rat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).

Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung, die deren

Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nach-
folger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder
der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Der Alleingesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung können beschließen, einen oder mehrere

Geschäftsführer der Kategorie A sowie einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.

Art. 10. Geschäftsführungsrat. Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen

Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Ge-
schäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der
Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist

einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen

den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt
sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum
zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

59818

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schrift-

licher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehe-
nen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über
Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche Zu-
stimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet wer-
den. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren
Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungs-

rat von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen

Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind. Sind Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B bestellt worden, so ist der
Geschäftsführungsrat nur dann beschlussfähig, wenn gleichzeitig mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer
sowie mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder ver-
treten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnli-

chen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig
miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleich-
wertig.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-

bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden,
wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden

und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-

legt werden, werden vom Vor- sitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmit-
gliedern unterzeichnet.

Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein

solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für
die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz
oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäfts-
führungsrats.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne

Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte
Personen oder Vertreter übertragen.

Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-

einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/
sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma
ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der
Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma,
mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbin-
dung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-

schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsfüh-
rungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber
abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleinge-
sellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift jedes

Geschäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die
Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Ge-
schäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertra-
genen Befugnisse gilt.

Sind jedoch ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie

B durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt worden, so wird die Gesellschaft gegen-
über Dritten durch die gemeinschaftlichen Unterschriften eines Geschäftsführers der Kategorie A sowie eines Ge-
schäftsführers der Kategorie B oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von
Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich
verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

59819

Art. 16. Kommissare. Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,

muss einem oder mehreren Kommissaren anvertraut werden, welche keine Gesellschafter sein müssen.

Die Kommissare werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, von der Gesellschafterver-

sammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie blei-
ben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können
jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesell-
schafterversammlung abberufen werden.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 17. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die

Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Ge-
schäftsführer oder den Geschäftsführungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden.
Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zu-
gang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberu-

fung gemäss luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführungsrat, oder
subsidiär, durch den Kommissar, oder subsidiär dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, be-
inhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Tele-

gramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,

wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats liegen, dies erforderlich machen.

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschaf-

terversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Mit Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den Ge-

schäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsrat vorbehalten sind, ist sie mit den weitestreichendsten Befug-
nissen ausgestattet, um jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung durchzuführen oder zu
genehmigen.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten

ist, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am 31. Oktober um 15.30 Uhr am Gesell-
schaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag ab-

gehalten.

Art. 20. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages

und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Geset-
zes, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit un-
terliegt, muss von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten
Gesellschaftskapitals vertreten.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages werden alle

übrigen Beschlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht wer-

den können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschaftsführer unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats August und endet

am einunddreissigsten Tag des Monats Juli eines jeden Jahres.

Art. 22. Bilanz. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder

der Geschäftsführungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesell-

schafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz

einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen
vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

59820

Art. 23. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn

abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann
nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jähr-

lichen Reingewinns. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen,
ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen

eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Betrag und
das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 24.  Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der gemäß den-
selben Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die für die Abänderung des vorliegenden Ge-
sellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder

juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegen.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird

das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet, und zwar im Verhältnis
zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag

geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei erstellt worden ist, hat diese Partei

folgende Anzahl Geschäftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt: 

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht, der bestätigt, dass die Bestimmungen des

Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung ein-
gehalten worden sind.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr 39.500,- EUR geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Juli 2005.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Der Alleingesellschafter, der stellvertretend für die Gesellschafterversammlung handelt, hat unverzüglich die folgen-

den Beschlüsse gefasst:

1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf vier (4) festzulegen, und beschließt außer-

dem folgende Personen zu Geschäftsführern der Kategorie A für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestäti-
gung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:

- Herrn Robert Ian Kauffman, Finanzier, geboren am 22. Oktober 1963 in New-York (Vereinigte Staaten von Ame-

rika), wohnhaft in Via della Mercede 39, 00187 Rom (Italien); und

- Herrn Jonathan Ashley, Finanzier, geboren am 28. Februar 1966 in New-York (Vereinigte Staaten von Amerika),

wohnhaft in Carlton Hill Road 21, NW8 0JX London (Großbritannien).

Der Alleingesellschafter beschließt außerdem, folgende Person zum Geschäftsführer der Kategorie B für einen Zeit-

raum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene
Geschäftsjahr endet:

- Herrn Luc Hansen, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, wohnhaft in 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

- Herr John Seil, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 28. September 1948 in Luxemburg, wohnhaft in 5, bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

2. Der Sitz der Gesellschaft wird sich befinden in:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

obengenannten erschienen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst

Gesellschafter

gezeichnetes

Anzahl

Einzahlung

Kapital (EUR)

Geschäftsanteile

(EUR)

BASTION LIMITED PARTNER, S.à r.l., vorbennant . . . . . . .

3.487.650,- EUR

139.506

3.487.650,- EUR

Summe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.487.650,- EUR

139.506

3.487.650,- EUR

59821

ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird
der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekann-

ten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 88, case 5. – Reçu 34.876,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(060354.3/206/612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 81.464. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG01427, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058581.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

WEST-EL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.826. 

<i>Cession d’actions sous seing privé

L’an deux mille deux, le vingt-cinq mars.

Entre les soussignés: 

1. La société anonyme holding WINTRUST HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg L-1660, 84, Grand-rue,

ici représentée par son administrateur Monsieur Patrick Arama, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

2. La société anonyme holding INTERALPINA HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg L-1660, 84, Grand-

rue, ici représentée par son administrateur Monsieur Patrick Arama, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants, ont procédé ce jour ainsi qu’il suit à la présente cession sous seing privé des actions de la so-

ciété à responsabilité limitée WEST-EL, S.à r.l. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, société constituée le 14 mars 2002 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster
(Grand-Duché de Luxembourg).

Le capital de la société WEST-EL S.à r.l. a été fixé aux termes des statuts à quarante mille euros (EUR 40.000,-), divisé

en cent (100) actions, de quatre cent euros (EUR 400,-), chacune, les actions ayant été souscrites comme suit: 

<i>Modalités de la cession

1. La société anonyme holding WINTRUST HOLDING S.A., prédite, déclare céder et transporter avec toute garantie

de droit et de fait, la totalité de ses actions de la société à responsabilité limitée WEST-EL S.à r.l., soit cinquante actions
(50) à Monsieur Villemenne Nicolas au prix de deux mille cinq cents (EUR 2.500) euros.

2. La société anonyme holding INTERALPINA HOLDING S.A., prédite, déclare céder et transporter avec toute ga-

rantie de droit et de fait, la totalité de ses actions de la société à responsabilité limitée WEST-EL, S.à r.l. soit cinquante
actions (50) à Monsieur Villemenne Nicolas au prix de deux mille cinq cents (EUR 2.500) euros.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour servir et valoir ce que de droit

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058832.3/850/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Luxemburg-Eich, den 11. Juli 2005.

P. Decker.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

1) La société anonyme holding WINTRUST HOLDING S.A., prédite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 actions
2) La société anonyme holding INTERALPINA HOLDING S.A.,prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 actions

«Bon pour cession, pour acquit»
WINTRUST HOLDING S.A. / INTERALPINA HOLDING S.A.
«Bon pour acceptation»
Signature / Signature

59822

INFRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 32, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 12.370. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01689, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058679.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

LUXEMBOURG GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.699. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 28 juin 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
* Monsieur Marc-André Bechet, Senior Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,

69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

* Monsieur Léon Hilger, Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg,

* Monsieur Marc Schammo, Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg,

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2006,

- de renouveler le mandat de:
* PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. B 65.477, en qualité de Réviseur

d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01531. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058620.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

BASTION LUX PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 34,950.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.156. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirtieth of June.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

LUXGATE, GmbH, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 17 December

2004, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered under number B 105.092,

represented by M

e

 Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg, 

by virtue of a proxy given on June 29, 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the

«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of BASTION LUX PARTICIPATION, S.à r.l.

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the municipality of the City of Luxem-

bourg.

Echternach, le 7 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour LUXEMBOURG GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

59823

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a

resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social

developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may tempo-
rarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tempo-
rary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at thirty four thousand nine hundred and fifty

euro (EUR 34,950.-) divided into one thousand three hundred and ninety-eight (1,398) shares, with a par value of twen-
ty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

The authorized capital of the Company is set at seventy million euro (EUR 70,000,000.-), divided into two million

eight hundred thousand (2,800,000) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share.

The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers is/are authorised and empowered, to (i) realise any

increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the
issuing of new shares with or without share premium, against payment in cash or in kind, following the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers under
the terms of share subscription warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments),
convertible preferred equity certificates, convertible notes or similar instruments issued from time to time by the Com-
pany, by conversion of claims or in any other manner; (ii) issue any rights in whatever form under the terms of share
subscription warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible pre-
ferred equity certificates, convertible notes or similar instruments entitling to the subscription of such shares; and (iii)
determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the sub-
scription of and paying up on the new shares.

This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the

resolutions taken by the Company’s sole shareholder on June 30, 2005 in the Mémorial C and it may be renewed by
the sole shareholder or, as the case may be, by a general meeting of shareholders.

The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may delegate to any duly authorized officer of the

Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares
representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the
legally required form by the the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers within the limits of the au-
thorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

59824

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. Manager(s), Board of Managers, Statutory auditors

Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers

which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and
who need not be shareholders (the «Manager(s)»). 

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Manager(s) and one or

several Class B Manager(s).

Art. 10. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman

(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence
or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A Manager and one
Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such
meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in

case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Man-
ager(s) or of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-

59825

cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature

of any single Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.

However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one

or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A
Manager and one Class B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exer-

cises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August
10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by
the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obli-
gation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written
vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in

compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more
subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-

er(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of

Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual general meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on 31 March at 2.30 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Manager.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial year. The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on

the last day of December.

59826

Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than twenty-five shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on

dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixe the amount and the date of payment of any such advance pay-
ment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law. 

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2005.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1. The sole shareholder resolved to set at four (4) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as Class A Managers for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year
ended 31 December 2005:

- Mr Robert Ian Kauffman, Financier, born on 22 October 1963 in New York (United States of America), residing at

39, via della Mercede, 00187 Rome (Italy); and

- Mr Jonathan Ashley, Financier, born on 28 February 1966 in New York (United States of America), residing at 21

Carlton Hill Road, London NW8 0JX (United Kingdom).

The sole shareholder further resolved to appoint the following as Class B Manager for a period ending at the date of

approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005:

- Mr Luc Hansen, chartered accountant, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

- Mr John Seil, chartered accountant, born on 28 September 1948 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Shareholder

Subscribed

Number

Amount

capital (EUR)

of shares paid-in (EUR)

LUXGATE, Gmbh, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,950.- EUR

1,398 34,950.- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,950.- EUR

1,398 34,950.- EUR

59827

2. The registered office shall be at:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg). 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am 30. Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

LUXGATE, GmbH, eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht des Grossherzogstums Luxemburg am 17.

Dezember 2004gegründet worden ist, mit Sitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen unter der
Nummer B 105.092,

vertreten durch M

e

 Sabine Hinz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 30. Juni 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung erstellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit durch den Alleingesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschafts-
vertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Die Gesellschaft zählt ursprünglich einen Alleingesellschafter, Eigentümer aller Geschäftsanteile. Die Gesellschaft

kann jedoch jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Geschäftsanteilen oder der Ausgabe neuer Geschäfts-
anteile, aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf.

Der Name der Gesellschaft ist BASTION LUX PARTICIPATION, S.à r.l.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Ge-

schäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in

anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-

scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vor-
übergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu brin-
gen.

Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in

luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Be-
teiligungen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-

scheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, die gemäss den

Gesetzesbestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden. 

Kapitel II. Kapital, Geschäftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf vierunddreissigtausendneunhundertfünfzig Euro

(EUR 34.950,-) festgesetzt, eingeteilt in eintausenddreihundertachtundneunzig (1.398) Geschäftsanteile mit einem Nenn-
wert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll eingezahlt. 

59828

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt siebzig Millionen Euro (EUR 70.000.000,-), eingeteilt in zwei Millionen

achthunderttausend (2.800.000) Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro
(EUR 25,-).

Der/die Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführungsrat ist/sind in den Grenzen des genehmigten Ka-

pitals dazu ermächtigt, (i) jede, eventuell auf einer Ausübung, gemäss den Bedingungen der ausgegebenen Zeichnungs-
optionen, Wandelvorzugszertifikate, Wandelanleihen, Schuldscheinen oder ähnlichen, von Zeit zu Zeit von der
Gesellschaft ausgebebenen Wertpapieren, der von ihm beziehungsweise ihnen, im Rahmen des genehmigten Kapitals,
gewährten Zeichnungs- und/oder Umwandlungsrechte (die entweder gesondert von den Geschäftsanteilen, Schuld-
scheinen oder anderen Wertpapieren oder diesen beigefügt ausgegeben wurden) beruhende Erhöhung des Gesell-
schaftskapitals vorzunehmen, und zwar in einer oder in mehreren Phasen durch die Ausgabe neuer Geschäftsanteile,
entweder mit oder ohne Emissionsaufgeld, gegen eine Geld- oder eine Sacheinlage, durch eine Umwandlung von An-
sprüchen gegenüber der Gesellschaft oder auf jede andere Weise; (ii) Rechte in jedweder Form gemäß den Geschäfts-
bedingungen von Zeichnungsoptionen, Wandelvorzugszertifikaten, Wandelanleihen, Schuldscheinen (die entweder
gesondert von den Geschäftsanteilen, Schuldscheinen oder anderen Wertpapieren oder diesen beigefügt ausgegeben
wurden) zu gewähren, die die Zeichnung von Gesellschaftsanteilen gestatten; und (iii) den Ort und den Zeitpunkt der
Geschäftsanteilausgabe oder der aufeinander folgenden Geschäftsanteilausgaben, den Ausgabepreis, die Bedingungen
der Zeichnung und der Einzahlung der neuen Geschäftsanteile festzulegen.

Diese Ermächtigung gilt bis zum Ende eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung des Protokolls

der durch den Alleingesellschafter am 30. Juni 2005 getroffenen Beschlüsse im Mémorial C und kann durch einen Be-
schluss des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafterversammlung erneuert werden.

Der/die Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführungsrat kann/können jedem befugten Mitarbeiter der

Gesellschaft oder jeder anderen ordnungsgemäß ermächtigten Person die Aufgaben der Annahme der Zeichnung und
der Einzahlung der neuen Geschäftsanteile überlassen, die das erhöhte Kapital ganz oder teilweise vertreten. Nach jeder
Erhöhung des ausgegebenen Kapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form
durch den/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls den Geschäftsführungsrat, wird dieser Artikel dergestalt abgeän-
dert, dass er die vorgenommene Erhöhung wiedergibt.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Geschäftsanteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag
dieses Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Geschäftsanteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurück-
kauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter in Form von Dividenden oder
zur Bereitstellung der gesetzlichen Rückstellungen genutzt werden. 

Art. 6. Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Ver-

mögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum
eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. 
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen

gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft meh-

rere Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen
die Geschäftsanteile lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei
der drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.

Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen

Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder

mehrmals durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabge-
setzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorlie-
gendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden
Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird

weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das
den Alleingesellschafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Kapitel III. Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare

Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern,

die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden können (der «Geschäftsführungs-
rat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).

Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafter-versammlung, die deren

Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nach-
folger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder
der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Der Alleingesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung können beschließen, einen oder mehrere

Geschäftsführer der Kategorie A sowie einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.

59829

Art. 10. Geschäftsführungsrat. Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen

Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Ge-
schäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der
Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist

einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen

den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt
sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum
zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schrift-

licher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehe-
nen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über
Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche Zu-
stimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet wer-
den. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren
Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungs-

rat von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen

Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind. Sind Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B bestellt worden, so ist der
Geschäftsführungsrat nur dann beschlussfähig, wenn gleichzeitig mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer
sowie mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder ver-
treten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnli-

chen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig
miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleich-
wertig.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-

bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden,
wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden

und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-

legt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitglie-
dern unterzeichnet.

Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein

solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für
die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz
oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäfts-
führungsrats.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne

Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte
Personen oder Vertreter übertragen.

Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-

einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/
sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma
ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der
Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma,
mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbin-
dung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-

schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsfüh-
rungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber
abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleinge-
sellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

59830

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift jedes

Geschäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die
Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Ge-
schäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertra-
genen Befugnisse gilt.

Sind jedoch ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie

B durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt worden, so wird die Gesellschaft gegen-
über Dritten durch die gemeinschaftlichen Unterschriften eines Geschäftsführers der Kategorie A sowie eines Ge-
schäftsführers der Kategorie B oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von
Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich
verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

Art. 16. Kommissare. Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,

muss einem oder mehreren Kommissaren anvertraut werden, welche keine Gesellschafter sein müssen.

Die Kommissare werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, von der Gesellschafterver-

sammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie blei-
ben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können
jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesell-
schafterversammlung abberufen werden.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 17. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die

Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Ge-
schäftsführer oder den Geschäftsführungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden.
Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zu-
gang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberu-

fung gemäss luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführungsrat, oder
subsidiär, durch den Kommissar, oder subsidiär dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, be-
inhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Tele-

gramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,

wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats liegen, dies erforderlich machen.

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschaf-

terversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Mit Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den Ge-

schäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsrat vorbehalten sind, ist sie mit den weitestreichendsten Befug-
nissen ausgestattet, um jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung durchzuführen oder zu
genehmigen.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten

ist, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am 31. März um 14.30 Uhr am Gesellschafts-
sitz oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag ab-

gehalten.

Art. 20. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages

und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Geset-
zes, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit un-
terliegt, muss von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten
Gesellschaftskapitals vertreten.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages werden alle

übrigen Beschlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht wer-

den können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschaftsführer unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen 

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet

am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres. 

59831

Art. 22. Bilanz. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder

der Geschäftsführungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesell-

schafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz

einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen
vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 23. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn

abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann
nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jähr-

lichen Reingewinns. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen,
ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen

eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Betrag und
das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 24. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der gemäß den-
selben Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die für die Abänderung des vorliegenden Ge-
sellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder

juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegen.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird

das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet, und zwar im Verhältnis
zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschafts- vertrag

geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei erstellt worden ist, hat diese Partei

folgende Anzahl Geschäftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt: 

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht, der bestätigt, dass die Bestimmungen des

Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung ein-
gehalten worden sind.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr 3.000,- Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Der Alleingesellschafter, der stellvertretend für die Gesellschafterversammlung handelt, hat unverzüglich die folgen-

den Beschlüsse gefasst:

1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf vier (4) festzulegen, und beschließt außer-

dem folgende Personen zu Geschäftsführern der Kategorie A für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestäti-
gung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:

- Herrn Robert Ian Kauffman, Finanzier, geboren am 22. Oktober 1963 in New-York (Vereinigte Staaten von Ame-

rika), wohnhaft in Via della Mercede 39, 00187 Rom (Italien); und

- Herrn Jonathan Ashley, Finanzier, geboren am 28. Februar 1966 in New-York (Vereinigte Staaten von Amerika),

wohnhaft in Carlton Hill Road 21, NW8 0JX London (Großbritannien).

Gesellschafter

gezeichnetes

Anzahl

Einzahlung

Kapital (EUR)

Geschäftsanteile

(EUR)

LUXGATE, GmbH, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.950,- EUR

1.398 34.950,- EUR

Summe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.950,- EUR

1.398 34.950,- EUR

59832

Der Alleingesellschafter beschließt außerdem, folgende Person zum Geschäftsführer der Kategorie B für einen Zeit-

raum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene
Geschäftsjahr endet:

- Herrn Luc Hansen, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, wohnhaft in 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

- Herr John Seil, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 28. September 1948 in Luxemburg, wohnhaft in 5, bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

2. Der Sitz der Gesellschaft wird sich befinden in:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

obengenannten erschienen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst
ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird
der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekann-

ten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet. 

Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 88, case 3. – Reçu 349,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(060348.3/206/612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EUROINVEST (POLAND 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 70.931. 

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la société que Jan Willem van Koeverden Brouwer est nommé en

tant que gérant de la société en remplacement de M. Hugo Neuman, gérant démissionnaire. M. Jan Willem van Koever-
den Brouwer est nommé avec effet au 1

er

 juillet 2005 et pour une période sans limitation de durée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058617.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

DOCU GROUP (LUX 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 102.524. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 6 juillet 2005

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 6 juillet 2005 que Mme Nora Kerppola,

demeurant à Sackville House, 40 Piccadilly, Londres, W1J 0DR, Grande-Bretagne, a été nommée comme gérant unique
de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en remplacement de M. Rupert Henry Gildroy Shaw.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058952.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Luxemburg-Eich, den 11. Juli 2005.

P. Decker.

Pour avis conforme
Signature
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire

Pour extrait
DOCU GROUP (LUX 2), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

59833

FLORIDA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 109.068. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit juin.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société WASCO INVEST &amp; TRADE S.A., avec siège social à Belize City - Belize, Jasmine Court, 35A, Regent

Street, inscrite au International Business Companies de Belize sous le numéro 43.587,

ici représentée par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée délivrée en date du 8 juin 2005, laquelle restera annexée au présent acte.
2) Monsieur Richard Lopes, gérant de société, demeurant à L-2561 Luxembourg, 27, rue de Strasbourg.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FLORIDA IMMO S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par

simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prestation de services, la mise en relation clientèle, l’acquisition et la gestion de

patrimoine immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut signer tous actes d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes
sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges
du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature unique de l’administrateur délégué, y compris les

actes d’achat, de vente ou d’échange d’immeubles, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les actes de postpo-

59834

sition et les actes d’emprunt ou d’ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la stipulation de
la voie parée conformément aux dispositions de l’article 879 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (ancien
article 71 de la loi du 2 janvier 1889) sur la saisie immobilière.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui - même pour finir le 31 décembre

2005.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) La société WASCO INVEST &amp; TRADE S.A., avec siège social à Belize City - Belize, Jasmine Court, 35A, Regent

Street, inscrite au International Business Companies de Belize sous le numéro 43.587.

1) La société WASCO INVEST &amp; TRADE S.A., prédite, quatre-vingt-dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2) Monsieur Richard Lopes, prédit, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

59835

2) Monsieur Richard Lopes, gérant de société, né à Paris/France, le 30 novembre 1957, demeurant à L-2561 Luxem-

bourg, 27, rue de Strasbourg.

3) La société LANGCRAFT INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Londres N3 1RL, Lawford House, Albert

Place (Angleterre), inscrite au Companies House à Londres sous le numéro 5019056.

Monsieur Richard Lopes, prédit, est nommé administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.
Est nommé commissaire:
La société FID’AUDIT LIMITED, avec siège social à Belize City - Belize, Jasmine Court, 35A, Regent Street, inscrite

au IBC INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY à Belize le 14 janvier 2002 sous le numéro 23.869.

Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2011.
2. Le siège de la société est établi à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Krimou, R. Lopes, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, vol. 148S, fol. 82, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059292.3/216/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

MULTIPLE MANAGERS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.934. 

En date du 27 avril 2005 l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:
1. de réélire:
- Mr. Steve Georgala, MAITLAND &amp; CO, S.à r.l., 35, rue La Boétie, F-75008 Paris,
- Mr. Jacobus Johannes Human, INSINGER DE BEAUFORT ASSET MANAGEMENT NV, Herengracht 537, NL-1017

BV Amsterdam,

- Mr. Thomas Melchior, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch L-2953

Luxembourg,

- Mr. Peter George Sieradzki, BANK INSINGER DE BEAUFORT NV, Herengracht 537, NL-1017 BV Amsterdam
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2006

2. de renommer:
- ERNST &amp; YOUNG, Parc d’Activité Syrdall, 7 L-5365 Munsbach
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01055. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058635.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

REISS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.514. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juin 2005 que;
- suite à la démission de la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts comptables, sise à L-1361

Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, de son poste de commissaire aux comptes, la société FIDU-
CONCEPT, S.à r.l., experts comptables et fiscaux, sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chê-
ne, est nommée nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1

er

 janvier 2005. Son mandat prendra fin à l’issue de

l’assemblée générale de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01243. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058672.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

<i>Pour MULTIPLE MANAGERS Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Signature

59836

CHARME INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.675. 

EXTRAIT

En vertu des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire des associés tenue extraordinairement le 29 juin

2005, il a été décidé

- de renommer les membres du Conseil de Surveillance:
* Monsieur Bernard Trempont,
* Monsieur Jean Pierre Leburton,
* Monsieur Camille Paulus.
Leur mandat prendra fin aussitôt après la tenue de l’Assemblée Générale de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058648.3/275/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

TETRA LAVAL FINANCE &amp; TREASURY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 109.400. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eighteenth of July.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

- TETRA LAVAL FINANCE &amp; TREASURY BV, with registered office at Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, The

Netherlands, registered with the trade register under number 33149245, represented by Cécile Jager, by virtue of a
proxy given on July 13, 2005;

- TETRA LAVAL CAPITAL BV, with registered office at Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, The Netherlands, reg-

istered with the trade register under number 33063580, represented by Cécile Jager, by virtue of a proxy given on July
13, 2005.

The aforementioned proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary

shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said above, have requested the notary to state as follows the Articles of In-

corporation of a corporation (société anonyme) which they form between themselves:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of TETRA LAVAL FINANCE &amp; TREASURY

LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office of the company is established in the Municipality of Schuttrange.

Art. 3. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company shall also have as its business purpose to carry on the business of a group finance company. The com-

pany may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies and may
carry out its financing activities through branches located abroad.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises, in Luxembourg and abroad.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The share capital is set at fifty thousand Euro (50,000.- EUR) divided into one thousand (1,000) shares having

a nominal value of fifty Euro (50.- EUR) each.

<i>CHARME INVESTMENTS ScA
Représenté par
CHARME MANAGEMENT S.A.
J. Wagner
<i>Company Secretary and Investors Relationship Manager

59837

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 6. The company is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Any director of the company may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by cable

or telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member of the Board of Directors as his proxy. 

The Board of Directors may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in

person or by proxy.

Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors

by means of a communication device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members
of the Board of Directors present at such meeting (whether in person or by proxy, or by means of such communication
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting.

Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by

means of such communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. 

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present either in person or by proxy

at such meeting.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

Art. 8. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors unless special de-

cisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the
Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of a special branch to one or more managers, and give special powers for de-

termined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held at the registered office of the company or at such other place of the mu-

nicipality of the registered office as specified in the convening notices on the last Thursday of the month of June of each
year at 4.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first

of December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal re-
serve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below ten percent (10%) of the capital of the company.

59838

The balance is at the disposal of the general meeting.
The general meeting of the shareholders shall determine, upon recommendation of the board of directors, how the

remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amount proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the company is

dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the gen-
eral meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the company and end on the thirty-first of De-

cember 2005.

The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place indicated in the articles of in-

corporation in 2006.

<i>Shares

The articles of association of the corporation having been established as aforesaid, the shares of the company are

attributed to the shareholders as follows: 

The shares have been entirely paid by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of the

present deed, are estimated approximately at one thousand eight hundred Euro (1,800.- EUR).

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of August 10, 1915 on

commercial companies have been observed. 

<i>Extraordinary general meeting

The above-named shareholders, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly con-

vened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1) The number of directors is set at three (3).
The following have been appointed as directors:
a) Mr Geert H.T. van der Molen, born on December 30, 1961 in Rotterdam, The Netherlands, with professional ad-

dress at 70, avenue General-Guisan, PO Box 430, CH-1009 Pully Switzerland;

b) Mr John Seil, born on 28 September 1948 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg);

c) Mr Michel Waringo, born on November 2, 1936, in Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 22,

route de Dommeldange, L-7222 Walferdange (Grand Duchy of Luxembourg).

Their mandate will expire at the general meeting of shareholders resolving on the accounts for the financial year end-

ing December 31, 2010.

2) The number of statutory auditors is set at one.
Has been appointed statutory auditor: ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand

Duchy of Luxembourg, for a period ending with the next annual general meeting.

3) The registered office of the company is fixed at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Lux-

embourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their names, surnames, civil

statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Nb shares

Payments

TETRA LAVAL FINANCE &amp; TREASURY BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 shares

49,950 EUR

TETRA LAVAL CAPITAL BV   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

50 EUR

1,000 shares

50,000 EUR

59839

Ont comparu:

- TETRA LAVAL FINANCE &amp; TREASURY BV, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, (NL), imma-

triculée sous le numéro 33149245, représentée par Cécile Jager, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée
le 13 juillet 2005;

- TETRA LAVAL CAPITAL BV, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, (NL), immatriculée sous le

numéro 33063580, représentée par Cécile Jager, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 13 juillet 2005.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de TETRA LAVAL FINANCE &amp;

TREASURY LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Schuttrange.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toutes autres manières, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toutes autres manières de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toute espèce,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales, affiliées ou faisant partie du même groupe.

La société peut aussi créer des succursales à Luxembourg et à l’étranger.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Art. 7. Le Conseil d’Administration peut choisir un président parmi ses membres.
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur de la société peut agir à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique, un autre membre du Con-
seil d’Administration comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente en personne ou par mandataire.

Tout membre du Conseil d’Administration qui participe à une réunion du Conseil d’Administration via un moyen de

communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil d’Adminis-
tration présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’en-
tendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera
considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé
à voter sur les matières traitées à cette réunion.

Les membres du Conseil d’Administration qui participent à une réunion du Conseil d’Administration via un tel moyen

de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réu-
nion.

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à une telle réunion.

59840

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d’Administration seront considérées comme

étant valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être
apposées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration est autorisé à payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont

un résident luxembourgeois à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation
de pouvoirs n’aient été prises par le Conseil d’Administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion d’une branche spéciale de la société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pou-

voirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres mem-
bres ou non, actionnaires ou non.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le Conseil d’Administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué
à cet effet.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années. 

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège

social spécifié dans la convocation, le dernier jeudi du mois de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélè-
vement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son
cours si, à un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de dix pour cent (10%)
du capital social.

Le solde du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur recommandation du conseil d’administration, de l’affectation du

bénéfice annuel net, et pourra, sans pour autant outrepasser le montant proposé par le conseil d’administration, décla-
rer les dividendes de temps en temps.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra au jour, lieu et place indiqués dans les statuts et pour

la première fois en 2006.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille euros (50.000,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

Nbre d’actions

Paiements

TETRA LAVAL FINANCE &amp; TREASURY BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

49.950 EUR

TETRA LAVAL CAPITAL BV   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

50 EUR

1.000 actions

50.000 EUR

59841

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Estimation des frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille huit cents euros
(1.800,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Les personnes ci-après désignées ont été élues administrateurs:
a) M. Geert H.T. van der Molen, né le 30 décembre 1961 à Rotterdam, (NL), domicilié au 70, avenue General-Guisan,

PO Box 430, CH-1009 Pully Suisse;

b) M. John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, domicilié au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg);

c) M. Michel Waringo, né le 2 novembre 1936, à Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, domicilié au 22, route

de Dommeldange, L-7222 Walferdange (Grand-Duché de Luxembourg).

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale des actionnaires appelés à statuer sur les comptes de l’année se

terminant le 31 décembre 2010.

2) Le nombre de réviseur est fixé à un.
A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de

Luxembourg, pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

3) Le siège social de la société est fixé 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande du même comparant il est spé-
cifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, vol. 149S, fol. 30, case 1. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063848.3/202/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DOCU GROUP (LUX 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 101.454. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 6 juillet 2005

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 6 juillet 2005 que Mme Nora Kerppola,

demeurant à Sackville House, 40 Piccadilly, Londres, W1J 0DR, Grande-Bretagne, a été nommée comme gérant unique
de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en remplacement de M. Rupert Henry Gildroy Shaw.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058956.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Senningerberg, le 20 juillet 2005.

P. Bettingen.

Pour extrait
DOCU GROUP (LUX 1), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

59842

FINAPOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.619. 

In the year two thousand five, on the twentieth of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of FINAPOL, S.à r.l., having its registered office at

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-
bourg, on June 27, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 801 of November
2, 2000.

The Meeting is presided over by Mr. Manuel Frias, company director, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Pierre Stemper, manager, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mrs. Chantal Mathu, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

II. As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-

sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
beforehand informed.

Ill. That the agenda of the Meeting is the following:
1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of a liquidator.
3. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to

dissolve the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator:
FIN-CONTROLE S.A., having its registered office at L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders

in the cases in which it is requested.

It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its

powers it determines and for the period it will fix.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FINAPOL, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 801 du 2 novembre 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Manuel Frias, administrateur de société, demeurant à Luxem-

bourg. 

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Stemper, gérant, demeurant à Luxembourg.

59843

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I. Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’entre eux sont

indiqués sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite
liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Divers.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, l’assemblée

décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur: 
FIN-CONTROL S.A., ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des actionnaires dans les

cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: M. Frias, P. Stemper, C. Mathu, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 juin 2005, vol. 432, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059457.3/242/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

DING INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.685. 

L’an deux mille cinq, le dix juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DING INTERNATIONAL,

ayant son siège social à L-9710 Clervaux, 22, Grand-rue, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 77.685), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 août 2000, publié au Mémorial C numéro 109 du 13 février
2001,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
en date du 23 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1166 du 17 novembre 2004 et
en date du 10 janvier 2005, non encore publié au Mémorial C,
ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent dix

euros (310,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guowei Ding, commerçant, demeurant à Clervaux.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Yun Long Dong, cuisinier, demeurant à Aspelt.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Svetlana Ding-Toukalevskaya, comptable, demeurant à Clervaux.

Mersch, le 5 juillet 2005.

H. Hellinckx.

59844

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Nominations statutaires.
2. Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Yun Long Dong à la fonction d’administrateur-délégué.
3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Fung Chiu Leung comme administrateur et administrateur-

délégué de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Yun Long Dong, cuisinier, né à Wenzhou (Chine), le 10 novembre 1953,

demeurant à L-5710 Aspelt, 11, rue Pierre d’Aspelt, comme nouvel administrateur de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguér les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Yun Long Dong, préqualifié, avec co-signature obliga-
toire concernant le domaine de l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec établissement
de restauration.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. Ding, Y.L. Dong, S. Ding-Toukalevskaya, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 2005, vol. 532, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059647.3/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

PARA PRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.801. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00013, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(058907.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Junglinster, le 1

er

 juillet 2005.

J. Seckler.

<i>Pour PARA PRESS S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.à r.l.
Signature

59845

IBM SERVICES FINANCIAL SECTOR LUXEMBOURG,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 98.800. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03618, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058960.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

SOGIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 58.559. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00011, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(058908.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

FRANVEST INVESTISSEMENTS, Société Anonyme,

(anc. FRANVEST S.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 109.050. 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de FRANVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 25 mai 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Maître Jean Wagener, avocat à la Cour, avec

adresse professionnelle au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Jeanny Schroeder, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Maître Pierre Goedert, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 10A,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de quatre cent cinquante euros (EUR 450,-) chacune constituant l’intégralité du capital
social de quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réu-
nir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en FRANVEST INVESTISSEMENTS et modification afférente

de l’article 1

er

 des statuts.

2. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

La dénomination sociale de la Société est changée de FRANVEST S.A. en FRANVEST INVESTISSEMENTS.
En conséquence, l’article 1

er

 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FRANVEST INVESTISSEMENTS.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures qua-

rante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour SOGIS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.à r.l,
Signature

59846

Signé: J. Wagener, J. Schroeder, P. Goedert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 85, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059034.2/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

FRANVEST INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 109.050. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 794 du 25 mai 2005 et n

°

 1016 du 28 juin 2005, déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059036.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

MARINELLI IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7246 Helmsange, 15, rue Paul Elvinger.

R. C. Luxembourg B 91.536. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01765, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059087.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

EUROINVEST (POLAND 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 70.930. 

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la société que Jan Willem van Koeverden Brouwer est nommé en

tant que gérant de la société en remplacement de M. Hugo Neuman, gérant démissionnaire. M. Jan Willem van Koever-
den Brouwer est nommé avec effet au 1

er

 juillet 2005 et pour une période sans limitation de durée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058614.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

CLAYMORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.846. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juni 2005, réf. LSO-BG00571, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(058512.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Signature.

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

<i>Pour HOOGEWERF &amp;CIE
Agent domiciliataire
Signature

59847

MASCO EUROPE SCS, Société en commandite simple.

Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 68.105. 

In the year two thousand four, on the nineteenth day of August, at 04.00 p.m.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MASCO EUROPE SCS, a «société en commandite

simple», having its registered office at L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall, incorporated by deed enacted on
the 29th of December 1998, inscribed at Luxembourg trade register section B under number 68.105, and whose articles
of association have been amended for the last time on the 18th June 2004.

The meeting is presided by Mr André Pesch, Director at L-5365 Munsbach.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman requests the secretary to act that:
I. The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, the 50.000.000 (fifty million) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, rep-

resenting the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of
the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decrease of the partnership capital by an amount of EUR 70,000,000.- (seventy million Euro) so as to bring it from

its present amount of EUR 1,250,000,000.- (one billion two hundred fifty million Euro) to EUR 1,180,000,000.- (one bil-
lion one hundred eighty million Euro) by the redemption of 2.800.000 (two million eight hundred thousand) shares of
commanditaire with a par value of EUR 25.- (twenty five Euro) from MASCO CORPORATION.

2. Repayment of a share premium in the amount of EUR 828,816.- (eight hundred twenty-eight thousand eight hun-

dred and sixteen Euro) to MASCO CORPORATION.

3. Acceptance by the specially authorized persons of MASCO EUROPE SCS.
4. Amendment of article 6 of the articles of Incorporation in order to reflect the capital decrease.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The partners decide to decrease the issued partnership capital by EUR 70,000,000.- (seventy million Euro, so as to

bring it from its present amount of EUR 1,250,000,000.- (one billion two hundred fifty million Euro) to EUR
1,180,000,000.- (one billion one hundred eighty million Euro) by redemption of 2.800.000 (two million eight hundred
thousand) shares of commanditaire with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) from MASCO CORPORATION.

<i>Second resolution

The partners decide to repay to MASCO CORPORATION, Michigan, United States of America, a share premium in

the amount of EUR 828,816.- (eight hundred twenty-eight thousand eight hundred and sixteen Euro).

<i>Intervention of the specially authorized persons

Thereupon intervenes André Pesch, specially authorized person of MASCO EUROPE SCS as well as Robert B.

Rosowski, Lau Frandsen, and David A. Doran, all specially authorized persons and here represented by André Pesch by
virtue of a power here annexed.

Messrs André Pesch, Robert B. Rosowski, Lau Frandsen and David A. Doran expressly agree with the decrease of

partnership capital and the repayment of share premium.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the partners decide to amend the article 6 of the

Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 1,180,000,000.- (one billion one hundred and eighty million Euro),

consisting of EUR 250.- (two hundred and fifty Euro) for the «active» partner (Commandité) and EUR 1,179,999,750.-
(one billion one hundred seventy-nine million nine hundred ninety-nine thousand seven hundred and fifty Euro) for the
limited «sleeping» partners (commanditaires).

The capital is represented by 47.200.000 (forty seven million two hundred thousand) shares of EUR 25.- (twenty-five

Euro) each, themselves divided into 10 (ten) shares of commandité and 47.199.990 (forty seven million one hundred
ninety-nine thousand nine hundred and ninety) shares of commanditaires.

Each share of commandité or share of commanditaire gives one voting right in meetings of partners, either annual or

extraordinary.»

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le dix-neuf août, à partir de seize heures.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite simple MASCO EUROPE

SCS, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall, constituée suivant acte reçu le 29 décembre
1998, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg section B sous le numéro 68.105, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois par acte du 18 juin 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur André Pesch, directeur à L-5365 Munsbach.

59848

Le président désigne comme secrétaire de l’assemblée Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président prie le secrétaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 50.000.000 (cinquante millions) de parts sociales, ayant une valeur nominale

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de EUR 70.000.000,- (soixante-dix millions d’euros) pour

le ramener de son montant actuel de EUR 1.250.000.000,- (un milliard deux cent cinquante millions d’euros) à EUR
1.180.000.000,- (un milliard cent quatre-vingts millions d’euros) par le rachat de 2.800.000 (deux millions huit cent mille)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune de MASCO CORPORATION. 

2. Remboursement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 828.816,- (huit cent vingt-huit mille huit cent seize

euros) à MASCO CORPORATION. 

3. Acceptation par les gérants de MASCO EUROPE SCS.
4. Modification afférente de l’article 6 des statuts afin de montrer la réduction du capital social.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident de réduire le capital à concurrence de EUR 70.000.000,- (soixante-dix millions d’euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 1.250.000.000,- (un milliard deux cent cinquante millions d’euros) à EUR
1.180.000.000,- (un milliard cent quatre-vingts millions euros) suite au rachat de 2.800.000 (deux millions huit cent mille)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune par MASCO CORPORATION, société
ayant son siège à Michigan 48180, Etats Unis d’Amérique. 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident qu’il soit procédé au remboursement à MASCO CORPORATION d’une prime d’émission d’un

montant de EUR 828.816,- (huit cent vingt-huit mille huit cent seize euros).

<i>Intervention de la gérance

Sont alors intervenus Monsieur André Pesch, gérant de la société luxembourgeoise MASCO EUROPE SCS ainsi que

Robert B. Rosowski, Lau Frandsen et David A. Doran, tous gérants de MASCO EUROPE scs et représentés par André
Pesch en vertu d’un pouvoir ci-annexé.

Messieurs André Pesch, Robert B. Rosowski, Lau Frandsen et David A. Doran marquent expressément leur accord

sur la réduction du capital social et le remboursement de prime d’émission.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier

l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 1.180.000.000,- (un milliard cent quatre-vingts millions d’euros), dont EUR

250,- (deux cent cinquante euros) pour l’associé commandité et EUR 1.179.999.750,- (un milliard cent soixante-dix-neuf
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros) pour les associés commanditaires.

Le capital est représenté par 47.200.000 (quarante-sept millions deux cent mille) parts sociales, ayant chacune une

valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), dont 10 (dix) parts de commandité, et 47.199.990 (quarante-sept
millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) parts de commanditaires.

Chaque part de commandité ou part de commanditaire donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées

générales ordinaires et extraordinaires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Pesch, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, vol. 21CS, fol. 87, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059630.3/211/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

J. Elvinger.

59849

COMPAGNIE DE RESERVATIONS, SERVICES ET INVESTISSEMENTS HOTELIERS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 42.393. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG01384, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058602.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

LISGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.297. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01692, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058680.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.600.000.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 102.130. 

Les comptes annuels de RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l. au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7

juillet 2005, réf. LSO-BG03089, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058881.3/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

EUROVIEW REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.497. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01617, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058474.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

NABEUL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 77.210. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG01437, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058576.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Echternach, le 7 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour <i>RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l.
W. Zettel
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

59850

FORSYTHIA MANAGEMENT &amp; ENGINEERING (F.M.E.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.644. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF07044, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058563.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT DES DOUZE S.A. (S.I.D.), Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.657. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF07038, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058569.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 36.195. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01431, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058585.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

2 LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 74.908. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01430, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058587.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

GAUME SECOURS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 86, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 107.828. 

L’an deux mille cinq, le seize juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Daniel Charlier, chauffeur, demeurant 60, rue de Dampicourt, B-6762 Saint-Mard / Virton.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter:
1) Qu’il est l’associé unique de la société à responsabilité limitée Gaume Secours Luxembourg, avec siège social à L-

2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, dont il détient l’intégralité des parts sociales.

2) Que la société Gaume Secours Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous la section B, numéro 107.828, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 avril
2005, non encore publié au Mémorial C.

3) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

4) Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité des parts sociales, a pris les décisions suivantes, conformes à

l’ordre du jour:

Signature.

Signature.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

59851

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg à 86, rue

du Canal, L-4051 Esch-sur-Alzette et de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. 1

er

 alinéa. «Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’objet social de la société en insérant après le premier alinéa de l’article 4 un

nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante:

Art. 4. 2

e

 alinéa. «La société a également pour objet le commerce en détail de tissus d’habillement et d’ameuble-

ment, de bijouterie de fantaisie, de gadgets, de rideaux, de vitrages et d’articles d’ameublement divers en matières
textiles.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Charlier, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, vol. 148S, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(059438.3/212/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

GAUME SECOURS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 86, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 107.828. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059439.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

FINANCIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 37.689. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG01424, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058599.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

WINDPOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 93.992. 

L’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2005 a nommé:
- Monsieur Klaus Brucherseifer, assessor jur., né le 11 février 1957 à Trêves, demeurant à D-54294 Trèves, Gratians-

traße 10, administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Hoffmann, dont il terminera le mandat expirant à l’is-
sue de rassemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2009;

- Monsieur Luc Reinig, ingénieur, né le 26 novembre 1972 à Luxembourg, demeurant à L-7662 Medernach, 4, Hals-

bach, administrateur en remplacement de Monsieur Nicolas Glaesener, dont il terminera le mandat expirant à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059025.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

P. Frieders.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

WINDPOWER S.A.
Signature

59852

ASHANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.752. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01416, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058604.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.299. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 24 juin 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
* Monsieur Marcus P.S. Thompson, Chief Investment Officer, Level 17, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong,
* Monsieur George Alton Raffini, Managing Director, HSBC PRIVATE EQUITY (ASIA) LIMITED, Level 17, 1 Queen’s

Road Central, Hong Kong,

* Monsieur Vincent James Warner, Director, HSBC PRIVATE EQUITY (ASIA) LIMITED, Level 17, 1 Queen’s Road

Central, Hong Kong

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2006,

- de renouveler le mandat de:
* KPMG AUDIT, Société Civile, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une

période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01538. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058632.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

MULHOUSE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.760. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, du 14 juin 2005:
* que la démission des administrateurs suivants Monsieur Norbert Schmitz, Monsieur J. Bintner et S. G. A. SERVICES

S.A., avec effet au 14 juin 2005, est acceptés;

* que la nomination de Monsieur Karl Stagl, domicilié à Karl Millöcker, G. 1-9, 2353 Gunstramsdorf, Autriche, de

Monsieur Anders Ericsson, domicilié à Segersta Gårds Väg 13, SE-746 93 Bålsta, Suède, de Monsieur Roman Scharf, do-
micilié à Gumpendorfer Straße 83-85, 1060 Vienne, Autriche et de Monsieur Daniel Mattes domicilié au Ginzkeystraße
5, 4600 Wels, Autriche, au poste d’Administrateurs, avec effet au 14 juin 2005, est acceptée. Ils poursuivent le mandat
de leurs prédécesseurs qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle de 2010;

* que la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Eric Herrmans est acceptée,
* que la nomination du Commissaire aux Comptes, La société ANGLO NORDIC LIMITED, avec Siège social à Akara

Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Les Iles Vierges Britanniques, avec effet au 14 juin
2005, est acceptée;

* que le changement du siège social au 25A, boulevard Royal. L-2449 Luxembourg est accepté.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03914. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058647.3/5029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANOUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
N. Thomsen

59853

SALON TERESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 6, rue Macher.

R. C. Luxembourg B 72.991. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01711, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058682.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

SELF SERVICE VIVOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 2, place de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 75.227. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01728, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058684.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

SELF SERVICE VIVOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 2, place de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 75.227. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01730, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058685.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Londres.

Siège de direction effective: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 83.654. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que le rapport du réviseur d’enterprises y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03108, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(058870.3/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

SOFT SHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wassserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 90.993. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03155, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(059068.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Echternach, le 7 juillet 2005.

Signature.

Echternach, le 7 juillet 2005.

Signature.

Echternach, le 7 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’enterprises
Signatures

59854

CITIGROUP PARTICIPATION LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.197. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que le rapport du réviseur d’enterprises y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03111, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(058871.3/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

RALLY LUX HOLDING TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.612.500.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 102.129. 

Les comptes annuels de RALLY LUX HOLDING TWO, S.à r.l. au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le

7 juillet 2005, réf. LSO-BG03078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058879.3/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

NAKAISPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.463. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 13 juin 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en rempla-
cement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Lors de cette même Assemblée, MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg a été nommé aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Ensuite, lors de cette Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, UNIVERSAL MANA-

GEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enfin, cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur.
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058715.3/029/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour RALLY LUX HOLDING TWO, S.à r.l. 
W. Zettel
<i>Gérant

<i>Pour NAKAISPA HOLDING S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

59855

MK GESTION &amp; PARTICIPATION S.A., Société Anonyme,

(anc. BOISSONS DE L’EST S.A.).

Siège social: L-6665 Herborn, 1, Fleeschgaass.

R. C. Luxembourg B 100.313. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01700, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058681.3/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

INTERNATIONAL WAVE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.511. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01836, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059050.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

PATRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.138. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01818, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059063.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

BUGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 99.929. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03159, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, le 1

er

 juillet 2005.

(059070.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

TOGO LUXE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 101.417. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03161, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

(059072.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Echternach, le 7 juillet 2005.

Signature.

Signatures.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’enterprises
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’enterprises
Signatures

59856

PERALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.476. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01831, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059069.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

THE BRIDGE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.965. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01825, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059071.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

AGNES CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 126, rue Michel Weber.

R. C. Luxembourg B 94.222. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03164, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(059073.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

AMPERSAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.562. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01796, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059074.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Siganture.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’enterprises
Signatures

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Auto-Boutique, S.à r.l.

Financière Esch

San Bernardino International Holding S.A.

Bastion Limited Partner

Société de Participations Ricordeau S.A.

West-El, S.à r.l.

Infralux, S.à r.l.

Luxembourg Global Asset Management S.A.

Bastion Lux Participation

Euroinvest (Poland 2), S.à r.l.

Docu Group (Lux 2), S.à r.l.

Florida Immo S.A.

Multiple Managers Sicav

Reiss Holding S.A.

Charme Investments S.C.A.

Tetra Laval Finance &amp; Treasury Luxembourg S.A.

Docu Group (Lux 1), S.à r.l.

Finapol, S.à r.l.

Ding International

Para Press S.A.

IBM Services Financial Sector Luxembourg, S.à r.l.

Sogis, S.à r.l.

Franvest Investissements

Franvest Investissements

Marinelli Immobilière, S.à r.l.

Euroinvest (Poland 1), S.à r.l.

Claymore Holding S.A.

Masco Europe SCS

Compagnie de Réservations, Services et Investissements Hôteliers S.A.

Lisgo, S.à r.l.

Rally Lux Holding One, S.à r.l.

Euroview Real Estate, S.à r.l.

Nabeul International S.A.

Forsythia Management &amp; Engineering (F.M.E.) S.A.

Société d’Investissement des Douze S.A. (S.I.D.)

Compagnie Financière Industrielle S.A.

2 Lux S.A.

Gaume Secours Luxembourg

Gaume Secours Luxembourg

Financière Notre-Dame S.A.

Windpower S.A.

Ashantis S.A.

Wardley Asia Pacific Investments Limited

Mulhouse Investissements S.A.

Salon Teresa, S.à r.l.

Self Service Vivot, S.à r.l.

Self Service Vivot, S.à r.l.

Citigroup International Luxembourg Limited

Soft Shoes S.A.

Citigroup Participation Luxembourg Limited

Rally Lux Holding Two, S.à r.l.

Nakaispa Holding S.A.

MK Gestion &amp; Participation S.A.

International Wave Holding

Patris S.A.

Bugs S.A.

Togo Luxe

Peralex S.A.

The Bridge Group S.A.

Agnès Constructions, S.à r.l.

Ampersand S.A.