This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
54913
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1145
4 novembre 2005
S O M M A I R E
Advanced Supplies Investments S.A., Luxem-
I.L.V. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54951
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54958
Idea Light, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54922
Akaccia Investments Holding S.A., Luxembourg . .
54952
Information & Communication Technologies Eu-
Akaccia Investments Holding S.A., Luxembourg . .
54958
rope S.A. «ICT Europe S.A.», Strassen . . . . . . . .
54943
Aqua d’Or S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54922
KNL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54915
Arbed Building Concepts S.A., Esch-sur-Alzette . .
54914
KNL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54915
Areco Holding Société Anonyme, Luxembourg . . .
54942
KNL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54915
Atradius Emerging Markets S.A., Luxembourg . . .
54948
KNL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54915
Atradius Emerging Markets S.A., Luxembourg . . .
54948
Larochette Investment S.A., Luxembourg . . . . . .
54958
Atradius Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54944
Logan Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
54952
Atradius Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54944
Lunetterie, S.à r.l., Mensdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . .
54949
Atradius Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54944
Lux-Audit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54943
B-Technic S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54951
Luxembourg Business Consultants S.A., Luxem-
Baltic Financial Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .
54933
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54942
C.T.T.L. Centre de Télécommunications et
Luxmédical, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . .
54922
Téléinformatique Luxembourgeois S.A., Lu-
Mat & Kam, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
54916
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54922
Mawashi Geri S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54953
Cardinal Participations et Investissements S.A. . . .
54948
Mobile Business S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
54943
Carlyle/Riverstone Participations, S.à r.l., Luxem-
Montségur Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54952
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54959
Montségur Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54952
Carlyle/Riverstone Participations, S.à r.l., Luxem-
Pagos, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54950
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54960
Palos Rent a Car, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . .
54950
Centrale Informatique S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54943
Panatella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54933
Cité du Soleil S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54929
Panatella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54934
Cornaline International Holding S.A., Luxem-
Panatella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54934
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54945
Panatella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54934
Cult Mix, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54933
Pudel, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54914
Da Silva Services, S.à r.l., Berchem . . . . . . . . . . . . .
54954
Quatrième Place S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . .
54950
Dimetal International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
54953
SOFICOSA, Société Financière des Construc-
Emsay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54953
tions S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54949
Euroclear Finance 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54930
Société Européenne d’Aquaculture, S.à r.l., Lu-
Euroclear Finance 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54933
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54933
F.S.A. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54951
Solar und Vakuum Technologie (SVT) A.G. . . . . .
54949
Ficel Office Center S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54944
Strange, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
54923
Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A., Luxem-
T&B Investissement S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . .
54914
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54915
Texinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54953
Fiduciaire Centrale du Luxembourg Salaires et
Tinska Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54914
Social S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54945
Torrent Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54929
Flandre Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
54934
Ultracalor Commercial S.A., Niederanven . . . . . .
54929
Garage Albert Pauly-Losch, S.à r.l., Strassen . . . . .
54950
Vandemoortele Participations S.A., Luxembourg
54914
Geo-Bildinx, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54949
VICARE S.A., Victoire Abeille Réassurances, Lu-
Gilead Sciences Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54950
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54955
Waistuff, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54929
Gilead Sciences Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Westchester S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54935
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54957
54914
VANDEMOORTELE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 93.002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03729, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049464.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
T&B INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.434.
—
Le bilan au 9 mai 2005, (date de dissolution de la société), enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-
BF02837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049512.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
ARBED BUILDING CONCEPTS, Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.646.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02289, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050365.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PUDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 49, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.447.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01662, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050065.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
TINSKA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 53.154.
—
La convention de domiciliation conclue le 3 novembre 2000 entre SG AUDIT, S.à r.l. (alors dénommée STENHAM
GESTINOR AUDIT, S.à r.l.), 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. n
°
75.908, et la société
TINSKA REAL ESTATE S.A., R.C. B 53.154, a été résiliée avec effet au 17 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04191. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050135.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Signature.
Strassen, le 13 juin 2005.
Signature.
Signature.
<i>Pour PUDEL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
54915
KNL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06192, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(049966.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
KNL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06196, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(049976.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
KNL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06198, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(049982.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
KNL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06219, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050016.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 57.321.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01685, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050102.3/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
54916
MAT & KAM, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 108.616.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fifteenth day of June.
Before Maître Léon Thomas, known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
Mr Dariusz Jerzy Krajewski, businessman, born in Chelm (Poland), on April 21st, 1967, residing in 119 Ragged Staff
Whare, Queensway Quay, Gibraltar,
duly represented by Maître Sonja Streicher, «Avocat», residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
by virtue of a power of attorney under private seal given in Luxembourg on March 12th, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder, acting in her above mentioned capacity, and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration au-
thorities.
Such appearing person, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles
of association of a limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the
present articles:
Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,
a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), which will be governed by the laws in force, namely
the law of August 10th, 1915 on the commercial companies, as amended, and by the present articles of association,
under the name of MAT & KAM, GmbH (hereafter referred to as «the Corporation»).
Art. 2. The Corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the sole manager or the board of managers.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the nationality of the Corporation. The declaration of the transfer of the registered office
will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Corporation which is best situated for
this purpose under the given circumstances.
Art. 4. The purpose of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.
The Corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Title II. Capital - Units
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five
hundred) units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, which have been fully subscribed and paid in.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of mem-
bers of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the Corporation.
The capital and other provisions of these articles of association may, at any time, be changed by the sole member or
by a majority of members representing at least 3/4 (three quarters) of the capital. The members may also change the
nationality of the Corporation by unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-
ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the Corporation.
The same applies in case of a conflict between the usufructuary («usufruitier») and the bare owner («nu-pro-
priétaire») or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
54917
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to its relation-
ship with the number of units in existence.
Art. 8. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on
minutes or drawn-up in writing.
Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.
Art. 9. If the Corporation has at least two members, the units are freely transferable between the members.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of the members
representing at least 3/4 (three quarters) of the Corporation’s capital.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units
representing no less than 3/4 (three quarters) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
The Corporation may, to extent and under terms permitted by law acquire its own units.
Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the Corporation.
Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets
or documents of the Corporation, nor interfere in any manner in the management of the Corporation.
Title III. Management and audit
Art. 12. The Corporation shall be managed by one or several managers, who need not be members of the Corpo-
ration.
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of the members.
The general meeting of the members determines the manager’s/managers’ powers, compensation and duration of
their mandates. Each term of their mandate may not exceed a period of six years and they shall hold office until their
successors are appointed.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or by any other manager, at the place indicated in the
notice of meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.
This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each manager. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-
agers’ meetings.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any two managers.
Art. 15. The sole manager/board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administra-
tion and disposition on behalf of the Corporation in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of the members fall within the competence of the
sole manager/board of managers.
The sole manager/board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the
Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the gen-
eral meeting of the members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which
need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the manager/board of managers shall
determine. The manager/board of managers may also confer all powers and special mandates to any person who need
not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 16. The Corporation will be bound by the sole signature of the single manager or by the sole signature of any
manager in case of plurality of managers.
54918
Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally responsible for the obligations
of the Corporation. As agents of the Corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-
cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Cor-
poration and shall terminate on December 31st, of the year two thousand and five.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager/board of managers as at the end of each fiscal year and
will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation. Each member may inspect at any time
the annual accounts and in general the books of the Corporation at the registered office of the Corporation. The credit
balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and
the provisions represents the net profit of the Corporation.
Out of the annual net profits of the Corporation, 5% (five per cent) shall be placed into the legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the Corpo-
ration, but will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever rea-
son the latter has been touched.
The general meeting of the members, upon recommendation of the manager/board of managers, will determine by
vote how the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager/board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Cor-
poration are not threatened.
Art. 20. The financial statements of the Corporation may be audited by one or several independent or statutory
auditors. The general meeting of the members shall decide on the opportunity to appoint one or several independent
or statutory auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed 6
(six) years.
Title IV. Winding up - Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
When the liquidation is closed, the assets of the Corporation will be distributed to the members proportionally to
the units they are holding.
Art. 22. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of
August 10th, 1915 on the commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
All the units have been entirely subscribed by Mr. Dariusz Jerzy Krajewski, prenamed.
The 500 (five hundred) corporate units of the Corporation have been fully paid-up by the subscriber, proof of which
payment having been given to the undersigned notary, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euro) is as of now available to the Corporation.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.- (one thousand and five hundred Euro).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Then the sole member of the Corporation, representing the entire subscribed capital, represented as here above
stated, has immediately taken the following resolutions:
1) The registered office of the Corporation is set, at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2) The number of managers is fixed at 1 (one).
3) The following person is appointed as manager of the Corporation for an unlimited duration:
Mr Dariusz Jerzy Krajewski, prenamed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, represented as here above stated, the present deed is worded in English followed by a German version. On
request of the same appearing person, represented as here above stated, and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder, acting in her above mentioned capacity, she signed together
with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendfünf am fünfzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg,
Grossherzogtum Luxemburg.
54919
Ist erschienen:
Herr Dariusz Jerzy Krajewski, Geschäftsmann, geboren in Chelm (Polen) am 21. April 1967, wohnhaft in 119 Ragged
Staff Whare, Queensway Quay, Gibraltar,
hier vertreten durch Maître Sonja Streicher, «Avocat», beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la
Pétrusse,
aufgrund privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 12. März 2005.
Diese Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Person, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von
ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäß dem geltenden
Recht und den Artikeln der vorliegenden Satzung aufzunehmen:
Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem Zeichner und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft
werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»), die
dem derzeitigen geltenden Recht, namentlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie ab-
geändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung MAT & KAM, GmbH, gegründet (nachfolgend
«die Gesellschaft»).
Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch
im Ausland durch den alleinigen Geschäftsführer oder die Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland ver-
legt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung
von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter den
gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen in welcher Form auch immer in luxemburgischen oder ausländi-
schen Gesellschaften zu halten, ebenso wie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonst wie, und die Übertragung
durch Verkauf, Tausch oder sonst wie von Aktien, Anleihen, Schuldanerkennungen, Noten und Wertpapieren im allge-
meinen sowie das Halten, die Verwaltung, die Überwachung und Betreuung dieser Wertpapiere.
Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und der Betreuung von Finanz-, Industrie- und Handelsunter-
nehmen in Luxemburg und im Ausland und diese in jeder Hinsicht unterstützen, sei es durch die Gewährung von Dar-
lehen, Garantien oder in anderer Weise.
Die Gesellschaft kann Anleihen in jeder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen und Schuldanerkennungen aus-
geben.
Sie kann grundsätzlich sämtliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen unternehmen, sowie jede Handlungen ausführen,
die sie für die Verfolgung und Entwicklung des Gesellschaftszweckes für notwendig erachtet.
Titel II. Gesellschaftskapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 500
(fünfhundert) Geschäftsanteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche voll gezeichnet und einbezahlt wurden.
Art. 6. Jede ordnungsmäßige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft
vertreten. Sie wird die weitestgehenden Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft an-
zuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschaf-
ters oder per Beschluss der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 (drei Viertel) des Stammkapitals vertreten, geändert
werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der Gesell-
schafter herbeigeführt werden.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Be-
sitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäfts-
anteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt
wurde.
Das gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher («usufruitier») und dem Eigentümer («nu-propriétai-
re») oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten
proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen.
54920
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-
schafterversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein
Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin sind Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen
Gesellschaft geschlossen werden, in ein Protokoll aufzunehmen, oder schriftlich abzufassen.
Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen
eingegangen werden.
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaf-
tern übertragbar.
Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern
die mindestens 3/4 (drei Viertel) des Stammkapitals vertreten, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von
der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als 3/4 (drei Viertel) der Rechte der verbleibenden Gesellschaf-
ter vertreten. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen ihre eigenen Anteile erwerben.
Art. 10. Der Konkurs oder die Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Ge-
sellschaft zur Folge.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der
Gesellschaft eingreifen.
Titel III. Geschäftsführung und Prüfung
Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführer(n), die nicht Gesellschafter der
Gesellschaft sein müssen.
Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und
abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats, welches sechs Jahre
nicht überschreiten darf, wobei diese ihr Amt noch solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann weiterhin einen
Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten der Protokolle der Sit-
zungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer zusam-
men und zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen,
wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax durch jeden Geschäftsführer ver-
zichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und
an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbe-
schluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm,
Telex oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern
auf der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung an-
wesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.
Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben dieselbe Wirkung
wie Beschlüsse, über die auf Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzenden unterzeichnet oder, in
dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.
Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise vorgelegt
werden können, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 15. Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Ver-
waltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen
in die Zuständigkeit des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer.
Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und
Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Ange-
legenheiten, mit vorherigem Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an
ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter
den Bedingungen und Befugnissen, die vom Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer festgelegt werden, beraten und
beschließen. Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten
54921
an jede Person, welche nicht zwingend Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und
ihre Bezüge festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder im Falle von mehre-
ren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen
der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen ob-
liegenden Pflichten.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember
eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung und
endet am 31. Dezember zweitausendfünf.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den Geschäftsführer/den Rat der Geschäftsführer ein Jah-
resabschluss erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann
zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen. Das Gut-
haben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Provisionen
stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage
verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht
haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt aber auf bis zur vollständigen Wie-
derherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen auch immer die Rücklagen ange-
griffen werden müssen.
Auf Empfehlung des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer entscheidet die Gesellschafterversammlung durch
Beschluss über die Verwendung des jährlichen Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. Dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne,
3. Die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer außerordentlichen Generalver-
sammlung der Gesellschafter gefasst,
4. Die Zahlungen erfolgen nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Ge-
sellschaft nicht berührt werden.
Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer oder
Aufsichtskommissare erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung eines
oder mehrerer Wirtschaftsprüfer(s) oder Aufsichtskommissare(s) und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer des
Mandats, welches 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, fest.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-
che natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt
werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie hal-
ten, den Gesellschaftern zugeteilt.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-
zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Sämtliche Anteile wurden von Herrn Dariusz Jerzy Krajewski, vorbenannt, voll gezeichnet.
Die 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile wurden vollständig durch den Zeichner eingezahlt, der Nachweis über die Ein-
zahlung ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhun-
dert Euro) ab heute zur Verfügung der Gesellschaft steht.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-
lass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 1.500,- (eintausendfünfhundert Euro) abgeschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Alsdann fasste nach der Gründung der Gesellschaft der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorbenannt, welcher
das gesamte Stammkapital vertritt folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf 1 (einen) festgesetzt.
3) Wird als Geschäftsführer für unbestimmte Zeit bestellt:
Herr Dariusz Jerzy Krajewski, vorbenannt.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben genann-
ten erschiene Person, vertreten wie vorbenannt, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt
von einer deutschen Übersetzung. Auf Wunsch derselben erschienenen Person, vertreten wie vorbenannt, und im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
54922
Und nach Verlesung der Urkunde an die Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, hat diese zusammen mit dem
Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: S. Streicher, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, vol. 24CS, fol. 58, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(052564.3/222/380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
IDEA LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 38, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 50.576.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01664, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050067.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
C.T.T.L. CENTRE DE TELECOMMUNICATIONS ET TELEINFORMATIQUE LUXEMBOURGEOIS
S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 33.061.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 2003+2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01666, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050074.3/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
LUXMEDICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 74, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 46.537.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01668, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050076.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
AQUA D’OR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald.
R. C. Luxembourg B 43.011.
—
Le bilan au 13 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05040, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050108.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Luxemburg-Bonneweg, den 20. Juni 2005.
T. Metzler.
<i>Pour IDEA LIGHT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour C.T.T.L. CENTRE DE TELECOMMUNICATIONS ET TELEINFORMATIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour LUXMEDICAL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
N. Crahay.
54923
STRANGE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 108.622.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fifteenth day of June.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
Mr. Przemyslaw Ireneusz Szostak, businessman, born in Bedzin (Poland) on June 16th, 1965, residing in 24, Rosia Pla-
za, Rosia Road, Gibraltar,
duly represented by Maître Sonja Streicher, «Avocat», residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
by virtue of a power of attorney under private seal given in Luxembourg on March 12th, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder, acting in her above mentioned capacity, and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration au-
thorities.
Such appearing person, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles
of association of a limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the
present articles:
Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,
a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), which will be governed by the laws in force, namely
the law of August 10th, 1915 on the commercial companies, as amended, and by the present articles of association,
under the name of STRANGE, GmbH (hereafter referred to as «the Corporation»).
Art. 2. The Corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the sole manager or the board of managers.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the nationality of the Corporation. The declaration of the transfer of the registered office
will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Corporation which is best situated for
this purpose under the given circumstances.
Art. 4. The purpose of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.
The Corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Title II. Capital - Units
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five
hundred) units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, which have been fully subscribed and paid in.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of mem-
bers of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the Corporation.
The capital and other provisions of these articles of association may, at any time, be changed by the sole member or
by a majority of members representing at least 3/4 (three quarters) of the capital. The members may also change the
nationality of the Corporation by unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-
ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the Corporation.
The same applies in case of a conflict between the usufructuary («usufruitier») and the bare owner («nu-pro-
priétaire») or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
54924
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to its relation-
ship with the number of units in existence.
Art. 8. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on
minutes or drawn-up in writing.
Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.
Art. 9. If the Corporation has at least two members, the units are freely transferable between the members.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of the members
representing at least 3/4 (three quarters) of the Corporation’s capital.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units
representing no less than 3/4 (three quarters) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
The Corporation may, to extent and under terms permitted by law acquire its own units.
Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the Corporation.
Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets
or documents of the Corporation, nor interfere in any manner in the management of the Corporation.
Title III. Management and audit
Art. 12. The Corporation shall be managed by one or several managers, who need not be members of the Corpo-
ration.
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of the members.
The general meeting of the members determines the manager’s/managers’ powers, compensation and duration of
their mandates. Each term of their mandate may not exceed a period of six years and they shall hold office until their
successors are appointed.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or by any other manager, at the place indicated in the
notice of meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.
This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each manager. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-
agers’ meetings.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any two managers.
Art. 15. The sole manager/board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administra-
tion and disposition on behalf of the Corporation in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of the members fall within the competence of the
sole manager/board of managers.
The sole manager/board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the
Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the gen-
eral meeting of the members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which
need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the manager/board of managers shall
determine. The manager/board of managers may also confer all powers and special mandates to any person who need
not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 16. The Corporation will be bound by the sole signature of the single manager or by the sole signature of any
manager in case of plurality of managers.
54925
Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally responsible for the obligations
of the Corporation. As agents of the Corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-
cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Cor-
poration and shall terminate on December 31st, of the year two thousand and five.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager/board of managers as at the end of each fiscal year and
will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation. Each member may inspect at any time
the annual accounts and in general the books of the Corporation at the registered office of the Corporation. The credit
balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and
the provisions represents the net profit of the Corporation.
Out of the annual net profits of the Corporation, 5% (five per cent) shall be placed into the legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the Corpo-
ration, but will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever rea-
son the latter has been touched.
The general meeting of the members, upon recommendation of the manager/board of managers, will determine by
vote how the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager/board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Cor-
poration are not threatened.
Art. 20. The financial statements of the Corporation may be audited by one or several independent or statutory
auditors. The general meeting of the members shall decide on the opportunity to appoint one or several independent
or statutory auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed 6
(six) years.
Title IV. Winding up - Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
When the liquidation is closed, the assets of the Corporation will be distributed to the members proportionally to
the units they are holding.
Art. 22. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of
August 10th, 1915 on the commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the units have been entirely subscribed by Mr. Przemyslaw Ireneusz Szostak, prenamed.
The 500 (five hundred) corporate units of the Corporation have been fully paid-up by the subscriber, proof of which
payment having been given to the undersigned notary, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euro) is as of now available to the Corporation.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.- (one thousand and five hundred Euro).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Then the sole member of the Corporation, representing the entire subscribed capital, represented as here above
stated, has immediately taken the following resolutions:
1) The registered office of the Corporation is set at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2) The number of managers is fixed at 1 (one).
3) The following person is appointed as manager of the Corporation for an unlimited duration:
Mr. Przemyslaw Ireneusz Szostak, prenamed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, represented as here above stated, the present deed is worded in English followed by a German version. On
request of the same appearing person, represented as here above stated, and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder, acting in her above mentioned capacity, she signed together
with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendfünf am fünfzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg,
Grossherzogtum Luxemburg.
54926
Ist erschienen:
Herr Przemyslaw Ireneusz Szostak, Geschäftsmann, geboren in Bedzin (Polen) am 16. Juni 1965, wohnhaft in 24, Rosia
Plaza, Rosia Road, Gibraltar,
hier vertreten durch Maître Sonja Streicher, «Avocat», beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la
Pétrusse,
aufgrund privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 12. März 2005.
Diese Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Person, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von
ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäß dem geltenden
Recht und den Artikeln der vorliegenden Satzung aufzunehmen:
Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem Zeichner und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft
werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»), die
dem derzeitigen geltenden Recht, namentlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie ab-
geändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung STRANGE, GmbH gegründet (nachfolgend «die
Gesellschaft»).
Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch
im Ausland durch den alleinigen Geschäftsführer oder die Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland ver-
legt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung
von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter den
gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen in welcher Form auch immer in luxemburgischen oder ausländi-
schen Gesellschaften zu halten, ebenso wie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonst wie, und die Übertragung
durch Verkauf, Tausch oder sonst wie von Aktien, Anleihen, Schuldanerkennungen, Noten und Wertpapieren im allge-
meinen sowie das Halten, die Verwaltung, die Überwachung und Betreuung dieser Wertpapiere.
Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und der Betreuung von Finanz-, Industrie- und Handelsunter-
nehmen in Luxemburg und im Ausland und diese in jeder Hinsicht unterstützen, sei es durch die Gewährung von Dar-
lehen, Garantien oder in anderer Weise.
Die Gesellschaft kann Anleihen in jeder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen und Schuldanerkennungen aus-
geben.
Sie kann grundsätzlich sämtliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen unternehmen, sowie jede Handlungen ausführen,
die sie für die Verfolgung und Entwicklung des Gesellschaftszweckes für notwendig erachtet.
Titel II. Gesellschaftskapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 500
(fünfhundert) Geschäftsanteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche voll gezeichnet und einbezahlt wurden.
Art. 6. Jede ordnungsmäßige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft
vertreten. Sie wird die weitestgehenden Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft an-
zuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschaf-
ters oder per Beschluss der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 (drei Viertel) des Stammkapitals vertreten, geändert
werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der Gesell-
schafter herbeigeführt werden.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Be-
sitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäfts-
anteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt
wurde.
Das gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher («usufruitier») und dem Eigentümer («nu-propriétai-
re») oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten
proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen.
54927
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-
schafterversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein
Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin sind Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen
Gesellschaft geschlossen werden, in ein Protokoll aufzunehmen, oder schriftlich abzufassen.
Nichtsdestotrotz ist diese letzte Bedingung nicht anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen
eingegangen werden.
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaf-
tern übertragbar.
Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern
die mindestens 3/4 (drei Viertel) des Stammkapitals vertreten, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von
der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als 3/4 (drei Viertel) der Rechte der verbleibenden Gesellschaf-
ter vertreten. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen ihre eigenen Anteile erwerben.
Art. 10. Der Konkurs oder die Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Ge-
sellschaft zur Folge.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der
Gesellschaft eingreifen.
Titel III. Geschäftsführung und Prüfung
Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführer(n), die nicht Gesellschafter der
Gesellschaft sein müssen.
Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und
abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats, welches sechs Jahre
nicht überschreiten darf, wobei diese ihr Amt noch solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann weiterhin einen
Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten der Protokolle der Sit-
zungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer zusam-
men und zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen,
wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax durch jeden Geschäftsführer ver-
zichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und
an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbe-
schluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm,
Telex oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern
auf der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung an-
wesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.
Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben dieselbe Wirkung
wie Beschlüsse, über die auf Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzenden unterzeichnet oder, in
dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.
Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise vorgelegt
werden können, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 15. Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Ver-
waltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen
in die Zuständigkeit des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer.
Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und
Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Ange-
legenheiten, mit vorherigem Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an
ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter
den Bedingungen und Befugnissen, die vom Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer festgelegt werden, beraten und
beschließen. Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten
54928
an jede Person, welche nicht zwingend Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und
ihre Bezüge festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder im Falle von mehre-
ren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen
der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen ob-
liegenden Pflichten.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember
eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung und
endet am 31. Dezember zweitausendfünf.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den Geschäftsführer/den Rat der Geschäftsführer ein Jah-
resabschluss erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann
zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen. Das Gut-
haben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Provisionen
stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage
verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht
haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt aber auf bis zur vollständigen Wie-
derherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen auch immer die Rücklagen ange-
griffen werden müssen.
Auf Empfehlung des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer entscheidet die Gesellschafterversammlung durch
Beschluss über die Verwendung des jährlichen Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. Dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne,
3. Die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer außerordentlichen Generalver-
sammlung der Gesellschafter gefasst,
4. Die Zahlungen erfolgen nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Ge-
sellschaft nicht berührt werden.
Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer oder
Aufsichtskommissare erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung eines
oder mehrerer Wirtschaftsprüfer(s) oder Aufsichtskommissare(s) und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer des
Mandats, welches 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, fest.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-
che natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt
werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie hal-
ten, den Gesellschaftern zugeteilt.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-
zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Sämtliche Anteile wurden von Herrn Przemyslaw Ireneusz Szostak, vorbenannt, voll gezeichnet.
Die 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile wurden vollständig durch den Zeichner eingezahlt, der Nachweis über die Ein-
zahlung ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhun-
dert Euro) ab heute zur Verfügung der Gesellschaft steht.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-
lass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 1.500,- (eintausendfünfhundert Euro) abgeschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Alsdann fasste nach der Gründung der Gesellschaft der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorbenannt, welcher
das gesamte Stammkapital vertritt folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf 1 (einen) festgesetzt.
3) Wird als Geschäftsführer für unbestimmte Zeit bestellt:
Herr Przemyslaw Ireneusz Szostak, vorbenannt.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben genann-
ten erschiene Person, vertreten wie vorbenannt, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt
von einer deutschen Übersetzung. Auf Wunsch derselben erschienenen Person, vertreten wie vorbenannt, und im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
54929
Und nach Verlesung der Urkunde an die Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, hat diese zusammen mit dem
Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: S. Streicher, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, vol. 24CS, fol. 58, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(052631.3/222/380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
CITE DU SOLEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.
R. C. Luxembourg B 85.497.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01672, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050081.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
WAISTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.
R. C. Luxembourg B 92.035.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01670, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050083.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ULTRACALOR COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6944 Niederanven, 33, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 6.632.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01674, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050087.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
TORRENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 85.057.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-
BF04362, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050554.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Luxemburg-Bonneweg, den 20. Juni 2005.
T. Metzler.
<i>Pour CITE DU SOLEIL S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour WAISTUFF, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ULTRACALOR COMMERCIAL S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
54930
EUROCLEAR FINANCE 2 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 108.194.
—
In the year two thousand and five, on the seventh of June.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Paul Decker, no-
tary, residing in Luxembourg-Eich.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company EUROCLEAR
FINANCE 2 S.A. a «société anonyme» incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-1882 Lux-
embourg, 5, rue Guillaume Kroll,
incorporated by a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on May 4th 2005, not yet published
in the Recueil du Mémorial C,
filed in the Luxembourg trade register (R.C.S. B 108.194).
The meeting was opened at 3.15 p.m. and was presided by Mr. Régis Galiotto, private employee, residing profession-
nally in Luxembourg-Eich.
The Chairman appointed as secretary Mrs. Céline Fournier, private employee, residing professionnally in Luxem-
bourg-Eich.
The meeting elected as scrutineer Mr. Johny De Smet, director and administrative officer, residing professionnally in
L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the share capital from 3,900,000.- EUR to 4,500,000.- EUR, by issue of 600 new shares with a nominal
value of 1,000.- EUR each, having the same rights and obligations as the existing shares.
2. Subscription and payment in cash.
3. Renunciation by the shareholders of their preferential subscription right, if necessary.
4. To increase the authorized capital from 6,000,000.- EUR to 15,000,000.- EUR.
5. To amend subsequently Article 5, first and third paragraph of the Articles of Association which will be read as
follows:
«Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is fixed at four million five hundred thousand Euro (4,500,000.-
EUR), divided into four thousand five hundred (4,500) shares. Each issued share has a nominal value of one thousand
Euro (EUR 1,000.-) and is fully paid up.»
«Art. 5. (third paragraph). The authorised capital of the Company is set at fifteen million Euro (EUR 15,000,000)
divided into fifteen thousand (15,000) shares. Each authorised share has a nominal value of one thousand Euro (EUR
1,000.-).
6. Nomination of Mr. Yasushi Watanabe as new director.
7. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders
present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.
III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraor-
dinary general meeting.
IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The
shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.
The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopt-
ed by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital from its current amount of three million nine hundred
thousand Euro (3,900,000.- EUR) to four million five hundred thousand Euro (4,500,000.- EUR), by issue of six hundred
(600) new shares with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and obligations
as the existing shares.
The other shareholder having waived its preferential subscription right, the new shares have been entirely subscribed
by EUROCLEAR BANK S.A., a company incorporated under the laws of Belgium, with registered office at 1, boulevard
du Roi Albert II, B-1210 Brussels,
filed in Brussels, Register of Legal Entities N
°
0429.875.591,
here represented by Mr. Johny De Smet, prenamed,
by virtue of a proxy given in Brussels, on 6 June, 2005,
said proxy, after being initialled ne varietur by the appearer and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
It has been proved to the undersigned notary that the amount of six hundred thousand Euro (600,000.- EUR) is at
the free disposal of the company, who expressly acknowledges it.
54931
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to increase the authorized capital from its current amount of six million Euro
(6,000,000.- EUR) to fifteen million Euro (15,000,000.- EUR).
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend Article 5 first and third paragraph of the Articles of Incorporation, so as to
read as follows:
«Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is fixed at four million five hundred thousand Euro (4,500,000.-
EUR), divided into four thousand five hundred (4,500) shares. Each issued share has a nominal value of one thousand
Euro (EUR 1,000.-) and is fully paid up.»
«Art. 5. (third paragraph). The authorised capital of the Company is set at fifteen million Euro (EUR 15,000,000)
divided into fifteen thousand (15,000) shares. Each authorised share has a nominal value of one thousand Euro (EUR
1,000.-).
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to fix the number of directors at four and nominate Mr. Yasushi Watanabe, Managing
Director, BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., residing in L-1150 Luxembourg, 287-289, route
d’Arlon, for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 3.30 p.m.
<i>Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-
timated at 8,000.- EUR.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing per-
son, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary this original deed.
Suit la traduction en français:
L’an deux mille cinq, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hespérange, agissant en remplacement de Maître Paul Dec-
ker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROCLEAR FINANCE 2
S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich le 4 mai 2005, non
encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 108.194.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, em-
ployé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.
Le président nomme comme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg-Eich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Johny De Smet, director and administrative officer, demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation de capital pour le porter de son montant actuel de 3.900.000,- EUR à 4.500.000,- EUR par émission
de 600 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000.- EUR chacune ayant les mêmes droits et les mêmes obligations
que les actions antérieures.
2. Souscription et libération intégrale en espèces.
3. Renonciation pour autant que de besoin par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
4. Augmentation du capital autorisé pour le porter de 6.000.000,- EUR à 15.000.000,- EUR.
5. Modification correspondante de l’article 5, premier et troisième paragraphe des statuts qui aura désormais la te-
neur suivante:
«Art. 5. (premier paragraphe). Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions cinq cent mille euros (EUR
4.500.000,-) représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions. Chaque action émise a une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-) et est entièrement libérée.»
«Art. 5. (troisième paragraphe). Le capital autorisé de la Société est fixé à quinze millions d’euros (EUR
15.000.000,-) représenté par quinze mille (15.000,-) actions. Chaque action autorisée a une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-).»
6. Nomination de M. Yasushi Watanabe en tant que nouvel administrateur.
7. Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
54932
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l’ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises
à l’unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital pour le porter de son montant actuel de trois millions neuf cent
mille euros (3.900.000,- EUR) à quatre million cinq cent mille euros (4.500.000,- EUR) par émission de six cents (600)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1000,- EUR) chacune ayant les mêmes droits et les mêmes obli-
gations que les actions antérieures.
Un des actionnaires actuels ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été en-
tièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par la société EUROCLEAR BANK S.A., une société de droit
belge, établie et ayant son siège social à 1, boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruxelles,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bruxelles, N
°
0429.875.591,
ici représentée par Monsieur Johny De Smet, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, le 6 juin 2005,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément que le montant de six cent mille euros
(600.000,- EUR) est à la libre disposition de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé pour le porter de son montant actuel de six million
d’euros (6.000.000,- EUR) à quinze million d’euros (15.000.000,- EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, premier et troisième paragraphe pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. (premier paragraphe). Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions cinq cent mille euros (EUR
4.500.000,-) représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions. Chaque action émise a une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-) et est entièrement libérée.»
«Art. 5. (troisième paragraphe). Le capital autorisé de la Société est fixé à quinze millions d’euros (EUR
15.000.000,-) représenté par quinze mille (15.000,-) actions. Chaque action autorisée a une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-).»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de porter le nombre d’administrateurs à quatre (4) et de nommer M. Yasushi Watanabe,
Managing Director, BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à L-1150 Luxembourg, 287-
289, route d’Arlon, pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 15.30 heures.
<i>Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison
du présent acte sont évalués à environ 8.000,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même com-
parant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Galiotto, C. Fournier, J. De Smet, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, vol. 24CS, fol. 58, case 7. – Reçu 6.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(052659.3/206/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
Luxembourg-Eich, le 20 juin 2005.
P. Decker.
54933
EUROCLEAR FINANCE 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 108.194.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 20 juin 2005.
(052663.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
BALTIC FINANCIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 83.401.
—
Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02027, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050640.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SOCIETE EUROPEENNE D’AQUACULTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.879.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04502, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 juin 2005.
(050162.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CULT MIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 7, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.271.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01683, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050093.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PANATELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01933, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(049299.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
Signature.
<i>Pour SOCIETE EUROPEENNE D’AQUACULTURE, S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour CULT MIX, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour PANATELLA HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
54934
PANATELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01929, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(049297.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
PANATELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01927, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(049296.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
PANATELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01926, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(049295.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
FLANDRE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.400.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire tenue le 11 août 2004i>
4. Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Pierre Hoffmann, Romain
Thillens et Romain Alber venant à échéance, l’Assemblée, à l’unanimité des voix, décide de renouveler leurs mandats
pour une nouvelle période d’eun an.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2004.
De même, le mandat de commissaire aux comptes DELOITTE & TOUCHE venant à échéance à l’issue de la présente
Assemblée, l’assemblée décide de ne pas renouveler son mandat et décide de nommer avec effet immédiat HRT REVI-
SION, S.à r.l. ayant son siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg. Le mandat de HRT REVISION, S.à r.l. viendra
à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05905. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(050300.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
<i>Pour PANATELLA HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour PANATELLA HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour PANATELLA HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
54935
WESTCHESTER S.C.A., Société en commandite par actions.
Registered office: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.
R. C. Luxembourg B 108.625.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the tenth day of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depository of the
present minutes.
There appeared:
1) AIM SERVICES, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
74.676,
duly represented by Mr. Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 10 June 2005; and
2) OAKBROOK S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg with registered address at 14,
rue Erasme, L-1468 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 10 June 2005.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain at-
tached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of association
of a société en commandite par actions, which they declare organised among themselves as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a company in the form of a société en commandite par actions, under the name of WESTCHESTER S.C.A.
Art. 2. The company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited shareholder with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar corporate structures.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City.
Within the same municipality, the registered office of the company may be transferred by resolution of the manager.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager.
Art. 5. The general partner of the company is liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the
company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the general partner), shall refrain from act-
ing on behalf of the company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general
meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the company.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company has a subscribed capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of six thousand
two hundred (6,200) shares with a par value five euro (EUR 5.-) each.
The subscribed capital and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the
general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The
company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 7. The shares of the company are in registered form.
A shareholders’ register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any share-
holder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by the manager upon request of the relevant shareholder.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been desig-
nated as the sole owner in relation to the company.
54936
C. General meetings of shareholders
Art. 8. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-
holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company.
The general meeting is convened by the manager or the Board of auditors.
It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the company’s
share capital.
Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-
pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 20 May. If such day is a legal
holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders
may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of
shareholders of the company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at
a meeting of shareholders duly convened will be passed with the unanimous consent of the shareholders present or
represented.
The manager may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any
meeting of shareholders.
If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
D. Management
Art. 10. The company shall be managed by OAKBROOK S.A. in its capacity as general partner (associé commandité)
and manager of the company. The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of
the company.
Art. 11. The manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing
the company’s object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of share-
holders or to the Board of auditors fall within the powers of the manager.
Art. 12. The company is validly bound vis-à-vis third parties by the sole signature of any duly appointed representa-
tive of the manager, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the manager
for specific transactions.
Art. 13. In the event of legal incapacity, liquidation, or other permanent situation preventing the manager from acting
as manager of the company, the company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the board of au-
ditors appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until
a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen days of his appointment.
At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and ma-
jority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment, the company shall be dissolved and liq-
uidated.
Art. 14. The appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the manager.
E. Board of auditors
Art. 15. The business of the company and its financial situation, including more in particular its books and accounts,
shall be supervised by a board of auditors composed of not less than three members, who need not be shareholders.
For the carrying out of its supervisory duties, the board of auditors shall have the powers of a statutory auditor, as
provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time.
Art. 16. The members of the board of auditors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period
of one year. The members of the board of auditors are re-eligible for election and may be removed at any time, with
or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.
Art. 17. In the event of the total number of members of the board of auditors falling below three or below one half
of the number of members determined by the general meeting of shareholders, the manager shall forthwith convene a
shareholders’ meeting in order to fill such vacancies. If one or more members of the board of auditors are temporarily
prevented from attending meetings of the said board, the remaining members may appoint a person chosen from within
the shareholders to provisionally replace them until they are able to resume their functions. The remuneration of the
members of the board of auditors shall be set by the general meeting of shareholders.
Art. 18. The board of auditors shall meet at the place in Luxembourg as indicated in the notice of meeting. The board
of auditors will choose from among its members a chairman. It will also choose a secretary, who need not be a member
of the board of auditors, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of auditors.
The board of auditors shall be convened by its chairman or by the manager. A meeting of the board must be convened
if any of its members so requests.
The chairman of the board of auditors will preside at all meetings of such board, but in his absence the board of au-
ditors will appoint another member of the board of auditors as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.
54937
Written notice of any meeting of the board of auditors shall be given by letter, by telefax or by electronic mail (with-
out electronic signature) to all its members at least (8) eight days prior to the date set for such meeting, except in the
case of emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of the meeting. The notice
will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof. The notice may be waived by the consent
in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Special notices shall not be
required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the board of auditors.
Any member of the board of auditors may act at any meeting of the board of auditors by appointing another member
as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A member may
represent several of his colleagues.
The board of auditors can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-
sented. Resolutions are taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.
Resolutions of the board of auditors are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Any
proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or else-
where shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.
The board of auditors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.
Any member of the board of auditors may participate in any meeting of the board of auditors by means of a confer-
ence call or by any similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one an-
other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The member(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments reg-
ularly made by them in the name of the company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The company shall indemnify any member of the board of auditors and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit, or proceeding to which he may be made a
party by reason of his being or having been a member of the board of auditors of the company. He shall not be entitled
to be indemnified in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for negligence or misconduct. In the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with
such matters covered by the settlement as to which the company is advised by its counsel that the person to be indem-
nified did not commit a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
he may be entitled.
The company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any pro-
ceeding in advance of the final disposition, so long as the company receives a written and legally binding undertaking by
such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to in-
demnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea
of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount incurred by such person and to be indemnified promptly upon noti-
fication of an obligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the company shall
reasonably require.
F. Financial year - Profits
Art. 19. The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-
ber thirty-first of the same year.
Art. 20. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the manager, will determine how the remainder of
the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by the manager by observing the terms and conditions provided for by law.
G. Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
H. Amendment of the articles of incorporation
Art. 22. Subject to the approval of the manager, these Articles may be amended from time to time by the general
meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for in article 67-1 of the law of 10 Au-
gust 1915 governing commercial companies, as amended.
I. Final clause - Applicable law
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
54938
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-
cember 2005.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) AIM SERVICES, S.à r.l., prenamed, paid thirty thousand nine hundred ninety-five euro (EUR 30,995.-) in subscrip-
tion for six thousand one hundred ninety-nine (6,199) shares;
2) OAKBROOK S.A., pre-named, paid five euro (EUR 5.-) in subscription for one (1) share;
Total: thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) paid for six thousand two hundred (6,200) shares.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now
available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been ful-
filled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred fifty (2,550.-) euro.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of managers is fixed at one and the number of members of the board of auditors at three.
2. OAKBROOK S.A., prenamed, is appointed sole manager of the company with immediate effect.
3. The following persons are appointed members of the board of auditors of the company:
a) AIM SERVICES, S.à r.l. a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
74.676;
b) Mr Guy Marie Harles, born on 4 mai 1955 in Luxembourg, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468
Luxembourg;
c) Mr Jean-Marc Ueberecken, born on 31 May 1972 in Luxembourg, with professional address at 14, rue Erasme, L-
1468 Luxembourg.
4. The address of the company is set at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
5. The term of office of the members of the board of auditors shall end at the general meeting called to approve the
accounts of the accounting year 2005 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same proxy holder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together
with Us the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendundfünf, den zehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines Kollegen
Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, momentan abwesend, welcher die gegenwärtige
Urkunde verwahren wird.
Sind erschienen:
1) AIM SERVICES, S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Geschäftsadresse in 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B
74.676,
vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 10. Juni 2005.
2) OAKBROOK S.A. eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Geschäftsadresse in 14, rue Erasme, L-1468 Lu-
xemburg, noch nicht eingetragen beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister,
vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 10. Juni 2005.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Mandatar der Erschienenen und den unter-
zeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
54939
Die Erschienenen, vertreten wie vorgennant, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
A. Name - Sitz - Dauer - Zweck
Art. 1. Es besteht eine zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestellten
Aktien eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die Bezeichnung WESTCHESTER S.C.A. führt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf,
Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie durch die Übertragung von Wertpapieren jeder Art erwerben und jegliche
sonstigen Maßnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wertpapieren
sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen treffen.
Die Gesellschaft kann daneben solchen Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder die zu ihrer
Unternehmensgruppe gehören, Darlehen gewähren, zu ihren Gunsten Bürgschaften abgeben und sie anderweitig unter-
stützen.
Die Gesellschaft kann daneben in Personengesellschaften oder in ähnlichen Gesellschaftsformen Gesellschafter mit
begrenzter oder mit unbegrenzter Haftung werden.
Die Gesellschaft kann daneben in eigenem oder fremdem Namen alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres
Zweckes förderlich sind.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäfts-
führers. Durch einfachen Beschluß des Geschäftsführers können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl
im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden.
Art. 5. Der Komplementär haftet für alle Schulden, die nicht aus den Güter der Gesellschaft beglichen werden kön-
nen. Die anderen Aktionäre (zum Ausschluss jedes Zweifels, ausschließlich des Komplementärs) sollen jede Handlung
im Namen der Gesellschaft, in jeder Art und Funktion unterlassen, außer durch Ausübung Ihrer Rechte als Aktionäre
bei Hauptversammlungen. Die Kommanditäre haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.
B. Kapital - Aktien
Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in sechstausendzwei-
hundert (6.200) Aktien mit einem Nennwert von fünf Euro (EUR 5,-) eingeteilt.
Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluß der Hauptversammlung
der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt wer-
den.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben.
Art. 7. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.
Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses
Register festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Ein-
tragung im Register bestätigen und von dem Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen
diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 8. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft.
Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer oder den Aufsichtsrat einberufen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberu-
fen werden.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der
Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am 20. Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser
Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt. Andere Hauptversam-mlungen können an den
in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.
Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den
gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestim-
mungen trifft.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-
simileübertragung oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden nur mit Einstimmigkeit
der anwesenden und vertretenen Stimmen gefaßt.
54940
Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,
um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.
Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-
nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
D. Geschäftsführung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch OAKBROOK S.A. in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Geschäftsführer
der Gesellschaft verwaltet. Die anderen Aktionäre dürfen an dieser Verwaltung der Gesellschaft weder teilnehmen noch
sich darin einmischen.
Art. 11. Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-
fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Geschäftsführer hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre oder
dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.
Art. 12. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Vertreters des
Geschäftsführers oder durch die Unterschrift jeder vom Geschäftsführer für spezifische Rechtsgeschäfte bevollmächtig-
ten Person(en) verpflichtet.
Art. 13. Im Falle einer rechtlichen Geschäftsunfähigkeit, einer Liquidation, oder einer anderen endgültigen Lage wel-
che den Geschäftsführer verhindert als Geschäftsführer der Gesellschaft zu fungieren, wird die Gesellschaft nicht un-
mittelbar aufgelöst und liquidiert, sofern der Aufsichtsrat einen Verwalter ernennt, welcher nicht Aktionär sein muss,
damit dieser die dringende Geschäftsführung übernimmt, bis eine Hauptversammlung der Aktionäre stattgefunden hat,
die der Verwalter innerhalb von fünfzehn Tagen nach seiner Ernennung, einberuft. Auf dieser Hauptversammlung kön-
nen die Aktionäre, den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen folgend, einen Nachfolger des Ge-
schäftsführers ernennen. Sollte diese Ernennung nicht geschehen, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.
Art. 14. Die Ernennung des Nachfolger des Geschäftsführers benötigt nicht die Zusage des Geschäftsführers.
E. Aufsichtsrat
Art. 15. Die Geschäfte sowie die finanzielle Situation der Gesellschaft, insbesondere ihre Bilanzen und Konten, un-
terliegen der Überwachung des Aufsichtsrats, der aus mindestens drei Mitglieder besteht, die nicht Aktionäre der Ge-
sellschaft sein müssen. Der Aufsichtsrat hat für seine Überwachungsfunktion die in Artikel 62 des Gesetzes des 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehenen Befugnisse eines Rechnungs-
prüfers.
Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wählt den Aufsichtsrat für ein Jahr. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden und können jederzeit und unbegründet durch Beschluß
der Hauptversammlung abberufen werden.
Art. 17. Sollte die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates unter drei oder unter die Hälfte der von der Hauptver-
sammlung bestimmten Zahl der Mitglieder fallen, wird durch den Geschäftsführer sofort eine Hauptversammlung ein-
berufen, um die leerstehenden Stellen zu besetzen. Ist ein oder sind mehrere Mitglieder des Aufsichtsrates
vorübergehend unfähig an dessen Versammlungen teilzunehmen, können die restlichen Mitglieder einen oder mehrere
Aktionäre ernennen, um diese bis zur Wiederaufnahme zu ersetzen.
Art. 18. Der Aufsichtsrat kommt an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort innerhalb Luxemburgs zu-
sammen. Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär be-
stellen, welcher nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des
Aufsichtsrates verantwortlich ist.
Der Aufsichtsrat wird von seinen Vorsitzenden oder von dem Geschäftsführer einberufen. Der Aufsichtsrat muss auf
Anfrage einer seiner Mitglieder einberufen werden.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Aufsichtsrates; in seiner Abwesenheit kann der Aufsichtsrat mit
Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig
zu führen.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält wenigstens acht Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Fak-
simileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungsschreiben, außer im
Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben an-
gegeben werden müssen. Das Einberufungsschreiben enthält den Ort und die Tagesordnung der Sitzung. Auf schriftliche,
durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene
Einwilligung eines jeden Mitglieds der Aufsichtsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein speziel-
les Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Aufsichtsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort
abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Aufsichtsrates auf dem Kalender festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder
durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des
Aufsichtsrats vertreten lassen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats kann mehrere andere Mitglieder vertreten.
Der Aufsichtsrat ist nut beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten
sind. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
54941
Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Protokollen festgehalten und von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Ver-
tretungsvollmächte werden an dieser angeheftet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder ander-
weitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern unterzeichnet.
Einstimmige Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftli-
cher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommu-
nikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.
Die Mitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche sie im Namen der Ge-
sellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft und sind daher aus-
schließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jedes Mitglied des Aufsichtsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Verwalter für
angemessene Kosten die im Zusammenhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen sei-
ner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind.
Das Mitglied hat kein Recht auf Entschädigung, wenn im Zusammenhang mit der Handlung, dem Prozess oder dem
Verfahren gerichtlich festgestellt wurde, dass es wegen Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung haftbar ist. Im
Falle eines Vergleiches wird Entschädigung nur in Bezug auf die im Vergleich einbegriffenen Angelegenheiten gezahlt, bei
denen die Gesellschaft von ihrem Rechtbeistand Bestätigung erhält, dass das betroffene Mitglied seine Pflichten nicht
verletzt hat. Das hiervor aufgeführte Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte die dem Mitglied zustehen sollten
nicht aus.
Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit
jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung
dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf
Entschädigung von der Gesellschaft besteht.
Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines Verfahrens durch ein Urteil, eine Anwei-
sung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Verteidigung, entsteht nicht die Vermutung, dass
die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart, durch den das Entschädigungsrecht entsteht,
nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Entschädigungsberechtigten machen, in gleicher
Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflichtungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer
Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt von den Informationen welche die Gesellschaft
vernünftigerweise fordern kann.
F. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 20. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen
Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals
oder wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.
Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Geschäftsführers über die Verwendung des rest-
lichen Betrages des Reingewinns. Der Geschäftsführer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdivi-
denden ausschütten.
G. Auflösung der Gesellschaft
Art. 21. Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrerer Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.
H. Satzungsänderung
Art. 22. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausge-
setzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften, wie abgeändert, werden beachtet.
I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 23. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915,
über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Die Zeichner habe die auszugebenen Aktien wie folgt gezeichnet:
1) AIM SERVICES, S.à r.l., vorgenannt, hat dreißigtausendneunhundertfünfundneunzig Euro (EUR 30.995,-) eingezahlt
und sechstausendeinhundertneunundneunzig (6.199) Aktien gezeichnet;
2) OAKBROOK S.A., vorgenannt, hat fünf Euro (EUR 5,-) eingezahlt und eine (1) Aktie gezeichnet;
Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingezahlt für sechstausendzweihundert (6.200) Aktien.
Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
54942
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr zweitausendfünfhundertfünfzig (2.550,-) Euro.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-
lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
2. OAKBROOK S.A. wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung.
3. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
a) AIM SERVICES, S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Geschäftsadresse in 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B
74.676;
b) Herr Guy Marie Harles, geboren am 4. Mai 1955 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue Erasme, L-1468
Luxemburg;
c) Herr Jean-Marc Ueberecken, geboren am 31. Mai 1972 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue Erasme,
L-1468 Luxemburg.
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: rue Erasme, L-1468 Luxemburg.
5. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten für das
Rechnungsjahr 2005 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, welcher Englisch spricht und versteht, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Mandatars der
vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher
Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maß-
gebend.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Mandatar der Erschienenen, hat derelbe mit Uns Notar
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Opitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, vol. 148S, fol. 86, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052686.3/230/463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 76.858.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01715, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050094.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ARECO HOLDING SOCIETE ANONYME, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 17.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08469, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054999.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.
Luxembourg, le 21 juin 2005.
A. Schwachtgen.
<i>Pour LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
54943
CENTRALE INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 23.318.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01719, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050096.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
MOBILE BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 78.014.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01721, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050097.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
LUX-AUDIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 25.797.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01713, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050098.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES EUROPE S.A. «ICT EUROPE S.A.»,
Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 84.502.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2005i>
Sont présents:
(1) AUDICO INTERNATIONAL S.A.
(2) SCOTMARSH FOUNDATION LLC.
L’assemblée a accepté la démission des administrateurs:
* MAYA INVEST LTD,
* AUDICO INTERNATIONAL S.A.,
* SCOTMARSH FOUNDATION LLC.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02691. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050482.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
<i>Pour CENTRALE INFORMATIQUE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour MOBILE BUSINESS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour LUX-AUDIT S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
L. Voet
<i>Un mandatairei>
54944
FICEL OFFICE CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 85.739.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01717, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050101.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ATRADIUS RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 27.110.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2005i>
6. Nominations statutaires
Le mandat de Monsieur Jean Pirrotte vient à échéance; il est reconduit pour une durée de 6 ans, prenant fin à l’As-
semblée Générale de 2011.
7. Reconduction du mandat du Réviseur Externe et fixation de ses émoluments
Le mandat du Réviseur Externe, la Société KPMG dont le siège est situé 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vient
à échéance et est renouvelé pour une période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale d’avril 2006.
Luxembourg, le 20 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2005, réf. LSO-BF00336. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(050184.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ATRADIUS RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 27.110.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02987, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050186.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ATRADIUS RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 27.110.
—
EXTRAIT
II résulte d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue sous seing privé en date du 19 avril
2005, enregistrée à Luxembourg - Sociétés, le 1
er
juin 2005, Référence LSO-BF00336, que:
Le mandat de Monsieur Jean Pirrotte, demeurant au 2, allée Léopold Goebels, L-1635 Luxembourg, est reconduit
pour une durée de six ans, prenant fin à l’assemblée générale de 2011.
Le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT, dont le siège est situé au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, est renouvelé pour une période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale d’avril 2006.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050174.3/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
<i>Pour FICEL OFFICE CENTER S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
G. van Brakel
<i>Administrateur-déléguéi>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 15 juin 2005.
Signature.
54945
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SALAIRES ET SOCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 29.200.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01710, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(050104.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CORNALINE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 108.949.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edi-
fico Tila, Officina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 440712, doc. 535811,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 23 juin 2005;
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama
- République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 23 juin 2005.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CORNALINE INTERNATIONAL HOLDING
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières négociables.
La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
<i>Pour FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SALAIRES ET SOCIAL S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
54946
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 27 juin 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 29 mai à 15.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
54947
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante (1.650,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et
domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
°
B 79.327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2011.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, vol. 148S, fol. 95, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057624.3/230/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.
1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . .
155
2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Luxembourg, le 6 juillet 2005.
A. Schwachtgen.
54948
CARDINAL PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 58.858.
—
La convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT, S.à r.l. (anciennement STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à
r.l.), 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. Luxembourg B n
°
75.908 et la société CARDINAL
PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A., R.C. Luxembourg B n
°
58.858, a été dénoncée avec effet au 31 mai
2005.
Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par
conséquent également dénoncé.
M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et Mme Geneviève Blauen se sont démis de leurs mandats d’administrateurs à
cette même date.
Luxembourg, le 31 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04183. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050134.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ATRADIUS EMERGING MARKETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-26, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.841.
—
<i>Extrait du Conseil d’Administration écrit du 15 décembre 2004i>
<i>Démission - nomination d’un Administrateur - Octroi de pouvoirsi>
Le Conseil d’Administration acte la démission de Monsieur Guy Lammens en tant que membre du Conseil d’Admi-
nistration à dater du 15 décembre 2004.
Le Conseil d’Administration regrette la décision de Monsieur Lammens et le remercie pour le travail effectué et le
temps consacré à la gestion de la société.
Le Conseil décide de nommer Monsieur Tarek Abou-Khater Robbiati, domicilié Linden Gardens 7 à London W2 4HA
(United Kingdom), en tant qu’Administrateur coopté.
Par ailleurs, suite au départ de Monsieur Jean-Paul Gason, le Conseil décide de nommer Monsieur Gérard van Brakel
en tant que Directeur Général.
Luxembourg, le 23 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2005, réf. LSO-BF00339. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050270.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ATRADIUS EMERGING MARKETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-26, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.841.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un extrait du Conseil d’Administration écrit sous seing privé en date du 15 décembre 2004, enregistré à
Luxembourg-Sociétés, le 1
er
juin 2005, référence LSO-BF00339, que
Monsieur Guy Lammens, né le 12 novembre 1940 à Uccle/Belgique, demeurant à B-1380 Lasne/Belgique, 32, rue du
Chêne au Corbeau, a démissionné de ses fonctions d’Administrateur à dater du 15 décembre 2004.
Le Conseil d’Administration regrette la décision de Monsieur Lammens et le remercie pour le travail effectué et le
temps consacré à la gestion de la société.
Monsieur Tarek Abou-Khater Robbiati, né le 19 juin 1965 à Zahle/Liban, demeurant à Linden Gardens 7, W2 4HA
Londres/Grande-Bretagne, a été nommé nouvel administrateur.
Suite au départ de Monsieur Jean-Paul Gason, demeurant à B-1060 Bruxelles, rue Defacqz, 100, Monsieur Gérard van
Brakel, 4, rue Schoetter, L-2523 Luxembourg, est nommé en tant que Directeur Général.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050262.3/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
G. van Brakel
<i>Directeur Générali>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
54949
SOLAR UND VAKUUM TECHNOLOGIE (SVT) A.G., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.354.
—
La convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT, S.à r.l. (anciennement STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à
r.l.), 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. Luxembourg B n
°
75.908 et la société SOLAR
UND VAKUUM TECHNOLOGIE (SVT) A.G., R.C. Luxembourg B n
°
37.354, a été dénoncée avec effet au 31 mai 2005.
Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par
conséquent également dénoncé.
M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et Mme Geneviève Blauen se sont démis de leurs mandats d’administrateurs à
cette même date, ainsi que le commissaire aux comptes, STENHAM, S.à r.l. (anciennement StenGest, S.à r.l.).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04190. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050140.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
GEO-BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 77.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04491, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 juin 2005.
(050159.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
LUNETTERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mensdorf.
R. C. Luxembourg B 72.848.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04504, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 juin 2005.
(050167.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SOFICOSA, SOCIETE FINANCIERE DES CONSTRUCTIONS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 5.765.
—
<i>Résolution du 27 mai 2005 i>
Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 27 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02992. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050341.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Pour GEO-BILDINX, S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour LUNETTERIE, S.à r.l.
i>J. Reuter
Pour avis sincère et conforme
<i>Pouri> <i>SOFICOSA, SOCIETE FINANCIERE DES CONSTRUCTIONS
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures
54950
PAGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 31.337.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04506, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 juin 2005.
(050169.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 21.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04508, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 juin 2005.
(050177.4/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PALOS RENT A CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 10.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04510, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 juin 2005.
(050179.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
QUATRIEME PLACE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 20.787.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04511, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 juin 2005.
(050180.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
VICARE S.A., VICTOIRE ABEILLE REASSURANCES, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 29, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05796, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055089.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.
<i>Pour PAGOS, S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour PALOS RENT A CAR, S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour QUATRIEME PLACE S.A.H.
i>J. Reuter
<i>Pour la société VICARE S.A.
i>ACSG (EUROPE)
Signature
54951
I.L.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 71.254.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2005i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en date
du 8 juin 2005 que:
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance, l’Assemblée a décidé d’appeler
aux fonctions d’Administrateur les personnes suivantes:
Sont réélus:
* Maître Bernard Felten, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,
* Monsieur Frédéric Collot, demeurant à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
* La société CD-GEST, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2011.
L’Assemblée décide d’appeler au poste de Commissaire aux comptes la société suivante:
Est réélue:
* La société CD-SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04485. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050271.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
B-TECHNIC S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-9023 Ettelbruck, 10, rue des Chariots.
R. C. Luxembourg B 98.927.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 8 avril 2005i>
<i>Première résolutioni>
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur David di Loretto, administrateur-délé-
gué, chargé de la gestion journalière de la société. Son mandat qui prend cours immédiatement prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l’an 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00105. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050298.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
F.S.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.787.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 20 mai 2005i>
«Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l’unanimité la continuation des activités de la société en
dépit de la perte de plus des trois quarts du capital social.»
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02590. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050445.3/813/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
<i>Pour extrait conforme
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signatures.
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Géranti> / <i>Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-déléguéi> / <i>Administrateur-déléguéi>
54952
AKACCIA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 22.831.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02613, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050429.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
LOGAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 61.470.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2004, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,
Guy Kettmann, Christoph Kossmann et du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été
renouvelés pour une durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03500. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050430.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
MONTSEGUR GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 87.186.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 mai 2005i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange, et désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable,
demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06639. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053410.3/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2005.
MONTSEGUR GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 87.186.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06651, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053409.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2005.
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
<i>Pour LOGAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
MONTSEGUR GESTION S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
MONTSEGUR GESTION S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
54953
TEXINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 35.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02611, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050431.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
MAWASHI GERI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 32.114.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02608, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050432.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
EMSAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 40.422.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02605, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050433.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
DIMETAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 35.570.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02603, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050435.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
54954
DA SILVA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3321 Berchem, 26, rue Hans Adam.
R. C. Luxembourg B 108.774.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le premier juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Madame Julia Mendes Ribeiro, employée privée, demeurant à L-3321 Berchem, 26, rue Hans Adam, née à Clermont-
Ferrand (France), le 4 septembre 1970.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée unipersonnelle qu’elle va constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dis-
positions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’assurance par l’intermédiaire d’une personne physique
dûment agréée.
Elle a en outre pour objet, tant en tout endroit de la communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde
entiers, l’exploitation d’une agence immobilière, l’exploitation de tout commerce en incluant toutes prestations de ser-
vice et de conseil s’y rattachant de près ou de loin pourvu qu’elles soient connexes et accessoires et non dans l’attribu-
tion exclusive d’une profession spécialement réglementée par une loi.
Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières et encore accomplir toutes
autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de DA SILVA SERVICES, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Berchem. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les
autres localités du pays et à l’étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Toutes ces parts ont été souscrites par Madame Julia Mendes Ribeiro, prénommée.
Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 8. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou,
selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.
Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre
tenu au siège social.
L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-
blies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit, Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
54955
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les
comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l’inventaire
et du bilan.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ mille deux cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-3321 Berchem, 26, rue Hans Adam.
2. Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:
Madame Julia Mendes Ribeiro prénommée.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante uni-
que.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Alzingen, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la comparante prémentionnée a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: J. Mendes Ribeiro, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 juin 2005, vol. 431, fol. 85, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055094.3/242/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.
GILEAD SCIENCES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 20,000.-.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.952.
—
In the year two thousand five, on the twenty-fifth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GILEAD SCIENCES LUXEMBOURG, S.à r.l., a «so-
ciété à responsabilité limitée» (limited liability company), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 101.952, incorporated by deed dated on June 8, 2004 pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 990 of October 6, 2004; and whose Articles of
Association have never been amended.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist in L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist in L-1450 Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 200 (two hundred) shares, representing the whole capital of the company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been beforehand informed.
Mersch, le 21 juin 2005.
H. Hellinckx.
54956
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Amendment of article 11 of the Articles of Association.
2) Appointment of Mr Gérard Becquer as manager class B of the Company.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner decides what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend article 11 of the Articles of Association and to give it the following wording:
«Art. 11. The Company is by one or more managers. If several managers have been appointed, the will constitute a
board of managers. In this case, managers will be appointed as class A manager or class B manager. The managers need
not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of share-
holders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by:
i) the sole signature of its single manager;
ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of one class A manager and one class B manager;
iii) in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the class A manager if there is no class B
manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, board of managers will be validly held provided that the majority of class A managers
and class B managers are present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decided to appoint as manager of class B for an undetermined duration:
- Mr Gérard becquer, réviseur d’entreprises, born on April 29, 1956 at Briey with professional address 5, rue Guil-
laume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The meeting decided to attribute class A managers to the existing managers, i.e.
- Mr John Milligan, Executive Vice President and Chief Financial Officer, GILEAD SCIENCES, INC., with professional
address at 333, Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States.
- Mr Gregg Alton, Vice President and General Counsel, GILEAD SCIENCES, INC., with professional address at 333,
Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée GILEAD SCIEN-
CES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 101.952, constituée suivant acte reçu le 8 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 990 du 6 octobre 2004 dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à
L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent est renseigné sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
54957
II.- Il ressort de la liste de présence que les 200 (deux cents) parts, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification l’article 11 des statuts.
2) Nomination de Mr Gérard Becquer en tant que gérant de la classe B.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un con-
seil de gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés en tant que gérant de class A ou gérant de classe B. Le(s) gé-
rant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du conseil de gérance.
La Société sera engagée par:
i) la signature individuelle de son gérant unique,
ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant de classe A et un gérant de classe B,
iii) en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle des gérants de classe A s’il n’y a pas de gérant de classe B.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
de classe A et des gérants de classe B sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme gérant de la classe B pour une durée illimité:
- M. Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey dont l’adresse professionnelle est 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
L’assemblée décide d’attribuer la classe A aux gérants existants c’est-à-dire:
- M. John Milligan, Executive Vice President and Chief Financial Officer, GILEAD SCIENCES, INC., dont l’adresse pro-
fessionnelle est 333, Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States,
- M. Gregg Alton, Vice President and General Counsel, GILEAD SCIENCES, INC., dont l’adresse professionnelle est
333, Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2005, vol. 148S, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052802.3/211/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
GILEAD SCIENCES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,-.
Siège social L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.952.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052805.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
54958
ADVANCED SUPPLIES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siége social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.489.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2004, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,
Jean Bodoni, Guy Kettmann et Christoph Kossmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A.,
société anonyme ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an
2010.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03509. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050444.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
LAROCHETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 48.403.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2005, les mandats de Messieurs Jean Bodoni, Guy Bau-
mann et Guy Kettmann, Administrateurs de catégorie «A» et de Monsieur Pedro de Esteban Altirriba, Administrateur
de catégorie «B», ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., ont été renouvelés pour un durée
de 5 ans. Leurs mandats s’achèveront avec celui de Madame Maria José Esteban Ferrer, Administrateur de catégorie
«B», à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
<i>Administrateurs de catégorie «A»:i>
M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg et M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
<i>Administrateurs de catégorie «B»:i>
Mme Maria José Esteban-Ferrer, Calle Benedetti 44, E-Barcelone et M. Pedro de Esteban Altirriba, 30 Bolton Gardens
Flat 8, GB-London.
Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050448.3/1017/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
AKACCIA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 22.831.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 2 juin 2005i>
Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVI-
CES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, ils ont été
réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se
tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02612. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050498.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
<i>Pour ADVANCED SUPPLIES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour LAROCHETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant i>/ <i>Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué i>/ <i>Administrateur-déléguéi>
54959
CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share Capital: EUR 18,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 104.545.
—
In the year two thousand and five, on the sixteenth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appear:
CARLYLE/RIVERSTONE GLOBAL ENERGY AND POWER FUND II (CAYMAN) L.P., a limited partnership formed
under the laws of the Cayman Islands, with registered address at C/O Walker House, PO Box 265GT, Mary Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Mr. Nicolas Cuisset, employee, with professional address at Aérogolf Center Building Bloc B, 1,
rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given on April 30, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through their proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée») existing in Luxembourg under the name of CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS, S.à r.l. (the «Company»),
with registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register section B, under number 104.545, incorporated by a deed of the undersigned notary of November 18, 2004,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
164 dated February 23, 2005.
II. The Company’s share capital is fixed at eighteen thousand Euro (EUR 18,000.-) represented by seven hundred and
twenty (720) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital by one million Euro (EUR 1,000,000)
to raise it from its present amount of eighteen thousand Euro (EUR 18,000.-) to one million eighteen thousand Euro
(EUR 1,018,000.-) by creation and issue of forty thousand (40,000) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vest-
ed with the same rights and obligations as the existing shares.
IV. The sole shareholder resolves to accept the subscription and the payment of the forty thousand (40,000) new
shares as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
CARLYLE/RIVERSTONE GLOBAL ENERGY AND POWER FUND II (CAYMAN) L.P., prenamed, through its prox-
yholder, declared to subscribe to the forty thousand (40,000) new shares in the amount of one million Euro (EUR
1,000,000.-) by contribution in kind consisting of a receivable held towards the Company, corresponding to the amount
due and payable under the terms and conditions of a loan agreement signed between the Company and CARLYLE/RIV-
ERSTONE GLOBAL ENERGY AND POWER FUND II (CAYMAN) L.P. on April 14, 2005.
V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
«Art. 6. The share capital is fixed at one million eighteen thousand Euro (EUR 1,018,000.-) represented by forty
thousand seven hundred and twenty (40,720) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately fourteen thousand euros Euro (EUR 14,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le seize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CARLYLE/RIVERSTONE GLOBAL ENERGY AND POWER FUND II (CAYMAN) L.P., un limited partnership régi
par les lois des Iles Caymans, avec adresse à C/O Walker House, PO Box 265GT, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Iles Caymans,
ici représentée par M. Nicolas Cuisset, employé privé, avec adresse professionnelle à Aérogolf Center Building Bloc
B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
en vertu d’une procuration donnée le 30 avril 2005.
54960
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le nu-
méro 104.545, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 18 novembre 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n
°
164 du 23 février 2005.
II. Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) divisé en sept cent vingt (720) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un million d’euros (EUR
1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) à un million dix-huit mille euros
(EUR 1.018.000,-) par la création et l’émission de quarante mille (40.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
IV. L’associé unique décide d’accepter la souscription et le paiement des quarante mille (40.000) parts sociales nou-
velles comme suit:
<i>Souscription - Paiementi>
CARLYLE/RIVERSTONE GLOBAL ENERGY AND POWER FUND II (CAYMAN) L.P., désignée ci-dessus, par l’in-
termédiaire de son représentant, déclare souscrire aux quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales pour un montant
d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-) par un apport en nature consistant en une créance détenue à l’encontre de la
Société, correspondant au montant dû et payable en vertu d’un contrat de prêt conclu entre la Société et CARLYLE/
RIVERSTONE GLOBAL ENERGY AND POWER FUND II (CAYMAN) L.P. en date du 14 avril 2005.
V. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à un million dix-huit mille euros (EUR 1.018.000,-) représenté par quarante mille
sept cent vingt (40.720) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatorze mille euros (EUR 14.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Cuisset, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 70, case 5. – Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057564.3/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.
CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 104.545.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.
(057565.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Vandemoortele Participations S.A.
T&B Investissement S.A.
Arbed Building Concepts
Pudel, S.à r.l.
Tinska Real Estate S.A.
KNL S.A.
KNL S.A.
KNL S.A.
KNL S.A.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.
Mat & Kam, GmbH
Idea Light, S.à r.l.
C.T.T.L. Centre de Télécommunications et Téléinformatique Luxembourgeois S.A.
Luxmédical, S.à r.l.
Aqua d’Or S.A.
Strange, GmbH
Cité du Soleil S.A.
Waistuff, S.à r.l.
Ultracalor Commercial S.A.
Torrent Investments S.A.
Euroclear Finance 2 S.A.
Euroclear Finance 2 S.A.
Baltic Financial Holdings
Société Européenne d’Aquaculture, S.à r.l.
Cult Mix, S.à r.l.
Panatella Holding S.A.
Panatella Holding S.A.
Panatella Holding S.A.
Panatella Holding S.A.
Flandre Europe
Westchester S.C.A.
Luxembourg Business Consultants S.A.
Areco Holding Société Anonyme
Centrale Informatique S.A.
Mobile Business S.A.
Lux-Audit S.A.
Information & Communication Technologies Europe S.A. «ICT Europe S.A.»
Ficel Office Center S.A.
Atradius Ré S.A.
Atradius Ré S.A.
Atradius Ré S.A.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg Salaires et Social S.A.
Cornaline International Holding S.A.
Cardinal Participations et Investissements S.A.
Atradius Emerging Markets S.A.
Atradius Emerging Markets S.A.
Solar und Vakuum Technologie (SVT) A.G.
Geo-Bildinx, S.à r.l.
Lunetterie, S.à r.l.
SOFICOSA, Société Financière des Constructions
Pagos, S.à r.l.
Garage Albert Pauly-Losch, S.à r.l.
Palos Rent a Car, S.à r.l.
Quatrième Place S.A.H.
VICARE S.A., Victoire Abeille Réassurances
I.L.V. S.A.
B-Technic S.A.
F.S.A. International S.A.
Akaccia Investments Holding S.A.
Logan Investment S.A.
Montségur Gestion S.A.
Montségur Gestion S.A.
Texinvest S.A.
Mawashi Geri S.A.
Emsay Holding S.A.
Dimetal International S.A.
Da Silva Services, S.à r.l.
Gilead Sciences Luxembourg, S.à r.l.
Gilead Sciences Luxembourg, S.à r.l.
Advanced Supplies Investments S.A.
Larochette Investment S.A.
Akaccia Investments Holding S.A.
Carlyle/Riverstone Participations, S.à r.l.
Carlyle/Riverstone Participations, S.à r.l.