This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
54385
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1134
2 novembre 2005
S O M M A I R E
AB Europroperty, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
54415
ITI Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
54407
AGF World Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . .
54422
ITI Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
54407
Alcelec, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
54386
Jurian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54415
AME Life Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54405
Kalbax, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54408
Anchor Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
54415
Kapateco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
54421
Ayubowan, A.s.b.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54410
Kronospan Luxembourg S.A., Sanem . . . . . . . . . .
54408
Bentim International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54409
L.I., Luxembourgeoise d’Interventions S.A., Luxem-
Biel Fund Management Company S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54412
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54417
Luxembourg Company of Metals & Alloys S.A.,
Business Consultants Europe S.A., Dommeldange.
54409
Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54432
Christa Intershipping, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . .
54407
Luxembourg Congres S.A., Luxembourg . . . . . . .
54386
Colonnade Holdco N° 5 S.A., Luxembourg . . . . . . .
54419
M2M S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54419
(Le) Comitium International S.A., Luxembourg . .
54422
(La) Maison du Tapis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
54417
Compagnie Helvétique de déstockage S.A., Luxem-
Multiworld, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54417
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54412
Myrtus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54406
Compagnie Helvétique de déstockage S.A., Luxem-
NBCA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54425
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54413
NBCA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54425
Compagnie Helvétique de déstockage S.A., Luxem-
North Miami Beach Investment Corp S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54413
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54423
Compagnie Helvétique de déstockage S.A., Luxem-
Perform Invest S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54430
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54413
Perform Invest S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54431
Dexia Participation Luxembourg S.A., Luxem-
Placinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54426
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54408
Polifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54408
Display Center, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . .
54386
Quilmes Industrial (Quinsa) S.A., Luxembourg . .
54426
Euroturistica Holding S.A., Luxembourg-Kirch-
Quilmes Industrial (Quinsa) S.A., Luxembourg . .
54429
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54420
Roule Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54416
Evita S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54422
Sanest-Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
54432
Fendi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54407
Socom S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54414
Foncière T.M.G.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54423
Solidarité Action «Gouye Gui», A.s.b.l., Mersch . .
54418
Gaviota Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54417
Somel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54409
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Sprumex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54410
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54406
Staples Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54417
Graficom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54414
Staples Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54417
Hardt Group Securities S.A., Luxembourg . . . . . . .
54387
Strongbow Capital Holdings S.A., Luxembourg . .
54423
IKB CorporateLab S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
54414
Strongbow Capital Holdings S.A., Luxembourg . .
54425
Image Investments Holding S.A., Dommeldange . .
54414
Symphony Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54386
Institut Rosenfeld, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
54406
Symphony Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54386
Inter-Actions, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54412
Tesei S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54423
Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54416
Top Roule Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
54416
International Company of Investment S.A., Lu-
Top Université Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .
54416
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54420
Université Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
54416
IT Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54406
Zirouc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54415
54386
ALCELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 10, rue de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 101.360.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01157, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047770.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
DISPLAY CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 12, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 86.595.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01158, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047771.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.
R. C. Luxembourg B 58.684.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01161, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047774.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
SYMPHONY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 86.043.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07051, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047914.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
SYMPHONY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 86.043.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07049, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Comissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047913.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
<i>Pour ALCELEC, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour DISPLAY CENTER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
Luxembourg, le 26 mai 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 26 mai 2005.
Signatures.
54387
HARDT GROUP SECURITIES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 110.966.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fourth day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
1) HARDT GROUP INVESTMENTS AG, a company governed by the laws of Austria, having its registered office at
Stubenring 18, A-1010 Vienna, represented by Max Welbes, avocat, by virtue of a proxy given in Vienna on 27 Septem-
ber 2005;
2) DDr Alexander Schweickhardt, residing in Stubenring 18/24, A-1010 Vienna, Austria represented by Max Welbes,
avocat, by virtue of a proxy given in Vienna on 27 September 2005;
which two proxies after being signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary will remain
attached to the present deed to be filed at the same time.
The said persons represented as described above have drawn up the following articles of incorporation of a company
which they hereby declare to form among themselves and on which they have agreed as follows:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Corporate Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter created a company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, especially by the law of 10 August 1915 on commercial companies, by the law of 22 March
2004 on securitisation and by the present articles of incorporation (the «Articles»).
The company will exist under the name of HARDT GROUP SECURITIES S.A. (the «Company»).
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of
its board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company.
Art. 3. Corporate Object. The corporate object of the Company is the acquisition and assumption, directly or
through another vehicle, of risks - inter alia - associated with alternative investments and linked to claims, other assets
or obligations of third parties or pertaining to all or part of the activities carried out by third parties and the issuance
of equity, beneficiary shares and debt instruments, in particular notes, certificates and convertible bonds and any other
securities the value or return of which is dependent upon such risks as defined in the law of 22 March 2004 on securi-
tisation and which may rank sub- and/or superordinated (the «Instruments»). The Instruments may be issued on an iso-
lated basis or by private placement. The Instruments may be issued in different compartments.
The Company may carry out any transactions, - inter alia - entering into any financial derivative instruments, which
are directly or indirectly connected with its corporate object out any banking activity and engage in any lawful act or
activity and exercise any powers permitted for excluding securitisation vehicles under the law on securitisation of 22
March 2004 to which the Company is subject, that, in either case, are incidental to and necessary or convenient for the
accomplishment of the above mentioned purposes; provided that same are not contrary to the foregoing purposes and
are not otherwise prohibited by any agreements to which the Company may then be a party.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Corporate Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The Company has an issued and paid-up corporate capital of thirty-one thousand euro
(EUR 31,000) divided into thirty-one (31) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.
The corporate capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles.
Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered shares only (the «Ordinary Shares»).
Art. 7. Beneficiary Shares
7.1. Issue of Beneficiary Shares
Subject to the provisions of the Articles, the rights and obligations attaching to any beneficiary share (the «Beneficiary
Share») shall be determined at the time of issue and from time to time thereafter by the board of directors in its absolute
discretion. Each Beneficiary Share shall be issued by the board of directors on behalf of the Company as part of a tranche
(a «Tranche»). One or more Tranches of Beneficiary Shares may be designated by the board of directors as a series
(the «Series»). The rights and obligations attaching to each Series or Tranche of Beneficiary Shares in addition to those
set out in the Articles shall be set out in the relevant terms and conditions as determined in the supplement (the «Sup-
plement») with respect to the relevant Series or Tranche (the «Conditions»).
Beneficiary Shares may be issued against contributions in cash or, where so permitted or determined in the Condi-
tions of the relevant Compartment (as defined below), contributions in kind. Contributions in kind are subject to an
54388
independent external auditor’s control in respect of the valuation of these contributions, in accordance with the 1915
Law.
The relevant Supplement shall identify the issue price for each Beneficiary Share and shall disclose details where ap-
plicable of the basis on which Beneficiary Shares of the relevant Series or Tranche may be issued or offered.
7.2 Rights of Beneficiary Shares
7.2.1 General
The Conditions in respect of each Series or Tranche of Beneficiary Shares shall not override the provisions of the
Articles and shall comprise or include:
(a) the currency of the Beneficiary Shares and their nominal value, if any;
(b) the Series and Tranche to which each Beneficiary Share shall belong, such Series to be designated with a Series
number and title and a Tranche (if more than one in a Series) to be designated with a Tranche number and title;
(c) any restrictions on investments in relation to the relevant Compartment;
(d) details of any dividend payments payable in respect of the relevant Series or Tranche, the currency in which div-
idends will be paid, the redemption amount, the currency in which the redemption amount will be paid and the date on
which the redemption amount is payable by the Company in accordance with the relevant Conditions, subject to the
Articles and as disclosed in the relevant Supplement (the «Redemption Date»);
(e) the method of determining the redemption amount and a description of the nature of the relevant specific risks
and/or assets by reference to which any redemption amount or dividends will be calculated;
(f) any additional transfer or selling restrictions applying to the Beneficiary Shares;
(g) limitations, if any, of the voting rights attaching to the Beneficiary Shares; and
(h) any other rights, obligations and restrictions attaching to the Beneficiary Shares of any Tranche as the board of
directors may determine in its sole and absolute discretion.
7.2.2 Effect of Conditions
Once Conditions have been adopted for a Series or a Tranche of Beneficiary Shares, then:
(a) subject to article 7.2.1 the Conditions shall be binding on the Beneficiary Shareholders, the Ordinary Shareholders
(as defined below), the holders of any debt instruments and the board of directors as if contained in the Articles;
(b) the provisions of article 7.9 shall apply to any variation or abrogation thereof that may be effected by the board
of directors on behalf of the Company pursuant to this article 7.2; and
(c) all moneys payable on or in respect of any Beneficiary Share (including, without limitation, the subscription and
redemption moneys) shall be paid in the currency in which such Beneficiary Share is issued, in such other currency or
currencies as the Conditions may provide and, if there is any difficulty in making payments in such currency, in such
other currency as the board of directors may determine in its absolute discretion.
7.2.3 Rights to dividends
Subject to the Articles and the relevant Conditions, each Beneficiary Share shall confer on the holder a right, on an
accrual basis, to receive such dividends including interim dividends (if any) out of the profits or the reserve account of
the relevant Compartment payable on such terms as set out in the Articles and the relevant Conditions.
Subject to any particular rights or limitations as to dividends for the time being attached to any Beneficiary Shares, as
may be specified in the Articles or any Conditions, all dividends shall be apportioned and paid pro rata according to the
amounts paid on the Beneficiary Shares.
All unclaimed dividends may be invested or otherwise made use of by the board of directors for the benefit of the
relevant Compartment until claimed. No dividend shall bear interest as against the relevant Compartment or the Com-
pany.
Any dividend unclaimed after a period of ten (10) years from the date of declaration of such dividend shall, if the board
of directors so resolves, be forfeited and shall belong to the relevant Compartment or, where the relevant Compart-
ment has been liquidated by that time, to the Company.
Subject to the provisions of the Articles, the board of directors may resolve in its absolute discretion, without prej-
udice to the immediate and irrevocable accrual of dividend rights as determined above, to capitalize the profits of a
Compartment (which may include profits carried forward and credited to any Beneficiary Shares reserve account).
7.2.4 Rights to the redemption amounts
The Beneficiary Shares are not redeemable at the election of the Beneficiary Shareholders. The board of directors
(or its delegate) may decide from time to time in its absolute discretion to repurchase (and determine the terms of
repurchase of) some or all Beneficiary Shares of any Series or Tranche, in particular from an entity acting as market
maker in respect of these Beneficiary Shares.
Subject to the Articles and the relevant Conditions, each Beneficiary Share shall confer on the holder a right to re-
ceive repayment of an amount equal to the redemption amount on the Redemption Date out of the assets of the rele-
vant Compartment. If on the Redemption Date the realised net assets of the relevant Compartment are insufficient to
pay the full redemption amount payable to each Beneficiary Shareholder within that Series or Tranche, the proceeds of
the relevant Compartment will, subject to the Conditions, be distributed pro rata amongst each Beneficiary Shareholder
of that Series or Tranche and no Beneficiary Shareholder shall have any claim against the Company in respect of any
shortfall. Upon the redemption of a Beneficiary Share pursuant to the Conditions relating thereto, such Beneficiary
Share shall be cancelled and the holder thereof shall cease to be entitled to any rights in this respect.
7.2.5 Payments
Subject to the provisions of the Articles and any Conditions, any dividend or other monies payable in respect of Ben-
eficiary Shares in registered form may be paid by cheque or any other means as determined by the board of directors
sent through the post to the address of the Beneficiary Shareholder as recorded in the relevant register of the Company
or person entitled thereto, and in the case of joint holders to any one of such joint holders, or to such person and to
54389
such address as the holder or joint holder may indicate in writing. Every such cheque or any other means as determined
by the board of directors shall be made payable to the order of the person to whom it is sent or to such other person
as the holder or joint holders may indicate in writing, and payment of the cheque or any other means as determined by
the board of directors shall be a good discharge to the Company. Every such cheque or any other means as determined
by the board of directors shall be sent at the risk of the addressee.
The Company may deduct from any dividend or other monies payable to any Beneficiary Shareholder on or in respect
of a Beneficiary Share all sums of money (if any) presently payable by such Beneficiary Shareholder to the Company and
any sums required to be deducted there from by law.
7.2.6 Voting rights - General
In principle, Beneficiary Shares do not confer any voting rights in favour of to the Beneficiary Shareholders.
Each Beneficiary Shareholder of a particular Series or Tranche has the right to receive notice of, and to attend and
to vote at such meetings of Ordinary Shareholders the agenda of which lists a variation of the rights of the Beneficiary
Shareholders as previously determined in the relevant Conditions. Each fully paid up Beneficiary Share is entitled to one
vote.
All provisions of Chapter IV entitled «General Meeting of Ordinary Shareholders» of the Articles apply, if not sup-
plemented by the provisions of this Article 7.
7.2.7 Voting rights - Special
(a) Subject to the relevant Conditions, each holder of Beneficiary Shares of any Series or Tranche shall have the right
to:
1. request the board of directors to convene a meeting of the holders of Ordinary Shares and Beneficiary Shares of
each Series or Tranche entitled to vote pursuant to this article 7.2.7 provided that the holder of Beneficiary Shares of
the relevant Series or Tranche requesting such meeting represents at least twenty (20) per cent. of the issued and out-
standing Beneficiary Shares of the relevant Series or Tranche;
2. receive notice of such meeting; and
3. attend and vote at such meeting;
in each case with respect to:
(i) the change of the corporate form of the Company;
(ii) the transfer of the registered office of the Company outside the Grand Duchy of Luxembourg;
(iii) the material amendment of the corporate objects of the Company;
(iv) the removal of any director of the Company for cause, in particular, of serious misconduct or fraud;
(v) except for the decisions to be taken under article 100 of the 1915 Law, the dissolution and liquidation of the Com-
pany; and/or
(vi) any merger, demerger or similar corporate reorganization of the Company, where the Company is not the sur-
viving entity.
(b) Any resolution with respect to paragraphs (i), (ii), (iii), (v) and (vi) of article 7.2.7(a) shall be passed by a two-thirds
majority of the votes cast at the meeting provided that, in addition, holders of Ordinary Shares vote unanimously in
favor of any resolution with respect to paragraph (ii) of article 7.2.7(a). All provisions of Chapter IV entitled «General
Meeting of Ordinary Shareholders» of the Articles apply (including the determination of the number of votes, which
shall be one vote per Beneficiary Share of each Series or Tranche entitled to vote pursuant to this article 7.2.7), mutatis
mutandis, to the meeting provided that:
1. the number of issued and outstanding Beneficiary Shares of each Series or Tranche entitled to vote at the meeting
pursuant to this article 7.2.7 shall be deemed reduced pro rata between each Series or Tranche so that the aggregate
number of issued and outstanding Beneficiary Shares of all Series or Tranche entitled to vote pursuant to this article
7.2.7 will not exceed the aggregate number of issued and outstanding Ordinary Shares present or represented at the
meeting or any adjourned meeting; and
2. the meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the issued and outstanding Ordinary Shares and
Beneficiary Shares of each Tranche or Series entitled to vote pursuant to this article 7.2.7 are present or represented.
If such quorum has not been reached, a second meeting may be convened which shall validly deliberate and resolve re-
gardless of the proportion of the issued and outstanding Ordinary Shares and Beneficiary Shares present or represented;
3. any resolution with respect to paragraph (iv) of article 7.2.7(a) shall be passed by a simple majority of the votes
cast at the meeting where no difference is made between Ordinary Shares and Beneficiary Shares.
7.3 Form of Beneficiary Shares
The board of directors may decide to issue Beneficiary Shares in registered form only.
One or more registers of Beneficiary Shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such reg-
ister(s) shall set out the name of each Beneficiary Shareholder, its residence, registered address or elected domicile, the
number of Beneficiary Shares held by it, the amounts paid in on each such Beneficiary Share, the transfer of Beneficiary
Shares and the dates of such transfers. Ownership of Beneficiary Shares will be conclusively established by the entry in
these registers.
No certificates representing Beneficiary Shares in registered form shall be issued. Beneficiary Shareholders will re-
ceive in lieu thereof a confirmation of their holding.
7.4 Transfer of Beneficiary Shares
Transfer of Beneficiary Shares in registered form shall be effected by a written declaration of transfer recorded in the
register(s) of Beneficiary Shares of the Company, such declaration of transfer to be duly executed by the transferor and
the transferee or by any person(s) holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of
transfer other instruments of transfer satisfactory to it.
54390
7.5 Joint holders of Beneficiary Shares
Where two or more persons are registered in the register(s) of Beneficiary Shareholders as the holders of any Ben-
eficiary Share () they shall be deemed to hold the same as joint owners, subject to the following provisions:
(a) the Company shall not be bound to register more than four (4) persons as the joint holders of any Beneficiary
Share;
(b) the joint holders of any Beneficiary Share shall be liable, severally as well as jointly, in respect of all payments to
be made in respect of such Beneficiary Share; and
(c) any one of such joint holders may give a good receipt for any dividend, bonus or return of capital payable to such
joint holders.
7.6 Beneficiary Shares reserve accounts
The board of directors will create one or more reserve accounts in respect of each Series or Tranche of Beneficiary
Shares. The reserve account(s) will reflect the contributions made from time to time by the Beneficiary Shareholders
of the relevant Series or Tranche and/or net profits allocated from time to time to the reserve account(s), as determined
hereafter. Subject to the relevant Conditions, the board of directors may decide from time to time, in its absolute dis-
cretion, to allocate and transfer any net profits of the relevant Compartment, to the extent not paid as dividends in-
cluding interim dividends (if any), to the relevant reserve account(s). Such reserve account(s) shall form part of the
relevant Compartment and may be applied for the purpose of paying dividends (including interim dividends), the re-
demption amounts or any return of capital with respect to the relevant Series or Tranche of Beneficiary Shares.
7.7 Calls on Beneficiary Shares
7.7.1 The board of directors may, subject to the provisions of the Articles and the Conditions, from time to time,
make calls upon the Beneficiary Shareholders in respect of any monies unpaid on the Beneficiary Shares and each Ben-
eficiary Shareholder shall (subject to being given at least fourteen (14) clear days’ notice specifying the time and place
of payment) pay the specified amount to the Company at the time and place so specified.
7.7.2 A call may be made payable by instalments. A call may be postponed or in whole or in part, be totally or partially
revoked, as determined in its absolute discretion by the board of directors. A call shall be deemed to have been made
at the time when the resolution of the board of directors authorising the call has been passed.
7.7.3 Any unpaid sum at the time or times as determined in the notice under article 7.7.1 may be charged with an
interest rate as determined by the board of directors, which shall not exceed the rate of ten (10) per cent. per annum.
7.7.4 Any sum becomes due at the time or times as specified in the notice under article 7.7.1.
7.7.5 The board of directors may, distinguish between one or more Series or Tranche(s) and between different Ben-
eficiary Shareholders of one Series or Tranche.
7.8 Forfeiture of Beneficiary Shares
7.8.1 If a Beneficiary Shareholder fails to pay any call or instalment of a call on or before the day appointed for payment
thereof, the board of directors may at any time thereafter, serve a notice on it requiring the payment of the unpaid
amount, together with any interest which may have accrued and any expenses which may have been incurred by the
Company by reason of such non-payment.
7.8.2 The notice shall name a further day (not earlier than fourteen (14) days from the date of service thereof) on or
before which and the place where the payment is to be made, and may also state that in the event of non-payment at
or before the time and at the place so determined, the Beneficiary Shares will be forfeited.
7.8.3 If the requirements of any such notice are not complied with, any Beneficiary Share (in respect of which such
notice has been given) may at any time thereafter, before the complete payment of all calls and interests due, be forfeited
by a resolution of the board of directors, and such forfeiture shall include all dividends which shall have been declared
but not yet been paid on the forfeited Beneficiary Shares.
7.8.4 If any Beneficiary Share has been forfeited in accordance with the Articles, notice of the forfeiture shall be given
to the concerned Beneficiary Shareholder and the relevant recording shall be made in the register(s) of Beneficiary
Shares; but no forfeiture shall be invalidated in any manner by any omission or neglect to give such notice or to make
such recording.
7.8.5 A forfeited Beneficiary Share may be sold, re-allotted or otherwise disposed of by the board of directors, either
to the person who was the holder thereof, or to any other person, upon such terms and in such manners as the board
of directors thinks fit.
7.8.6 A holder of Beneficiary Share whose Beneficiary Shares have been forfeited shall cease to be the holder of such
Beneficiary Shares but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the Company all monies which at the
date of forfeiture were payable by it to the Company, with interest thereon at a rate determined by the board of direc-
tors but not exceeding ten (10) per cent. per annum from the date of forfeiture until payment.
7.9 Variation of Rights of Beneficiary Shares
7.9.1 The special rights attached to any Series or Tranche may, unless otherwise provided by the Conditions relating
thereto, be varied or abrogated by the board of directors either during the life of the Company or of the relevant Com-
partment or during or in contemplation of the liquidation of the Company or of the relevant Compartment, either with
the approval in writing of the holders of the majority of the issued and outstanding Beneficiary Shares of that Series or
Tranche or with the approval of a resolution passed by a simple majority of the votes cast at a separate meeting of
Beneficiary Shareholders of that Series or Tranche; but such approvals shall not be required in the case of a variation,
amendment or abrogation which does not materially prejudice the interests of the relevant Beneficiary Shareholders;
provided, however, that one or more Beneficiary Shareholder(s) holding at least twenty (20) per cent. of the issued and
outstanding Beneficiary Shares of the relevant Series or Tranche may request the board of directors, notwithstanding
its earlier termination, to have this variation subjected to such approvals. Any such variation, amendment or abrogation
54391
shall be set out in revised Conditions, a copy of which will be provided to and be binding on the affected Beneficiary
Shareholders in accordance with the Articles.
7.9.2 Where the approval by way of a resolution of Beneficiary Shareholders is required pursuant to article 7.9.1,
such resolution shall be put on the agenda of a meeting of the relevant Beneficiary Shareholders. To every such separate
meeting all the provisions of the 1915 Law shall apply.
7.9.3 The special rights conferred to the Beneficiary Shareholders of any Series or Tranche shall be deemed to be
varied by the reduction of the paid up capital on such Beneficiary Shares or by the creation of further Beneficiary Shares
ranking in priority thereto (unless otherwise expressly provided by the Articles or by the Conditions of such Beneficiary
Shares) but shall, without limitation, not be deemed not to be varied by:
(a) the creation, allotment or issue of further securities not participating in the relevant Compartment; or
(b) the creation, allotment or issue of Ordinary Shares; or
(c) the repayment of some or all Beneficiary Shares of any Series or Tranche in accordance with the applicable Con-
ditions; or
(d) the payment of a dividend on the Beneficiary Shares of any other Series or Tranche where the dividend is paid
out of the assets of the Compartment for that other Series or Tranche; or
(e) the amendment of the definition in the Articles of «US Persons» or «Prohibited Person» where the Company has
been advised that such amendment will not materially prejudice the interests of the Company.
7.10 General restrictions on Beneficiary Shares
7.10.1 The Beneficiary Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended, and trading in the Beneficiary Shares has not been and will not be approved by the US Commodity Futures
Trading Commission under the US Commodity Exchange Act, as amended. No Beneficiary Share shall be issued by the
Company to or may be offered or sold, directly or indirectly, in the United States of America to or for the account of
any US Person as defined in Rule 902 under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, to a Prohibited Person i.e. any
benefit plan investor or any person by virtue of his holding of a Beneficiary Share might, in the opinion of the board of
directors, cause or be likely to cause the Company:
(a) some pecuniary tax or regulatory disadvantage;
(b) to be in breach of the law or requirements of any country or governmental authority applicable to the Company
including, without being limited to, any exchange control regulations; or
(c) to be transferred to or be beneficially owned by any US Person or Prohibited Person.
7.10.2 The board of directors and any of the Company’s duly authorized agents shall have the right, on behalf of the
Company, to require such evidence that the transferee is not a US Person or Prohibited Person as the board of directors
or such agent shall in their discretion deem sufficient and to refuse to register such transfer in the register(s) of Bene-
ficiary Shareholders until the receipt of such satisfactory evidence.
7.10.3 Any Beneficiary Shareholder intending to become a US Person or Prohibited Person shall immediately notify
the Company of such intention and each Beneficiary Shareholder, prior to becoming a US Person or Prohibited Person,
shall transfer all his Beneficiary Shares to a person (including, without limitation, an existing Beneficiary Shareholder)
who is qualified under the Articles to hold such Beneficiary Shares.
7.10.4 If it shall come to the notice of the board of directors that any Beneficiary Share is or becomes owned, directly
or indirectly, by a US Person or by a Prohibited Person, the board of directors shall be entitled to give notice (the «Com-
pulsory Transfer Notice») to such person requiring it to transfer such Beneficiary Share(s) to a person (including, with-
out limitation, an existing Beneficiary Shareholder) which is qualified under the Articles to hold such Beneficiary Share(s).
The above at a price equal to the relevant Net Asset Value of the relevant Beneficiary Share(s) or, if no purchaser of
the Beneficiary Share(s) at the relevant price is found, by the Company, at the time the Company requires the transfer
to be made, at the highest price as any purchaser found by the Company is willing to pay therefore. The Company shall
have no obligation to the relevant Beneficiary Shareholder to find the best purchase price for the relevant Beneficiary
Shares.
7.10.5 The board of directors and any of the Company’s duly authorized agents may, for any proposed transfer of
any Beneficiary Shares, require any information and/or evidence it shall deem fit in its sole discretion.
7.10.6 A person who, being subject to the laws and regulations of a country, becomes aware that it holds or owns
Beneficiary Share(s) in contravention of any laws or requirement of that country or governmental authority thereof shall
forthwith notify the Company and transfer such Beneficiary Share(s) to a person duly qualified to hold the same under
the Articles unless it has already received notice under article 7.10.4.
7.10.7 If any such person upon whom a Compulsory Transfer Notice has been served does not transfer such Bene-
ficiary Share(s) within thirty (30) days after the Compulsory Transfer Notice, such Beneficiary Share(s) shall be forfeited
immediately upon the expiration of such thirty (30) day period and the provisions of article 7.8 shall apply.
7.10.8 The board of directors shall have the power (but not the duty) to impose such other restrictions as it may
think necessary for the purpose of ensuring that no Beneficiary Share is acquired, held by or transferred to any US Per-
son or any Prohibited Person.
7.10.9 The board of directors, the Company and any duly authorised agent thereof shall not be liable to any Benefi-
ciary Shareholder for any loss incurred by the fact that a US Person or a Prohibited Person becomes a holder of a Ben-
eficiary Share or the breach of any of the provisions of this article 7.10. Any holder who is in breach of the provisions
of the Articles or any restrictions imposed by the board of directors pursuant to this article 7.10. shall indemnify the
Company for any loss incurred.
54392
7.10.10 Subject to the relevant Conditions, each Beneficiary Share will bear a legend to which each holder is deemed
to agree to; such legend being recorded as follows:
«The Beneficiary Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended
(the Securities Act) and trading in the Beneficiary Shares has not been, and will not be, approved by the US Commodity
Futures Trading Commission under the US Commodity Exchange Act, as amended. Neither this Beneficiary Share nor
any interest herein may be offered, sold, pledged or otherwise transferred except to a transferee that is a non US person
in an offshore transaction in accordance with Regulation S under the Securities Act and applicable securities laws of any
state of the United States or any other jurisdiction and in compliance with the provisions of the Articles pursuant to
which the security was issued.
If this Beneficiary Share or any interest herein is held by or on behalf of a US Person in violation of the applicable
transfer restrictions, the Company shall have the right at any time, at the expense and risk of the holder of any Benefi-
ciary Shares held by or on behalf of a US person, to require such holder to sell such Beneficiary Shares to a non US
person outside the United States.
Unless otherwise specified in the applicable Supplement, each purchaser or holder of this Beneficiary Share or any
interest herein shall be deemed to have represented by such purchase and/or holding that it is not a benefit plan investor,
is not using the assets of a benefit plan investor to acquire such Beneficiary Shares, and shall not at any time hold such
Beneficiary Shares for or on behalf of a benefit plan investor.
If any interest in this Beneficiary Shares is held by or on behalf of a benefit plan investor in violation of this legend,
the Company shall have the right at any time, at the expense and risk of the holder of such interest, to require such
holder to sell such Beneficiary Shares to a non US Person outside the United States.
As used herein, the terms offshore transaction and US Person have the meanings given to them by rule 902 of Reg-
ulation S under the Securities Act.»
7.11 Notices to Beneficiary Shareholders
7.11.1 Any notice to be given to or by any Beneficiary Shareholder pursuant to the Articles shall be in writing.
7.11.2 Notices to the Beneficiary Shareholders will be mailed to them by ordinary post at their respective address as
recorded in the relevant register(s) of Beneficiary Shareholders, provided that, as long as the Beneficiary Shares are list-
ed on any stock exchange or publicly offered in any jurisdiction, any notice to the Beneficiary Shareholders shall be pub-
lished in accordance with the applicable rules and regulations.
As long as any Beneficiary Share in registered form is held in its entirety by and in the name of a Clearing Agent or
Clearing Agents, notices to Beneficiary Shareholders may be delivered to the Clearing Agent(s) for communication to
the Beneficiary Shareholders. Any such notice shall be deemed to have been given to the Beneficiary Shareholders on
the Luxembourg Business Day immediately following the day on which such notice has been given to the Clearing
Agent(s).
Notices given pursuant to the preceding paragraphs will become effective: (a) if delivered to the relevant Clearing
Agent(s), the third (3) day after such delivery to the Clearing Agent or all the Clearing Agents (if more than one); (b) in
the case of Beneficiary Shares in registered form, on the third (3) day after the date of mailing by ordinary post; (c) if
published, on the date of such publication, or, if published or required to be published more than once, on the date of
the first publication.
7.11.3 Any Beneficiary Shareholder present in person at any meeting of the Company shall, for all purposes, be
deemed to have received the convening notice of such meeting and, where required, of the agenda of such meeting.
7.11.4 Notwithstanding the provisions of the Articles, a notice may be given by the Company to a Beneficiary Share-
holder in any manner agreed in advance by such Beneficiary Shareholder.
7.12 Information rights of Beneficiary Shareholders
Subject to the relevant Conditions, the Beneficiary Shareholders shall have in the same information rights as Ordinary
Shareholders (as defined below).
Art. 8. Compartments. The board of directors may establish one or more compartments which may be distin-
guished by the nature of acquired risks or assets, the distinctive terms of the issues made in their respect, the reference
currency or other distinguishing characteristics (each a «Compartment»).
The terms and conditions of the Instruments (including the Articles, the Supplement, the Series and the Tranches as
far as Beneficiary Shares are concerned) issued in respect of, and the specific objects of, each Compartment shall be
determined by the board of directors and shall be stated in the conditions relating to that Compartment. Each holder
of Instruments issued shall be deemed to fully adhere to, and be bound by, the conditions applicable to these Instruments
and these Articles by subscribing to these Instruments.
The rights of investors and of creditors concerning a Compartment or which have arisen in connection with the cre-
ation, operation or liquidation of a Compartment are limited to the assets of that Compartment.
The assets of a Compartment are exclusively available to satisfy the rights of investors in relation to that Compart-
ment and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liqui-
dation of that Compartment.
For the purpose of the relations between investors, each Compartment will be deemed to be a separate entity.
The board of directors shall (as and when several Compartments have been created) establish and maintain separate
accounting records for each of the Compartments of the Company for the purposes of ascertaining the rights of holders
of Instruments issued in respect of each Compartment for the purposes of the Articles and the conditions, such ac-
counting records to be conclusive evidence of such rights in the absence of manifest error.
Where any asset is derived from another asset (whether cash or otherwise) such derivative asset shall be applied in
the books of the Company to the same Compartment as the asset from which it was derived and on each revaluation
of an asset the increase or diminution in the value of such asset shall be applied to the relevant Compartment.
54393
In the case of any asset of the Company (not being attributable to the Ordinary Shares) which the board of directors,
or any person acting on behalf of the board of directors, does not consider in their own discretion to be attributable
to a particular Compartment, the board of directors, or any person acting on behalf of the board of directors, shall have
the discretion to determine the basis upon which any such asset shall be allocated or apportioned between Compart-
ments, if at all, and the board of directors shall have power at any time and from time to time to vary such basis.
Unless otherwise determined in the conditions of a Compartment, the board of directors (or its delegate) may at
any time liquidate single Compartments, unless such liquidation occurs in the context of a general liquidation of the
Company.
As and when several Compartments have been created the Company shall establish consolidated accounts. Such con-
solidated accounts of the Company, including all Compartments, shall be expressed in the reference currency of the
corporate capital of the Company. The reference currencies of the Compartments may be in different denominations.
Chapter III. Board of Directors, Auditor
Art. 9. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three
members who need not be shareholders.
The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a pe-
riod not exceeding six (6) years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and
they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.
In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-
maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
ratify the election at their next general meeting.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a
chairman. It may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of directors and of the general meeting of shareholders.
The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if
any two directors so require.
The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in
his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore
of such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the
general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax or any other electronic means
approved by the board of directors to all directors at least forty-eight (48) hours in advance of the day set for such
meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the
notice of meeting. The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.
Each director may waive this notice by his consent in writing or by cable, telex, fax or any other electronic means
approved by the board of directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing
or by cable, telex, fax or any other electronic means approved by the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via
any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultane-
ously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content.
Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors
will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman of the board of directors.
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s corporate object. In particular, the board of directors
is vested with the power to create one or several compartments in relation to bonds, notes, convertible bonds and
other debt instruments issued by the Company, compartments corresponding to separate pools of assets and liabilities
of the Company and each compartment being segregated from all other compartments of the Company and each com-
partment will be deemed to be a separate entity.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are within
the competence of the board of directors.
The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may be but need not be
directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine the powers
of the committee(s).
Art. 13. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and
the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
54394
ployees or other persons who may be but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
specific permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of shareholders.
Art. 14. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
tures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person(s) to
whom such signatory power has been delegated by the board of directors but only within the limits of such power.
Art. 15. Custodian. The Company appoints a custodian established in the Grand Duchy of Luxembourg which shall
fulfil the duties and bear the responsibilities as provided by the law of 22 March 2004.
Art. 16. Independent External Auditor(s). The accounts of the Company are audited by one or more independ-
ent external auditors.
The independent auditor(s) shall be appointed by the board of directors of the Company in accordance with the law
of 22 March 2004, and the board of directors shall determine their number and the duration of their appointment.
Chapter IV. General Meeting of Ordinary Shareholders
Art. 17. Powers of the General Meeting of Ordinary Shareholders. Any regularly constituted general meet-
ing of ordinary shareholders of the Company (the «Ordinary Shareholders») represents the entire body of sharehold-
ers. Subject to the provisions of article 12 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.
Art. 18. Annual General Meeting of Ordinary Shareholders. The annual general meeting shall be held at the
registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
30 May of each year, at 11:00 a.m..
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 19. Other General Meetings of Ordinary Shareholders . The board of directors may convene other gen-
eral meetings of Ordinary Shareholders. Such meetings must be convened if Ordinary Shareholders representing at least
one fifth of the Company’s capital so require.
General meetings of Ordinary Shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judge-
ment of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 20. Procedure, Vote. General meetings of Ordinary Shareholders are convened by notice made in compli-
ance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of Ordinary Shareholders and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
An Ordinary Shareholder may act at any general meeting of Ordinary Shareholders by appointing in writing or by
telegram, telex, fax or any other electronic means as his proxy another person who need not be an Ordinary Share-
holder.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general
meeting of Ordinary Shareholders.
Each Ordinary Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of Ordinary Shares repre-
sented, by a simple majority of votes.
Beneficiary Shares do not confer any voting rights at the Annual General Meeting of Ordinary Shareholders or at any
other General Meeting of Ordinary Shareholders, except if stated otherwise in the Articles or in the Supplement (as
defined above).
Copies or extracts of the minutes of the general meeting of Ordinary Shareholders to be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.
Chapter V.- Fiscal year, Allocation of Profits
Art. 21. Fiscal Year. The Company’s accounting year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.
The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 22. Appropriation of Profits. Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of share-
holders determines how the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the
annual net profits to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to dis-
tribute it to the shareholders as a dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends (interim
dividends). The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment (interim dividends).
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided
by law.
Each compartment of the Company may be separately liquidated without such separate liquidation resulting in the
liquidation of another compartment. Only the liquidation of the last remaining compartment of the Company will result
in the liquidation of the Company
54395
Should the Company be dissolved and liquidated anticipatively or by expiration of its term (if applicable), or any com-
partment of the Company (if any) be liquidated, the liquidation of the Company or of the relevant compartment will be
carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders respectively the board of di-
rectors for each compartment which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII. Limited recourse and non petition
Art. 24. Limited Recourse. The rights of investors and of creditors concerning a Compartment or which have
arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a Compartment are limited to the assets of that Com-
partment.
The assets of a Compartment are exclusively available to satisfy the rights of investors in relation to that Compart-
ment and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liqui-
dation of that Compartment.
For the purpose of the relations as between investors, each Compartment will be deemed to be a separate entity.
Art. 25. Non Petition
No holder of any debt instruments issued by the Company or any other creditor of the Company (including those
whose claims relate to a particular Compartment) may attach any of the assets of the Company, institute against or
consent to any bankruptcy, insolvency, controlled management, reprieve of payment, composition, moratorium or any
similar proceedings, unless so required by law.
Chapter VIII. Applicale Law
Art. 26. Applicable Law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the «1915 Law») and by the law on securitisation of 22 March 2004.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 26 of the 1915 Law have been observed.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on 31 December 2006.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day and time and at the place as indicated in the
Articles in the year 2007.
<i>Subscription and Paymenti>
The parties appearing, having drawn up the Articles of the Company, they have subscribed to the number of shares
and paid up the amounts specified below:
Proof of all these payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
Article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Valuation of Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its
formation, are estimated at approximately five thousand euro (EUR 5.000).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:
I) The number of directors is set at five (5).
II) The following have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2007:
1. DDr Alexander Schweickhardt, born on 14 January 1965 in Klagenfurt, Austria, residing in Stubenring 18/24, 1010
Vienna, Austria;
2. Dr Alexander Goetzinger, born on 28 June 1962 in Salzburg, Austria, residing in Neulinggasse 18/15, 1030 Vienna,
Austria;
3. Mr Stefan Heinrich, born on 25 March 1967 in Frankfurt/Main, Germany, residing in 2 Duke’s Yard W1J 5AW Lon-
don, United Kingdom;
4. Mr Godfrey Abel, born on 2 July 1960, residing in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and
5. Mr Keith Mc Shea, born on 18 February 1972, residing in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
III) Pursuant to the provisions of the Articles and of the Company law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, the meeting of shareholders hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of
the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members of the
board of directors.
IV) The registered office of the Company is established at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the persons ap-
pearing, named above, this deed and the Articles contained herein, are worded in English, followed by a German version;
Shareholders
Subscribed Number
of Payments
Capital Share(s)
HARDT GROUP INVESTMENTS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000.- EUR
30
30,000.- EUR
DDr Alexander Schweickhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000.- EUR
1
1,000.- EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000.- EUR
31
31,000.- EUR
54396
at the request of the same persons appearing, in case of divergences between the English and the German texts, the
English version shall prevail.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to persons appearing known to the undersigned notary by their
names, usual surnames, civil status and residences, the said persons appearing have signed with us, the notary, the
present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundfünf, am vierten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Sind erschienen:
1) HARDT GROUP INVESTMENTS AG, eine Gesellschaft österreichischen Rechts, mit Geschäftssitz in Stubenring
18, A-1010 Wien, vertreten durch Max Welbes, avocat, aufgrund einer am 27. September 2005 gegebenen Vollmacht.
2) DDr Alexander Schweickhardt, wohnhaft in Stubenring 18/24, A-1010 Wien vertreten durch Max Welbes, avocat,
aufgrund einer am 27. September 2005 gegebenen Vollmacht.
Die vorbezeichneten Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur pa-
raphiert wurden, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die obengenannten Komparenten haben die Satzung einer Gesellschaft verfasst, die sie hiermit gründen und wie folgt
beurkunden:
Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Form, Name. Zwischen den unterzeichnenden Parteien und all jenen Personen, die Eigentümer der hier-
nach erstellten Aktien werden, wird hiermit eine Gesellschaft in Form einer société anonyme gegründet. Diese Gesell-
schaft wird den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften
vom 10. August 1915, dem Gesetz über die Verbriefung vom 22. März 2004 und den Bestimmungen dieser Satzung un-
terliegen (die «Satzung»).
Die Gesellschaft trägt den Namen HARDT GROUP SECURITIES S.A. (die «Gesellschaft»).
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Sitz kann aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrates an jeden Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt
werden.
Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung am eingetragenem Sitz oder die Verbin-
dung mit einem solchen Sitz oder die Verbindung zwischen diesem und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann
der eingetragene Sitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins
Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei Auswirkungen auf die Nationalität der Gesell-
schaft, sie behält unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des eingetragenen Sitzes die luxemburgische Nationalität
bei.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist, direkt oder durch andere Vehikel, der Erwerb und
die Übernahme von Risiken die, unter anderen, mit alternativen Anlagen verbunden sind, und die entweder im direkten
Zusammenhang mit Ansprüchen, anderen Vermögenswerten oder Verpflichtungen Dritter stehen, oder der Erwerb
oder die Übernahme von Risiken die mit dem Rückgabewert der mit jeglicher Aktivität von Dritten verbunden sind und
die Ausgabe von Eigenkapital, Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, insbesondere Wechsel (notes), Zertifikaten
und Wandelschuldverschreibungen sowie jeglicher anderer Wertpapiere, wie im Gesetz vom 22. März 2004 über Ver-
briefung definiert und die über- und/oder untergeordnet sein können (die «Instrumente»), verbunden ist. Die Instru-
mente können auf einer isolierten Weise oder durch private Anlage ausgegeben werden. Die Instrumente können von
verschiedener Teilfonds ausgegeben werden.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, unter anderem Finanzderivate schließen, welche direkt oder indirekt,
mit dem Gesellschaftszweck verbunden sind, mit der Ausnahme von Geschäften, die Banken vorenthalten sind, sowie
jedwede Handlungsweise, Aktivität und Betätigung für sich beanspruchen, die Verbriefungs- Vehikeln gemäss des Geset-
zes vom 22. März 2004, dem die Gesellschaft unterliegt, erlaubt sind und dem Gesellschaftszweck entsprechen, sowie
notwendig und geeignet erscheinen; sofern diese nicht den vorgenannten Zwecken widersprechen, oder durch jedwede
andere Abkommen, deren Partei die Gesellschaft sein kann, verboten ist.
Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Gesellschaftskapital. Die Gesellschaft hat ein gezeichnetes und eingezahltes Kapital, das sich auf einund-
dreißig Tausend Euro (EUR 31.000,-) beläuft und in einunddreissig (31) Aktien mit einem Nennwert von Tausend Euro
(EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt ist.
Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, der unter den für eine Änderung die-
ser Satzung nach Luxemburger Recht erforderlichen Bedingungen erfolgt, erhöht oder reduziert werden.
Art. 6. Aktien. Die Aktien haben ausschließlich die Form von Namensaktien (die «Gewöhnlichen Aktien»).
Art. 7. Vorzugsaktien
7.1 Ausgabe der Vorzugsaktien
Gemäß den Bestimmungen der Satzung werden die Rechte und Pflichten die an jeder Vorzugsaktien (die «Vorzugs-
aktie») anhängen nach dem alleinigen Ermessen des Vorzugsrats an deren Ausgabetermin oder an einem späteren Zeit-
54397
punkt bestimmt. Jede Vorzugsaktien wird vom Verwaltungsrat im Namen der Gesellschaft als Teil einer Teilsausgabe,
Tranche (die «Tranche») ausgegeben. Eine oder mehrere Tranche(n) können vom Verwaltungsrat als Serie (die «Serie»)
bezeichnet werden. Die Rechte und Pflichten die, zusätzlichen der Satzung, jeder Serie oder Tranche von Vorzugsaktien
anhängen, werden in den entsprechenden Bestimmungen und Bedingungen des Anhangs (der «Anhang») bezüglich der
entsprechenden Serie oder Tranche (die «Bedingungen») angeführt.
Vorzugsaktien können gegen Geldeinlage oder gegen Sacheinlage, wie in den Bestimmungen des entsprechenden Teil-
fonds (wie unten definiert) erlaubt oder bestimmt, ausgegeben werden. Die Bewertung der Sacheinlagen unterliegt, ge-
mäß dem 1915 Gesetz, der Kontrolle eines Wirtschaftsprüfers.
Der entsprechende Anhang zeigt den Ausgabepreis jeder Vorzugsaktie an und legt, wenn anwendbar, die Ausgabe-
details der Vorzugsaktien der entsprechenden Serie offen.
7.2 Rechte der Vorzugsaktien
7.2.1 Allgemeines
Die Bedingungen jeder Serie oder Tranche von Vorzugsaktien können die Bestimmungen der Satzung nicht aufheben
und beinhalten:
(a) die Währung und, eventuell, der Nennwert der Vorzugsaktien;
(b) die Serie oder Tranche zu der jede Vorzugsaktie gehört, jede Serie wird mit einer Seriennummer versehen und
jede Tranche (wenn mehrere in einer Serie) wird mit einer Tranchennummer und Titel versehen;
(c) die Anlagegrenzen des entsprechenden Teilfonds;
(d) Einzelheiten über die Dividendenzahlung bezüglich der entsprechenden Serie oder Tranche, die Währung in der
die Dividenden ausgezahlt werden, der Rücknahmebetrag, die Währung in der die Rückzahlungen getätigt werden und
das Datum an dem der Rückzahlungsbetrag von der Gesellschaft gemäß den Bedingungen und in Übereinstimmung mit
der Satzung, wie in den entsprechenden Anhang dargelegt, ausgezahlt wird;
(e) die Bewertungsmethode des Rückzahlungsbetrags und die Beschreibung der spezifischen Risiken und/oder Ver-
mögenswerte bezüglich derer jeder Rückzahlungsbetrag oder jede Dividende berechnet wird;
(f) jede zusätzliche Übertragungs- oder Verkaufsbegrenzung bezüglich der Vorzugsaktien;
(g) jede Beschränkung der Wahlrechte die den Vorzugsaktien anhängen; und
(h) jede zusätzliche Rechte, Pflichten und Begrenzungen die einer Vorzugsaktie jeder Tranche durch das alleinige Er-
messen des Verwaltungsrats anhängen.
7.2.2 Folge der Bedingungen
Werden die Bedingungen bezüglich einer Serie oder einer Tranche einmal angenommen, so:
(a) binden diese, vorbehaltlich Artikel 7.2.1. die Vorzugsaktionäre, die Gewöhnlichen Gesellschafter (wie unten defi-
niert), die Halter von Schuldverschreibungen und den Verwaltungsrat als wenn sie in der Satzung enthalten wären;
(b) jede Änderung oder Abschaffung durch den Verwaltungsrat gemäß diesen Artikel 7.2 untersteht den Bedingungen
von Artikel 7.8;
(c) alle Zahlungen bezüglich Vorzugsaktien (insbesondere Zeichnungen und Rückzahlungen) werden in der Währung
in der die Vorzugsaktie ausgegeben wurde zurückgezahlt, in jeder anderen Währung(en) wie in den Bedingungen fest-
gelegt und, sollte eine Schwierigkeit bei der Zahlung in dieser Währung auftreten, in jeder anderen Währung, wie ab-
schließend vom Verwaltungsrat festgelegt.
7.2.3 Recht auf Dividenden
Gemäß der Satzung und den entsprechenden Bedingungen verleiht jede Vorzugsaktie ihrem Besitzer das Recht die
aufgelaufen Dividenden, einschließlich Zwischendividenden (wenn anwendbar), aus dem Profit oder dem Reservekonto
des entsprechenden Teilfonds, in Übereinstimmung mit der Satzung und den entsprechenden Bedingungen, ausgezahlt
zu bekommen.
Außer es werden verschiedene Rechte und Pflichten verschiedenen Vorzugsaktien, wie in der Satzung oder in einer
Bedingungen dargelegt, angehängt, werden alle Dividenden pro rata zu den auf die Vorzugsaktien einbezahlten Beträge
aufgeteilt und bezahlt.
Alle unangespruchten Dividenden werden, bis sie geltend gemacht werden, angelegt oder anderwertig vom Verwal-
tungsrat für den Nutzen des entsprechenden Teilsfonds gebraucht. Die Dividenden tragen keine Zinsen gegenüber des
entsprechenden Teilfonds oder der Gesellschaft.
Sollte der Verwaltungsrat so entscheiden, verfallen alle unangespruchten Dividenden zehn (10) Jahre nach ihrer Aus-
gabe zu Gunsten des entsprechenden Teilsfonds oder, sollte dieser Teilfonds bis dato liquidiert worden sein, zu Gunsten
der Gesellschaft.
Gemäß den Bestimmungen der Satzung kann der Verwaltungsrat in seinem alleinigen Ermessen beschließen die Er-
träge (die die Ergebnisvorträge die auf einem Vorzugsaktienkonto verbucht werden beinhalten) eines Teilfonds zu kapi-
talisieren, schadlos dem unverzüglichen und umwiderruflichen Auflaufen der Rechte auf Dividende, wie oben bestimmt.
7.2.4 Recht auf die Rückkaufbeträge
Die Vorzugsaktien können nicht nach Wunsch des Vorzugsaktionärs zurückgenommen werden. Der Verwaltungsrat
(oder sein Beauftragter) kann von Zeit zu Zeit nach seinem alleinigen Ermessen entscheiden alle oder nur einige der
Vorzugsaktien einer Serie oder einer Tranche zurückzunehmen (und die Bestimmungen des Rücklaufs festzulegen), ins-
besondere von einer Einheit die als sogenannte Market Maker der Vorzugsaktien handelt.
Gemäß der Satzung und den entsprechenden Bedingungen verleiht jede Vorzugsaktie ihrem Besitzer das Recht den
Betrag, der am Rückzahlungstag dem Rücknahmebetrag aus den Vermögenswerten des entsprechenden Teilfonds ent-
spricht, gezahlt zu bekommen. Sollte am Rückzahlungsdatum die veräußerten Nettovermögenswerte des betroffenen
Teilfonds nicht ausreichen, den integralen Rückzahlungsbetrag, dem jedem Vorzugsaktionär dieser Serie oder dieser
Tranche zusteht, auszuzahlen, werden, gemäß den Bedingungen, die Veräußerungswerte anteilmäßig zwischen den ver-
schiedenen Vorzugsaktionären dieser Serie oder dieser Tranche verteilt und kein Vorzugsaktionär hat irgendein An-
54398
spruch gegenüber der Gesellschaft bezüglich einem Ausfall. Bei Rückzahlung eines Vorzugsaktionärs gemäß den
entsprechenden Bedingungen werden die betroffenen Vorzugsaktien annulliert und ihr Besitzer hört auf irgend ein Recht
in diesem Zusammenhang zu besitzen.
7.2.5. Zahlungen
Gemäß den Bestimmungen der Satzung und der Bedingungen werden die Dividenden oder andere Gelder den Vor-
zugsaktionären in Namensform mittels Scheck oder jedem anderen Mittel, wie vom Verwaltungsrat festgelegt, per Post
an die Adresse des Vorzugsaktionärs wie diese in den entsprechenden Register der Gesellschaft aufgezeichnet ist oder
an die diesbezüglich berechtigte Person geschieht, im Falle von gemeinschaftlichen Inhabern an jedweden dieser Inhaber,
oder zu solcher Person oder an die Adresse wir vom Besitzer oder vom gemeinschaftlicher Inhaber schriftlich mitgeteilt.
Ein solcher Scheck oder jedes andere Mittel das vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, erfolgt zur Entlastung der Ge-
sellschaft. Die Schecks und andere Mittel, die vom Verwaltungsrat festgelegt wurden, werden auf Risiko des Adressaten
verschickt.
Die Gesellschaft kann von jeder Dividend oder anderen Gelder die einem Vorzugsaktionär bezüglich einer Vorzugs-
aktie bezahlt werden soll jeden Geldbetrag (wenn anwendbar) der Zurzeit von diesen Vorzugsaktionär an die Gesell-
schaft geschuldet wird oder jeden Betrag der dem Gesetz nach hiervon abgezogen werden muss, abhalten.
7.2.6 Stimmrechte - Allgemeines
Grundsätzlich verleihen die Vorzugsaktien den Vorzugsaktionären kein Stimmrecht.
Jeder Vorzugsaktionär hat das Recht die Einberufungsschreiben von jeder Versammlung zu erhalten, an dieser Teil zu
nehmen und zu stimmen, wenn deren Tagesordnungspunkte eine Abänderung ihrer Rechte, wie diese vorher in den
entsprechenden Bedingungen festgelegt wurden, vorsieht. Jede voll eingezahlte Vorzugsaktien gewährt ein Recht auf eine
Stimme.
Die Bestimmungen von Kapitel IV «Generalversammlung der Ordentlichen Gesellschafter», wenn nicht von den Be-
stimmungen dieses Artikel 7 abgeändert, sind anwendbar.
7.2.7 Stimmrechte - Spezifisches
(a) Gemäß den Bestimmungen der entsprechenden Bedingungen hat jeder Vorzugsaktionär einer Serie oder einer
Tranche das Recht:
1. den Verwaltungsrat aufzufordern eine Versammlung der Ordentlichen Gesellschafter und der Vorzugsaktionären
jeder Serie oder Tranche, die stimmberechtigt gemäß dieses Artikels 7.2.7 sind, einzuberufen, sofern dieser Vorzugsak-
tionär mindestens zwanzig (20) Prozent des ausgegebenen und ausstehenden Vorzugsaktien der betroffenen Serie oder
Tranche ausmacht;
2. die Einberufungsschreiben solcher Versammlungen zu erhalten; und
3. an solchen Versammlungen teilzunehmen und zu stimmen;
in jedem Fall bezüglich:
(i) der Abänderung der Gesellschaftsform der Gesellschaft;
(ii) der Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft ausserhalb des Großherzogtums Luxemburg;
(iii) der wesentlichen Abänderung des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft;
(iv) die Entlassung eines Verwaltungsratsmiglieds der Gesellschaft für, insbesonders, ernsthaftes Fehlverhalten oder
Betrug;
(v) außer für die Entscheidung die gemäß den Artikel 100 des 1915 Gesetzes zu treffen ist, der Auflösung und Liqui-
dation der Gesellschaft; und der
(vi) jeder Fusion, Spaltung oder ähnliche Gesellschaftsumstrukturierungen der Gesellschaft in der die Gesellschaft
nicht die hinterbleibende Einheit ist.
(b) Jeder Beschluss bezüglich den Paragraphen (i), (ii), (iii), (v) und (vi) von Artikel 7.2.7 (a) müssen mit einer Zwei-
drittel Mehrheit gefasst werden unter der zusätzlichen Maßgabe, dass die Ordentlichen Gesellschafter einstimmig den
Beschluss bezüglich Artikel 7.2.7 (a) Paragraphen (ii) fassen. Alle Bestimmungen vom Kapitel IV «Generalversammlung
der Ordentlichen Gesellschafter» sind mutatis mutandis anwendbar (einschließlich die Bestimmung der Anzahl der Stim-
men pro Vorzugsaktie jeder Serie oder Tranche die nach diesem Artikel 7.2.7 stimmberechtigt ist), unter der Voraus-
setzung dass:
1. die Anzahl der ausgegeben und ausstehenden Vorzugsaktien jeder Serie oder Tranche die gemäß diesem Artikel
7.2.7 stimmberechtigt ist, wird pro rata zwischen jeder Serie oder Tranche so reduziert, dass sie die Gesamtanzahl der
ausgegebenen und ausstehenden Gewöhnlichen Aktien, die in dieser Versammlung oder jeder vertagten Versammlung
anwesend oder vertreten sind, nicht überscheiten;
2. die Versammlung kann nicht ordnungsgemäß tagen solange nicht mindestens die Hälfte aller ausgegebenen und aus-
stehenden Gewöhnlichen Aktien und Vorzugsaktien jeder Serie oder Tranche, die gemäß diesem Artikel 7.2.7 stimm-
berechtigt sind, anwesend oder vertreten sind. Sollte dieses Quorum nicht erreicht werden, muss eine zweite
Versammlung einberufen werden die ungeachtet der anwesenden und ausstehenden Gewöhnlichen Aktien und Vorzugs-
aktien tagen und abstimmen kann;
3. jeder Beschluss bezüglich Artikel 7.2.7 (a) Paragraphen (v) kann mittels einer einfachen Mehrheit in der Versamm-
lung abgegebenen Stimmen gefasst werden, wobei keinen Unterschied zwischen Gewöhnlichen Aktien und Vorzugsak-
tien besteht.
7.3 Form der Vorzugsaktien
Der Verwaltungsrat kann Vorzugsaktien nur in Namensform ausgeben.
Ein oder mehrere Register von Vorzugsaktionären werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft geführt. Dieses oder
diese Register weisen den Namen jeden Vorzugsaktionär, sein Wohnsitz, Sitz oder Wohnsitz, die Anzahl von ihm ge-
haltenen Vorzugsaktien, den auf jede Vorzugsaktie eingezahlten Betrag, die Übertragung von Vorzugsaktien und das Da-
tum dieser Übertragungen aus.
54399
Es werden keine Zertifikate von Vorzugsaktien in Namensform ausgegeben. Dafür erhalten die Vorzugsaktionäre eine
Besitzbestätigung.
7.4 Übertragung von Vorzugsaktien
Die Übertragung von Vorzugsaktien in Namensform erfolgt mittels einer schriftlichen und ordentlichen ausgeführten
Übertragungsangabe die vom Überträger und vom Übernehmer oder von jeder anderen Person, die die entsprechenden
Vollmachten besitzt, ausgeführt wurde.
7.5 Gemeinschaftliche Inhaber von Vorzugsaktien
Wenn zwei oder mehrer Personen in dem oder den Vorzugsaktienregister(n) als die Inhaber einer Vorzugsaktie (in
Namensform) eingetragen sind, werden diese als die gemeinschaftlichen Inhaber, gemäß den folgenden Bestimmungen
angesehen:
(a) die Gesellschaft ist nicht gehalten mehr als vier (4) Personen als die gemeinschaftlichen Inhaber einer Vorzugsaktie
einzutragen;
(b) die gemeinschaftlichen Inhaber einer Vorzugsaktie haften einzeln wie auch gemeinschaftlich für die Zahlungen in
Bezug auf diese Vorzugsaktie; und
(c) jeder einzelne dieser gemeinschaftlichen Inhaber kann Quittung für jede Dividende, Bonus oder Rückzahlung an
dies gemeinschaftliche Inhaber geben.
7.6 Rücklagekonten der Vorzugsaktien
Der Verwaltungsrat wird ein oder mehrere Rücklagekonten für jede Serie oder Tranche von Vorzugsaktien führen.
Die oder das Rücklagekonto / Rücklagenkonten spiegeln die Einbringungen, die von den Vorzugsaktionären der entspre-
chenden Serie oder Tranche von Zeit zu Zeit getätigt wurden und/oder die Nettoprofite die diesem/diesen Rücklagen-
konto/Rücklagenkonten von Zeit zu Zeit zugeteilt wurden, wie nachfolgend aufgeführt, wurden. Gemäß den
entsprechenden Bedingungen kann der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit nach seinem alleinigem Ermessen bestimmen
die Nettoprofite des betroffenen Teilfonds, wenn diese nicht als Dividende oder Zwischendividende (wenn anwendbar)
ausgeschüttet wurden, den entsprechenden Rücklagenkonto / Rücklagenkonten zuzuweisen und zu übertragen. Diese /
diese Rücklagenkonto / Rücklagenkonten sind Teil des entsprechenden Teilfonds und können zur Dividenden (ein-
schließlich Zwischendividende), Rückzahlungen oder Kapitalrückerstattungen bezüglich der betroffenen Serie oder
Tranche von Vorzugsaktien verwendet werden.
7.7 Zahlungsforderungen auf Vorzugsaktien
7.7.1 Gemäß den Bestimmungen der Satzung und der Bedingungen kann der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit den
Vorzugsaktionären die Zahlung der noch nicht einbezahlten Gelder auf Vorzugsaktienfordern und jeder Vorzugsaktionär
muss (unter Wahrung einer vierzehntätigen (14) Mitteilungsfrist und unter Angabe des Zahlungsdatums und Zahlungs-
orts) diesen Betrag an den angegebenen Ort und Zeit an die Gesellschaft zahlen.
7.7.2 Zahlungsforderungen können auf Raten erfolgen. Eine Zahlungsforderung kann ganz oder teilweise, wie vom
Verwaltungsrat in seinem alleinigen Ermessen bestimmt, storniert oder widerrufen wurden. eine Zahlungsforderung gilt
als gestellt, wenn der Verwaltungsrat den diesbezüglichen Beschluss getroffen hat.
7.7.3 Jede am Fälligkeitsdatum oder den Fälligkeitsdaten, wie in der Mitteilung gemäß Artikel 7.7.1 festgelegt, unbe-
zahlte Summe trägt Zinsen, wie vom Verwaltungsrat festgelegt, bis zu zehn (10) Prozent per annum.
7.7.4 Das Fälligkeitsdatum oder die Fälligkeitsdaten jeder Summe werden in der Mitteilung, die gemäß Artikel 7.7.1
erstellt wurde, festgelegt.
7.7.5 Der Verwaltungsrat kann zwischen einer oder mehreren Serien oder Tranchen und zwischen verschiedenen
Vorzugsaktionären einer Serie oder Tranche unterscheiden.
7.8 Verfall der Vorzugsaktien
7.8.1 Sollte ein Vorzugsaktionär einer Zahlungsaufforderung oder einem Teil einer Zahlungsaufforderung am oder
vor dem Fälligkeitsdatum nicht nachkommen, kann der Verwaltungsrat ihm zu einem späteren Zeitpunkt eine diesbe-
zügliche Zahlungsaufforderung, mit den Zinsen und den eventuell diesbezüglichen angefallenen Kosten, übermitteln.
7.8.2 Die Mitteilung ernennt einen weiteren Tag (der nicht eher als vierzehn (14) Tage nach der Entsendung sein kann)
an dem die Zahlung erfolgen muss, zusammen mit dem Zahlungsort, und kann ebenfalls angeben, dass bei Nicht-Zahlung
am oder vom Zahlungsdatum und dem Zahlungsort (wie angegeben) die Vorzugsaktien verfallen.
7.8.3 Sollten die Bedingungen dieser Mitteilung nicht befolgt wurden, kann zu einem späteren Zeitpunkt aber vor der
integralen Zahlung der Zahlungsforderung und den fälligen Zinsen, jede Vorzugsaktie (bezüglich derer eine solche Mit-
teilung ausgegeben wurde) per Verwaltungsratbeschluss verfallen, und dies betrifft alle beschlossenen aber noch nicht
ausgezahlten Dividenden bezüglich der verfallen Vorzugsaktien.
7.8.4 Verfällt eine Vorzugsaktie gemäß der Satzung, so wird eine Mitteilung an den betroffenen Vorzugsaktionär ge-
schickt und die entsprechende Eintragung in das oder die Register der Vorzugsaktien getätigt; aber kein Verfall wird
durch die Nicht-Entsendung dieser Mitteilung oder dieser Nicht-Eintragung hinfällig.
7.8.5 Eine verfällte Vorzugsaktie kann nach den Bedingungen und in der Art und Weise, wie vom Verwaltungsrat fest-
gelegt, verkauft, wieder zugewiesen oder andersseitig verfügt werden; entweder an die Person die derer Besitzer war
oder an jede andere Person.
7.8.6 Der Inhaber von verfällten Vorzugsaktien hört auf deren Inhaber zu sein, ist aber nichtsdestotrotz gegenüber
der Gesellschaft für alle nicht bis zum Verfallsdatum gezahlten Gelder haftbar und dies zu einem Zinssatz der nach dem
alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats, der jedoch zehn (10) Prozent per annum nicht übersteigen darf, festgelegt wird
und der als dem Verfallsdatum bis zur Zahlung anfällt.
7.9 Veränderung der Rechte der Vorzugsaktien
7.9.1 Die besonderen Rechte einer Serie oder Tranche können, außer dies ist in der entsprechenden Bedingungen
anders vorgesehen, vom Verwaltungsrat während der Laufzeit der Gesellschaft oder des betroffenen Teilfonds oder
während oder mit Blick auf die Liquidation der Gesellschaft oder des betroffenen Teilfonds abgeändert oder aufgehoben
54400
werden, dies entweder mittels einer schriftlichen Zustimmung der Mehrheit der Inhaber des ausgegebenen und ausste-
henden Vorzugsaktien dieser Serie oder Tranche oder mittels eines zustimmenden Beschlusses, der in einer getrennten
Versammlungen der Vorzugsaktionäre der betreffenden Serie oder Tranche mit einer einfachen Mehrheit getroffen wur-
den; diese Zustimmungen sind jedoch nicht erforderlich im Falle einer Änderung, Abänderung oder Aufhebung die die
Interessen der betroffenen Vorzugsaktionären nicht wesentlich beeinträchtigt, es sei denn, ein oder mehrere Vorzugs-
aktionäre, die mindestens zwanzig (20) Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Vorzugsaktien der betreffenden
Serie oder Tranche halten, fordern den Verwaltungsrat dazu auf, diese Änderung den obigen Zustimmungen zu unter-
werfen, dies unbeschadet der vorzeitigen Auflösung. Jede Änderung, Abänderung oder Aufhebung wird in den abgeän-
derten Bedingungen aufgeführt und eine diesbezügliche Kopie den betroffenen Vorzugsaktionären übermittelt und ist
für diese bindend.
7.9.2 Sollte die Zustimmung gemäß Artikel 7.9.1 durch einen Beschluss der Vorzugsaktionären erfolgen, muss diese
Beschluss auf die Tagesordnung der Versammlung der betroffenen Vorzugsaktionäre genommen wurden. Jede Bestim-
mung des 1915 Gesetzes ist auf eine solche getrennte Versammlung anwendbar.
7.9.3 Die besonderen Rechte die den Vorzugsaktionären jeder Serie oder Tranche erteilt wurden, gelten abgeändert
durch die Reduzierung des einbezahlten Kapitals auf diese Vorzugsaktien oder durch die Auflegung vorrangiger Vorzugs-
aktien (außer anderenfalls expressis verbis von der Satzung oder den Bedingungen dieser Vorzugsaktien bestimmt) gel-
ten aber, ohne Beschränkung, als nicht abgeändert durch:
(a) die Auflegung, Zuteilung oder Ausgabe von zusätzlichen Wertpapieren die nicht in dem betroffenen Teilfonds par-
tizipieren; oder
(b) die Auflegung, Zuteilung oder Ausgabe von Gewöhnlichen Aktien; oder
(c) die Rückzahlung, gemäß den anwendbaren Bedingungen, von einigen oder sämtlichen Vorzugsaktien einer Serie
oder Tranche; oder
(d) der Zahlung einer Dividende auf Vorzugsaktien einer anderen Serie oder Tranche aus den Vermögenswerten des
Teilfonds dieser anderen Serie oder Tranche; oder
(e) die Abänderung der Definition in der Satzung von «US Person» oder «Ausgeschlossene Person» wenn die Gesell-
schaft beraten wurde, dass diese Abänderung die Interesse der Gesellschaft nicht wesentlich beeinträchtigen wird.
7.10 Allgemeine Einschränkungen bezüglich
7.10.1 Die Vorzugsaktien wurden und werden nicht unter dem U.S. Act von 1933, wie abgeändert, registriert und ihr
Handel wurde und wird nicht von der U.S. Commodity Futures Trading Commission unter dem U.S. Commodity Ex-
change Act, wie abgeändert, zugelassen. Keine Vorzugsaktie wird von der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von
Amerika an oder für die Rechnung einer U.S. Person, wie unter Regel 902 im U.S. Securities Act von 1933, wie abgeän-
dert, definiert, an eine Ausgeschlossene Person d.h. jedem sog. «benefit plan» Investor oder an eine andere Person die
durch das Halten einer Vorzugsaktie der Gesellschaft einen Schaden zufügen könnte, begeben, angeboten oder verkauft,
wenn dies:
(a) einen Steuerschaden oder eine aufsichtsrechtliche Benachteiligung für die Gesellschaft darstellt oder darstellen
könnte;
(b) für die Gesellschaft eine Verletzung eines Gesetzes oder einer Bestimmung eines Landes oder einer Regierungs-
behörde die sich auf die Gesellschaft anwenden, einschliesslich, aber nicht begrenzt auf, jede devisenrechtliche Bestim-
mungen darstellen kann, oder:
(c) die Gesellschaft an eine US Person oder an eine Ausgeschlossene Person übertragen würde oder wenn eine US
Person oder eine Ausgeschlossene Person die Gesellschaft ökonomisch besitzen würde.
7.10.2 Der Verwaltungsrat und jeder rechtsmässiger Bevollmächtigter der Gesellschaft, im Namen der Gesellschaft,
jeden Beweis verlangen, der nach ihrem alleinigen Ermessen zufriedenstellend ist, dass der Erwerber keine US Person
oder keine Ausgeschlossene Person ist und, bis zum Erhalt dieses zufriedenstellenden Beweises, die Einschreibung in das
oder die Register der Vorzugsaktionäre verweigern.
7.10.3 Jeder Vorzugsaktionär der beabsichtigt eine US Person oder eine Ausgeschlossene Person zu werden muss die
Gesellschaft unverzüglich von diesem Vorhaben unterrichten und jeder Vorzugsaktionäre muss, bevor er eine US Per-
son oder eine Ausgeschlossene Person wird, alle seine Vorzugsaktien einer Person (einschliesslich, aber nicht begrenzt
auf einen derzeitigen Vorzugsaktionär) die der Satzung nach berechtigt ist diese Vorzugsaktien zu halten, abtreten.
7.10.4 Sollte der Verwaltungsrat wissen, dass eine Vorzugsaktie, entweder mittelbar oder unmittelbar, von einer US
Person oder von einer Ausgeschlossenen Person gehalten wird der von einer solchen Person entstanden werden soll,
so kann der Verwaltungsrat diese Person mittels einer Mitteilung (die «Zwingende Abtretungsmitteilung») diese Person
zwingen diese Vorzugsaktie (n) einer Person (einschliesslich, aber nicht begrenzt auf einen derzeitigen Vorzugsaktionär),
die der Satzung nach berechtigt ist diese Vorzugsaktie (n) zu halten, abzutreten. Das obige zu einem Preis den dem ent-
sprechenden Nettoinventar der betroffenen Vorzugsaktie(n) entspricht, oder, sollte kein Ankäufer für diese Vorzugs-
aktie(n) zu diesem Preis gefunden werden, zu dem höchst gebotenen Preis. Die Gesellschaft ist dem betroffenen
Vorzugsaktionär nicht verpflichtet den höchsten Verkaufspreis zu finden.
7.10.5 Der Verwaltungsrat und jeder rechtmässiger Bevollmächtigter der Gesellschaft kann für jede vorgeschlagene
Abtretung von Vorzugsaktie(n) jede Information oder Beweis, die sie nach ihrem alleinigen Ermessen für angepasst hal-
ten, fordern.
7.10.6 Sollte eine Person, die den Gesetzen und Bestimmungen eines Landes untersteht, sich bewusst werden, dass
sie Vorzugsaktie(n) in Zuwiederhandlung der Gesetze oder Bestimmungen dieses Landes oder einer seiner Regierungs-
behörden hält oder besitzt, und unverzüglich die Gesellschaft hiervon unterrichten und die Vorzugsaktie(n) einer Per-
son, die diese gemäss der Satzung halten kann, abtreten, ausser diese Person hat eine Mitteilung gemäss Artikel 7.10.4
erhalten.
54401
7.10.7 Sollte eine Person, die eine Zwingende Abtretungsmitteilung erhalten hat, die Vorzugsaktie (n) nicht innerhalb
von dreißig (30) Tag ab der Zwingenden Abtretungsmitteilung abgetreten haben, so verfallen diese Vorzugsaktie(n) un-
verzüglich nach dem Ablauf dieser dreissigtägigen (30) Frist und die Bestimmungen von Artikel 7.8 sind anwendbar.
7.10.8 Der Verwaltungsrat hat, in seinem alleinigen Ermessen, jede Befugnis (aber nicht die Pflicht) jede weitere Ein-
schränkung aufzuerlegen, um sicher zu stellen, dass keine Vorzugsaktie von einer US Person oder einer Ausgeschlosse-
nen Person erworben, gehalten oder abgetreten bekommt.
7.10.9 Der Verwaltungsrat, die Gesellschaft und jeder ihrer rechtmässigen Bevollmächtigter ist den Vorzugsaktionä-
ren gegenüber für keinen Schaden der im Zusammenhang, dass eine US Person oder eine Ausgeschlossene Person In-
haber von einer Vorzugsaktie geworden ist, oder im Zusammenhang des Verstosses einer Bestimmung dieses Artikels
7.10, haftbar. Jeder Inhaber der gegen eine Bestimmung der Satzung oder gegen eine Beschränkung die vom Verwal-
tungsrat gemäss diesem Artikel 7.10 aufgelegt wurde verstösst, muss die Gesellschaft schadlos halten.
7.10.10 Jede Vorzugsaktie muss, vorbehaltlich den entsprechenden Bedingungen, einen Hinweistext beinhalten, von
dem jeder Inhaber angesehen wird, dass er ihm zustimmt. Dieser Hinweistext (auf Englisch) lautet wie folgt:
«The Beneficiary Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended
(the Securities Act) and trading in the Beneficiary Shares has not been, and will not be, approved by the US Commodity
Futures Trading Commission under the US Commodity Exchange Act, as amended. Neither this Beneficiary Share nor
any interest herein may be offered, sold, pledged or otherwise transferred except to a transferee that is a non US person
in an offshore transaction in accordance with Regulation S under the Securities Act and applicable securities laws of any
state of the United States or any other jurisdiction and in compliance with the provisions of the Articles pursuant to
which the security was issued.
If this Beneficiary Share or any interest herein is held by or on behalf of a US Person in violation of the applicable
transfer restrictions, the Company shall have the right at any time, at the expense and risk of the holder of any Benefi-
ciary Shares held by or on behalf of a US person, to require such holder to sell such Beneficiary Shares to a non US
person outside the United States.
Unless otherwise specified in the applicable Supplement, each purchaser or holder of this Beneficiary Share or any
interest herein shall be deemed to have represented by such purchase and/or holding that it is not a benefit plan investor,
is not using the assets of a benefit plan investor to acquire such Beneficiary Shares, and shall not at any time hold such
Beneficiary Shares for or on behalf of a benefit plan investor.
If any interest in this Beneficiary Shares is held by or on behalf of a benefit plan investor in violation of this legend,
the Company shall have the right at any time, at the expense and risk of the holder of such interest, to require such
holder to sell such Beneficiary Shares to a non US Person outside the United States.
As used herein, the terms offshore transaction and US Person have the meanings given to them by rule 902 of Reg-
ulation S under the Securities Act.»
7.11 Mitteilungen an die Vorzugsaktionäre
7.11.1 Jede Mitteilung an oder von den Vorzugsaktionären erfolgt schriftlich.
7.11.2 Mitteilungen an die Vorzugsaktionäre werden ihnen mittels normaler Post an ihre jeweilige Adresse, wie in den
entsprechenden Register der Vorzugsaktionäre verzeichnet, gesendet. Werden die Vorzugsaktien auf einer Börse ge-
handelt in einer Juridiktion öffentlich vertrieben, wird jede Mitteilung an die Vorzugsaktionäre im Einklang mit den an-
wendbaren Regeln und Bestimmungen veröffentlicht.
So lange wie eine Vorzugsaktie in Namensform ganz von einen oder mehreren sog. Clearing Agents gehalten wird,
können die Mitteilungen an die Vorzugsaktionäre dem oder den Clearing Agenten zur Benachrichtigung der Vorzugsak-
tionären abgeliefert werden. Diese Mitteilungen gelten den Vorzugsaktionären ab dem Luxemburger Bankarbeitstag
übermittelt, der dem Tag an dem diese Mitteilung dem oder den Clearing Agenten übergeben wurden unmittelbar folgt.
Mitteilungen die gemäss den vorherstehenden Paragraphen erteilt wurden, treten wie folgt in Kraft: (a) wenn an Clea-
ring Agenten übermittelt, am dritten (3) Tag ihrer Übermittlung an den Clearing Agenten oder die Clearing Agenten
(sollten diese in der Mehrzahl sein); im Falle von Vorzugsaktien in Inhaberform, am dritten (3) Tag ihrer Versendung per
Post; (c) im Fall einer Veröffentlichung, oder, wenn die Veröffentlichung mehrfach erfolgte oder erfolgen muss, an dem
Datum der ersten Veröffentlichung.
7.11.3 Jeder Vorzugsaktionär der persönlich an einer Versammlung der Gesellschaft teilnimmt, gilt, in jeder Hinsicht,
das Einberufungsschreiben und, wenn erforderlich, die Tagesordnung dieser Versammlung erhalten zu haben.
7.11.4 Ungeachtet den Bestimmungen der Satzung kann die Gesellschaft eine Mitteilung in der Art und Weise an eine
Vorzugsaktionär übermitteln, wie dieser sie vorher angenommen hat.
7.12 Informationsrechte der Vorzugsaktionäre
Vorbehaltliche den entsprechenden Bedingungen haben die Vorzugsaktionäre die selben Informationsrechte wie die
Gewöhnlichen Gesellschafter (wie unten definiert).
Art. 8. Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Teilfonds, welche sich durch die Art der erwor-
benen Risken oder Vermögenswerte, die unterschiedlichen Arten der Referenzwährung oder andere charakteristische
Merkmale unterscheiden, auflegen (jeder ein «Teilfonds»).
Die Fristen und Bedingungen der Instrumente (einschließlich der Satzung, Anhang, Series und Tranchen in bezug auf
Vorzugsaktien) in bezug auf jeden Teilfonds und die besonderen Ziele jedes Teilfonds werden durch den Verwaltungsrat
festgelegt und in den Teilfonds beschrieben. Jeder Inhaber der Instrumente wird durch das Zeichnen solcher Instrumen-
te den Bedingungen, die auf diese Instrumente anwendbar sind, und dieser Satzung beitreten und verpflichtet sein.
Die Rechte der Anleger und die der Kreditgeber bezüglich eines Teilfonds oder solche, die in Verbindung mit der
Gründung, Geschäftsführung oder Liquidation eines Teilfonds entstanden sind, sind auf die Vermögenswerte dieses Teil-
fonds beschränkt.
54402
Die Vermögenswerte eines Teilfonds stehen ausschließlich zur Verfügung um die Rechte der Anlegern zu erfüllen,
die in Verbindung mit dem Teilfonds stehen, sowie um die Rechte der Kreditgebern, deren Ansprüche in Verbindung
mit der Gründung, Geschäftsführung oder Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind, zu erfüllen.
Zum Zwecke der Beziehungen zwischen Anlegern, wird jeder Teilfonds als gesonderte Einheit betrachtet.
Der Verwaltungsrat soll (sobald und falls mehrere Teilfonds gegründet werden) separate Geschäftsbücher für jeden
Teilfonds der Gesellschaft einrichten und führen. Dies geschieht zum Zwecke der Ermittelung der Rechte der Inhaber
der Instrumente, die gemäss der Satzung ausgegeben wurden, sowie als beweiskräftiger Beleg, es sei denn es liegt ein
offenkundiger Fehler vor.
Sollte ein Vermögenswert aus einem anderen Vermögenswert entstehen, (bar oder auf andere Art und Weise), so
soll dieser Vermögenswert in den Geschäftsbüchern desselben Teilfonds geführt werden, wie der Vermögenswert, aus
dem er entstanden ist. Bei jeder Neubewertung eines Vermögenswertes, soll dessen Reduzierung oder Aufwertung auf
den einschlägigen Teilfonds angewendet werden.
Sollte ein Vermögenswert der Gesellschaft (der nicht den Gewöhnlichen Aktien zugeordnet werden kann) nach dem
alleinigen Ermessen des Verwaltungsrates, oder jeder Person die im Namen des Verwaltungsrates handelt, nicht einem
bestimmten Teilfonds zugeordnet werden können, so kann der Verwaltungsrat, oder jede Person die in Namen des Ver-
waltungsrates handelt, nach seinem alleinigen Ermessen die Basis auf Grund welcher ein solcher Vermögenswert zwi-
schen den Teilfonds zugeordnet oder zugeteilt wird, festlegen. Der Verwaltungsrat hat das Recht diese Basis von Zeit
zu Zeit abzuändern.
Sofern nicht in den Bestimmungen eine Teilfonds anderweitig geregelt, kann der Verwaltungsrat (oder sein Delegier-
ter) jeder Zeit einzelne Teilfonds liquidieren. Es sei denn eine solche Liquidierung geschieht während einer generellen
Liquidation der Gesellschaft.
Wenn mehrere Teilfonds errichtet wurden, muss die Gesellschaft eine konsolidierte Bilanz erstellen. Diese schliesst
alle Teilfonds ein und wird in der Referenzwährung des Gesellschaftskapitals ausgedrückt. Die Referenzwährungen der
Teilfonds können verschieden lauten.
Kapitel III. Verwaltungsrat, Rechnungskommissar
Art. 9. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern, die
keine Gesellschafter zusein brauchen, geführt.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung ernannt, die ihre Zahl festlegt, für eine Dauer
die sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben bis zur Wahl ihres Nachfolgers im Amt. Sie sind wiederwählbar
und können zu jeder Zeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Für den Fall dass ein oder mehrere Verwaltungsratsposten durch einen Todesfall, Pensionierung oder ein sonstiges
Ereignis frei werden, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chend diese freie Stelle besetzen. In diesem Fall, muss die Wahl von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt
werden.
Art. 10. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen. Wei-
terhin, kann er einen Sekretär ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss, der für die Protokollführung der
Verwaltungsratssitzungen und der Generalversammlungen verantwortlich ist.
Der Verwaltungsrat tritt aufgrund der Einberufung des Vorsitzenden zusammen. Eine Verwaltungsratssitzung kann
weiterhin von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen werden.
Der Vorsitzende hat bei allen Generalversammlungen und allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz, in seiner Ab-
wesenheit wird die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat eine anderes Verwaltungsratsmitglied oder, wenn zu-
treffend, eine andere Person, pro tempore zum Vorsitzenden per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden der jeweiligen
Versammlung oder Sitzung ernennen.
Die schriftliche Einberufung jeder Sitzung erfolgt mittels Brief oder mittels Fax oder mittels sonstiger elektronischer
Kommunikationsmittel, die vom Verwaltungsrat gutgeheißen wurden, an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48
Stunden vor dem festgelegten Tag der Sitzung, es sei denn in Notfällen, wobei dann der Grund des Notfalls in der Ein-
berufung angegeben ist. Die Einberufung gibt den Ort und die Tagesordnung der Sitzung an.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann auf diese Einberufung mittels einer Zustimmung, per Brief, per Telegram, per Fax,
oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel, die vom Verwaltungsrat gutgeheißen wurden, verzichten.
Es bedarf keiner gesonderten Einberufung für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als der Sitzungsort, in einem
früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in jeder Verwaltungsratssitzung mittels einer Vollmacht handeln, die er einem an-
deren Verwaltungsratsmitglied schriftlich oder telegraphisch, per Telegram, Fax oder mittels sonstiger elektronischer
Kommunikationsmittel, die vom Verwaltungsrat gutgeheißen wurden, erteilt.
Der Verwaltungsrat kann nur dann rechtswirksam beraten oder handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Ver-
waltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Entscheidungen werden durch einen Mehrheitsbeschluss aller in der Sitzung anwesenden oder vertretenden Ver-
waltungsratsmitglieder getroffen.
Ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder können an einer Verwaltungsratssitzung telefonisch, per Videokonfe-
renz oder ähnlichen Art und Weise der Kommunikation, die es den verschiedenen Personen erlaubt gleichzeitig zu kom-
munizieren, teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teilnahme an der Sitzung gleichgestellt.
Eine schriftliche Entscheidung, die von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben wurde, ist rechtsverbindlich
und gültig, als ob sie in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasst worden wäre. Eine
solche Entscheidung, kann in einem oder mehreren Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.
54403
Art. 11. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen. Der Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird von dem
Vorsitzenden der Sitzung und von einem Verwaltungsratsmitglied unterschrieben. Die Vollmachten werden dem Pro-
tokoll beigefügt.
Kopien oder Auszüge von Verwaltungsratsprotokollen, die vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden, müssen
von dem Verwaltungsratsvorsitzenden unterschrieben werden.
Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat die weittestgehende Befugnisse, um alle
Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks nützlich oder notwendig sind. Der Verwaltungs-
rat hat insbesondere die Befugnis einen oder mehrere Teilfonds einzurichten, die in Verbindung stehen mit Wechsel
(notes), Wechselschuldverschreibungen und anderen Schuldverschreibungen die durch die Gesellschaft ausgegeben
wurden, einzurichten. Teilfonds, die seperaten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechen
können ebenfalls aufgelegt werden. Jeder Teilfonds wird von allen anderen Teilfonds der Gesellschaft getrennt und als
gesonderte Einheit betrachtet.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten
sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann entscheiden einen oder mehrere Ausschüsse zu bilden, deren Mitglieder Verwaltungsrats-
mitglieder sein können aber nicht müssen. In diesem Fall, wird der Verwaltungsrat sowohl die Mitglieder ernennen als
auch ihre Befugnisse bestimmen.
Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung und die Vertre-
tung der Gesellschaft im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder sonstigen Personen die keine Gesellschafter zu sein brauchen übertragen, oder
auch besondere Vollmachten oder besondere Befugnisse übertragen, oder dauerhaft oder vorübergehend Funktionen
auf Personen oder Vertreter seiner Wahl übertragen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf ein Verwaltungsratsmitglied, bedarf einer vorherigen Zustim-
mung der Generalversammlung.
Art. 14. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten Parteien durch die gemeinsame Un-
terschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der mit der täglichen Geschäftsführung
der Gesellschaft betrauten Personen im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder durch die gemeinsame oder
einzelne Unterschrift jener Personen, die vom Verwaltungsrat eine entsprechende Vertretung erhalten haben, dies je-
doch nur im Rahmen dieser Befugnis.
Art. 15. Depotbank. Die Gesellschaft benennt eine im Großherzogtum Luxemburg niedergelassene Depotbank,
welche die Aufgaben und die Pflichten im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 erfüllen wird.
Art. 16. Unabhängige externe Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte werden von einem oder mehreren unabhän-
gigen externen Wirtschaftsprüfern geprüft.
Die Wirtschaftsprüfer werden vom Verwaltungsrat im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 ernannt. Der Verwal-
tungsrat kann ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandates bestimmen.
Kapitel IV. Generalversammlung der Gewöhnlichen Gesellschafter
Art. 17. Befugnisse der Generalversammlung der Gewöhnlichen Gesellschafter. Jede Generalversamm-
lung der gewöhnlichen Gesellschafter, die ordnungsgemäß zusammenkommt, vertritt die Gesamtheit der gewöhnlichen
Gesellschafter der Gesellschaft (die «Gewöhnlichen Gesellschafter»). Unter Vorbehalt des Artikel 12, hat sie die weit-
testgehende Befugnisse, Handlungen bezüglich der Tätigkeiten der Gesellschaft zu anzuweisen, auszuführen oder zu ge-
nehmigen.
Art. 18. Jährliche Generalversammlung der Gewöhnlichen Gesellschafter. Die jährliche Generalversamm-
lung der Gewöhnlichen Gesellschafter tritt am eingetragenem Sitz der Gesellschaft oder an dem im Einberufungsbe-
scheid angegebenen Ort am 30. Mai jeden Jahres um 11:00 Uhr zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Versammlung am darauffolgendem Geschäftstag abgehalten.
Art. 19. Andere Generalversammlungen der Gewöhnlichen Gesellschafter. Der Verwaltungsrat kann an-
dere Generalversammlungen einberufen. Diese müssen einberufen werden, wenn Gewöhnliche Gesellschafter, die min-
destens ein Fünftel des Gesellschaftskapital vertreten, diese Einberufung verlangen.
Die Generalversammlungen der Gewöhnlichen Gesellschafter, einschließlich der jährlichen Generalversammlung der
Gewöhnlichen Gesellschafter, können im Ausland abgehalten werden, wenn gemäß des freien Ermessens des Verwal-
tungsrats, welches endgültig ist, Umstände höhere Gewalt dies erforderlich machen.
Art. 20. Verfahren, Abstimmungen. Die Generalversammlungen der Gewöhnlichen Gesellschafter werden
durch eine Einberufung, im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, einberufen.
Sofern alle Gewöhnliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Tagesordnung der Sit-
zung unterrichtet worden zu sein, kann die Sitzung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Ein Gewöhnliche Gesellschafter kann in jeder Generalversammlung der Gewöhnlichen Gesellschafter mittels einer
Vollmacht, die er einer anderen Person schriftlich oder per Telegramm, per Telex, per Fax oder sonstiger elektroni-
scher Kommunikationsmittel erteilt, handeln, ohne dass diese Person ein Gewöhnlicher Gesellschafter zu sein braucht.
Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen, die zur Teilnahme an der Generalversammlung der Gewöhnli-
chen Gesellschafter zu erfüllen sind, festlegen.
Jede Aktie gewährt ein Recht auf eine Stimme, den gesetzlichen Einschränkungen unterliegend.
Falls das Gesetz nichts anderes vorschreibt, werden die Beschlüsse durch einfache Mehrheit, unbeachtet der Zahl der
anwesenden oder vertretenden Aktien, gefasst.
54404
Vorzugsaktien verleihen keine Stimmrechte in der jährlichen Generalversammlung der Gewöhnlichen Gesellschafter
oder in jedweder anderen Generalversammlung der Gewöhnlichen Gesellschafter, außer andersseitig in der Satzung
oder im Supplement (wie oben definiert) vorgesehen.
Kopien oder Auszüge der Protokolle der Versammlung der Gewöhnlichen Gesellschafter, die vor Gericht vorgelegt
werden, müssen von dem Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben wer-
den.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 22. Gewinnverteilung. Die Generalversammlung bestimmt nach Empfehlung des Verwaltungsrates wie die
jährliche Netto - Gewinne verteilt werden. Sie kann entscheiden, alle oder ein Teil der jährliche Netto-Gewinne einer
Rücklage oder eine Abschreibungsrücklage zuzuführen, um einen Transfer in das folgende Steuerjahr zu erreichen, oder
eine Dividende auszuschütten.
Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat eine Vorauszahlung auf Dividenden tätigen
(Zwischendividende). Der Verwaltungsrat setzt die Höhe und das Datum einer solchen Vorauszahlung fest (Zwischen-
dividende).
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 23. Auflösung, Liquidation. Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, kann die Gesellschaft durch einen
Beschluss der Generalversammlung, unter dem gleichen Quorum und den gleichen Mehrheitsbedingungen die für eine
Satzungsänderung erforderlich sind, aufgelöst werden.
Jeder Teilfond kann separat liquidiert werden, ohne dass aus einer solchen Liquidation die Liquidation eines anderen
Teilfonds hervor geht. Nur die Liquidation des letzten verbleibenden Teilfonds der Gesellschaft führt die Liquidation der
Gesellschaft herbei.
Sollte die Gesellschaft frühzeitig oder durch Ablauf ihrer Laufzeit (falls anwendbar) aufgelöst und liquidiert werden,
oder sollte ein Teilfonds der Gesellschaft (falls vorhanden) liquidiert werden, wird die Liquidation der Gesellschaft oder
des betreffenden Teilfonds von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die von der Generalversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise vom Verwaltungsrat ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Vergütung bestimmen.
Kapitel VII. Begrenzter Regressanspruch und Verzicht auf Zwangsvollstreckung
Art. 24. Begrenzter Regressanspruch. Die Rechte von Anleger und Kreditgebern die einen Teilfonds betreffen,
oder welche in Verbindung mit der Gründung, der Geschäftsführung oder Liquidation eines Teilfonds entstanden sind,
sind auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds beschränkt.
Die Vermögenswerte sind ausschließlich dazu bestimmt die Rechte der Anleger die in Verbindung zu diesem Teilfonds
bestehen zu befriedigen und dazu, die Rechte von Kreditgebern deren Ansprüche während der Gründung, Führung oder
Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind zu befriedigen.
Zum Zwecke der Beziehungen der Anleger, wird jeder Teilfonds als gesonderte juristische Person erachtet.
Art. 25. Verzicht auf Zwangsvollstreckung. Kein Inhaber einer durch die Gesellschaft ausgegebenen Schuldver-
schreibung, oder anderer Kreditgeber der Gesellschaft (inklusive derjenigen, deren Ansprüche mit einem bestimmten
Teilfonds verbunden sind) kann, es sei denn gesetzliche Vorschriften schreiben dies vor, Vermögenswerte der Gesell-
schaft gegen oder für einen Bankrott, eine Insolvenz, überwachte Gesellschaftsführung, Zahlungsaufschub, eine Ver-
gleich, Stundung oder jegliche ähnliche Vorgehensweise.
Kapitel VIII. Anwendbares Recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Alle Bereiche, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, werden in
Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das «Gesetz von
1915») sowie von der Bestimmungen vom Gesetz, vom 22. März 2004 über die Verbriefung bestimmt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnende Notar stellt hiermit fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt
wurden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung wird im Jahr 2007 an dem Tag, der Zeit und dem Ort abgehalten werden,
wie es in der Satzung bestimmt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nachdem die vorgenannten Parteien, die Satzung der Gesellschaft aufgestellt haben, haben sie folgende Aktien ge-
zeichnet und folgende Summen eingezahlt:
Dem unterzeichnenden Notar wurden Nachweise über die erfolgten Zahlungen vorgelegt. Der unterzeichnende No-
tar stellt hiermit fest, dass die Vorschriften des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften eingehal-
ten wurde.
Gesellschafter
Gezeichnetes
Anzahl
der Zahlung
Kapital
Aktien
HARDT GROUP INVESTMENTS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,- EUR
30 30.000,- EUR
DDr Alexander Schweickhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,- EUR
1
1.000,- EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,- EUR
31 31.000,- EUR
54405
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Auslagen, Kosten, Honorare und Unkosten jeder Art, die der Gesellschaft durch ihre Gründung entstehen wer-
den auf rund fünftausend Euro (5.000 EUR) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Die obengenannten Personen, die die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals darstellen, haben sich zu einer außeror-
dentlichen Generalversammlung, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden.
Nachdem sie festgestellt haben, dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß zusammen gekommen
ist, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
I) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 5 (Fünf) festgesetzt.
II) Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten im Jahre 2007 zu haltenden jährlichen Generalversamm-
lung ernannt:
1. DDr Alexander Schweickhardt, geboren am 14. Januar 1965 in Klagenfurt, Österreich, wohnhaft in Stubenring 18/
24, 1010 Wien, Österreich;
2. Dr Alexander Goetzinger, geboren am 28. Juni 1962 in Salzburg, Österreich, wohnhaft in Neulinggasse 18/15, 1030
Wien, Österreich;
3. Mr Stefan Heinrich, geboren am 25. März 1967 in Frankfurt/Main, Deutschland, wohnhaft in 2 Duke’s Yard, W1J
5AW London, Vereinigtes Königreich;
4. Mr Godfrey Abel, geboren am 2. Juli 1960, wohnhaft in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; und
5. Mr Keith Mc Shea, geboren am 18. Februar 1972, wohnhaft in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
III) Gemäß den Bestimmungen der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes von 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften, wie abgeändert, ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung und
die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsrats-
mitgliedern zu übertragen.
IV) Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg errichtet.
Der unterzeichnete Notar der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben erwähnten
Parteien, die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst worden
ist; auf Begehren der erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, ist der englische Text maßgebend.
Zu Urkunde dessen, aufgenommen in Luxemburg an dem Tag, dessen Datum eingangs erwähnt ist.
Nach Lesung und Übersetzung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar die vorliegende original Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Welbes, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 150S, fol. 19, case 2. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(088885.3/220/1191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.
AME LIFE LUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 30.566.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue le 13 avril 2005i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Paul-Henri Meyers de son mandat d’Administrateur et nom-
me Monsieur Paul Zimmer en remplacement de Monsieur Paul-Henri Meyers démissionnaire en date du 30 octobre
2004. Son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale de 2011 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2010. En
conséquence, le Conseil est composé de Madame Sophie Beuvaden et de Messieurs Eric Ancion, Jacques Baerten, Dirk
van Berlaer, Guy Burton, Joseph Daleiden, Thierry Derez, Jean Fleury, Alain Hauglustaine, Romain Rossetti, Christian
Sastre et Paul Zimmer.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03047. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048327.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Luxemburg, den 11. Oktober 2005.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
A. Hauglustaine / R. Rossetti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
54406
IT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 283.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 70.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02559, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047949.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
INSTITUT ROSENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 20, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 68.501.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01903, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
(048020.3/1039/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.001.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02397, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048117.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.661.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 9 juin 2005 que:
1. Les personnes suivantes ont démissionnés de leur mandat d’administrateur avec effet immédiat:
- Monsieur Victor Kharitonin;
- Monsieur Valery Egorov;
- Monsieur Egor Kulkov.
2. Les administrateurs suivants sont nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires pour une période
de 6 ans:
- ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, avec siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur François Pfister, né le 25 octobre 1961, à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03093. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048332.3/1035/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
N. Stejn Mortensen.
<i>Pouri> <i>INSTITUT ROSENFELD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FORIG S.C.
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
Luxembourg, le 31 mai 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54407
ITI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.742.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2004 ainsi que le rapport du réviseur d’enterprises y relatif, enregistrés à Luxem-
bourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02594, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
(048131.3/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
ITI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.742.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes y relatif, enregistrés à
Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02598, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
(048137.3/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
FENDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 76.233.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-BF02573, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048209.3/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
CHRISTA INTERSHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 62.982.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales daté du 30 mai 2005 i>
II résulte du contrat de cession conclu en date du 30 mai 2005 entre Monsieur Taddeus H.M. Van Laak, en tant que
cédant, et ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, en tant que cessionnaire, que Monsieur Taddeus H.M. van Laak a cédé
une (1) part sociale de CHRISTA INTERSHIPPING, S.à r.l. qu’il possédait, à ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED.
Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de CHRISTA INTERSHIPPING, S.à r.l. sont les
suivants:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02696. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048333.3/1035/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
<i>Pouri> <i>INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., LUXEMBOURG
i>Signature
<i>Pouri> <i>INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., LUXEMBOURG
i>Signature
Signature.
Nom des associés
Nombre des
parts
WESTGATE FINANCIAL HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499
ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54408
DEXIA PARTICIPATION LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 95.732.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01618, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
(048311.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
POLIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.712.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, AUDIEX S.A. a été nommée nouveau commissaire
aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02681. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048352.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
KRONOSPAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.
R. C. Luxembourg B 46.483.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2005i>
Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 septembre 2005:
- DELOITTE S.A., société anonyme, 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
DELOITTE S.A. (anc. DELOITTE & TOUCHE S.A.), société anonyme, a démissionné de son mandat de commissaire
aux comptes depuis l’assemblée générale du 24 octobre 2003.
Luxembourg, le 24 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00504. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048356.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
KALBAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.450.
—
RECTIFICATIF
Changement d’adresse du gérant et associé suivant:
Monsieur Sandro Grigolli, demeurant au Flat 17, Paultons House, Paultons Square, Londres SW3 5DU, Royaume Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07310. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048801.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
<i>Pour DEXIA PARTICIPATION A LUXEMBOURG S.A.
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG, Société Anonyme
M.-A. Fischer / P. Pasquasy
<i>Assistant Vice President / Attaché de directioni>
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 24 mai 2005.
Signature.
54409
SOMEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.345.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 2 juin 2005 à 14.00 heures au siège sociali>
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maryse Santini de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet immédiat Madame Pascale Mariotti, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son
prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03014. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048379.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
BENTIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.059.
—
EXTRAIT
II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2005 que, le mandat des organes sociaux étant
venu à échéance, ont été renommés:
a) administrateurs
- Monsieur Carlo Crocco, administrateur de société, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano, Via Montalba-
no 22;
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à 12, avenue de la Porte-Neuve, L-
2227 Luxembourg;
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à 23, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg.
Les pouvoirs d’administrateur délégué de M. Crocco sont annulés immédiatement.
b) commissaire aux comptes
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élu viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an
2010.
Luxembourg, le 23 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048401.3/535/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
BUSINESS CONSULTANTS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Dommeldange, 1, rue du Comte de Ferraris.
R. C. Luxembourg B 99.046.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03631, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048440.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour extrait conforme
SOMEL S.A., Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
Le 13 juin 2005.
Signature.
54410
SPRUMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 40.666.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2005 que, le mandat des organes sociaux étant
venu à échéance, ont été renommés:
a) administrateurs
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard
Prince-Henri;
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve;
- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
b) commissaire aux comptes
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élu viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de
l’an 2011.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01908. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048406.3/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
AYUBOWAN, Association sans but lucratif.
Siège social: L-8119 Bridel, 7, rue Paul Binsfeld.
R. C. Luxembourg F 1.111.
—
STATUTS
Objet: Aide aux victimes du Tsunami au Sri-Lanka.
Promouvoir, créer, ou soutenir des projets concernant l’éducation, la santé ou l’environnement.
Promouvoir le parrainage d’enfants.
Créer ou élargir des structures d’accueil ou d’appui et/ou soutenir des projets d’autres associations déjà établies,
d’écoles ou de temples locaux.
Aide à l’emploi par le financement de matériel des dons ou des prêts sans intérêts.
Aide à la reconstruction ou à la réparation de logements ou maisons.
Achat d’équipement ménager, garderobe, chaussures etc.
Date de constitution: le 3 juin 2005.
Durée: illimitée.
Les membres fondateurs:
- Claire Steffen, 7, rue Paul Binsfeld, L-8119 Bridel, Infirmière Luxembourgeoise.
- Nelly Winandy, 34, rue de Schifflange, L-4392 Pontpierre, Infirmière Luxembourgeoise.
- Jeanne Klein, 7, rue de l’église, L-8398 Roodt-Eisch, Infirmière anesthésiste Luxembourgeoise.
- Josée Thilmany, 13, Chaussée blanche, L-8014 Strassen, Infirmière Luxembourgeoise.
- Viviane Schmit, 170, rue des sources, L-2542 Luxembourg, Employée Luxembourgeoise.
Créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle
a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination: AYUBOWAN, A.s.b.l. Elle a son siège à: 7, rue Paul Binsfeld, L-8119
Bridel.
Art. 2. Voir Objet.
Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Art. 4. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite ou verbale.
Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association. Est réputé démissionaire après le
délai de 3 mois à compter du jour de l’échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.
Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association s’ils portent atteinte aux intérêts de l’association. A partir
de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à la décision définitive de l’assemblée géné-
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
54411
rale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion est envisagée est suspendu de plein droit
de ses fonctions sociales.
Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existance de l’association et n’ont
aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 50 EUR.
Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration
régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.
Art. 10. La convocation se fait au moins 30 jours avant la date fixée par l’assemblée générale, moyennant simple
lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Art. 11. Toute proposition écrite, signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle
doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
Modification des statuts et règlement interne.
Nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse.
Approbation des budjets et comptes.
Dissolution de l’association.
Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents,ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents, dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont
modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des
voix des membres présents.
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée
par le tribunal civil.
Art. 14. Les délibérations de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers.
Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de trois années par l’assemblée
générale. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants:
Le /la président(e) représente l’association, et peut signer les chèques de l’association.
Le/(la) vice président(e) remplace le/la président(e) lorsque celui ou celle-ci est absent(e) et peut signer les chèques
de l’association.
Le/la sécrétaire envoie les invitations et écrit les comptes rendus des réunions.
Le/la trésorier/ère gère les finances de l’association
Le/la réviseur de caisse contrôle les comptes de l’association et fait un rapport de caisse.
Art. 16. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-
lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.
Art. 17. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée
à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.
Art. 18. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale les comptes de
l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
Art. 19. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à une association ayant un but similaire.
Art. 20. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites
et ce au 31 décembre.
Art. 21. Les ressources de l’association comprennent notamment: les cotisations des membres, les subsides et sub-
ventions, les dons ou legs en sa faveur.
Art. 22. Constituée pour venir à l’aide aux victimes du Tsunami du Sri-Lanka, l’A.s.b.l. AYUBOWAN ne se limitera
néanmoins pas à l’intervention dans ce pays, mais pourra élargir son champs d’intervention à d’autres pays y compris le
Luxembourg, en respectant l’objet fixé lors de sa constitution.
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01658. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048385.3/000/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
S. Claire / N. Winandy / J. Thilmany / J. Klein / V. Schmit
54412
INTER-ACTIONS, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 9, route de Thionville.
R. C. Luxembourg F 829.
—
<i>Rapport de l’Assemblée Générale extraordinaire du 25 avril 2005i>
<i>Ordre du jour: Modification des statutsi>
Les modifications des articles 7 et 10 ont été retenues par l’assemblée comme suit:
Art. 7. (nouveau texte). L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins six
membres. Deux membres sont: MM. Roger Faber et Jan Nottrot. Les autres membres sont élus par l’assemblée géné-
rale. Le conseil d’administration choisit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Il dé-
finit leurs attributions. Le président et le vice-président sont obligatoirement parmi les membres élus. Chaque année la
moitié des membres élus du conseil d’administration est réélue pour un terme de deux ans. Les membres sortants sont
rééligibles. La première année une moitié des membres du conseil d’administration aura seulement un mandat d’un an.
Pour la première fois les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
Art. 10. (nouveau texte). Les actes qui engagent l’association doivent être signés par le président ou son rempla-
çant et par un deuxième membre du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer son pouvoir à
un autre membre ou à un tiers pour des charges déterminées. La gestion journalière est assurée par un comité de di-
rection composé de MM. Roger Faber et Jan Nottrot.
Luxembourg, le 25 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03566. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048420.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
L.I., LUXEMBOURGEOISE D’INTERVENTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.408.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 16 décembre 2003 que Ma-
dame Sylvie Comman, employée privée, avec adresse professionnelle à MC-98000 Monaco, 7, rue Suffren Reymond, a
été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., sortante.
Luxembourg, le 17 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06383. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048428.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 97.059.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 5 mai 2005 que:
«Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 32, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02983. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048872.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
INTER-ACTIONS
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54413
COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 97.059.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale statutaire tenue en date du 27 mai 2005 que:
«L’Assemblée constate que les mandats des actuels Administrateurs, Administrateur délégué et Commissaire aux
comptes prennent fin à l’issue de la présente Assemblée et procède donc à la nomination des nouveaux Administrateurs
ainsi que du nouveau Commissaire aux comptes pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statutaire
à tenir en l’an 2011 suivants:
<i>1) Administrateurs:i>
- Monsieur Robert Langmantel, Administrateur de société, demeurant à L-5752 Frisange, 1, rue Bellevue.
- Monsieur François Metzler, directeur de banque, demeurant à L-2630 Luxembourg, 99, route de Trèves.
- Monsieur Dieter Feustel, diplômé en sciences économiques, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Na-
poléon I
er
.
<i>2) Commissaire aux comptes:i>
FIDES INTER-CONSULT S.A. avec siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02988. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048873.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 97.059.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenu en date du 27 mai 2005 que:
«Conformément à l’autorisation préalable conférée par l’Assemblée générale des actionnaires tenue en date du 27
mai 2005, le Conseil d’administration nomme Monsieur Robert Langmantel, Administrateur de société, demeurant à
Frisange, aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura pouvoir de signature individuelle dans le cadre de la gestion
journalière de la société, pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2011.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02990. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048874.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 97.059.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg,
le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02979, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
(048867.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54414
IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Dommeldange, 1, rue Comte de Ferraris.
R. C. Luxembourg B 31.953.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03625, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048465.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
IKB CorporateLab S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1468 Luxemburg, 12, rue Erasme.
H. R. Luxemburg B 95.897.
—
AUSZUG
Die Generalversammlung der Aktionäre hat am 31. Mai 2005 folgende Personen in den Verwaltungsrat der Gesell-
schaft gewählt:
- Herr Wolfgang Güth, mit beruflicher Adresse 12, rue Erasme, L-1468 Luxemburg;
- Herr Joachim Neupel, mit beruflicher Adresse 1, Wilhelm-Bötzkes-Strasse, D-40474 Düsseldorf, Deutschland;
- Herr Helmut Laux, mit beruflicher Adresse 1, Wilhelm-Bötzkes-Strasse, D-40474 Düsseldorf, Deutschland;
- Herr Jürgen Rauscher, mit beruflicher Adresse 1, Wilhelm-Bötzkes-Strasse, D-40474 Düsseldorf, Deutschland;
- Herr Winfried Reinke, mit beruflicher Adresse 1, Wilhelm-Bötzkes-Strasse, D-40474 Düsseldorf, Deutschland; und
- Herr Claus-Dieter Wagner, mit beruflicher Adresse 1, Wilhelm-Bötzkes-Strasse, D-40474 Düsseldorf,
Deutschland.
Herr Wolfgang Güth wurde als täglicher Geschäftsführer ernannt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 10. Juni 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03317. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048492.3/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
SOCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 49.898.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 juin 2005, réf. DSO-BF00077, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 10 juin 2005.
(048602.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
GRAFICOM, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 49.865.
—
<i>Résolution du 27 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 27 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02731. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048896.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Le 13 juin 2005.
Signature.
<i>Für IKB CorporateLab S.A.
i>Unterschrift
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GRAFICOM
i>J. Claeys
54415
ANCHOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.928.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg extraordinairement en date du
8 juin 2005 que:
Sont réélus administrateurs jusqu’aux prochaines élections statutaires qui auront lieu à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Annuelle de 2010:
- Jytte Dyring Jorgensen,
- Flemming Frandsen,
- Francis N. Hoogewerf.
Est réélu commissaire aux comptes jusqu’aux prochaines élections statutaires qui auront lieu à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle de 2010:
- Henri Vanherberghen.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048652.3/634/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
AB EUROPROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. S. Luxembourg B 92.615.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03524, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048659.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
ZIROUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. S. Luxembourg B 67.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03527, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048668.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
JURIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 53.535.
—
<i>Résolution du 19 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 19 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02538. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048889.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliataire
i>Signature
Signature.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour JURIAN S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures
54416
TOP UNIVERSITE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. S. Luxembourg B 94.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03530, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048670.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
ROULE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. S. Luxembourg B 88.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03534, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048673.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
TOP ROULE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. S. Luxembourg B 88.977.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03542, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048676.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
UNIVERSITE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. S. Luxembourg B 94.373.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03548, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048677.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.537.
—
<i>Résolution du 27 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 27 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048897.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour INTERLIGNUM S.A.
i>J. Claeys
54417
LA MAISON DU TAPIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 1, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 39.492.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF03901, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048678.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.610.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BE03120, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048679.3/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.
BIEL FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 90.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03149, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048700.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
MULTIWORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 76.862.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03146, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048703.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
STAPLES LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 89.442.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01765, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049050.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
STAPLES LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 89.442.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01763, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049030.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
Signature.
54418
SOLIDARITE ACTION «GOUYE GUI», Association sans but lucratif.
Siège social: L-7560 Mersch, D6 Centre Marisca.
R. C. Luxembourg F 1.143.
—
STATUTS
Ont comparu:
Mamadou Diouf, employé, demeurant à Mersch, D6 Centre Marisca, L-7560, de nationalité luxembourgeoise.
Ndougou Ndao, employée, demeurant à Howald, 244, route de Thionville, L-2610, de nationalité sénégalaise.
Mbaye Ngom, commerçant, demeurant à Luxembourg, 56, Cité J. Steichen, L-3944, de nationalité luxembourgeoise.
Lesquels comparants ont déclaré avoir fondé entre eux et tous ceux qui par la suite adhèrent aux présents statuts et
sont admis dans l’association, une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et la loi du 21 avril 1928
sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée par les lois des 21 février 1984 et 4 mars 1994.
Art. 1
er
. L’association est dénommée SOLIDARITÉ ACTION «GOUYE GUI». Le siège social de l’association est
établi à Mersch, D6 Centre Marisca, L-7560, sous couvert de M. Mamadou Diouf (provisoire). Il ne pourra être déplacé
que par décision du Comité de Direction, prise à l’unanimité des membres présents.
Art. 2. La durée de l’association est illimitée.
Art. 3. L’association est indépendante et n’a aucune appartenance politique, philosophique ou confessionnelle.
Art. 4. (fondateur). L’association a pour but essentiel de:
Construire les bases d’une solidarité d’entr’aide à l’intérieur de notre communauté.
Contribuer à la promotion d’une culture de vie associative.
Art. 5. L’association se compose de ses membres. Leur nombre est illimité sans pouvoir être inférieur à trois. L’ad-
hésion à l’association est ouverte à tous les ressortissants sénégalais résidant au Luxembourg ainsi qu’aux membres de
leurs familles et aux membres sympathisants.
Art. 6. La qualité de membre se perd:
(a) Par la démission volontaire, adressée au secrétaire du comité directeur.
(b) Par l’exclusion avec effet immédiat en cas d’infraction grave à l’objet de l’association, la non-conformité aux statuts
ou d’atteinte aux intérêts ou à la réputation de l’association. Cette exclusion est prononcée par le comité directeur,
après avoir entendu le membre en ses explications et moyens ou après l’avoir dûment invité à fournir ces moyens de
défense.
(c) Par l’exclusion pour toute raison grave constatée par l’assemblée générale, avec une majorité des deux tiers des
voix. Cette décision d’exclusion ne pourra être prise par l’assemblée générale avant que l’intéressé n’ait été appelé par
le comité directeur à fournir des explications.
Le membre démissionnaire, sortant ou exclu et les héritiers d’un membre décédé n’ont aucun droit sur le fonds so-
cial.
Art. 7. Une délibération de l’assemblée est nécessaire pour les objets suivants:
(a) la modification des statuts;
(b) la nomination et révocation des administrateurs, la fixation de la durée de leur mandat, la décharge des adminis-
trateurs;
(c) l’approbation des budgets et des comptes;
(d) la dissolution de l’association;
(e) l’exclusion d’un membre de l’association.
Art. 8. Les assemblées générales sont convoquées par le comité directeur ou par son président, huit jours avant la
date de l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour. Il sera loisible aux membres de se faire représenter par
un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois représenter plus de deux membres.
Art. 9. Tous les membres ont un droit de vote égal dans les assemblées générales. Sous réserve des dispositions de
la loi relative aux modifications des statuts, les résolutions peuvent être prises quel que soit le nombre de membres
présents et à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside l’assemblée est prépondérante.
Art. 10. Le comité directeur est composé de différents administrateurs dont:
- un président;
- un vice-président;
- un modérateur;
- un secrétaire général;
- un trésorier;
- un responsable de la cellule d’organisation et des relations publiques.
En cas d’absence du président, la réunion est présidée par le secrétaire ou le trésorier. Le comité directeur peut s’ad-
joindre, soit temporairement, soit définitivement, des personnes qu’il charge d’une mission spéciale.
Art. 11. Le comité directeur se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, aussi souvent que
l’intérêt de l’association l’exige. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou re-
présentée. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des
voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Art. 12. Les ressources de l’association se composent notamment de:
(a) les recettes des diverses manifestations;
54419
(b) les subventions de l’Etat, des communes;
(c) les sponsorisations des personnes morales ou physiques;
(d) les cotisations des membres et les ventes de cartes de membres;
(e) les ventes d’articles promotionnels divers: logos, badges, etc.
Cette énumération n’est pas limitative.
Art. 13. Le montant des cotisations annuelles des membres est fixé par le comité directeur en tenant compte de
l’avis des membres tiers.
Art. 14. Le comité directeur a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association et sa repré-
sentation dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.
Il peut notamment accepter tous les dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.
A l’égard des tiers, l’association sera valablement engagée par deux signatures conjointes parmi le président, le secré-
taire et le trésorier sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial, mais
dans la limite de leurs pouvoirs.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association seule.
Art. 15. L’exercice social commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. A la fin de l’année,
le comité directeur arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain exercice.
L’excédent favorable appartient à l’association.
Art. 16. La dissolution et la liquidation de l’association sont réglées par les articles 18 et suivants de la loi modifiée
du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. En cas de dissolution de l’association, le comité
directeur fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, l’excédent du fonds social sera reversé à des oeuvres
de charité.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09959. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056269.3/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.
M2M S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 96.293.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02881, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(048712.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
COLONNADE HOLDCO N
o
5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 101.881.
—
<i>Résolution du 19 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 19 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048909.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Secrétaire Général / Le Président / Le Trésorieri>
<i>Pour la société
i>Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COLONNADE HOLDCO Ni>
<i>oi>
<i> 5 S.A.i>
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures
54420
EUROTURISTICA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 35.114.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le quinze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GREEN GLOBET VENTURES LIMITED, inscrite au Canada (Province du Nouveau-Brunswick) sous le n
o
515155, une
société avec siège social au 44, Chipman Hill, 10th Floor, Station «A» Saint John, New Brunswick E2L 4S6, Canada,
ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 mai 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme EUROTURISTICA HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 35.114, dénommée ci-après «la So-
ciété», fut constituée originairement sous la dénomination de EMC, EUROPE MANAGEMENT COMPANY S.A. suivant
acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 18 octobre 1990, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
119 du 12 mars 1991.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 octobre 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
364 du 17 mai 2001.
- Le capital social est actuellement fixé à quatre cent mille (400.000,-) euros (EUR), représenté par huit mille (8.000)
actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libé-
rées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats
jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel
a immédiatement été annulé.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société EUROTURISTICA HOLDING S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, vol. 148S, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054336.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.
INTERNATIONAL COMPANY OF INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 93.906.
—
Conformément à I’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-
bourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03375, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048733.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Luxembourg, le 21 juin 2005.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Signature.
54421
KAPATECO, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2630 Luxembourg, 128, rue de Trèves.
R. C. Luxembourg B 108.775.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Patrick De Ridder, gérant de société, demeurant rue de Trèves 128, à L-2630 Luxembourg.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il
déclare vouloir constituer.
Art. 1
er
. Une société à responsabilité limitée luxembourgeoise est régie par les présents statuts et les lois actuelle-
ment en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, sous la dénomination de KAPATECO.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du gérant publiée au Mémorial C.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La société a pour objet la vente et l’application de produits d’entretien, notamment pour le jardin, ainsi que
la location et la vente de containers pour le recyclage des cannettes.
La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’investisse-
ment et à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra exercer les activités d’agent commercial pour des tiers, et procéder à l’achat et à la vente de matériel
informatique et de bureautique, et réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’exten-
sion ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 15.000,- (quinze mille euros), représenté par 150 (cent cinquante) parts so-
ciales de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 6. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application des prescriptions légales.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscription et libérationi>
Les 150 (cent cinquante) parts sociales ont toutes été souscrites par Monsieur Patrick De Ridder, prédésigné.
Elles ont toutes été intégralement libérées par un versement en espèces, dont il a été justifié au notaire instrumentant
par la production d’un certificat bancaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions
suivantes:
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
2) L’adresse de la société est fixée au 128, rue de Trèves L-2630 Luxembourg.
3) Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Monsieur Patrick De Ridder, gérant de société, né à Wilrijk (Belgique), le 2 janvier 1971 et demeurant rue de Trèves
128, à L-2630 Luxembourg.
54422
4) La société est engagée par la signature du gérant.
Le notaire a informé le comparant fondateur que la constitution de la présente société ne dispense pas la société de
l’obligation de demander, le cas échéant, une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des activités
décrites dans son objet social.
Il est en outre déclaré par le notaire soussigné que, aux termes des dispositions légales luxembourgeoises, la société
a acquis immédiatement dès ce jour, en tant qu’être moral, une personnalité juridique distincte de celle des associés à
la date du présent acte constitutif, dès avant même réalisation de toutes formalités de dépôt et de publication, l’opéra-
tion étant régie par le concept contractuel avec effet immédiat de la convention actée authentiquement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Après lecture faite de tout ce qui précède et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. De Ridder, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 59, case 9. – Reçu 150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055095.3/211/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.
LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.
R. C. Luxembourg B 83.527.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02879, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(048718.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
EVITA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 89.505.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02867, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(048726.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
AGF WORLD FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 63.356.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2005i>
En date du 18 mai 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Messieurs Franck Becker, Eric Machenaud, Géraud Brac de la Perriere et Jean-Paul
Duhamel en qualité d’Administrateurs pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2006.
- de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG S.A., en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.
Luxembourg, le 19 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049079.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Luxembourg, le 27 juin 2005.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
54423
FONCIERE T.M.G.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 89.276.
—
Conformément à I’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-
bourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03372, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048736.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
TESEI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 83.675.
—
Conformément à I’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-
bourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03369, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048738.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
NORTH MIAMI BEACH INVESTMENT CORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 64.614.
—
Conformément à I’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-
bourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03366, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048740.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
STRONGBOW CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.914.
—
In the year two thousand and five, on the seventh day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Luxembourg,
acting as the representative of the Board of Directors of STRONGBOW CAPITAL HOLDINGS S.A. (the «Compa-
ny»), a company having its registered office at L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey,
by virtue of proxies given by the three directors, which shall remain annexed to the present deed.
Such appearing person, acting in his aforesaid capacity, has required the undersigned notary to state his declarations
as follows:
1) The Company has been incorporated in the form of a public limited company pursuant to a deed of the undersigned
notary, on the 19th of March 2003, published in the Mémorial of 8 May 2003, number 501. The articles of incorporation
have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 13th August 2003, published in the Mémorial
of 21 October 2003, number 1089.
2) The corporate capital of the Company is fixed at five hundred and fifty-two thousand two hundred and thirty-two
US Dollars (USD 552,232.-) divided into two hundred seventy-six thousand one hundred and sixteen (276,116) shares
of a par value of two US dollars (USD 2.-) per share.
3) Pursuant to article 5 of the Articles of Incorporation, the Company has an authorized capital of seventy-seven mil-
lion US dollars (USD 77,000,000.-).
4) Pursuant to the same article 5 of the Articles of Incorporation, Shares other than shares issued at the time of in-
corporation of the Company may only be issued in Units comprising one (1) share and ten (10) convertible bonds.
5) According to article 5 of the Articles of Incorporation, the board of directors is authorized and empowered to
issue further shares with or without an issue premium and convertible bonds so as to bring the total capital of the Com-
pany up to the total authorized share capital, in whole or in part, from time to time as the board of directors at its
discretion may determine, and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by article 32
(2) and 32 (4) of the Law on commercial companies.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Signature.
54424
6) By circular resolution of the board of directors dated May 31st 2005, the directors have approved to increase the
capital of the Company up to five hundred fifty-eight thousand five hundred and thirty-four US dollars (USD 558,534.-)
by the issuance of three thousand one hundred and fifty-one (3,151) shares of a par value of two US dollars (USD 2.-)
each and an issue premium of five US dollars point two one two seven cent (USD 5.2127) per share each.
The foregoing resolution, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Mr Manfred Hoffmann, prenamed, states hereby that three thousand one hundred and fifty-one (3,151) shares have
been subscribed on 18 May 2005 at the par value of two US dollars (USD 2.-) per share and with an issue premium of
five US dollars point two one two seven cent (USD 5.2127) per share.
All the shares thus subscribed have been fully paid up, so that the amount of six thousand three hundred and two US
Dollars (USD 6,302.-) is allocated to the share capital of the Company and the amount of sixteen thousand four hundred
and twenty-five US dollars point thirty cent (USD 16,425.30) is allocated to an issue premium account.
The justifying documents of the subscriptions and of the payment have been produced to the undersigned notary,
who expressly acknowledges this.
7) As the consequence of such increase of capital, the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation
is amended and shall now read as follows:
«Art. 5, first paragraph. The corporation has an issued capital of five hundred fifty-eight thousand five hundred
and thirty-four US dollars (USD 558,534.-) divided into two hundred seventy-nine thousand two hundred and sixty-
seven (279,267) shares with a par value of two US Dollars (USD 2.-)».
<i>Expensesi>
For the purpose of registration, the total amount of the increase of capital (USD 6,302.-) and the allocation to the
issue premium account (USD 16,425.2177) being USD 22,727.2177 is valued at eighteen thousand five hundred and
eighty-seven Euro five cents (EUR 18,587.5)
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, incumbent on the Company and charged to
it by reason of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same person appearing and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le sept juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Manfred Hoffmann, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire du conseil d’administration de STRONGBOW CAPITAL HOLDINGS S.A. (la
«Société»), une société ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey,
en vertu de procurations signées par les trois administrateurs, lesquelles resteront annexées aux présentes.
Lequel comparant, ès dites qualité, qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ses déclarations comme suit:
1) La Société a été constituée sous forme d’une société anonyme suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 19 mars 2003, publié au Mémorial en date du 8 mai 2003, numéro 501. Les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 août 2003, publié au Mémorial du 21 octobre 2003, numéro 1089.
2) Le capital social de la Société est fixé à cinq cent cinquante-deux mille deux cent trente-deux dollars U.S. (USD
552.232,-) divisé en deux cent soixante-seize mille cent seize (276.116) actions d’une valeur nominale de deux dollars
U.S. (USD 2,-) chacune.
3) Conformément à l’article 5 des Statuts, la Société a un capital autorisé de soixante-dix-sept millions de dollars U.S.
(USD 77.000.000,-).
4) Conformément au même article 5 des statuts, les actions autres que les actions émises lors de la constitution de
la Société seront émises en unités comprenant une (1) action et dix (10) obligations convertibles.
5) Conformément à l’article 5 des statuts, le conseil d’administration est autorisé à émettre d’autres actions avec ou
sans prime d’émission et des obligations convertibles afin de porter le capital total de la Société jusqu’au total du capital
social autorisé, en une ou plusieurs fois aux moments qu’il jugera opportuns et à accepter des souscriptions pour ces
actions pendant la période telle que définie aux articles 32 (2) et 32 (4) de la Loi sur les sociétés commerciales.
6) Par résolution circulaire du conseil d’administration en date du 31 mai 2005, les membres du conseil d’administra-
tion ont approuvé d’augmenter le capital social de la Société à cinq cent cinquante-huit mille cinq cent trente-quatre
dollars U.S. (USD 558.534,-) par l’émission de trois mille cent cinquante et une (3.151) actions d’une valeur nominale
de deux dollars U.S. (USD 2,-) chacune et une prime d’émission de cinq dollars U.S. virgule deux un deux sept cents
(USD 5,2127) chacune.
La résolution sus-mentionnée, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexée aux présentes pour être soumise aux autorités d’enregistrement.
Monsieur Manfred Hoffmann, prénommé, déclare par les présentes que trois mille cent cinquante et une (3.151) ac-
tions ont été souscrites le 18 mai 2005, à la valeur nominale de deux dollars U.S. (USD 2,-) par action et avec une prime
d’émission de cinq dollars U.S. virgule deux un deux sept cents (USD 5,2127) par action.
54425
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de six mille trois cent deux
dollars U.S. (USD 6.302,-) est allouée au capital de la Société et la somme de seize mille quatre cent vingt-cinq dollars
U.S. et trente cents (USD 16.425,30) est allouée à la prime d’émission.
Les documents justificatifs des souscriptions et de la libération ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate
expressément.
7) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5, premier alinéa. La Société à un capital social émis de cinq cent cinquante-huit mille cinq cent trente-quatre
dollars U.S. (USD 558.534,-) représenté par deux-cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-sept (279.267) actions
d’une valeur nominale de deux US Dollars (USD 2,-).»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur totale de l’augmentation de capital (6.302.- USD) ainsi que la somme
allouée dans le compte de prime d’émission (16.425,2177 USD), savoir un montant total de 22.727,2177 USD est éva-
luée à dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-sept euros cinq cents (18.587,5 EUR).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations, et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents
euros (1.200,- EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte a été
rédigé en anglais suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: M. Hoffmann, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, vol. 24CS, fol. 53, case 7. – Reçu 185,17 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055598.3/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2005.
STRONGBOW CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.914.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055600.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2005.
NBCA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 96.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02264, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(048861.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
NBCA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 96.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02267, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(048859.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
Luxembourg, le 27 juin 2005.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 27 juin 2005.
G. Lecuit.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
54426
PLACINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 28.349.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale du 3 juin 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,
L-1340 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 3 juin 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03108. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049033.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.
QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA), Société Anonyme.
Registered office: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.501.
—
In the year two thousand five, on the twenty-fourth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA) (the «Company»),
a société anonyme having its registered office in L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, incorporated by notarial deed on
20th December, 1989, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number
209, of 26th June, 1990. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed
of the undersigned notary, on 4th August 2003, published in the Mémorial, number 941 of 12th September, 2003.
The meeting was presided by Mr. Jacques Louis de Montalembert, director, residing in 667, Tte. Gral J. D. Peron,
1038 Buenos Aires, Argentina.
There was appointed as secretary Mr. Carlo Hoffmann, Secretary General of the Corporation, residing in Luxem-
bourg.
There was appointed as scrutineers Mr. Alvaro Sainz De Vicuña representing BEVERAGE ASSOCIATES (BAC)
CORP., residing in Madrid and Mr. Thierry Becker representing the AmBev companies DUNVEGAN S.A. and NCAQ
SOCIEDAD COLECTIVA, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the undersigned notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list
signed by the proxy holders, the chairman, the secretary and the scrutineers and the undersigned notary. Said attend-
ance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. The present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent on 7th June, 2005
to registered shareholders and published in the Mémorial and the Luxemburger Wort on 7th June, 2005 and 16th June,
2005. The notices incorporated a letter to the shareholders dated 6th June, 2005.
The chairman informed the meeting that the present extraordinary general meeting will validly deliberate only if half
of the shares in issue at least are represented and that resolutions will be validly adopted if approved by a two thirds’
majority of shares represented.
As it appears from said attendance list, from the total seven hundred and seven million nine hundred and thirty-two
thousand one hundred and fifty-three (707,932,153) Shares in issue of the Company, a total of six hundred and thirty-
nine million eight hundred and forty-seven thousand six hundred and forty-five (639,847,645) Shares are represented,
at the present extraordinary general meeting representing 90.38% of the share capital. As the shares represented rep-
resent more than 50% of the share capital, the meeting is thus validly constituted and can validly deliberate and resolve
on all the items on the agenda.
III. The agenda of the meeting is as follows:
1) (i) to change for the purpose described in the letter to Shareholders dated June 6, 2005, with effect from the fi-
nancial year starting 1st January 2005, the year end of the Company to 30th April, and
(ii) to consequentially amend paragraph 1 of articles 22 and 17 of the Company as follows:
Art. 22. (first paragraph). «The financial year of the Company shall start on 1st May and shall end on 30th April
of the following year. Exceptionally the financial year which started on 1st January 2005 shall end on the 30th April
2005.»
Art. 17. (first paragraph). «The annual general meeting of the Company shall be ipso jure in the city of Luxem-
bourg at the place indicated in the notices to the meeting on the first business day following the second Thursday of July
<i>Pour PLACINVEST S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
54427
at 10:00 am (Luxembourg time), including for the The annual general meeting called to resolve on the annual accounts
for the financial year ending 30th April 2005 shall be held on 15th July, 2005.»
2) To approve the reduction of the share capital of the Company from its current amount of forty-one million six
hundred and ninety-nine thousand one hundred and one United States Dollars (USD 41,699,101.-) to thirty four million
six hundred and ninety six thousand four hundred and sixty United States Dollars (USD 34,696,460.-) by an amount of
seven million two thousand six hundred and forty one United States Dollars (USD 7,002,641.-) to be carried out by way
of cancellation of five million three hundred and thirty thousand eight hundred and seven (5,330,807) Class A shares
and twenty two million sixty thousand four hundred and twelve (22,060,412) Class B shares held in treasury as of April
30, 2005, together with a concurrent reduction of the non-distributable reserve corresponding to any cancelled shares
as well as the legal reserve (for an amount of seven hundred thousand two hundred and sixty-four United States Dollars
and ten cents (USD 700,264.10) and to consequentially amend Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company
to reflect the foregoing resolution.
IV. That, as a result of the foregoing, the present meeting was regularly convened, is regularly constituted and may
validly decide on the items of the agenda.
Then the meeting, after deliberation, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting decides (i) to change, for the purpose described in the letter to Shareholders dat-
ed June 6, 2005 and referred to above, with effect from the financial year starting 1st January 2005, the year end of the
Company to 30th April and (ii) to consequentially amend paragraph 1 of articles 22 and 17 of the Company so as to
read henceforth as follows:
Art. 22. (first paragraph). «The financial year of the Company shall start on 1st May and shall end on 30th April
of the following year. Exceptionally the financial year which started on 1st January 2005 shall end on the 30th April
2005.»
Art. 17. (first paragraph). «The annual general meeting of the Company shall be held ipso jure in the city of Lux-
embourg at the place indicated in the notices to the meeting on the first business day following the second Thursday of
July at 10:00 am (Luxembourg time), including for the annual general meeting called to resolve on the annual accounts
for the financial year ending 30th April 2005 which shall be held on 15th July, 2005.»
The resolution was adopted by unanimous vote.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting decides to reduce the share capital by an amount of seven million two thousand
six hundred and forty-one United States Dollars (USD 7,002,641.-) from its current amount of forty-one million six hun-
dred and ninety-nine thousand one hundred and one United States Dollars (USD 41,699,101.-) to thirty-four million six
hundred and ninety-six thousand four hundred and sixty United States Dollars (USD 34,696,460.-) through the cancel-
lation of five million three hundred and thirty thousand eight-hundred and seven (5,330,807) Class A shares and twenty-
two million sixty thousand four hundred and twelve (22,060,412) Class B shares which were held in treasury as of 30th
April 2005 and still are so held on the date hereof.
Together with such reduction of share capital and cancellation of shares, the extraordinary meeting decides to con-
currently reduce:
(i) the legal reserve so as to reduce it by seven hundred thousand two hundred sixty-four United States Dollars and
ten cents (USD 700,264.10);
(ii) the non-distributable reserve by an amount corresponding to the value of all cancelled shares so as to reduce it
by two hundred and one million six hundred and fifty-four thousand four hundred and eighteen United Stated Dollars
and ninety cents (USD 201,654,418.90).
As a consequence of the above, the number of shares representing the share capital is reduced to six hundred and
thirty-one million seven hundred and seventy-two thousand six hundred and ninety-three (631,772,693) Class A shares
without a par value and forty-eight million seven hundred and sixty-eight thousand two hundred and forty-one
(48,768,241) Class B shares without a par value.
As a consequence of the above the meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of Incor-
poration as follows:
Art. 5. (first paragraph). «The share capital is set at thirty-four million six hundred and ninety-six thousand four
hundred and sixty United States Dollars (USD 34,696,460.-) represented by six hundred and thirty-one million seven
hundred and seventy-two thousand six hundred and ninety-three (631,772,693) Class A shares without a par value and
forty-eight million seven hundred and sixty-eight thousand two hundred and forty-one (48,768,241) Class B shares with-
out a par value.»
The resolution was adopted by unanimous vote.
<i>Cost estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the Company as a result of this
deed are estimated at one thousand eight hundred Euro.
There being no further business, the meeting is terminated at 10.30 a.m.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two ver-
sions, the English version will be prevailing.
54428
The document having been read to the meeting, the members of the Board, all of whom are known to the notary,
by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA), (la «So-
ciété»), une société anonyme, ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, constituée suivant acte no-
tarié en date du 20 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro
209 du 26 juin 1990. Les Statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en
date du 4 août 2003, publié au Mémorial, numéro 941 du 12 septembre 2003.
L’Assemblée a été présidée par Monsieur Jacques Louis de Montalembert, administrateur, demeurant au 667, Tte.
Gral J. D. Peron, 1038 Buenos Aires, Argentine.
Monsieur Carlo Hoffmann, secrétaire général de la Société, demeurant à Luxembourg, a été nommé comme secré-
taire.
Ont été nommés comme scrutateurs Monsieur Alvaro Sainz De Vicuña, représentant BEVERAGE ASSOCIATES
(BAC) CORP., demeurant à Madrid et Monsieur Thierry Becker représentant les deux sociétés d’AmBev, la société
DUNVEGAN S.A. et la société NCAQ SOCIEDAD COLECTIVA, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire soussigné de constater que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de
présence signée par les représentants, le président, le secrétaire et les scrutateurs et le notaire soussigné. La liste de
présence sera annexée au présent acte en vue des formalités d’enregistrement.
II. La présente assemblée extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés en date du
7 juin 2005 aux actionnaires nominatifs et publiés au Mémorial ainsi qu’au Luxemburger Wort en date des 7 juin 2005
et 16 juin 2005. Les avis contenaient une lettre aux actionnaires datée au 6 juin 2005.
Le président informa l’assemblée que la présente assemblée générale extraordinaire ne délibérera valablement uni-
quement que si la moitié au moins des actions en circulation sera représentée et que les résolutions ne seront valable-
ment adoptées que si elles sont approuvées par les deux tiers des actions représentées.
Tel qu’il appert de la liste de présence du total des sept cent sept millions neuf cent trente-deux mille cent cinquante-
trois (707.932.153) actions en circulation de la Société, six cent trente-neuf millions huit cent quarante-sept mille six
cent quarante-cinq (639.847.645) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire représen-
tant 90,38% du capital social. Etant donné que les actions représentées représentent plus de 50% du capital social, l’as-
semblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et adopter des résolutions sur tous les points à l’ordre
du jour.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) (i) de modifier la fin de l’année sociale de la Société, pour les besoins tels que détaillés dans la lettre aux Action-
naires datée au 6 juin 2005, avec effet à partir de l’année sociale commençant le 1
er
janvier 2005, au 30 avril 2005, et
(ii) de modifier par conséquent le premier alinéa des articles 22 et 17 de la Société comme suit:
Art. 22. (alinéa 1
er
). «L’année sociale commence le premier (1
er
) mai et finit le trente (30) avril de l’année suivante.
Exceptionnellement, l’année sociale qui a commencé le 1
er
janvier 2005 se terminera le 30 avril 2005.»
Art. 17. (alinéa 1
er
). «L’assemblée générale annuelle de la Société se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit
indiqué dans les avis de convocation; elle a lieu de plein droit à 10 heures le premier jour ouvrable qui suit le deuxième
jeudi du mois de juillet.»
2) d’approuver la réduction du capital social de la Société de son montant actuel de quarante et un millions six cent
quatre-vingt dix neuf mille cent et un Dollars des Etats-Unis (USD 41.699.101,-) à trente-quatre millions six cent quatre-
vingt seize mille quatre cent soixante Dollars des Etats-Unis (USD 34.696.460,-), par un montant de sept millions deux
mille six cent quarante et un Dollars des Etats-Unis (USD 7.002.641,-) par le biais de l’annulation de cinq millions trois
cent trente mille huit cent sept (5.330.807) actions de la Catégorie A et vingt deux millions soixante mille quatre cent
douze (22.060.412) actions de la Catégorie B détenues en trésorerie, avec effet à partir du 30 avril 2005, ensemble avec
une réduction concomitante de la réserve non-distribuable qui correspond à toutes les actions annulées ainsi que de la
réserve légale (pour un montant de sept cent mille deux cent soixante-quatre et dix centimes de Dollars des Etat-Unis
(USD 700.264,10) et de modifier par conséquent l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la résolution précé-
dente.
IV. Que du fait de ce qui précède, la présente assemblée a été régulièrement convoquée et valablement constituée
et qu’elle peut valablement décider sur les points à l’ordre de jour.
L’assemblée prend ensuite, après délibération, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La présente assemblée générale extraordinaire décide (i) de modifier la fin de l’année sociale de la Société pour les
besoins tels que détaillés dans la lettre aux Actionnaires datée au 6 juin 2005, avec effet à partir de l’année sociale com-
mençant le 1
er
janvier 2005, au 30 avril et de modifier par conséquent le premier alinéa des articles 22 et 17 de la Société
comme suit:
Art. 22. (alinéa 1
er
). «L’année sociale commence le premier (1
er
) mai et finit le trente (30) avril de l’année suivante.
Exceptionnellement, l’année sociale qui a commencé le 1
er
janvier 2005 se terminera le 30 avril 2005.»
54429
Art. 17. (alinéa 1
er
). «L’assemblée générale annuelle de la Société se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit
indiqué dans les avis de convocation; elle a lieu de plein droit à 10 heures le premier jour ouvrable qui suit le deuxième
jeudi du mois de juillet.»
La résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de qua-
rante et un millions six cent quatre-vingt dix neuf mille cent et un Dollars des Etats-Unis (USD 41.699.101,-) à trente-
quatre millions six cent quatre-vingt seize mille quatre cent soixante Dollars des Etats-Unis (USD 34.696.460,-), par un
montant de sept millions deux mille six cent quarante- et-un Dollars des Etats-Unis (USD 7.002.641,-) par le biais de
l’annulation de cinq millions trois cent trente mille huit cent sept (5.330.807) actions de la Catégorie A et vingt deux
millions soixante mille quatre cent douze (22.060.412) actions de la Catégorie B qui sont détenues en trésorerie, avec
effet à partir du 30 avril 2005, et qui le sont toujours à la présente date.
Ensemble avec une réduction du capital social et l’annulation d’actions, l’assemblée générale extraordinaire décide de
réduire concomitamment:
(i) la réserve légale afin de la réduire par sept cent mille deux cent soixante-quatre Dollars des Etats-Unis et dix cen-
times (USD 700.264,10);
(ii) la réserve non-distribuable par un montant correspondant à la valeur de toutes les actions annulées afin de la ré-
duire par deux cent un millions six cent cinquante quatre mille quatre cent dix-huit Dollars des Etats-Unis et quatre-
vingt-dix centimes (USD 201.654.418,90).
En conséquence de ce qui précède, le nombre d’actions représentant le capital social est réduit à six cent trente et
un millions sept cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt-treize (631.772.693) actions de la Catégorie A sans va-
leur nominale et quarante-huit millions sept cent soixante-huit mille deux cent quarante et unes (48.768.241) actions de
la Catégorie B sans valeur nominale.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la
Société comme suit:
Art. 5. (alinéa 1
er
). «Le capital social est fixé à trente-quatre millions six cent quatre-vingt seize mille quatre cent
soixante Dollars des Etats-Unis (USD 34.696.460,-) représenté par six cent trente et un millions sept cent soixante-
douze mille six cent quatre-vingt-treize (631.772.693) actions de la Catégorie A sans valeur nominale et quarante-huit
millions sept cent soixante-huit mille deux cent quarante et une (48.768.241) actions de la Catégorie B sans valeur no-
minale.»
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée se termina à dix heures trente.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison du présent acte, est estimé à mille huit cents euros.
Sur ce, le présent acte fut dressé à Luxembourg au jour mentionné au début du présent document.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, aux membres du Conseil, tous connus du notaire par nom, prénom, état et de-
meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant exprimé son désir de signer.
Signé: J.-L. de Montalembert, C. Hoffmann, A. Sainz De Vicuña, T. Becker, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2005, vol. 895, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058029.3/239/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.
QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.501.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058031.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.
Belvaux, le 6 juillet 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 6 juillet 2005.
J.-J. Wagner.
54430
PERFORM INVEST S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 108.017.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PERFORM INVEST S.A., une société anonyme
holding, soumis au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, (ci-après: la «Société»).
La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 mai 2005, en voie de for-
malisation et publication au Mémorial C.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La séance est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Enzo Liotino, comptable, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire de l’assemblée Monsieur Raul Marques, employé, avec adresse professionnel-
le à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilbert Divine, employé, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’article quatre (4) des statuts de la Société afin de lui donner la teneur ci-après, la Société n’étant
par conséquent plus régie par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, la détention de créances, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra emprunter, avec ou sans garantie, en toutes monnaies y compris par voie d’émission d’obligations.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
2.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de Luxembourg-Ville à Bridel et modification af-
férente du premier alinéa de l’article deux (2) des statuts de la Société.
3.- Fixation de la nouvelle adresse de la Société au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel.
4.- Acceptation avec décharge de la démission collective du conseil d’administration de la Société et nomination de
leurs remplaçants, leurs mandats se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de
2006.
5.- Acceptation avec décharge de la démission du commissaire aux comptes de la Société et nomination de son rem-
plaçant, son mandat se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 2006.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article quatre (4) des statuts de la Société
afin de lui donner la teneur reproduite ci-après, la Société n’étant par conséquent plus régie par la loi du 31 juillet 1929
concernant les sociétés holding:
Art. 4. «La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, la détention de créances, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
54431
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra emprunter, avec ou sans garantie, en toutes monnaies y compris par voie d’émission d’obligations.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de
la Société de Luxembourg-Ville à Bridel et de fixer la nouvelle adresse au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de refléter ledit transfert de siège, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le
premier alinéa de l’article deux (2) des statuts de la Société, lequel alinéa aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. (premier alinéa). «Le siège social est établi à Bridel (commune de Kopstal).»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la démission collective des membres du con-
seil d’administration de la Société et d’accorder à chacun d’eux décharge pleine et entière pour l’accomplissement de
leur mandat jusqu’au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.
De même l’assemblée générale extraordinaire accepte avec effet immédiat la démission de l’actuel commissaire de la
Société et de lui donner pleine et entière décharge pour l’accomplissement de ce mandat de commissaire jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs
et commissaire en remplacement de ces membres démissionnaires, les personnes et sociétés suivantes:
a) en tant qu’administrateurs:
1.- Monsieur Marius Kaskas, administrateur de société, né à Athènes (Grèce), le 7 septembre 1956, avec adresse pro-
fessionnelle au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel;
2.- Madame Berendina ten Brinke, administratrice de société, née à Wisch (Pays-Bas), le 3 juillet 1953, avec adresse
professionnelle au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel;
3.- la société ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., une société anonyme de droit luxembour-
geois, avec siège social au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 80.766).
b) en tant que commissaire:
la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social au 15, rue des Carrefours, L-8124 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
37.039).
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les mandats des administrateurs et du commissaire
nouvellement désignés se termineront à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes de 2006,
en l’occurrence le dernier mercredi du mois de mai en 2007.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. Liotino, R. Marques, G. Divine, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2005, vol. 893, fol. 80, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057647.3/239/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.
PERFORM INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 108.017.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057648.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.
Belvaux, le 5 juillet 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 5 juillet 2005.
J.-J. Wagner.
54432
LUXEMBOURG COMPANY OF METALS & ALLOYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Ehlerange, Zone d’Activité ZARE .
R. C. Luxembourg B 55.567.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 18 janvier 2005 à 10.30 heuresi>
La séance est ouverte à 10 heures 30 sons la présidence de Monsieur Igor Turkin, demeurant professionnellement à
L-Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Jeanne Muller, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Lauriane Esteves, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
Tous les membres du bureau sont présents et acceptent leur fonction.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
1. que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence laquelle restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et/
ou les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau;
2. qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présente ou représentée, de sorte que la pré-
sente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents et/ou repré-
sentés déclarent par ailleurs, avoir été prévenus personnellement et eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable;
3. que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00444. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Otis Claeys demeurant pro-
fessionnellement à L-2450 Luxembourg au 15, bd Roosevelt.
<i>Deuxième résolutioni>
Aucun point n’est soulevé.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures après lecture et approbation du procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00446. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028115.3/850/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2005.
SANEST-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.290.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 3 juin 2005 que
le mandat des administrateurs suivants est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans:
1. Monsieur Patrick Broud, né le 13 mars 1946 à Vichy, France, demeurant au 11, rue Honoré de Balzac, Varennes
Vauzelles, F-58640 (France);
2. Monsieur Gilles Bessenay, né le 12 janvier 1953 à Villeurbanne, France, demeurant à Le Péage, Oytier-Saint-Oblas,
F-38780 (France).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01321. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047520.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
I. Turkin / L. Esteves / J. Muller
<i>Le président / La scrutatrice / La secrétairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Alcelec, S.à r.l.
Display Center, S.à r.l.
Luxembourg Congres S.A.
Symphony Finance S.A.
Symphony Finance S.A.
Hardt Group Securities S.A.
AME Life Lux S.A.
IT Investments, S.à r.l.
Institut Rosenfeld S.à r.l.
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.
Myrtus Finance S.A.
ITI Holdings S.A.
ITI Holdings S.A.
Fendi S.A.
Christa Intershipping, S.à r.l.
Dexia Participation Luxembourg
Polifin S.A.
Kronospan Luxembourg S.A.
Kalbax, S.à r.l.
Somel S.A.
Bentim International S.A.
Business Consultants Europe S.A.
Sprumex S.A.
Ayubowan
Inter-Actions
L.I., Luxembourgeoise d’Interventions S.A.
Compagnie Helvétique de destockage S.A.
Compagnie Helvétique de destockage S.A.
Compagnie Helvétique de destockage S.A.
Compagnie Helvétique de destockage S.A.
Image Investments Holding S.A.
IKB CorporateLab S.A.
Socom S.A.
Graficom
Anchor Investments S.A.
AB Europroperty, S.à r.l.
Zirouc, S.à r.l.
Jurian S.A.
Top Université Holding, S.à r.l.
Roule Holding, S.à r.l.
Top Roule Holding, S.à r.l.
Université Holding, S.à r.l.
Interlignum S.A.
La Maison du Tapis, S.à r.l.
Gaviota Re S.A.
Biel Fund Management Company S.A.
Multiworld
Staples Luxco, S.à r.l.
Staples Luxco, S.à r.l.
Solidarité Action «Gouye Gui»
M2M S.A.
Colonnade Holdco N˚ 5 S.A.
Euroturistica Holding S.A.
International Company of Investment S.A.
Kapateco
Le Comitium International S.A.
Evita S.A.
AGF World Fund, Sicav
Foncière T.M.G.F. S.A.
Tesei S.A.
North Miami Beach Investment Corp S.A.
Strongbow Capital Holdings S.A.
Strongbow Capital Holdings S.A.
NBCA Holding S.A.
NBCA Holding S.A.
Placinvest S.A.
Quilmes Industrial (Quinsa)
Quilmes Industrial (Quinsa) S.A.
Perform Invest S.A.
Perform Invest S.A.
Luxembourg Company of Metals & Alloys S.A.
Sanest-Lux S.A.