This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
52561
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1096
26 octobre 2005
S O M M A I R E
SEMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Luxembourg B 95.190.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04547, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047074.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
A.A. Abacus AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52606
Immobinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52607
Addison Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52589
Industrial Fine Wagon S.A., Luxembourg . . . . . . .
52608
Adeia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52605
IRADO Funding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
52563
Agrinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52604
Island Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52606
Alfred Berg Norden, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
52576
Kinnevik S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52588
Asher S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52563
Matrix La Gaude Investment, S.à r.l., Luxem-
Belvedere Investment Holdings S.A., Luxembourg
52608
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52608
Bordag International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
52572
Matrix La Gaude Property, S.à r.l., Luxembourg .
52607
Bordag International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
52572
Oasmia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52605
Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
52562
Partimmobiliare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52582
Coiffure Coccinella, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . .
52607
PBG Investment (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Constant Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52564
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52564
Constant Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52564
PBG Investment (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Courances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52579
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52571
Domus Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
52606
ProLogis France L, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
52603
Ekelmann, S.à r.l., Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . .
52607
ProLogis France LI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
52582
Eurel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52573
ProLogis France LII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
52580
Eurel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52575
ProLogis France LIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
52579
F & I Software S.A., Dippach-Gare. . . . . . . . . . . . . .
52605
ProLogis France LIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
52575
Fairfield Aerium International S.C.A., Luxem-
ProLogis France XII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
52573
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52583
Scipio Consulting, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . .
52602
Foxy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52571
Semalux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52561
Foxy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52571
Sogecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52604
General Electric International Japan Investments I,
Sonora Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52597
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52572
Tinska Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52562
Gori & Zucchi International S.A., Luxembourg . . .
52572
Tinska Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52562
Harvest Wealth Management, GmbH, Luxem-
TOC Investments Holding, S.à r.l., Luxembourg .
52604
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52580
Yellow Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
52575
Diekirch, le 17 mai 2005.
Signature.
52562
CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.755.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 avril 2005i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02268. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047810.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
TINSKA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.154.
—
<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 mai 2005i>
* L’Assembiée a accepté les démissions des deux Administrateurs, Monsieur Gérard Muller et Monsieur Sergio Bassi.
* L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en nommant M. Sergio
Scanavino, 19 Via Ottavio Revel, I-10121 Turin et la société DIRECTOR, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
aux fonctions d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2008.
* L’Assemblée a décidé de nommer M. Sergio Scanavino, préqualifié, aux fonctions d’Administrateur-Délégué, ayant
tous pouvoirs aux fins d’engager la société par sa signature individuelle.
* L’Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société au 16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046893.3/1629/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
TINSKA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.154.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01121, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2005.
(046880.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
MM. Dominique Billion, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
52563
IRADO FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,-.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 107.836.
—
EXTRAIT
Le 13 mai 2005, DEUTSCHE BANK AG, une société régie par le droit allemand, ayant son siège social à Taunusanlage
12, D-60262 Francfort sur le Main, Allemagne, enregistrée au Amstgericht de Francfort sur le Main, Allemagne sous le
numéro HRB 30 000 (DEUTSCHE BANK), a cédé, conformément à l’article 189 de la loi du 15 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, toute sa participation consistant en neuf (9) parts sociales dans IRADO
FUNDING, S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2, boulevard Konrad
Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg (IRADO FUNDING) à IRADO HOLDING LIMITED, une société régie par le
droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Deutsche Bank (Cayman) Limited, PO Box 1984GT, Elisabethan Square,
George Town, Grand Cayman, lles Cayman, enregistrée au Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro
148538 (IRADO HOLDING).
Le 17 mai, par acte notarié, il a été procédé à la conversion des neuf (9) parts sociales d’IRADO FUNDING en neuf
(9) parts sociales de catégorie A et à l’augmentation du capital social d’IRADO. FUNDING à concurrence de USD
20.000,- pour le porter à un montant de USD 40.000,- par la création de neuf (9) parts sociales de catégorie A et de
deux (2) parts sociales de catégorie B d’une valeur nominale de USD 2.000,- chacune. Ces parts sociales nouvelles ont
toutes été souscrites par IRADO HOLDING.
Le 13 mai 2005, mais avec effet le 20 mai 2005, IRADO HOLDING a cédé, conformément à l’article 189 de la loi du
15 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les deux (2) parts sociales de catégorie B qu’elle détenait
dans IRADO FUNDING à DEUTSCHE BANK.
Le 12 mai 2005, mais avec effet le 20 mai 2005, DEUTSCHE BANK a cédé à titre de garantie, conformément à la loi
du 1
er
août 2001 sur le transfert de propriété à titre de garantie et conformément à l’article 189 de la loi du 15 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les deux (2) parts sociales de catégorie B qu’elle détenait dans
IRADO FUNDING à HSH NORDBANK AG, une société régie par le droit allemand, ayant son siège social à Martens-
damm 6, D-24103 Kiel, Allemagne, enregistrée au Amstgericht de Kiel, Allemagne sous le numéro HRB 6127 Kl (HSH
NORDBANK).
Suite à ces cessions, le capital social de IRADO FUNDING est détenu par IRADO HOLDING (18 parts sociales de
catégorie A) et par HSH NORDBANK (2 parts sociales de catégorie B).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07545. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047563.3/267/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
ASHER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 86.082.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 mars 2005 a renouvellé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Marc Koeune,
- Monsieur Michaël Zianveni,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux compte est Monsieur Laurent Pêcheur, domicilié, professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07928. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046909.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
<i>Pour IRADO FUNDING, S.à r.l.
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
52564
CONSTANT SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.099.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF01070, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046802.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
CONSTANT SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.099.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01072, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046807.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.428.
—
In the year two thousand five, on the tenth of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
PBG INVESTMENT PARTNERSHIP, a general partnership organized under the laws of Ontario, having its registered
office at Second Floor-Williams House, 20 Reid Street, Hamilton, HM MX Bermuda,
here duly represented by Ms. Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney issued on May 10, 2005.
The aforementioned proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed for registration purposes.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. (the Company), a société à
responsabilité limitée unipersonnelle registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B
number 89.428, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, on September 26,
2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 21, 2002 under number 1671;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to create two groups of managers, being the group A-manager(s) and the group B-
manager(s).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to proceed with a complete restatement of the articles of association which shall
henceforth read as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name PBG INVEST-
MENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in par-
ticular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
Signature.
Signature.
52565
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at two million five hundred thousand United States dollars (USD
2,500,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) shares in registered form with a par value of twenty- five
United States dollars (USD 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
Inter vivos, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners
representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of the shares
of the deceased partner to new partners is subject to the approval given by the other partners in a general meeting, at
a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the
shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers composed of one or more group A managers and one or more group B managers. The manager(s)
need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
52566
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any group A manager of the Company acting jointly
with any group B manager of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members, including at least one group
A manager and one group B manager is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken
by the majority of the votes cast including the votes of at least one group A manager and one group B manager. The
resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at
the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any group A manager and
any group B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power
has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
52567
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed within the legal limits, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the single partner or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the partners,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
5. The partner(s), upon receipt of such interim dividend, undertake towards the Company to refund any amounts so
paid to them, in whole or in part, at the Company’s request, should it appear after the approval by the general meeting
of partner(s) of the final annual accounts for the accounting year in question, that the profits for that accounting year
were insufficient to cover the amount of the interim dividend(s) so paid.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to change the registered office of the Company as of today from 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to acknowledge the resignation of MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. as manager of
the Company with immediate effect and grants full discharge to MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. with respect to the
performance of its mandate during the period December 31, 2003 through today.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder appoints Mrs. Noëlla Antoine, expert comptable, born on January 11,1969 in Libramont (Bel-
gium) and Mr. Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, born on December 31,1958 in Alost (Belgium), both with pro-
fessional address in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, as group B-managers of the Company with immediate
effect for an indefinite period of time.
The sole shareholder appoints the other actual managers of the Company, being Mr. Inigo Madariaga, born on May
23,1961 in Bilbao (Spain), with professional address at Avenida De Los Olmos, 2, E-01013 Vitoria (Spain), and Mr. Ge-
offrey Kupferschmid, born on July 16,1962 in New York (United States), both with professional address at 1, Pepsi Way,
Somers, NY 10589 (United States) as group A-managers of the Company for an indefinite period of time.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille cinq, le dix mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PBG INVESTMENT PARTNERSHIP, une société en commandite («general partnership») organisée sous les lois de
l’Ontario, avec siège social à Second Floor-Williams House, 20 Reid Street, Hamilton, HM MX Bermuda,
ici dûment représenté par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée en date du 10 mai 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’elle est le seul associé de PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité
limitée unipersonnelle inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B numéro 89.428,
52568
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 septem-
bre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1671 du 21 novembre 2002;
- que le seul associé a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de créer deux groupes de gérants, à savoir le(s) gérant(s) du groupe A et le(s) gérant(s) du
groupe B.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de faire une refonte complète des statuts de sorte que les statuts seront rédigés désormais
comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.
(la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges tous ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tous ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 2.500.000,-), représenté par
cent mille (100.000) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis
(USD 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
52569
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
Entre vifs, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-
nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts so-
ciales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas
cependant, cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit
au conjoint survivant.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-
dat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance compose d’un ou de plusieurs gérant(s) du
groupe A et d’un ou plusieurs gérant(s) du groupe B. Les gérants ne doivent pas être associés.
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par un des gérants appartenant au groupe A de la société,
agissant conjointement avec un des gérants appartenant au groupe B de la société.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants, dont au moins un
gérant appartenant au groupe A et un gérant appartenant au groupe B, est présente ou représentée. Les décisions du
conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, comprenant les
votes d’au moins un gérant appartenant au groupe A et d’un gérant appartenant au groupe B. Les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant appartenant
au groupe A et d’un gérant appartenant au groupe B de la Société, ou par les signatures conjointes ou la signature unique
de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
52570
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués dans les limites légales à tout moment sous les conditions
suivantes:
1. Des comptes intermédiaires sont dressés par le gérant ou le conseil de gérance;
2. Ces comptes font apparaître un bénéfice, y inclus les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire;
3. La décision de distribuer des acomptes sur dividendes est prise par l’associé unique ou, selon le cas, par une as-
semblée générale extraordinaire des associés;
4. Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu la certitude que les droits des créanciers de la société ne
sont pas en danger;
5. L(es)’associé(s), lorsqu’il(s) reçoive(nt) un tel acompte sur dividende, s’engage(nt) envers la Société à rembourser
totalement ou partiellement les montants qu’ils ont touchés à la demande de la Société lorsqu’il se révélera après ap-
probation des comptes annuels de l’exercice social en question que les bénéfices de cet exercice étaient insuffisants
pour permettre la distribution de l’acompte sur dividende ainsi payé.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société avec effet à partir d’aujourd’hui du 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de prendre acte de la démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. comme gérant de la
Société avec effet immédiat et donne décharge pleine et entière à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exécution
de son mandat entre la période du 31 décembre 2003 jusqu’à aujourd’hui.
52571
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique nomme Madame Noëlla Antoine, expert comptable, née le 11 janvier 1969 à Libramont (Belgique)
et Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, né le 31 décembre 1958 à Alost (Belgique), tous les deux avec
adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, comme gérants de classe B de la Société avec
effet immédiat pour une période indéterminée.
L’associé unique nomme les autres gérants actuels de la Société, à savoir Monsieur Inigo Madariaga, né le 23 mai 1961
à Bilbao (Espagne), avec adresse professionnelle à Avenida De Los Olmos, 2, E-01013 Vitoria (Espagne) et Monsieur
Geoffrey Kupferschmid, né le 16 juillet 1962 à New York (Etats-Unis), avec adresse professionnelle à 1, Pepsi Way, So-
mers, NY 10589 (Etats-Unis) comme gérants de classe A de la Société pour une période indéterminée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 40, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(047586.3/212/435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.428.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047588.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
FOXY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01181, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
(046852.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
FOXY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01185, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
(046854.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Luxembourg, le 6 juin 2005.
P. Frieders.
Luxembourg, le 6 juin 2005.
P. Frieders.
<i>Pour FOXY S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur-délégué / Administrateuri>
<i>Pour FOXY S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur-délégué / Administrateuri>
52572
BORDAG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 87.712.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
L’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2005 a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme BORDAG INTERNATIONAL
S.A., en liquidation, ayant son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a définitivement cessé d’exister, même
pour les besoins de la liquidation. Les livres et les documents sociaux seront conservés au dernier siège de la société
pendant cinq ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01930. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047412.3/777/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
BORDAG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 87.712.
—
Le bilan de clôture de la liquidation au 4 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01931, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047409.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
GORI & ZUCCHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. S Luxembourg B 20.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01240, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2005.
(046829.3/273/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 2.503.800,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 58.865.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire de la Société en date du 12 mai 2005i>
Sont nommés gérants, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2005:
- M. Stephen M. Parks, avec adresse professionnelle à Fairfield, CT, Etats-Unis;
- M. Roeland Pels, avec adresse professionnelle à Luxembourg;
- M. Marlin Risinger, avec adresse professionnelle à Londres, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047890.3/2460/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Signatures.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
52573
ProLogis FRANCE XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 812.500,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.107.
—
Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04855. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046824.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
EUREL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 41.729.
—
In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUREL INTERNATIONAL S.A., a «société
anonyme», established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, here after referred
to as the «Company».
The Company is entered in the Luxembourg Company and Trade Register, section B number 41,729 and was incor-
porated formerly under the name of TYPHOON HOLDING S.A., pursuant to a notarial deed of October 8, 1992, pub-
lished in the Mémorial C number 17 of January 14, 1993.
The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned no-
tary, on 24 January 2003, published in the Mémorial C, number 321 of 25 March 2003.
The extraordinary general meeting is declared open by Mrs Angelina Scarcelli, employee, with professional address
in Luxembourg, in the chair.
The Chairwoman appoints as secretary of the meeting Mrs Laura Laine, employee, with professional address in Lux-
embourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Roberto Manciocchi, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairwoman declares and requests the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) To change the date of the annual general meeting from currently the 1st Monday in November at 10.00 a.m. to
the 1st Monday in June of each year at 10.00 a.m. The next annual general meeting will take place in June 2005.
2) To amend article 13 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the change of the date of the
annual general meeting.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an
attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all thousand two hundred fifty (1,250) shares representing the total
subscribed capital of the Company are present or represented at this meeting. All the shareholders present declare that
they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were neces-
sary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the date of the annual general meeting of
shareholders, so that it shall be held henceforth on the first Monday in the month of June of each year at 10.00 a.m.
instead of the first Monday in November at 10.00 a.m.
<i>Second resolutioni>
As a direct consequence of this change of the date of the annual general meeting, the extraordinary general meeting
of shareholders resolves to amend Article thirteen (13) of the Articles of Incorporation to read as follows:
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
52574
«Art. 13. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the
corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Monday in
the month of June at 10.00 a.m.
If such day is a public holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.»
Furthermore, the extraordinary general meeting of shareholders resolves that the next annual general meeting, ap-
proving the annual accounts, as per 31 December 2004, shall then be held at the amended date as here above mentioned.
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuvième jour du mois d’avril.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUREL INTERNATIONAL S.A., une société ano-
nyme, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, ci-après dénommée la «Société».
La Société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 41.729 et
fut constituée originairement sous la dénomination de TYPHOON HOLDING, suivant acte notarié du 8 octobre 1992,
publié au Mémorial C numéro 17 du 14 janvier 1993.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte du notaire soussigné, reçu en date du 24
janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 321 du 25 mars 2003.
La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Angelina Scarcelli, employée, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Laura Laine, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) De modifier la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du premier lundi du mois de
novembre à 10.00 heures au premier lundi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures. La prochaine assemblée
générale annuelle se tiendra en juin 2005.
2) De modifier l’article 13 des statuts de la Société, afin de refléter le prédit changement de la tenue de l’assemblée
générale annuelle.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-
gralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnais-
sent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires, de manière à ce qu’elle soit tenue à l’avenir le premier lundi du mois de juin de chaque année
à 10.00 heures.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence directe de cette modification de la date de l’assemblée générale annuelle, l’assemblée générale an-
nuelle des actionnaires décide de modifier l’article treize (13) des statuts de la Société de la manière suivante:
«Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque
année à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férie légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.»
En outre, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que l’assemblée générale annuelle statutaire de
la Société, devant statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, se tiendra donc à la date modifiée,
comme indiquée ci-avant.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
52575
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Scarcelli, L. Laine, R. Manciocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2005, vol. 893, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047900.3/239/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
EUREL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 41.729.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047901.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
ProLogis FRANCE LIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 105.926.
—
Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04849. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046827.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
YELLOW INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Maché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 108.177.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire i>
<i>tenue à Luxembourg le 27 mai 2005 à 14.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- La démission de EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que Commissaire de la société
est acceptée avec effet immédiat.
- La nomination de M. Karl Veit, citoyen allemand, né le 21 février 1969 à Köln, résidant au 74A, route de Luxem-
bourg, L-6633 Wasserbillig, en tant que Commissaire, est acceptée avec un mandat qui arrivera à échéance lors de l’as-
semblée générale annuelle de 2007.
Luxembourg, le 6 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02238. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048014.3/1084/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Belvaux, le 6 juin 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 6 juin 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
YELLOW INVEST S.A.
A. Noullet
<i>Administrateur Ai>
52576
ALFRED BERG NORDEN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.149.
—
In the year two thousand and five, on the sixteenth day of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ALFRED BERG NORDEN (the «Fund»), a société
d’investissement à capital variable with its registered office at 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, incorporated
under Luxembourg law by a deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, on 9 July 1987, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 11 August 1987.
The meeting was opened by Mr Stéphane Badey, employee, residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary Mrs Martina Dinklage, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Nicolas Muller, employee, residing in Hagondange.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The extraordinary general meeting convened for 12 January 2005 could not validly deliberate on the agenda of the
present meeting for lack of quorum, and the present extraordinary general meeting was reconvened by notices to share-
holders, containing the agenda published in the Mémorial, the Luxemburger Wort and the Tageblatt on 15 January 2005
and on 31 January 2005;
and by notices containing the agenda sent to every registered shareholders by mail on 14 January 2005.
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders present and the proxies of the shareholders represented and by the members of
the bureau. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this docu-
ment, to be registered with this deed.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
To approve the merger of the Fund into ABN AMRO Funds, a «société d’investissement à capital variable» under
Part I of the law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, as amended, having its registered
office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and to approve the merger of ALFRED BERG NORDEN - Aktier,
ALFRED BERG NORDEN - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obligationer, each a portfolio of
the Fund, into ABN AMRO Funds - Nordic Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Den-
mark Bond, respectively, each a newly created portfolio of ABN AMRO Funds, and more specifically, upon hearing:
(i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Propos-
al») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 10 December 2004 and depos-
ited with the registre de commerce et des sociétés of Luxembourg, and
(ii) the auditor’s report prescribed by Article 266 of the law on commercial companies prepared by ERNST &
YOUNG S.A., Luxembourg.
1) to approve such Merger Proposal;
2) to set the effective date (hereinafter the «Effective Date») of the merger on 18 February 2005 after close of busi-
ness;
3) to approve that, on the Effective Date, all assets and liabilities of each ALFRED BERG NORDEN - Aktier, ALFRED
BERG NORDEN - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obligationer shall be allocated to ABN
AMRO Funds - Nordic Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Denmark Bond respectively;
4) to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of all assets and liabilities of each ALFRED
BERG NORDEN - Aktier, ALFRED BERG NORDEN - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obliga-
tioner, ABN AMRO Funds issues to the shareholders of the Fund new shares of class A in ABN AMRO Funds Nordic
Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Denmark Bond respectively. The number of shares
to be issued for the benefit of the shareholders of the Fund’s portfolios will be equal to the number of shares held by
them in the portfolios of the Fund at a net asset value equivalent to the net asset value of each of the Fund’s portfolios
on the Effective Date. All new shares in ABN AMRO Funds in registered form will be issued with fractions of up to one
hundredth of a share.
5) to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be
cancelled.
IV. It appears from the attendance list that out of forty-seven thousand three hundred and twenty-nine point three
thousand four hundred and ninety (47,329.3490) shares issued and outstanding, six hundred and fifty (650) shares are
represented at the present extraordinary general meeting. As a consequence, the meeting can validly deliberate on the
agenda of the meeting.
V. That the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies concerning the mergers have been
observed i.e.:
1) Publication in the Mémorial on 10 December 2004 of the Merger Proposal signed in notarial form by the board of
directors of the merging companies.
2) Drawing up of a written report by the board of directors of each of the merging companies explaining and justifying
the Merger Proposal and in particular the exchange procedure of the shares.
3) Drawing up of the auditor’s report by ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, as independent auditor to the merging
companies.
52577
4) Deposit for inspection by shareholders of the documents required by article 267 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies at the registered office of the merging companies one month at least before this meeting which
has been convened in order to approve the Merger Proposal.
The reports of the board of directors and the auditor’s report of the independent auditor will remain annexed to the
present deed.
After deliberation, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
It was decided to approve the merger of the Fund into ABN AMRO Funds, a «société d’investissement à capital var-
iable» under Part I of the law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, as amended, having
its registered office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and more specifically upon hearing:
(i) the report of the board of directors explaining and justifying the Merger Proposal published in the Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 10 December 2004 and deposited with the registre de commerce
et des sociétés of Luxembourg, and
(ii) the auditor’s report prescribed by article 266 of the law on commercial companies prepared by ERNST &
YOUNG S.A., Luxembourg;
1) to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposal;
2) to set the Effective Date of the merger as defined in the Merger Proposal on 18 February 2005;
3) to approve that, on the Effective Date, all assets and liabilities of each ALFRED BERG NORDEN - Aktier, ALFRED
BERG NORDEN - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obligationer shall be allocated to ABN
AMRO Funds - Nordic Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Denmark Bond respectively;
4) to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of all assets and liabilities of each ALFRED
BERG NORDEN - Aktier, ALFRED BERG NORDEN - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obliga-
tioner, ABN AMRO Funds issues to the shareholders of the Fund new shares of class A in ABN AMRO Funds - Nordic
Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Denmark Bond respectively. The number of shares
to be issued for the benefit of the shareholders of the Fund’s portfolios will be equal to the number of shares held by
them in the portfolios of the Fund at a net asset value equivalent to the net asset value of each of the Fund’s portfolios
on the Effective Date. The new shares in ABN AMRO Fund in registered form will be issued with fractions of up to one
hundredth of a share.
5) to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be
cancelled.
<i>Statementi>
The undersigned notary declares in accordance with article 271, paragraph 2, of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, that he has verified the existence of the Merger Proposal as well as of all other acts and formalities
imposed to the Fund in relation with the merger.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
name, civil status and residences, the chairman, the secretary and the scrutineer signed together with Us, notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le seize février.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ALFRED BERG NORDEN (le «Fonds»), une
société d’investissement à capital variable ayant son siège social au 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée
en vertu de la loi luxembourgeoise par un acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 9
juillet 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 11 août 1987.
L’assemblée est présidée par Monsieur Stéphane Badey, employé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Martina Dinklage, employée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Nicolas Muller, employé, demeurant à Hagondange.
I. L’assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur l’ordre du jour de la
présente assemblée en absence de quorum et la présente assemblée générale extraordinaire a été reconvoquée par des
avis aux actionnaires, contenant l’ordre du jour, publiés dans le Mémorial, le Luxemburger Wort et le Tageblatt en dates
des 15 janvier 2005 et 31 janvier 2005;
et par des convocations, contenant l’ordre du jour, envoyées à tous les actionnaires nominatifs le 14 janvier 2005.
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur
une liste de présence signée par les actionnaires et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les mem-
bres du bureau. Ladite liste et les procurations signées ne varietur par les membres du bureau resteront annexées à
l’original du présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
52578
<i>Ordre du jour:i>
Approuver la fusion du Fonds dans ABN AMRO Funds, une «société d’investissement à capital variable» soumise à
la partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, ayant son siège
social au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et approuver la fusion de ALFRED BERG NORDEN - Aktier,
ALFRED BERG NORDEN - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obligationer, chacun un comparti-
ment du Fonds dans respectivement ABN AMRO Funds - Nordic Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN
AMRO Funds - Denmark Bond, chacun un nouveau compartiment créé de ABN AMRO Funds, et plus spécifiquement
après avoir entendu:
(i) le rapport du conseil d’administration expliquant et justifiant le projet de fusion (ci-après le «Projet de Fusion»)
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg le 10 décembre 2004 et déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, et
(ii) le rapport du réviseur d’entreprises prescrit par l’Article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, préparé par
ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.
1) approuver le Projet de Fusion;
2) fixer la date d’effet de la fusion (ci-après la «Date d’Effet») au 18 février 2005 à l’heure de fermeture des bureaux;
3) approuver qu’à la Date d’Effet, l’actif et le passif de chacun ALFRED BERG NORDEN - Aktier, ALFRED BERG
Norden - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obligationer seront attribués respectivement à ABN
AMRO Funds - Nordic Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Denmark Bond;
4) approuver qu’à la Date d’Effet, en échange de l’apport de l’actif et du passif de ALFRED BERG NORDEN - Aktier,
ALFRED BERG NORDEN - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obligationer, ABN AMRO Funds
émettra aux actionnaires du Fonds des nouvelles actions de classe A de respectivement ABN AMRO Funds - Nordic
Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Denmark Bond. Le nombre d’actions émises pour
le bénéfice des actionnaires des compartiments du Fonds seront égales au nombre d’actions tenues par eux dans les
compartiments du Fonds à la valeur nette d’inventaire équivalente à la valeur nette d’inventaire de chacun des porte-
feuilles du Fonds à la Date Effective. Les nouvelles actions de ABN AMRO Funds sous forme nominative seront émises
avec des fractions jusqu’à concurrence de deux décimales;
5) noter que suite à la fusion, le Fonds cessera d’exister à la Date d’Effet, et que toutes ses actions en circulation
seront annulées.
IV. Il résulte de la liste de présence que sur quarante-sept mille trois cent vingt-neuf virgule trois mille quatre cent
quatre-vingt-dix (47.329.3490) actions émises et en circulation, six cent cinquante (650) actions sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire. En conséquence, l’assemblée peut délibérer valablement sur l’ordre du
jour.
V. Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée relatives aux fusions
ont été respectées à savoir:
1) Publication au Mémorial le 10 décembre 2004 du Projet de Fusion établi en la forme notariée par les Conseils
d’Administration des sociétés qui fusionnent.
2) Rédaction d’un rapport écrit par le Conseil d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et
justifiant le Projet de Fusion et en particulier la procédure d’échange des actions.
3) Rédaction de rapport par ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, expert indépendant des sociétés qui fusionnent.
4) Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales au siège
social des sociétés un mois au moins avant la réunion de la présente assemblée appelée à se prononcer sur le Projet de
Fusion en vue de leur inspection par les actionnaires.
Les rapports des conseils d’administration et de l’expert indépendant resteront annexés aux présentes.
Après délibération l’assemblée a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Il a été décidé d’approuver la fusion du Fonds dans ABN AMRO Funds et plus spécifiquement après avoir entendu:
(i) le rapport du conseil d’administration de la société expliquant et justifiant le Projet de Fusion publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, en date du 10 décembre 2004 et déposé auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, et
(ii) le rapport du réviseur d’entreprises prescrit par l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales préparé par
ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.
1) d’approuver le Projet de Fusion.
2) de fixer la Date d’Effet de la fusion au 18 février 2005 à l’heure de fermeture des bureaux.
3) d’approuver qu’à la Date d’Effet, l’actif et le passif de chacun ALFRED BERG NORDEN - Aktier, ALFRED BERG
NORDEN - Danske Aktier and ALFRED BERG NORDEN - Danske Obligationer seront attribués respectivement à
ABN AMRO Funds - Nordic Fund, ABN AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Denmark Bond.
4) d’approuver qu’à la Date d’Effet, en échange de l’apport de l’actif et du passif de ALFRED BERG NORDEN - Aktier,
ALFRED BERG NORDEN - Danske Aktier et Alfred Berg Norden - Danske Obligationer, ABN AMRO Funds émettra
aux actionnaires du Fonds des nouvelles actions de classe A de respectivement ABN AMRO Funds - Nordic Fund, ABN
AMRO Funds - Denmark Fund and ABN AMRO Funds - Denmark Bond. Le nombre d’actions émises pour le bénéfice
des actionnaires des compartiments du Fonds seront égales au nombre d’actions tenues par eux dans les compartiments
du Fonds à la valeur nette d’inventaire équivalente à la valeur nette d’inventaire de chacun des portefeuilles du Fonds à
la Date Effective. Les nouvelles actions de ABN AMRO Funds sous forme nominative seront émises avec des fractions
jusqu’à concurrence de deux décimales.
5) que suite à la fusion, le Fonds cessera d’exister à la Date d’Effet et toutes ses actions en circulation seront annulées.
52579
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
a vérifié et atteste par la présente l’existence et la légalité du Projet de Fusion et tous les autres actes et exigences for-
melles imposées par la loi au Fonds en relation avec la fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre les textes anglais et
français, la version anglaise fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et demeure, le pré-
sident, le secrétaire et le scrutateur ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Badey, M. Dinklage, N. Muller, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 février 2005, vol. 430, fol. 68, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048028.3/242/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
ProLogis FRANCE LIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 104.617.
—
Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046828.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
COURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.236.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 6 juin 2005 que:
Sont réélus administrateurs jusqu’aux prochaines élections statutaires qui auront lieu à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Annuelle de 2010:
- Francis N. Hoogewerf;
- ARDAVON HOLDINGS LTD;
- Igor Kerez.
Est réélu commissaire aux comptes jusqu’aux prochaines élections statutaires qui auront lieu à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle de 2010:
- Henri Vanherberghen.
Est réélu administrateur-délégué jusqu’aux prochaines élections statutaires qui auront lieu à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle de 2010:
- Francis N. Hoogewerf.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02179. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047840.3/634/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Mersch, le 31 mai 2005.
H. Hellinckx.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliataire
i>Signature
52580
ProLogis FRANCE LII, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 104.618.
—
Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04846. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046831.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
HARVEST WEALTH MANAGEMENT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1610 Luxemburg, 8-10, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 108.435.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den neunundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitze zu Niederanven.
Ist erschienen:
Herr Cornelis Ferdinandus Klaassen, Direktor, geboren in Schiedam (Niederlande), am 11. Mai 1959, wohnhaft in
wohnhaft in NL-3233 BV Oostvoorne, Valkenlaan 25,
hier vertreten durch Herrn Marcel Learbuch, wohnhaft in L-7370 Lorentzweiler, 34, rue St. Laurent,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 29. April 2005,
welche Vollmacht nach gehörigerne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeichne-
ten Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mir ihr einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihm
zu gründenden unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung un-
ter der Bezeichnung HARVEST WEALTH MANAGEMENT, GmbH.
Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die
zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des
Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Handelsagentur.
Ausserdem ist Zweck der Gesellschaft das Durchführen von jeglichen Finanzoperationen, insbesondere Zeichnung,
Erwerb, Uebertragung, Verkauf, Titrierung von (a) Mobiliarwerten (darstellend eine Schuld oder andere) welche ausge-
stellt wurden von internationalen Organismen und Institutionen, durch unabhängige Staaten, durch öffentliche oder pri-
vate Unternehmen sowie durch andere Rechtsgebilde und (b) Aktiva und/oder Guthaben jedwelcher anderer Art und
Sorte.
Unbeschadet von allem Vorstehenden kann die Gesellschaft ihre Mittel namentlich verwenden zur Bildung, zur Ver-
waltung, zur Verwertung, zum Erwerb und zur Liquidation von jedwelchen Wertpapieren und anderen finanziellen Mit-
teln; sie kann sich an der Gründung, an der Weiterentwicklung und/oder der Kontrolle eines jedwelchen Unternehmens
beteiligen; sie kann mittels Einlage, Zeichnung, fester Uebernahme oder Kaufoption oder mittels jeglichen anderen Mit-
teln jegliche Wertpapiere oder anderen finanziellen Mittel erwerben; sie kann selbe durch Verkauf, Zession, Tausch
oder anderswie veräussern; sie kann denjenigen Gesellschaften an welchen sie beteiligt ist jegliche Unterstützung, Dar-
lehen, Vorschuss oder Garantie gewähren; sie kann Schuldverschreibungen und Mobiliarwerte jedwelcher Art in jegli-
chen Devisen ausstellen und auf jegliche anderen Art und Weisen Darlehen aufnehmen; sie kann sich an Swapverträgen
beteiligen, im Hinblick auf die Absicherung der Zahlung oder der Rückzahlung einer jeglichen Summe, welche durch die
Gesellschaft geschuldet ist aufgrund von oder im Zusammenhang mit Schuldverschreibungen jedwelcher Art welche von
Zeit zu Zeit durch die Gesellschaft ausgestellt werden, kann die Gesellschaft auf ihre Mittel und Rechte Pfand, Hypothek
oder jedwelche anderen Garantien bestellen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedwelche Techniken und Mittel im Zusammenhang mit ihren Gütern und/oder
ihren Investititionen anweden, welche eine leistungskräftige Verwaltung derselben erwirken, einbegriffen sämtliche
Techniken und Mittel um selbe abzusichern gegen Kurswechselrisiko und Zinsrisiko. Sie kann jegliche Mittel zur Kon-
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
52581
trolle und Aufsicht anwenden und jegliche Handlung finanzieller, mobiliarer, immobiliarer, geschäftlicher und industriel-
ler Art durchführen welche sie als nützlich erachtet zur Durchführung und zur Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes.
Sie kann selbst Zweigniederlassungen errichten.
Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in
fünfhundert (500) Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).
Alle fünfhundert (500) Anteile wurden von Herrn Cornelis Ferdinandus Klaassen, vorbenannt, gezeichnet.
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab
heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-
nen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen
unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-
stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
verwaltet.
Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten
Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen wer-
den.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-
len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Sonstige Bestimmungeni>
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (1.000,- EUR) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-
serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
52582
1) Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Cornelis Ferdinandus Klaassen, vorgenannt, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechts-
kräftig verpflichten kann.
Er kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-1610 Luxemburg, 8-10, avenue de la Gare.
Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit er-
forderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: M. Learbuch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, vol. 148S, fol. 23, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-
ons.
(048096.3/202/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
ProLogis FRANCE LI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.297.
—
Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046832.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
PARTIMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 81.262.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 mai 2005 a renouvellé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07941. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046912.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Senningerberg, le 20 mai 2005.
P. Bettingen.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
52583
FAIRFIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., Société en commandite par actions.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 106.769.
—
In the year two thousand and five, on the third day of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), who will be the
depositary of the present deed.
Was held the extraordinary general meeting (the «Extraordinary General Meeting») of the shareholders of FAIR-
FIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., a securitization company governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg and notably the law of March 22, 2004 on securitization, incorporated under the form of a partnership limited
by shares pursuant to a notarial deed of the undersigned notary on December 20, 2004, publication of which in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number 106.769 and having its registered office at 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, (the
«Company»).
The Extraordinary General Meeting was opened with Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, in
the chair.
The President appoints as secretary Mrs Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The Meeting elects as scrutineer, Mr Geoffroy T’Serstevens, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state:
I. That the agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:
1) Modification of the characteristics of the Ordinary B Shares;
2) Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company;
3) Authorization of fractional shares;
4) Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company;
5) Modification of the nominal value of the shares and increase of the share capital of the Company;
6) Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company;
7) Modification of the authorized capital;
8) Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company;
9) Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed
to the present deed.
III. That the entire share capital being represented at the present Extraordinary General Meeting and all the share-
holders represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Extraordinary
General Meeting, no convening notices were necessary.
IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and
may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the Extraordinary General Meeting, unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to modify the characteristics of the Ordinary B Shares which shall not
be entitled to receive any dividend until their redemption or the liquidation of the Company. Upon the payment of dis-
tributions to the holders of Ordinary A Shares, the net asset value of such class of shares shall be reduced by the amount
of such distributions.
<i>Second resolutioni>
Further to the approval of the preceding resolution, the Extraordinary General Meeting resolves to remove the fifth
paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company and to create the following additional paragraphs
to such article which shall read as follows:
«Art. 6. (new fifth paragraph). The Ordinary B Shares shall not be entitled to receive any dividend. Upon the
payment of distributions to the holders of Ordinary A Shares, the net asset value of such class of shares shall be reduced
by the amount of such distributions.»
The last paragraph of article 7 of the articles of incorporation of the Company is modified as follows:
«Art. 7. (last paragraph). The shares to be issued or sold pursuant to this Article 7 may, as the Manager(s) shall
determine, be either Ordinary A Shares or Ordinary B Shares or both Ordinary A Shares and Ordinary B Shares, as the
case may be.»
The other paragraphs of articles 6 and 7 of the articles of incorporation of the Company remain unchanged.
<i>Third resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to authorize fractional shares.
<i>Fourth resolutioni>
Further to the approval of the previous resolution, the Extraordinary General Meeting resolves to create an addi-
tional paragraph in the article 9 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:
52584
«Art. 9. (last paragraph). The Company may authorize fractional shares. Such fractional shares shall not be enti-
tled to vote but shall be entitled to participate in the net assets distributable to the relevant class of shares on a prorata
basis.»
<i>Fifth resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to reduce the nominal value of the shares issued or to be issued by the
Company from one thousand euros (EUR 1,000.-) to four euros (EUR 4.-) per share. The amount of thirty thousand
eight hundred and seventy-six euros (EUR 30,876.-) corresponding to the reduction of the nominal value of the thirty-
one (31) shares issued is allocated to a non distributable reserve.
Further to the modification of the nominal value of the shares, the Extraordinary General Meeting resolves to modify
the authorised capital of the Company which shall henceforth be fixed at one million euros (EUR 1,000,000.-) divided
into two hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-nine (249,999) Ordinary Shares of different classes and one
(1) Management Share, each with a nominal value of four euros (EUR 4.-).
The Extraordinary General Meeting therefore resolves to amend the first paragraph of article 7 of the articles of in-
corporation of the Company as follows:
«Art. 7. The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at one million euros (EUR 1,000,000.-) di-
vided into two hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-nine (249,999) Ordinary Shares of different classes and
one (1) Management Share with a nominal value of four euros (EUR 4.-) each. During the period of five years, from the
date of the publication of these articles of incorporation, the Manager(s) is (are) hereby authorised to issue shares and
to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to pro-
ceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.»
The other paragraphs of article 7 of the article of incorporation of the Company remain unchanged.
<i>Interventioni>
Thereafter appeared:
Maître Catherine Martougin, prenamed, acting in her capacity as a special proxy holder of the Company by virtue of
a power granted on May 3, 2005 by resolutions of the Manager of the Company FAIRFIELD GREENWICH REALTY
PARTNERS L.L.C.
Which power shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, represented as stated hereabove, has requested the attesting notary to record his decla-
rations and statements which follow:
I. That the share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Company is, as a result of the fifth resolution
of the hereabove extraordinary general meeting is set at one hundred twenty four euros (EUR 124.-) consisting of:
- thirty (30) ordinary A Shares having a par value of four euros (EUR 4.-) each, allocated to the Limited Shareholders
«associés commanditaires»;
- 1 (one) ordinary share having a par value of four euros (EUR 4.-) allocated to the Unlimited Shareholder the «associé
commandité».
II. That on terms of article 7 of the articles of incorporation as amended hereabove, the authorised capital, including
the issued share capital, is fixed at one million euros (EUR 1,000,000.-) divided into two hundred forty-nine thousand
nine hundred ninety-nine (249,999) Ordinary Shares of different classes and one (1) Management Share with a nominal
value of four euros (EUR 4.-) each. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of
incorporation, the Manager(s) is (are) hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares,
to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for
the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.
III. That the Manager, prenamed, in accordance with the authorities conferred on it by the terms of article 7 of in-
corporation, has realised a part of the authorised increase of capital and specifically by the amount of one hundred fifty-
two thousand two hundred ninety-six euros (152,296.- EUR.), so as to raise the subscribed capital from its present
amount of one hundred twenty-four euros (124.-) to one hundred fifty-two thousand four hundred twenty euros (EUR
152,420.-) by the creation and issue of thirty-eight thousand seventy-four (38,074) new Ordinary A Shares with a nom-
inal value of four euros (EUR 4.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares of the same
class.
IV. That still pursuant to the powers conferred to Manager and pursuant to Article 7 of the Articles of Incorporation,
the Manager has accepted the subscription of the thirty-eight thousand seventy-four (38,074) Ordinary A Shares, to-
gether with an issue premium, both having been fully paid up in cash, so that the aggregate amount of thirty-eight million
seventy-four thousand euros (EUR 38,074,000) is at the free disposal of said Company, as was certified to the under-
signed notary by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments.
V. The thirty-eight thousand seventy-four (38,074) new Ordinary A Shares have been subscribed and paid up together
with a share premium as follows:
Subscribers
Ordinary A
Value paid in
Nominal
Share
Shares
Euros
Value
Premium
STRONGBACK HOLDINGS. . . . . . . . . . . . . . . . .
1,956.4165
1,956,416.52
7,825.67
1,948,590.85
FAIRFIELD SENTRY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . .
1,082.3365
1,082,336.49
4,329.35
1,078,007.14
MOORE MACRO FUND L.P. . . . . . . . . . . . . . . . .
11,431.1850
11,431,185
45,724.74 11,385,460.26
CITCO GLOBAL CUSTODY - Ref 126107 . . . . .
270.7198
270,719.75
1,082.88
269,636.87
Mrs Veronica Van De Mortel . . . . . . . . . . . . . . . . .
193.3422
193,342.24
773.36
192,568.88
BORDIER & CIE, Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
300,000
1,200
298,800
52585
<i> Paymenti>
The reality and the value of the contributions consisting of one hundred fifty-two thousand two hundred ninety-six
euros (EUR 152,296.-) with an issue premium of thirty-seven million nine hundred twenty-one thousand seven hundred
and four euros (EUR 37,921,704.-) so as a total amount of thirty-eight million seventy-four thousand euros (EUR
38,074,000.-) have been proved to the undersigned notary by a certificate dated April 29, 2005 delivered by CITCO
BANK NEDERLANDS N.V., Dublin Branch, a certificate dated May 3, 2005 delivered by CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
FUND SERVICES DIVISION and a certificate issued by the Company’s Manager dated May 3rd 2005.
VI. That following the realisation of this portion of the authorised share capital the first paragraph of article six of the
articles of incorporation has therefore been amended and read as follows:
Art. 6. (first paragraph)
«Art. 6. The Company has a subscribed capital of one hundred fifty-two thousand four hundred twenty euros (EUR
152,420.-) divided into thirty-eight thousand one hundred and four (38,104) ordinary A shares (the «Ordinary A
Shares») and one (1) management share (the «Management Share») with a nominal value of four euros (EUR 4.-) each.»
<i>Capital duty - Reference to the law of March 22, 2004 on securitization i>
The Company having been incorporated with a share capital of thirty-one euros (EUR 31,000,-), the capital duty to
be paid is amounting to EUR 1,250.-.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at eight thousand euros (EUR 8,000.-).
Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, these persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, résidant à Niederanven (Grand-Duché du Luxembourg), qui sera le dépo-
sitaire du présent acte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire («Assemblée Générale Extraordinaire») des actionnaires de FAIR-
FIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., une société de titrisation régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg
et notamment la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, créé sous la forme d’une société en commandite par actions
suivant un acte notarié du notaire instrumentant du 20 décembre 2004, dont la publication au Mémorial C, Recueil des
MONTALCINO HOLDINGS LIMITED . . . . . . . .
5,000
5,000,000
20,000
4,980,000
BIPIELLE BANK (SUISSE) NOMINEE . . . . . . . . . .
250
250,000
1,000
249,000
BPU BANCA INTERNATIONAL S.A. . . . . . . . . .
1,000
1,000,000
4,000
996,000
CITCO GLOBAL CUSTODY NV Ref 190040. . .
750
750,000
3,000
747,000
CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD . . .
250
250,000
1,000
249,000
Mrs Christina Della Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
700,000
2,800
697,200
CITCO GLOBAL CUSTODY - Ref 190049 . . . . .
3,280
3,280,000
13,120
3,266,880
CA-ISBL S/A LIA PCP 9393 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
500,000
2,000
498,000
ROYAL BANK Of CANADA (SUISSE) S.A. . . . . .
1,000
1,000,000
4,000
996,000
CA-ISBL S/A LIA PCP 11351 . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
300,000
1,200
298,800
WALBROOK TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
400
400,000
1,600
398,400
CA-ISBL S/A LIA PCP 10159 . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250,000
1,000
249,000
COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
MONACO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250,000
1,000
249,000
CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD. . .
1,850
1,850,000
7,400
1,842,600
KREDITBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE . . . . .
550
550,000
2,200
547,800
ASSET BANCA S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250,000
1,000
249,000
RISTORANTE ARIOTTO DI CABIATA GRAZI-
ELLA SNC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250,000
1,000
249,000
BANK SARASIN & CIE AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,850
1,850,000
7,400
1,842,600
Mrs Joyce Grant Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
100,000
400
99,600
Mr Willem Jean Groossen Aalders Sr . . . . . . . . . .
150
150,000
600
149,400
FIDULEX MANAGEMENT INC.. . . . . . . . . . . . . .
3,150
3,150,000
12,600
3,137,400
CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A. . . . . . . . . . . . .
150
150,000
600
149,400
CITCO GLOBAL CUSTODY NV - Ref 190076 .
500
500,000
2,000
498,000
Mr Willem Jean Gooseen Aalders MBA . . . . . . . .
110
110,000
440
109,560
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38,074
38,074,000
152,296
37,921,704
52586
Sociétés et Associations est en cours, et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés du Luxembourg sous
le numéro 106.769 et ayant son siège social au 28, avenue Monterey, L 2163 Luxembourg (la «Société»),
L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte sous la présidence de Madame Catherine Martougin, avocat, de-
meurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à
Senningerberg.
L’assemblée nomme comme scrutateur M. Geoffroy T’Serstevens, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée Générale Extraordinaire ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire
d’acter que:
I. L’ordre du jour l’Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:
1) Modification des caractéristiques des Actions Ordinaires B;
2) Modification subséquente des statuts de la Société;
3) Autorisation des coupures d’actions;
4) Modification subséquente des statuts de la Société;
5) Modification de la valeur nominale des actions et augmentation du capital social de la Société;
6) Modification subséquente des statuts de la Société;
7) Modification du capital autorisé;
8) Modification subséquente des statuts de la Société;
9) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. L’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente Assemblée Générale Extraordinaire et tous
les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir été informés et avoir connaissance de l’ordre du jour avant
l’Assemblée Générale Extraordinaire, il a donc pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente Assemblée Générale Extraordinaire représentant l’intégralité du capital, est régulièrement constituée
et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée Générale Extraordinaire a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les caractéristiques des Actions Ordinaires B en décidant
qu’elles ne donneront pas droit à la perception de dividendes jusqu’à leur rachat ou la liquidation de la Société.
Lors du paiement de distributions aux détenteurs des Actions Ordinaires A, la valeur nette comptable de cette classe
d’actions sera diminuée du montant de ces distributions.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de supprimer
le cinquième paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société et d’ajouter le paragraphe supplémentaire qui aura la
teneur suivante:
«Art 6. (paragraphe cinquième nouveau). Les Actions Ordinaires B ne donnent pas droit à la perception de
dividendes. Lors du paiement de distributions aux détenteurs des Actions Ordinaires A, la valeur nette comptable de
cette classe d’actions sera diminuée du montant de ces distributions».
Le dernier paragraphe de l’article 7 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Art. 7. (dernier paragraphe). Les actions à émettre ou céder suivant cet article 7, pourront à la discrétion du
ou des gérant(s), être des Actions Ordinaires A ou des Actions Ordinaires B, ou à la fois des Actions Ordinaires A et
des Actions Ordinaires B, s’il y a lieu.»
Les autres paragraphes des articles 6 et 7 des statuts de la Société demeurent inchangés.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’autoriser les coupures d’actions.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’ajouter un
paragraphe supplémentaire à l’article 9 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
«Art. 9. (dernier paragraphe). La Société peut autoriser l’émission de coupures d’actions. Ces coupures d’actions
n’auront pas de droit de vote mais participeront proportionnellement aux actifs nets distribuables relatifs à leur classe
d’actions.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de réduire la valeur nominale des actions émises ou à émettre par la
Société de mille euros (EUR 1.000,-) à quatre euros (EUR 4,-) par action. Le montant de trente mille huit cent soixante-
seize euros (EUR 30.876,-) correspondant à la réduction de la valeur nominale des trente et une (31) actions émises est
affecté à une réserve non distribuable.
52587
Suite à la modification de la valeur nominale des actions, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le
capital autorisé de la Société pour le fixer à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) divisé en deux cent quarante-neuf mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (249.999) Actions Ordinaires de différentes classes et par une (1) Action de Comman-
dité avec une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-) chacune.
Suite à l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le premier
paragraphe de l’article 7 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 7. Le capital autorisé, comprenant le capital social émis, est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) divisé
en deux cent quarante neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (249.999) Actions Ordinaires de différentes classes et
par une (1) Action de Commandité avec une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-) chacune. Pendant une période
de cinq ans à partir de la publication des présents statuts, le(s) Gérant(s) est (sont) autorisé(s) à émettre des actions et
de conférer des options de souscription d’actions aux personnes et dans les conditions jugées adaptées et plus particu-
lièrement de procéder à une telle émission sans réserver pour les actionnaires existants un droit préférentiel de sous-
cription des actions ainsi émises.»
Les autres paragraphes de l’article 7 des statuts de la Société demeurent inchangés.
<i>Interventioni>
Madame Catherine Martougin, précitée, agissant en qualité de mandataire spécial de la Société en vertu d’un pouvoir
qui lui a été conféré en date du 3 mai 2005 par résolutions du Gérant de la Société FAIRFIELD GREENWICH REALTY
PARTNERS L.L.C.
Lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire instrumentant,
demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations
comme suit:
I. Le capital social souscrit (ci-après le «Capital Souscrit») de la Société est fixé, conforment à la cinquième résolution
de l’assemblée générale ci-dessus, à cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) consistant en:
- trente (30) actions ordinaires A ayant une valeur nominale de quatre euros (EUR. 4,-) chacune, détenues par les
«associés commanditaires»,
- 1 (une) action ordinaire ayant une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-), détenue par «le Gérant commandité».
II. Qu’aux termes de l’article 7 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à un million d’euros (EUR
1.000.000,-) divisé en deux cent quarante neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (249.999) Actions Ordinaires
de différentes classes et par une (1) Action de Commandité avec une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-) chacu-
ne. Pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts, le(s) Gérant(s) est (sont) autorisé(s)
à émettre des actions et de conférer des options de souscription d’actions aux personnes et dans les conditions jugées
adaptées et plus particulièrement de procéder à une telle émission sans réserver pour les actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription des actions ainsi émises.»
III. Que le Gérant, suivant pouvoir lui conféré par l’article 7 des statuts, a décidé de réaliser une augmentation jusqu’à
concurrence de cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-seize euros (EUR 152.296,-) pour porter le montant
actuel du capital de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) à cent cinquante-deux mille quatre cent vingt euros (EUR
152.420,-) par la création de trente-huit mille soixante-quatorze (38.074) actions nouvelles de classe A, d’une valeur
nominale de quatre euros (EUR 4,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV. Que toujours conformément aux pouvoirs conférés par les dispositions de l’article 7 des statuts, le Gérant de la
Société a décidé d’accepter la souscription de ces trente-huit mille soixante-quatorze (38.074) actions nouvelles de clas-
se A assorties d’une prime d’émission, libérées intégralement en espèces, soit un montant total de trente-huit millions
soixante-quatorze mille euros (38.074.000) qui est à la disposition de la société, comme attesté au notaire instrumentant
sur production de documents relatifs aux souscriptions et paiements.
V. Que les trente-huit mille soixante-quatorze (38.074) actions nouvelles de classe A assorties sont souscrites et li-
bérées avec une prime d’émission comme suit:
Souscripteurs Actions
Ordinaires Montants
payés
Valeur
Prime
A
en euros
nominale
d’émission
STRONGBACK HOLDINGS . . . . . . . . . . . . . . . .
1.956,4165
1.956.416,52
7.825,67
1.948.590,85
FAIRFIELD SENTRY LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . .
1.082,3365
1.082.336,49
4.329,35
1.078.007,14
MOORE MACRO FUND L.P. . . . . . . . . . . . . . . . .
11.431,850
11.431.185
45.724,74 11.385.460,26
CITCO GLOBAL CUSTODY - Ref 126107 . . . . .
270,7198
270.719,75
1.082,88
269.636,87
Mrs Veronica Van De Mortel . . . . . . . . . . . . . . . .
193.422
193,342.24
773.36
192.568,88
BORDIER & CIE, Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
300.000
1.200
298.800
MONTALCINO HOLDINGS LIMITED . . . . . . . .
5.000
5.000.000
20.000
4.980.000
BIPIELLE BANK (SUISSE) NOMINEE . . . . . . . . . .
250
250.000
1.000
249.000
BPU BANCA INTERNATIONAL S.A. . . . . . . . . .
1.000
1.000.000
4.000
996.000
CITCO GLOBAL CUSTODY NV Ref 190040. . .
750
750.000
3.000
747.000
CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD . . .
250
250.000
1.000
249.000
Mrs Christina Della Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
700.000
2.800
697.200
CITCO GLOBAL CUSTODY - Ref 190049 . . . . .
3.280
3.280.000
13.120
3.266.880
CA-ISBL S/A LIA PCP 9393 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
500.000
2.000
498.000
ROYAL BANK Of CANADA (SUISSE) S.A. . . . . .
1.000
1.000.000
4.000
996.000
52588
<i>Libérationi>
La réalité et la valeur des paiements consistant en cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-seize euros (EUR
152.296,-) et la prime d’émission de trente-sept millions neuf cent vingt et un mille sept cent quatre euros (EUR
37.921.704,-) soit un montant total de trente-huit millions soixante-quatorze mille euros (EUR 38.074.000,-) ont été
prouvées au notaire instrumentant par une attestation datée du 29 avril 2005 délivrée par CITCO BANK NEDERLAN-
DS N.V., Dublin Branch, un certificat daté du 3 mai 2005 délivré par CitCo (LUXEMBOURG) S.A. FUND SERVICES
DIVISION et un certificat émis par le Gérant de la Société daté du 3 mai 2003.
VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation, le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société devra
être lu ainsi qu’il suit:
«Art. 6. La Société a un capital souscrit de cent cinquante-deux mille quatre cent vingt euros (EUR 152.420,-) divisé
en trente-huit mille cent quatre (38.104) actions ordinaires A (les «Actions Ordinaires A»), et une (1) action de com-
mandité (l’«Action de Commandité») avec une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-) chacune.»
Les autres paragraphes de l’article 6 des statuts de la Société demeurent inchangés.
<i>Droit d’apport - Référence à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisationi>
La Société ayant été constituée avec un capital de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), le montant du droit d’en-
registrement s’élève à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison
de son augmentation de capital sont évalués environ à huit mille euros (EUR 8.000,-).
Le présent acte a été dressé à Senningerberg, à la date citée en tête d’acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d’une version française; sur demande des comparants représentés comme il est dit ci avant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure,
ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Martougin, S. Mathot G. T’Serstevens, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, vol. 148S, fol. 23, case 11. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048109.3/202/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
KINNEVIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.958.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01104, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047072.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
CA-ISBL S/A LIA PCP 11351 . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
300.000
1.200
298.800
WALBROOK TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
400
400.000
1.600
398.400
CA-ISBL S/A LIA PCP 10159 . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250.000
1.000
249.000
COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
MONACO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250.000
1.000
249.000
CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD. . . .
1.850
1.850.000
7.400
1.842.600
KREDITBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE . . . . . .
550
550.000
2.200
547.800
ASSET BANCA S.p.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250.000
1.000
249.000
RISTORANTE ARIOTTO DI CABIATA GRA-
ZIELLA SNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250.000
1.000
249.000
BANK SARASIN & CIE AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.850
1.850.000
7.400
1,842.600
Mrs Joyce Grant Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
100.000
400
99.600
Mr Willem Jean Groossen Aalders Sr . . . . . . . . . .
150
150.000
600
149.400
FIDULEX MANAGEMENT INC. . . . . . . . . . . . . . .
3.150
3.150.000
12.600
3.137.400
CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A. . . . . . . . . . . . .
150
150.000
600
149.400
CITCO GLOBAL CUSTODY NV - Ref 190076 . .
500
500.000
2.000
498.000
Mr Willem Jean Gooseen Aalders MBA . . . . . . . .
110
110.000
440
109.560
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.074
38.074.000
152.296
37.921.704
Senningerberg, le 18 mai 2005.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Signature.
52589
ADDISON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 108.506.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-seventh day of May.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
1) O&R CORPORATE FINANCE BERATUNGSGESELLSCHAFT mbH, a company governed by the laws of Germany,
having its registered office at Prinzregentenplatz 10, 81675 Munich, Germany, registered with the commercial register
of Munich under number 129578,
represented by M
e
Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given at Munich, on May 23, 2005; and
2) AROTRUST VERMÖGENSVERWALTUNG, GmbH, a company governed by the laws of Germany, having its reg-
istered office at Prinzregentenplatz 10, 81675 Munich, Germany, registered with the commercial register of Munich un-
der number HRB 142363,
represented by M
e
Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given at Munich, on May 23, 2005.
The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of
a company which they declared organized among themselves:
Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme - Aktiengesellschaft which
will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles (the «Articles of Incorpo-
ration»).
The Company will exist under the name of ADDISON LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-
eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.
Chapter II.- Capital, Shares
Art. 5. Corporate capital. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000)
divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a par value of one euro and twenty-five cent (EUR
1.25) per share. The shares are paid up to twenty-five (25) per cent.
Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the
shareholders.
If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be
kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.
52590
Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company
will be entitled to rely on the last address thus communicated.
Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and
signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.
Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
The Company may issue multiple share certificates.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital of the Company may be increased or reduced in one or
several times by a resolution of the General Meeting voting with the quorum and majority rules set out by these Articles
of Incorporation for any amendment thereof, unless otherwise provided by law.
The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.
Notwithstanding the above, the General Meeting, voting with the quorum and majority rules set out by these Articles
of Incorporation for any amendment thereof, unless otherwise provided by law, may limit or withdraw the preferential
subscription right or authorise the Board of Directors to do so.
Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the
law.
Chapter III.- Board of Directors, Statutory auditors
Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors»)
composed of at least three members who need not be shareholders (the «Directors»).
The Directors will be elected by the General Meeting, which will determine their number, for a period not exceeding
six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority
vote a Director to fill such vacancy until the next General Meeting.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will among others be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the General Meetings.
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two Directors so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and at general Meetings, except that in his absence
the Board of Directors may appoint another Director and the General Meeting may appoint any other person as chair-
man pro tempore by vote of the majority of the Directors or, as the case may be, of the shareholders present or rep-
resented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice
of meetings of the Board of Directors shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as
well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is
required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.
Every meeting of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors
may from time to time determine.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another
Director as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding
office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors
will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman or by any two members of the Board of Directors.
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers (except
for those powers which are expressly reserved by law to the General Meeting) to perform all acts necessary or useful
for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to the General Meeting are in the
competence of the Board of Directors.
52591
Art. 13. Delegation of powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and
the representation of the Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the
General Meeting.
Art. 14. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint sig-
natures of any two Directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.
Art. 15. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more au-
ditors who need not be shareholders (the «Auditors»).
The Auditors will be elected by the General Meeting, which will determine the number of such Auditors, for a period
not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors,
they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the
General Meeting.
Chapter IV.- Meeting of shareholders
Art. 16. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders (the «General Meeting»).
It has the powers conferred upon it by law.
Art. 17. Annual General Meeting. The annual General Meeting will be held at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday of May each
year, at 3.00 p.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 18. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other General Meetings. Such meetings
must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.
General Meetings, including the annual General Meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board of Di-
rectors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the Auditors made in
compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time
and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a General Meeting and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing, by fax or by telegram as his proxy another
person who need not be a shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General
Meeting.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple
majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the General Meeting.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the General Meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will
be signed by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.
Chapter V.- Financial year, Distribution of profits
Art. 20. Financial year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of the same year. The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements
of Luxembourg law and accounting practice.
Art. 21. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide
to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next
following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The
Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting voting
with the quorum and majority rules set out by these Articles of Incorporation for any amendment thereof, unless oth-
erwise provided by law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators
appointed by the General Meeting, which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII.- Applicable Law
Art. 23. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
52592
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have
subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred euro.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2005. The first annual general meeting will thus be held in the year 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time
by unanimous vote:
1. Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for
a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006:
1) Mr Franz Schaefer, attorney at law, born in Munich, Germany, on 25 November 1971 residing at Prinzregentenplatz
10, 81675 Munich, Germany,
2) Mr Stephan Morsch, attorney at law, born in Hildesheim, Germany, on 26 February 1970, residing at Prinzregen-
tenplatz 10, 81675 Munich, Germany, and
3) Mr Timo Engelhardt, attorney at law, born in Heidelberg, Germany, on 18 January 1973, residing at Prinzregenten-
platz 10, 81675 Munich, Germany.
2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006:
Dipl.-Kfm. Wolfgang Essler, born in Munich, Germany, on 20 October 1972, residing at Prinzregentenplatz 10, 81675
Munich, Germany.
3. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-
by authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.
4. The registered office shall be in N
°
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünf, am siebenundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-
burg).
Sind erschienen:
1) O&R CORPORATE FINANCE BERATUNGSGESELLSCHAFT mbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Ge-
sellschaftssitz in Deutschland, in 81675 München, Prinzregentenplatz 10, eingetragen in das Handelsregister München
unter der Nummer HRB 129578,
vertreten durch Herrn Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben in München, am 23. Mai 2005; und
2) AROTRUST VERMÖGENSVERWALTUNG, GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in
Deutschland, in 81675 München, Prinzregentenplatz 10, eingetragen in das Handelsregister München unter der Nummer
HRB 142363,
Shareholders
subscribed
number
Amount
capital
of shares
paid in
1) O&R CORPORATE FINANCE BERATUNGSGESELLSCHAFT mbH,
prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,875 EUR
24,700 7,718.75 EUR
2) AROTRUST VERMÖGENSVERWALTUNG, GmbH, prenamed. . . . . . .
125 EUR
100
31.25 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000 EUR
24,800 7,750.00 EUR
52593
vertreten durch Herrn Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in
München, am 23. Mai 2005.
Die obengenannten Vollmachten, unterzeichnet von den erschienenen Personen und dem amtierenden Notar, bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die erschienenen Parteien, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, haben den nachfolgenden Gesellschaftsver-
trag erstellt:
Kapitel I.- Form, Name, Gesellschaftssitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Gesellschaftsform, Name. Es wird hiermit zwischen den unterzeichnenden Parteien und all denjenigen,
die Eigentümer der hiernach geschaffenen Aktien werden, eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in Form einer société
anonyme - Aktiengesellschaft gegründet, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und dem vorliegenden Ge-
sellschaftsvertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).
Die Gesellschaft trägt den Namen ADDISON LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb dieses Stadtgebie-
tes verlegt werden.
Durch einen Verwaltungsratsbeschluss können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern
Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gegründet werden.
Sollte der Verwaltungsrat der Ansicht sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozia-
ler Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschafts-
sitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann er den Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur völligen Bei-
legung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei
Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des
Sitzes der Gesellschaft, weiterhin den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegen. Diese vorübergehenden
Maßnahmen werden von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung der Ge-
sellschaft beauftragt sind, angeordnet und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten
von Beteiligungen in luxemburgischen und / oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und
Betreuung solcher Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung
gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.
Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere
bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-
scheine ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-
führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Regeln bezüg-
lich Quorum und Mehrheit getroffenen Hauptversammlungsbeschluss aufgelöst werden.
Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) festge-
setzt. Es ist eingeteilt in vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einem
Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie. Die Aktien sind zu fünfundzwanzig (25) Prozent eingezahlt.
Art. 6. Aktien. Die Aktien werden nach Wahl der Aktionäre Namensaktien oder Inhaberaktien sein.
Gibt die Gesellschaft Namensaktien aus, so ist am Gesellschaftssitz ein Aktienregister zu führen, das jeder Aktionär
einsehen darf. In dem Register werden die genaue Namensbezeichnung jedes Aktionärs und die Anzahl gehaltener Ak-
tien, die auf die Aktien eingezahlten Beträge sowie die Aktienübertragungen zusammen mit deren Datum vermerkt.
Jeder Aktionär teilt der Gesellschaft per Einschreiben seine Anschrift und jedwede diesbezügliche Änderung mit. Die
Gesellschaft ist berechtigt, sich auf die zuletzt mitgeteilte Anschrift zu berufen.
Das Eigentum der Namensaktien ergibt sich aus den Eintragungen in das Aktienregister.
Die Übertragung von Aktien erfolgt durch eine in das Aktienregister eingetragene Übertragungserklärung, die vom
Veräußerer und vom Erwerber oder von deren Vertreter(n) unterzeichnet wird. Aktienübertragungen können ebenfalls
gemäß den in Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches vorgesehenen Bestimmungen betreffend die Über-
tragung von Forderungen erfolgen. Außerdem ist die Gesellschaft befugt, jede Übertragung in das Aktienregister einzu-
tragen, auf die sich ein Briefwechsel oder ein anderes Schriftstück bezieht, aus dem das Einverständnis des Veräußerers
und des Erwerbers hervorgeht.
Den Aktionären werden die Eintragung in das Aktienbuch dokumentierende Zertifikate ausgestellt.
Die Gesellschaft kann multiple Aktienzertifikate ausstellen.
Art. 7. Kapitalerhöhung und -verringerung. Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrfach durch einen
Hauptversammlungsbeschluss erhöht beziehungsweise verringert werden, der gemäß den Bestimmungen betreffend
Quorum und Mehrheit getroffen wird, die vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen in vorliegendem Ge-
sellschaftsvertrag für jede Abänderung desselben vorgesehen sind.
52594
Die neuen mittels Geldeinlage zu zeichnenden Aktien werden den bestehenden Aktionären im Verhältnis zu dem von
diesen Aktionären gehaltenen Anteil am Kapital bevorzugt angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum,
während dessen das Vorkaufsrecht auszuüben ist. Dieser Zeitraum darf dreißig Tage nicht unterschreiten.
Unbeschadet des Vorrangehenden ist die Hauptversammlung dazu befugt, das Vorkaufsrecht gemäß den Bestimmun-
gen betreffend Quorum und Mehrheit, die vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen in vorliegendem Ge-
sellschaftsvertrag für jede Abänderung desselben vorgesehen sind, zu begrenzen oder zu entziehen beziehungsweise den
Verwaltungsrat diesbezüglich zu ermächtigen.
Art. 8. Erwerb eigener Aktien. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien erwerben.
Der Erwerb und das Halten ihrer eigenen Aktien erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Bedin-
gungen und innerhalb des gesetzlichen Rahmens.
Kapitel III.- Verwaltungsrat, Kommissare
Art. 9. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat (der «Verwaltungsrat»),
der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt, die nicht notwendigerweise Aktionäre sind (die «Verwaltungs-
rats-mitglieder»).
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung, welche deren Anzahl festlegt, für eine Dauer von
höchstens sechs Jahren gewählt und bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind wiederwählbar, können je-
doch jederzeit durch einen Hauptversammlungsbeschluss mit oder ohne Grund abberufen werden.
Wird im Verwaltungsrat ein Sitz frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten und
durch einen Mehrheitsbeschluss ein Verwaltungsratsmitglied wählen, um den freigewordenen Sitz bis zur nächsten
Hauptversammlung zu besetzen.
Art. 10. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der
«Vorsitzende»). Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied zu sein
braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen ver-
antwortlich ist.
Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Verwaltungsratssitzung ist einzuberufen,
wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies fordern.
Der Vorsitzende führt bei allen Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen den Vorsitz, mit der Ausnahme,
dass der Verwaltungsrat beziehungsweise die Hauptversammlung befugt sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher
Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder beziehungsweise der bei besagter Versammlung anwesenden oder vertretenen
Aktionäre ein anderes Verwaltungsratsmitglied beziehungsweise eine andere Person zum zeitweiligen Vorsitzenden zu
ernennen.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schrift-
licher Einberufungsbescheid zu den Verwaltungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehenen
Datum entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über den Sitzungsort, die Tagesordnung
und die Art der zu verrichtenden Geschäfte.
Liegt die schriftliche Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in
einem früheren Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Verwaltungsrat von Zeit
zu Zeit festlegen kann.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in Verwaltungsratssitzungen vertreten lassen, indem es hierzu ein anderes
Verwaltungsratsmitglied per Brief, Telefax oder Telegramm zu seinem Bevollmächtigen ernennt.
Der Verwaltungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner amtierenden Mitglieder anwesend
oder vertreten sind.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneter Beschluss gültig und
rechtsverbindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasst worden wäre.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden,
wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben wird.
Art. 11. Sitzungsprotokolle. Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden un-
terzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-
legt werden, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist mit den weitreichendsten Befugnissen (mit
Ausnahme derer, die aufgrund des Gesetzes ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind) ausgestattet, um
jedwede Handlung vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder von Nutzen sind. Sämtliche
Befugnisse, die nicht aufgrund des Gesetzes ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zustän-
digkeit des Verwaltungsrats.
Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft
und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen einer solchen täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Ver-
waltungsratsmitgliedern, Direktoren, Bevollmächtigten, Angestellten oder sonstigen Personen übertragen, die Aktionä-
re sein können doch nicht sein müssen, oder Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen beziehungsweise dauerhafte
oder zeitweilige Handlungsbefugnisse auf Personen oder Beauftragte seiner Wahl übertragen.
52595
Für die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf ein Verwaltungsratsmitglied ist die vorherige Zustimmung
der Hauptversammlung erforderlich.
Art. 14. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet
durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der
Person, der die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wurde, jedoch nur innerhalb dieser täglichen Ge-
schäftsführung. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen
rechtsverbindlich verpflichtet, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Verwaltungsrat übertragen wurden, wobei
dies jedoch lediglich innerhalb dieser Befugnisse gilt.
Art. 15. Kommissare. Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte wird einem oder mehreren Kommissaren an-
vertraut, welche keine Aktionäre sein müssen (die «Kommissare»).
Die Kommissare werden von der Hauptversammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats
als Kommissar sind sie wiederwählbar, können jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Hauptversammlungs-
beschluss abberufen werden.
Kapitel IV.- Hauptversammlung
Art. 16. Befugnisse der Hauptversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Hauptversammlung der
Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Aktionäre (die «Hauptversammlung»).
Sie hat die Befugnisse, die gesetzlich festgelegt sind.
Art. 17. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung tritt jedes Jahr am ersten Mittwoch des Monats
Mai um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort
zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahreshauptversammlung am darauffolgenden Werktag abgehalten.
Art. 18. Andere Hauptversammlungen. Der Verwaltungsrat kann andere Hauptversammlungen einberufen.
Diese müssen einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, dies
verlangen.
Hauptversammlungen, die Jahreshauptversammlung inbegriffen, können jedes Mal dann im Ausland abgehalten wer-
den, wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Veraltungsrats liegen, dies erfor-
derlich machen.
Art. 19. Verfahren, Wahl. Hauptversammlungen treten nach in Übereinstimmung mit luxemburgischen Recht er-
folgter Einberufung durch den Verwaltungsrat oder die Kommissare zusammen. Der den Aktionären in Übereinstim-
mung mit dem Gesetz übermittelte Einberufungsbescheid enthält Angaben zu Zeitpunkt und Ort der Versammlung
sowie zur Tagesordnung und Art der zu tätigen Geschäfte.
Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die der Versamm-
lung zugrunde liegenden Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, kann die Versammlung auch ohne vorherige
Einberufung abgehalten werden.
Ein Aktionär kann an den Hauptversammlungen teilnehmen, idem er per Brief, Telefax oder Telegramm, eine andere
Person, die nicht notwendigerweise Aktionär ist, zu seinem Bevollmächtigten ernennt.
Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, die zwecks Teilnahme an einer Hauptversammlung zu
erfüllen sind.
Vorbehaltlich gegenteiliger Anforderungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrags werden Be-
schlüsse ungeachtet der Anzahl bei der Hauptversammlung anwesender oder vertretener Aktien durch einfache Mehr-
heit gefasst.
Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.
Kopien von oder Auszüge aus Hauptversammlungsprotokollen, die im Rahmen von Gerichtsverfahren oder ander-
weitig vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unter-
zeichnet.
Kapitel V.- Geschäftsjahr, Gewinnverwendung
Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißig-
sten Tag des Monats Dezember desselben Jahres. Der Verwaltungsrat bereitet gemäß den Bestimmungen des luxem-
burgischen Gesetzes und den Buchhaltungsregeln den Jahresabschluss vor.
Art. 21. Gewinnverwendung. Vom jährlichen Reingewinn werden fünf Prozent (5%) den gesetzlichen Rücklagen
zu gewiesen. Die Verpflichtung zu dieser Zuweisung entfällt, sobald und solange die gesetzliche Reserve zehn Prozent
(10 %) des Gesellschaftskapitals darstellt.
Die Hauptversammlung entscheidet über die Verwendung des Saldos des jährlichen Reingewinns. Sie kann entschei-
den, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen, ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder
ihn in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.
Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen eine Abschlagsdividende auszahlen.
Der Verwaltungsrat bestimmt den Betrag und das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.
Kapitel VI.- Auflösung, Liquidation
Art. 22. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft
durch einen Hauptversammlungsbeschluss aufgelöst werden, der gemäß den Regeln bezüglich des Quorums und der
Mehrheit getroffen wird, die in vorliegendem Gesellschaftsvertrag für Abänderungen desselben vorgesehen sind. Bei
52596
Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen, die von der
Hauptversammlung ernannt werden, welche deren Befugnisse und Bezüge festlegt.
Kapitel VII.- Anwendbares Recht
Art. 23. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die vorliegendem Gesellschaftsvertrag nicht unterlie-
gen, werden in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten, wie abgeändert, geregelt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnende Notar bestätigt, dass die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, eingehalten worden sind.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem der Gesellschaftsvertrag somit durch die erschienenen Parteien aufgestellt worden ist, haben diese Parteien
folgende Anzahl Aktien gezeichnet und folgende Beträge in bar eingezahlt:
Der Nachweis all dieser Zahlungen wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, der erklärt, dass die in Artikel 26
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt worden sind.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2005. Die erste
Jahreshauptversammlung findet folglich im Jahre 2005 statt.
<i>Außerordentliche Hauptversammlungi>
Die obengenannten Parteien, welche die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertreten und sich als formgerecht ge-
laden betrachten, sind unmittelbar dazu übergegangen, eine außerordentliche Hauptversammlung abzuhalten.
Nachdem sie zunächst überprüft haben, dass die Versammlung ordnungsgemäß zusammengetreten ist, haben sie je-
weils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Es wird beschlossen, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei (3) festzusetzen und es wird außerdem be-
schlossen, die folgenden Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrats für einen Zeitraum zu ernennen, der auf der im
Jahre 2006 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:
1) Herr Franz Schaefer, Rechtsanwalt, geboren in München, Deutschland, am 25. November 1971, wohnhaft am
Prinzregentenplatz 10, 81675 München, Deutschland,
2) Herr Stephan Morsch, Rechtsanwalt, geboren in Hildesheim, Deutschland, am 26. Februar 1970, wohnhaft am
Prinzregentenplatz 10, 81675 München, Deutschland, und
3) Herr Timo Engelhardt, Rechtsanwalt, geboren in Heidelberg, Deutschland, am 18. Januar 1973, wohnhaft am Prinz-
regentenplatz 10, 81675 München, Deutschland.
2. Es wird beschlossen, die Zahl der Kommissare auf eins (1) festzusetzen und es wird außerdem beschlossen, die
folgende Person zum Kommissar für einen Zeitraum zu ernennen, der auf der im Jahre 2006 abzuhaltenden Jahreshaupt-
versammlung endet:
Dipl.-Kfm. Wolfgang Essler, geboren in München, Deutschland, am 20. Oktober 1972, wohnhaft am Prinzregenten-
platz 10, 81675 München, Deutschland.
3. Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und des Gesellschaftsrechts ermächtigt die Hauptversamm-
lung hiermit den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretungsbefugnis der Gesell-
schaft innerhalb dieser täglichen Geschäftsführung auf eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.
4. Der Sitz der Gesellschaft wird sich in N
°
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, (Großherzogtum Luxem-
burg) befinden.
Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Verlangen der vorgenann-
ten erschienenen Personen vorliegende Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen derselben Personen und im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung
hat die englische Fassung Vorrang.
Und nach Vorlesung des Dokumentes an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannten Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: J.-P. Spang, M. Müller, J.-J. Wagner.
Gesellschafter
Gezeichnetes
Anzahl der
Einzahlung
Kapital
Aktien
1) O&R CORPORATE FINANCE BERATUNGSGESELLSCHAFT
mbH, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.875,- EUR
24.700
7.718,75 EUR
2) AROTRUST VERMÖGENSVERWALTUNG, GmbH, vorgenannt
125,- EUR
100
31,25 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,- EUR
24.800
7.750,00 EUR
52597
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 6. Juni 2005, Band 893, Blatt 88, Feld 7. – Erhalten 310 Euros.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-
einigungen.
(049448.3/239/502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
SONORA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 108.662.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fourteenth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) SOLANO HOLDING S.A., a company having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,
here represented by Mrs Viktoriya Gavrysyuk, private employee, with professional address at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 14, 2005.
2) ECOREAL S.A., R.C. Luxembourg B N
o
38.875, a company with registered office at 14, rue Aldringen, L-1118 Lux-
embourg,
here represented by Mrs Viktoriya Gavrysyuk, prenamed,
by virtue of a proxy given on June 14, 2005.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties («the Appearers»), through their proxy holder, have decided to form amongst themselves a
limited company (Société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a limited company (Société anonyme) under the name of SONORA INVESTMENT
S.A.
The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the Board of Directors and to
any other municipality within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by
the law for the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
The Company may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in re-
spect of real estate or movable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-
folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies
in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by three hundred and
ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares in compliance with the legal requirements set forth in the law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be of Class «A» and/or of Class «B».
Beles, den 8. Juni 2005.
J.-J Wagner.
52598
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years pursuant to a resolution passed by unanimous
vote at a general meeting of the shareholders at which the entire issued capital is represented. They shall be re-eligible
but may be removed at any time under the same conditions.
In the event of a vacancy on the Board of Directors the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting of shareholders.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of
the Company.
The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered
bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions
as well as any other conditions in relation thereto.
A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of
Incorporation are within the competence of the Board of Directors.
Art. 7. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside
over the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.
In case of urgency Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization by unanimous vote at a
general meeting of the shareholders at which the entire issued share capital is represented.
Towards third parties the Company is bound in all circumstances by the joint signatures of any Class «A» Director
with any Class «B» Director, or by the sole signature of the managing director within the limits of his powers.
Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December of the same year.
Art. 10. The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such
other place as indicated in the convening notices on the third Thursday in the month of May at two p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 11. Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the legal provi-
sions, each Director being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the shareholders must be
called at the request of any shareholder(s) holding at least ten percent of the issued capital.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-
ted to their consideration, the general meeting of the shareholders may take place without convening notices.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 12. The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as
may concern the Company.
The appropriation and distribution of the net profits fall within its exclusive competence.
Art. 13. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, the Board of Directors can be authorised to distribute interim dividends.
Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 2005.
2) The first annual general meeting shall be held in 2006.
<i>Subscription and paymenti>
The appearing parties have subscribed the shares as follows:
All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the amount of thirty-one thousand (31,000)
Euro is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness.
1) SOLANO HOLDING S.A., prenamed, three hundred and nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) ECOREAL S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
52599
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand two hundred and eighty
(2,280.-) Euro.
<i>Constitutive meetingi>
Here and now, the appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as
duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following are appointed Directors:
Class «A» Directors:
a) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N
o
64.474, a company with registered office
at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Class «B» Directors:
b) MONTEREY SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B N
o
51.100, a company with registered office at 14, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg;
c) EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B N
o
34.766, a company with registered office at 59,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) The following is appointed Auditor:
COMCOLUX S.A., R.C. Luxembourg B 58.545, a company with registered office at 123, avenue du X septembre, L-
2551 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.
5) The Company shall have its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first herein before mentioned
in Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SOLANO HOLDING S.A., une société avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg,
ici représentée par Madame Viktoriya Gavrysyuk, employée privée, avec adresse professionnelle au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 14 juin 2005.
2) ECOREAL S.A., R.C. Luxembourg B N
o
38.875, une société avec siège social au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg,
ici représentée par Madame Viktoriya Gavrysyuk, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée le 14 juin 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SONORA INVESTMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville par une décision du Conseil d’Adminis-
tration et dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée Générale des
actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
52600
Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition de
participations dans toutes entreprises, sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes
transactions en relation avec des immeubles ou biens meubles, que la société estimera utiles pour le développement de
son entreprise.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-
sant de tous titres et brevets de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et bre-
vets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs d’une, de deux ou plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article édictées par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de catégorie «A» et/ou de catégorie «B»
Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans par une décision unanime d’une
assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représentée. Ils sont rééligibles, mais tou-
jours révocables sous les mêmes conditions.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, une telle décision doit être ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa prochaine réunion.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non-con-
vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque
monnaie que ce soit.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de la compétence du Con-
seil d’Administration.
Art. 7. Le Conseil d’Administration peut désigner son président. En cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépon-
dérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable donnée par déci-
sion unanime d’une assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représenté.
Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur
de catégorie «A» avec un administrateur de catégorie «B», soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
dans la limite de ses pouvoirs.
Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, réeligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même
année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à quatorze heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque
administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra
être convoquée à la requête d’un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance
de l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.
52601
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
L’affectation et la distribution du bénéfice net est de sa compétence exclusive.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de
trente et un mille (31.000,-) euros est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire
qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille deux cent
quatre-vingt (2.280,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Administrateurs de catégorie «A»:
a) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N
o
64.474, une société avec siège social au
27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Administrateurs de catégorie «B»:
b) MONTEREY SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B N
o
51.100, une société avec siège social au 14, rue Aldringen, L-
1118 Luxembourg;
c) EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B N
o
34.766, une société avec siège social au 59, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
COMCOLUX S.A., R.C. Luxembourg B 58.545, une société avec siège social au 123, avenue du X septembre, L-2551
Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin immédiatement après l’assemblée générale an-
nuelle de 2010.
5) Le siège de la Société est fixé au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: V. Gavrysyuk, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, vol. 148S, fol. 85, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053162.3/230/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.
1) SOLANO HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) ECOREAL S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Luxembourg, le 17 juin 2005.
A. Schwachtgen.
52602
SCIPIO CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3377 Leudelange, 68, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 108.421.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
* Monsieur Patrice Duffort, directeur commercial, né le 3 décembre 1969 à F-54000 Nancy (France), et son épouse,
* Madame Jocelyn Duffort née Normand, femme au foyer, née le 22 septembre 1973 à Quantico, Virginia, (USA),
demeurant ensemble à L-3377 Leudelange, 68, rue de la Gare.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SCIPIO CON-
SULTING, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Leudelange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l’étranger.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objets:
* la réalisation de prestations de services, dans le domaine de l’informatique de haut niveau,
* les activités de représentation, commercialisation, promotion, communication, création et développement de ré-
seaux de distributions, consulting,
* la formation dans l’informatique de haut niveau avec une spécialité dans le calcul de haute performance et les ré-
seaux d’interconnect de haut débit.
Et ce notamment auprès des entreprises, institutions gouvernementales et académiques.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-), divisé en quatre cent quatre-vingt-seize
(496) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés repré-
sentant les trois quart (3/4) du capital social.
En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en ces-
sion.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des asso-
ciés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par décision de l’assemblée des associés.
Art. 8. Simple(s) mandataire(s) de la société, le ou les gérant(s) ne contracte(nt) en raison de ses/leurs fonctions
aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société; il(s)
ne sera/seront responsable(s) que de l’exécution de son/leur mandat.
Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 10. Chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix, proportionnellement
au nombre de parts qu’il possède; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur
de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives, ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
1. Monsieur Patrice Duffort, préqualifié, quatre cent quatre vingt quinze parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495
2. Madame Jocelyn Duffort née Normand, préqualifiée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: quatre cent quatre-vingt-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496
52603
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les
comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le bénéfice net constaté sera réparti de la façon suivante:
* cinq pourcent (5%) pour la constitution de la réserve légale jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital
social,
* le solde restant est à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 14. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
Art. 15. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu’il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 950,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et ensuite les associés présents, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale, à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après délibération, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est à L-3377 Leudelange, 68, rue de la Gare.
2. Le nombre de gérants est fixé à un (1).
Est nommé pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrice Duffort, préqualifié,
Le gérant a tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Duffort, J. Duffort, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, vol. 148S, fol. 64, case 5. – Reçu 62 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(047908.3/241/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
ProLogis FRANCE L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.310.
—
Le siège social de l’associé et/ou de l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04841. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046834.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Hesperange, le jeudi 9 juin 2005.
M. Decker.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i> P. Cassells
<i>Géranti>
52604
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 700.000,-.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 79.254.
—
L’Associé de TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l. (la Société) a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Dmitri Mojaev comme gérant de la Société;
- de nommer comme nouveau gérant de la Société Monsieur Gerald Ungar avec adresse 4, Chemin du Champ-carré
à CH-1256 Troinex (Suisse).
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01575. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046836.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
SOGECALUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
Siège administratif: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 35.200.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Münsbach, le 26 avril 2005i>
«L’Assemblée décide de nommer la société AUDIEX en tant que Commissaire aux Comptes de la société jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Fabrice Frere de son poste d’Administrateur avec effet à ce jour. L’As-
semblée remercie Monsieur Fabrice Frere pour l’intérêt qu’il a porté à la Société.
L’Assemblée nomme Monsieur Marc Lauer en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Fabrice Frere.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2006.»
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06132. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046895.3/730/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
AGRINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 247.893,52.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.715.
—
<i>Extrait des principales résolutions adoptées en date du 21 avril 2005 i>
<i>lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
A l’unanimité, l’assemblée a pris les décisions suivantes:
Les mêmes administrateurs sont renommés jusqu’à l’assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels clos
au 31 décembre 2005. Ces administrateurs sont:
Le même commissaire aux comptes est renommé jusqu’à l’assemblée des actionnaires statuant sur les comptes an-
nuels clos au 31 décembre 2005. Le commissaire aux comptes est:
- LA FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. ayant son siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047935.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Luxembourg, le 1
er
juin 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>M. Haag
<i>Directeur Déléguéi>
Catégorie B:
Monsieur Guy Paquot;
Monsieur Vincent Doumier;
Catégorie A:
Monsieur Michel Ducros;
Monsieur Dominique Aimé.
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour AGRINVEST EUROPE S.A.
i>FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA
P. Sganzerla
<i>Expert-Comptablei>
52605
ADEIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 84.431.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 mars 2005 a renouvellé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
Le commissaire aux compte est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07933. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046906.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
F & I SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4975 Dippach-Gare, 43, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.446.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07748, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
(047032.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
OASMIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.444.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 6 juin 2005 que:
Sont réélus administrateurs jusqu’aux prochaines élections statutaires qui auront lieu à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Annuelle de 2010:
- Julian Aleksov;
- Bo Cederstrand;
- Oleg Stralchonak.
Est réélu commissaire aux comptes jusqu’aux prochaines élections statutaires qui auront lieu à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle de 2010:
- Henri Vanherberghen.
Est réélu administrateur délégué jusqu’aux prochaines élections statutaires qui auront lieu à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle de 2010:
- Julian Aleksov.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02176. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047841.3/634/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
SOFINTER S.A.
Signature
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliataire
i>Signature
52606
ISLAND CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 246.004.350,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.403.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Associé unique en date du 13 décembre 2004 que:
- La démission de M. Raymond W. Vickers en tant que gérant est acceptée avec effet au 13 décembre 2004.
- M. Vincent Richard Harris, domicilié Ashlea Whiteway View Stratton Cirencester Gloucestershire GL7 2HY United
Kingdom a été nommé nouveau gérant avec effet au 13 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047941.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
A.A. ABACUS AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1145 Luxemburg, 180, rue des Aubépines.
H. R. Luxemburg B 63.456.
—
Laut Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2005 sind die Mandate der Verwaltungs-
ratsmitglieder HH. Guy Baumann, Jean Bodoni und Guy Kettmann sowie des Aufsichtskommissars LUDWIG CON-
SULT, S.à r.l. für die Dauer von sechs Jahren bis zu jährlichen Generalversammlung von Jahre 2010 verlängert worden.
Luxemburg, den 6. Juni 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01821. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047973.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
DOMUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.200,00.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.060.
—
<i>Extrait des résolutions des associés prises le 8 avril 2005 i>
Lors des résolutions prises par les associés de DOMUS HOLDINGS, S.à r.l., il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Christopher Voutsinas, de sa fonction de gérant et ce avec effet immédiat;
- de nommer Mme Nicoletta De Bona Bottegal, en qualité de gérant A de la société avec effet immédiat, et ce, pour
une durée indéterminée;
- d’accorder à Herman Boersen, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, pouvoir de re-
présenter la société afin de procéder aux publications relatives à cette résignation et nomination.
Luxembourg, le 8 mai 2005.
Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06082. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047862.3/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
B. Zech.
<i>Für A.A. ABACUS AG, Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
H. Boersen
<i>Géranti>
Alain Heinz
Gérant A
Joseph Mayor
Gérant A
Nicoletta De Bona Bottegal
Gérant A
Stephen Shaw
Gérant A
Michel van Krimpen
Gérant B
Herman Boersen
Gérant B
Dominique Bernier
Gérant B
Daniel Quai
Gérant B
52607
IMMOBINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.718.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 7 juin 2005 que:
* Monsieur Ménahem Eytan a démissionné de ses fonctions d’administrateur respectivement d’administrateur-délé-
gué avec effet immédiat;
* A été coopté au poste d’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire dont il terminera le
mandat:
- Monsieur Pierre Grotz, conseiller, demeurant à L-8392 Nospelt, 2, rue Goeblange.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02256. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047866.3/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
EKELMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6850 Manternach, 3, rue Koulerwee.
R. C. Luxembourg B 80.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07753, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
(047038.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
COIFFURE COCCINELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4451 Belvaux, 264B, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.064.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
(047039.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.
MATRIX LA GAUDE PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 90.910.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique qui ont été prises le 26 mai 2005i>
L’Associé Unique de MATRIX LA GAUDE PROPERTY, S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Madame Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Robert Kimmels ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en
qualité de Gérant de la société et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 26 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07861. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047865.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
H. Boersen
<i>Géranti>
52608
INDUSTRIAL FINE WAGON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 108.204.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2005, M. Walter Jay Ehrlich, 29, Harley Street, GB-
London W1G 9RQ, a été nommé Administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010. De ce fait le
nombre des Administrateurs a été augmenté de trois à quatre.
Luxembourg, le 6 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01819. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047974.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
BELVEDERE INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.200.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2003, la décision des administrateurs du 30 septembre 2002
de coopter M. Guy Kettmann au conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur définitive-
ment élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Luxembourg, le 6 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01805. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047980.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
MATRIX LA GAUDE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 90.911.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique qui ont été prises le 26 mai 2005i>
L’Associé Unique de MATRIX LA GAUDE INVESTMENT, S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Madame Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Robert Kimmels ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg, en
qualité de Gérant de la société et ce avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047864.3/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.
<i>Pour INDUSTRIAL FINE WAGON S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour BELVEDERE INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Luxembourg, le 26 mai 2005.
H. Boersen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Semalux S.A.
Chamly International S.A.
Tinska Real Estate S.A.
Tinska Real Estate S.A.
IRADO Funding, S.à r.l.
Asher S.A.
Constant Shipping S.A.
Constant Shipping S.A.
PBG Investment (Luxembourg), S.à r.l.
PBG Investment (Luxembourg), S.à r.l.
Foxy S.A.
Foxy S.A.
Bordag International S.A.
Bordag International S.A.
Gori & Zucchi International S.A.
General Electric International Japan Investments I, S.à r.l.
ProLogis France XII, S.à r.l.
Eurel International S.A.
Eurel International S.A.
ProLogis France LIV, S.à r.l.
Yellow Invest S.A.
Alfred Berg Norden
ProLogis France LIII, S.à r.l.
Courances S.A.
ProLogis France LII, S.à r.l.
Harvest Wealth Management, GmbH
ProLogis France LI, S.à r.l.
Partimmobiliare S.A.
Fairfield Aerium International S.C.A.
Kinnevik S.A.
Addison Luxembourg S.A.
Sonora Investment S.A.
Scipio Consulting, S.à r.l.
ProLogis France L, S.à r.l.
TOC Investments Holding, S.à r.l.
Sogecalux
Agrinvest Europe S.A.
Adeia S.A.
F & I Software S.A.
Oasmia S.A.
Island Capital, S.à r.l.
A.A. Abacus AG
Domus Holdings, S.à r.l.
Immobinvest S.A.
Ekelmann, S.à r.l.
Coiffure Coccinella, S.à r.l.
Matrix La Gaude Property, S.à r.l.
Industrial Fine Wagon S.A.
Belvedere Investment Holdings S.A.
Matrix La Gaude Investment, S.à r.l.