This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
43441
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 906
16 septembre 2005
S O M M A I R E
ACM International Health Care Fund, Sicav, Luxem-
Infor Global Solutions TopCo II S.C.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43447
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43450
Adpartners International S.A., Luxembourg. . . . . .
43487
Interfund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43479
Alliance Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.
43443
Italfortune International Advisors S.A., Luxem-
Answer Systems Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
43485
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43487
Atelier de Restauration Taillefert S.A., Esch-sur-
Jarcam Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43443
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43479
Kamea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43445
Atlantis Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
43445
Lubia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43481
BBVA Durbana International Fund, Sicav, Luxem-
Malerbetrieb Esch, GmbH, Remich . . . . . . . . . . . .
43447
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43447
New Land S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43448
Bidrolu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43444
New Land S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43448
Chatka International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43479
North European Financial Reinsurance S.A., Luxem-
Chelsfield (Global Switch), S.à r.l., Luxembourg . .
43447
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43444
Classic Line S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43442
Orbi Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43486
Columbus Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43448
Partsana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43484
Compagnie Aéronautique du Grand-Duché de
Peiperleck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43485
Luxembourg S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . .
43446
Peiperleck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43485
CVC Capital Partners Group, S.à r.l., Luxem-
Peiperleck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43485
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43481
Per Investments Holding S.A., Luxembourg . . . . .
43480
Eurotecnica Melamine S.A., Luxembourg . . . . . . . .
43448
Primafin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
43482
Flots Yachting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
43478
Propper, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43450
Gecis International Holdings, S.à r.l., Luxem-
Recem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43484
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43483
Regain S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43483
GM Inter-Est, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
43442
Regain S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43483
Go-Soft, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43478
Regain S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43483
Granite Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
43482
Robinia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43444
Helio Charleroi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . .
43486
Saipem (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
43446
Horizont Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
43449
Securicor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
43442
Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Luxem-
SI.TO.Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
43487
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43446
SISL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43484
I.E.D.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43444
Sorrilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43443
I.O.C. International Overseas Company S.A., Lu-
Tridamd, S.à r.l., Mondercange. . . . . . . . . . . . . . . .
43480
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43449
Valco Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43486
IMR International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43445
Venture Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43482
Immobilière Centuria Luxembourg 1 S.A., Luxem-
VVR S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43487
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43484
VVR S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43488
Immobilière Centuria Luxembourg 1 S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43478
43442
SECURICOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 8, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 10.427.
—
Le bilan consolidé au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04186, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037026.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
GM INTER-EST, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1725 Luxemburg, 28, rue Henri VII.
H. R. Luxemburg B 59.650.
—
Laut Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 7. März 2005 der GM INTER-EST, S.à r.l. ist die
Amtsabtretung von Herrn Gerhard Mahler als Geschäftsführer festgehalten und mit sofortiger Wirkung als neuer
Geschäftsführer berufen:
Herr Martin Reuber, Geschäftsführer, geboren am 21. Oktober 1971 in D-Stuttgart, wohnhaft in D-74585 Rot am
See, Elsässer Ring 8.
Luxemburg, den 7. März 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05641. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036354.3/664/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
CLASSIC LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.751.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue à Mamer le 25 février 2005i>
<i>Bureau:i>
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au siège social de la société ce jour à 19.00 heures.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Radoux Jean-Philippe.
Le président nomme Madame Ziane Katia secrétaire de l’Assemblée.
Monsieur Leonard Francis assure les fonctions de scrutateur.
<i>Présences:i>
Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’Assemblée sont mentionnés sur la liste des présences
ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents.
Ladite liste de présence, signée par les membres du bureau indique les actions présentes ou représentées.
<i>Ordre du jour:i>
Le Président donne lecture de l’ordre du jour, fixé comme suit:
1. Délégation de la cosignature obligatoire.
<i>Discussions - résolutions:i>
Après délibérations, l’Assemblée à l’unanimité,
<i>Décidei>
de déléguer la cosignature obligatoire à l’administrateur délégué Monsieur Radoux Jean-Philippe domicilié 14/1, rue
la Coulée à B-6661 Les Tailles.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19.20 heures.
Le secrétaire lit le procès-verbal de la séance lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou
mandataires qui en expriment le désir.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02984. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(036406.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
G. Mahler
<i>Geschäftsführeri>
J.-P. Radoux / K. Ziane / L. Francis
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
43443
ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.405.
—
EXTRAIT
Suivant l’assemblée générale des actionnaires de ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A. en date du 29 avril
2005:
- Le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
- M. Yves Prussen, docteur en droit, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- M. James Posch, Senior Vice President et Assistant General Counsel International, ALLIANCE CAPITAL
MANAGEMENT CORPORATION, 1345, Avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America;
- M. Kurt Schoknecht, Executive Vice President, ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION, 1345,
avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America;
- KPMG AUDIT a été réélue comme réviseur d’entreprises de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00391. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036364.3/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
JARCAM SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 72.678.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 22 mars 2005i>
1. Nomination aux postes d’administrateurs:
- Monsieur Arsène Kronshagen, avocat, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde,
- Madame Cindy Spieldenner, secrétaire, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-
Adélaïde,
- Madame Tina Cardoso, secrétaire, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’année 2010.
5. Nomination au poste de commissaire aux comptes de la société INTERAUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la faïencerie, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous
le numéro B 29.501.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle de 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00818. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036366.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
SORRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 33.135.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 avril 2005i>
L’Assemblée Générale du 28 avril 2005 nomme aux postes d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale qui sta-
tuera sur les comptes au 31 décembre 2005:
- Monsieur Robin White en remplacement de Monsieur Mark Falloon,
- Monsieur Michel Mund en remplacement de Monsieur Kenneth Krenicky.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00467. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036381.3/682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
<i>Pouri> <i>ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
A. Kronshagen
<i>Pour la société SORRILUX S.A.
i>AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
43444
NORTH EUROPEAN FINANCIAL REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 52.118.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 avril 2005i>
L’Assemblée Générale du 28 avril 2005 renomme aux postes d’Administrateur:
- Monsieur Esa Kaunistola,
- Monsieur Harry B. Rowell,
- Monsieur David Blair.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre
2005.
L’Assemblée Générale du 28 avril 2005 renomme également KPMG AUDIT LUXEMBOURG, comme Réviseur
d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036376.3/682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
I.E.D.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 74.928.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires réunie à Luxembourg le 27 avril 2005i>
«(...) L’assemblée décide de reconfier le mandat de Commissaire aux Comptes à la société EUROPEAN AUDIT, S.à
r.l. pour une nouvelle période de six ans, s’achevant à l’issue de l’assemblée générale devant se tenir en 2011 (...)».
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036389.3/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
BIDROLU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 94.400.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2005i>
- Madame Nadia Meyer, directeur, demeurant à Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de
Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2009.
Luxembourg, le 29 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06606. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036435.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
ROBINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.579.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00656, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037205.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
<i>Pour la société NORTH EUROPEAN FINANCIAL REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 9 mai 2005.
Signature.
43445
ATLANTIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 80.882.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 2004i>
- Le mandat d’administrateur de classe A de Monsieur Paolo Monarca, expert comptable, né le 24 décembre 1968 à
I-Napoli, demeurant c/o Studio Tarantino, Via Po 41, I-20010 Villa Stanza Parabiago (Ml), le mandat d’administrateur de
classe B de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912
Mondercange, 19, rue des Champs et le mandat de commissaire aux comptes de Triple A Consulting, ayant son siège
social à L-2156 Luxembourg, 2 Millegässel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 61.417, sont renouvelés pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
2010.
- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echtemach, demeurant au 19, rue de Kirchberg,
L-1858 Luxembourg, est nommé administrateur de classe B jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2010, vu que
Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à I-Vicari, demeurant au 1, rue de Prettange à L-7396
Hunsdorf, ne désire plus que son mandat d’administrateur de classe B soit renouvelé.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00841. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036458.3/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
IMR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 51.972.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 2005 i>
- Les mandats d’administrateurs de Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-
Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à
L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, Pascal Kim, directeur financier, né le 12 juillet
1960 à F-Strasbourg, demeurant à F-67235 Benfeld, 1, rue de Westhouse et Bernard Steyert, PDG d’entreprise, né le
7 janvier 1940 à F-Colmar, demeurant à F-67235 Benfeld, 1, rue de Westhouse ainsi que le mandat de commissaire aux
comptes de TRIPLE A CONSULTING, inscrite sous le numéro d’immatriculation B 61.417 auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dont le siège social se trouve à L-2156 Luxembourg, 2 Millegässel, sont
reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036460.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
KAMEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 95.359.
—
EXTRAIT
II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2005 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pescatore, L-2310 Luxembourg a été nommé
Commissaire en remplacement de Monsieur Olivier Dorier, démissionnaire.
Luxembourg, le 6 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01223. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036770.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ATLANTIS INVESTMENT S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour IMR INTERNATIONAL S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
43446
COMPAGNIE AERONAUTIQUE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6112 Junglinster, 7A, rue de Bourglinster.
R. C. Luxembourg B 23.275.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Junglinster le 29 octobre 2004i>
L’assemblée a pris acte de la démission des membres du conseil d’administration, à savoir Messieurs Marc Adler,
Dieter Jung, Claude Sauber, Norbert Theisen, Pierre Thibo et Dirk Vormberge.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Claude Sauber, demeurant à Olingen,
- Monsieur Pierre Thibo, demeurant à Larochette,
- CAMERON BALLOONS LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège à Junglinster.
Les mandats des administrateurs prendront fin le jour de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels de l’exercice 2005.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Junglinster, le 3 mai 2005
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00602. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036633.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
HYPO PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 71.104.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 22 März 2005 i>
Der Verwaltungsrat bestellt KPMG AUDIT, mit Sitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg zum Wirtschaftsprüfer
für das Geschäftsjahr 2005.
Luxemburg, den 26. April 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01214. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036796.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
SAIPEM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 65.133.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue au siège social le 24 novembre
2004 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, l’Assemblée décide d’appeler à la fonction d’Administrateur
de groupe A, les personnes suivantes:
Monsieur Sergio Polito, administrateur de sociétés, élisant domicile à Via Europa, 26/b, I-20097 San Donato Milanese.
Monsieur Daniele Rossi, administrateur de sociétés, élisant domicile à Via Donizetti, 13, I-20040 Carnate.
Monsieur Giancarlo Denegri, administrateur de sociétés, élisant domicile au 57/59, rue Antoine Meyer L-2153
Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat de l’Administrateur étant venu à échéance, est appelée à la fonction d’Administrateur B la personne
suivante:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 257, route
d’Esch L-1471 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, l’Assemblée décide d’appeler à la fonction de
Commissaire aux Comptes, la personne suivante:
Monsieur Paul Simon, taxe advisor, élisant domicile à Loyens et Loeff, 1, allée Scheffer L-2520 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06159. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036822.3/2329/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Ein Bevollmächtigteri>
43447
CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CHELSFIELD TrizecHAHN, S.à r.l.).
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 75.216.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du
30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
536 du 26 juillet 2000.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01211, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036797.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 27.711.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 2004, et I’affectation du résultat de I’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril
enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01137, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
(036804.3/1183/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 25.105.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2005, le Conseil d’Administration de la SICAV ACM INTERNA-
TIONAL HEALTH CARE FUND est composé comme suit, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire
de 2006:
- Kurt Schoknecht;
- James Posch;
- Robert C. Alexander;
- J. Kent Blair Jr.;
- David H. Dievler;
- William H. Henderson;
- Yves Prussen.
Luxembourg, le 4 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01142. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036806.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
MALERBETRIEB ESCH, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 3, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 62.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00843, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2005.
(036941.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l.
Signature
F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Mandataire Principali>
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
43448
EUROTECNICA MELAMINE, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 104.410.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036470.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
COLUMBUS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.793.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le
15 juillet 2004 que:
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Mamadou Dione comptable, en sa qualité d’Administrateur, élisant
domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Claude Ramon,
directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06175. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036849.3/2329/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
NEW LAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 34.668.
—
Le bilan au 31 décembre 2001 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06540, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036855.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
NEW LAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 34.668.
—
EXTRAIT
II résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 29 avril 2005
que:
- la cooptation de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, aux fonctions d’administrateurs, en
remplacement de Maître Philippe Morales, administrateur démissionnaire, a été ratifiée;
- Monsieur Emanuele Bozzone, administrateur de sociétés, demeurant à Viale Villa Foreste 13, CH-6850 Mendrisio
(Suisse) a été élu aux fonctions d’administrateur de la société en remplacement de Maître Lydie Lorang, administrateur
démissionnaire.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06537. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036856.3/317/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
Luxembourg, le 29 avril 2005.
P. Frieders.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandateuri>
43449
HORIZONT MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.808.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 3
février 2005 que:
Le mandat des administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes
suivantes:
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-
2449 Luxembourg.
SGG LTD, société de droit BVI, ayant son siège social au Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands.
LOUV, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle 2006.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
FIN-CONTROLE S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Beaumont L-1219 Luxem-
bourg.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle 2006.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,
le 3 février 2005 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le 3
février 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille
euro (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat,
de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administra-
teurs dont celle de l’administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06167. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036851.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
I.O.C. INTERNATIONAL OVERSEAS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 84.937.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 3 mars 2005i>
La séance est ouverte avec la constitution du bureau de l’Assemblée, dont la présidence revient à Monsieur Jeannot
Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux.
Monsieur le Président désigne Madame Gisèle Klein, employée privée, demeurant à Belvaux, comme secrétaire et
Madame Nadine Noyer, employée privée, demeurant à Gandrange, comme scrutateur.
Le Président, sous l’approbation de l’Assemblée, note que tous les actionnaires, ainsi que les éventuels représentés
par des mandataires sont présents et notés avec leur nombre d’actions représentées sur une liste de présence, se re-
connaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, déclarant avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convocations préalables.
Les actionnaires présents ou éventuellement représentés par des mandataires ainsi que le nombre d’actions possé-
dées par chacun d’eux, ont été portés sur une liste de présence, dressée et signée par les membres du bureau et signée
par les actionnaires présents ou les éventuel représentés par des mandataires.
A cette liste de présence, qui demeurera annexée à la présente Assemblée, avec laquelle elle sera enregistrée, les
membres de l’Assemblée déclarent se référer. De cette liste de présence résulte que l’entièreté du capital est repré-
senté dans la présente Assemblée et que l’Assemblée est ainsi autorisée à décider sur l’ordre du jour dont les action-
naires ont bien eu connaissance.
Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont les points et le texte sont les suivants:
<i>Ordre du jouri>
1. Nomination d’un nouvel administrateur.
2. Révocation d’un administrateur-délégué.
3. Nomination d’un nouveau Président du Conseil d’Administration.
4. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter les différents points de l’ordre du jour.
L’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
43450
<i>Première résolutioni>
Monsieur Fadil Licina, commerçant, né le 13 septembre 1958 à Rozaje, Yougoslavie, demeurant à 35, route de Bas-
togne, L-9011 Ettelbruck, est remplacé en sa qualité d’administrateur, par la société LUXEMBOURG FINANCIAL
SERVICES S.A. avec siège social à 270, route d’Arlon, L-8010 Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro B 37.917, et ce avec effet au 3 mars 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat de Monsieur Fadil Licina, commerçant, né le 13 septembre 1958 à Rozaje, Yougoslavie, demeurant à 35,
route de Bastogne, L-9011 Ettelbrück, comme administrateur-délégué se termine, et ce avec effet au 3 mars 2005.
<i>Troisième résolutioni>
Monsieur Fadil Licina, commerçant, né le 13 septembre 1958 à Rozaje, Yougoslavie, demeurant à 35, route de Bas-
togne, L-9011 Ettelbrück, est remplacé en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, par la société
INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. 116, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, inscrite au registre des Isles Vierges Britanniques sous le numéro 398986, et ce avec effet au 3
mars 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
est remplacée en sa qualité de commissaire aux comptes par la société FIDOM, S.à r.l., avec siège social à 2, rue Han-
nelaanst, L-9544 Wiltz, et ce avec effet au 14 février 2005.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’Assemblée.
Fait à Luxembourg, le 3 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06462. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036955.3/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
PROPPER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: 238, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.585.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique de la société qui s’est tenue
en date du 6 mai 2005 au siège social de la société que:
Madame Monique Marschal, demeurant à 59, rue du Canal, L-4051 Esch-sur-Alzette a été nommée gérant de la so-
ciété avec effet à ce jour en remplacement de Monsieur Raymond Guelff.
Luxembourg, le 6 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01537. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036963.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II S.C.A., Société en commandite par actions.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 107.218.
—
In the year two thousand and five, on the eighth day of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Mersch (Luxembourg), who will be the depositary of the present deed.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of INFOR GLOBAL SOLUTIONS TOPCO II S.C.A., a
société en commandite par actions, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (the
«Company»), incorporated pursuant to a deed of the replaced notary on 24 March 2005, not yet published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have not yet been amend-
ed.
The meeting was opened at 6.00 p.m. with Camille Bourke, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Saskia Konsbruck, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Yasmin Gabriel, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
J. Mousel / G. Klein / N. Noyer
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
Pour extrait conforme
<i>Par mandat
i>M
e
G. Ludovissy
43451
<i>Agenda:i>
1) Creation of eight new classes of shares divided into Class M Ordinary Shares, Class L-1 Ordinary Shares, Class P
Ordinary Shares, Class L Ordinary Shares, Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares, Class C Ordinary Shares
and Class D Ordinary Shares.
2) Increase of the share capital by an amount of three hundred seventy-seven thousand four hundred eighty-two US
Dollars (USD 377,482.-), to bring it from its current amount of forty-five thousand US Dollars (USD 45,000.-) up to an
amount of four hundred twenty-two thousand four hundred eighty-two US Dollars (USD 422,482.-) through the issue
of one hundred eighty-eight thousand seven hundred forty-one (188,741) new Class M Ordinary Shares, with a nominal
value of two US Dollars (USD 2.-) each.
3) Reduction of the share capital to three hundred seventy-seven thousand four hundred eighty-four US Dollars (USD
377,484.-) through cancellation of the twenty-two thousand four hundred ninety-nine (22,499) Ordinary Shares initially
issued by the Company upon its incorporation.
4) Subsequent full restatement of the articles of incorporation of the Company without changing the corporate pur-
pose or the legal form of the Company.
5) Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by
the appearing parties will also remain annexed to the present deed.
III. That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
The first three resolutions are adopted by INFOR GLOBAL SOLUTIONS TOPCO S.A., GOLDEN GATE CAPITAL
INVESTMENT FUND II (BVI), L.P. and CCG INVESTMENTS (BVI), L.P., the existing shareholders of the Company. The
third, fourth and fifth resolutions are adopted by the existing shareholders as well as all other persons and legal entities
which will become shareholders of the Company further to the adoption of the third resolution.
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to create eight new classes of shares, divided into Class M Ordinary Shares, Class L-1
Ordinary Shares, Class P Ordinary Shares, Class L Ordinary Shares, Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares,
Class C Ordinary Shares and Class D Ordinary Shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital by an amount of three hundred seventy-seven thousand
four hundred eighty-two US Dollars (USD 377,482.-), to bring it from its current amount of forty-five thousand US Dol-
lars (USD 45,000.-) up to an amount of four hundred twenty-two thousand four hundred eighty-two US Dollars (USD
422,482.-) through the issue of one hundred eighty-eight thousand seven hundred forty-one (188,741) new Class M Or-
dinary Shares, with a nominal value of two US Dollars (USD 2.-) each.
The existing shareholders waiwed their preferential subscription right to the extent necessary and the new shares
have been subscribed as follows:
- Fifteen thousand four hundred fifty-five (15,455) Class M Shares have been subscribed by CCG INVESTMENTS
(BVI), L.P., a limited partnership governed by the laws of the British Virgin Islands, with its principal office at One Em-
barcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of America,
- Seven hundred seventy-seven (777) Class M Shares have been subscribed by CCG ASSOCIATES - QP, L.L.C., a
Delaware limited liability company, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA
94111, United States of America,
- Seventy-two (72) Class M Shares have been subscribed by CCG ASSOCIATES - AI, L.L.C., a Delaware limited lia-
bility company, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States
of America,
- Two hundred seven (207) Class M Shares have been subscribed by CCG INVESTMENT FUND - AI, L.P., a Delaware
limited partnership, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United
States of America,
- One hundred eleven thousand four hundred twelve (111,412) Class M Shares have been subscribed by GOLDEN
GATE CAPITAL INVESTMENTS II (BVI), L.P., a limited partnership governed by the laws of the British Virgin Islands,
with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of America,
- Thirty-one thousand three hundred forty-four (31,344) Class M Shares have been subscribed by GOLDEN GATE
CAPITAL INVESTMENTS II-A ADJUNCT (BVI), L.P., a limited partnership governed by the laws of the British Virgin
Islands, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of
America,
- Two thousand seven hundred seventy-eight (2,778) Class M Shares have been subscribed by GOLDEN GATE CAP-
ITAL INVESTMENT FUND II (AI), L.P., a Delaware limited partnership, with its principal office at One Embarcadero
Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of America,
43452
- Seven hundred eighty-two (782) Class M Shares have been subscribed by GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENT
FUND II-A (AI), L.P., a Delaware limited partnership, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor,
San Francisco, CA 94111, United States of America,
- Three thousand three hundred fourteen (3,314) Class M Shares have been subscribed by GOLDEN GATE CAPITAL
INVESTMENT FUND II-QP, L.L.C., a Delaware limited liability company, with its principal office at One Embarcadero
Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of America,
- Fifty-two (52) Class M Shares have been subscribed by GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENT FUND II-AI,
L.L.C., a Delaware limited liability company, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Fran-
cisco, CA 94111, United States of America,
- Four thousand thirteen (4,013) Class M Shares have been subscribed by CCG AV, L.L.C. - Series C, a Delaware
limited liability company, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111,
United States of America,
- One thousand four hundred seventy-three (1,473) Class M Shares have been subscribed by CCG AV, L.L.C. - Series
D, a Delaware limited liability company, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco,
CA 94111, United States of America,
- Nine hundred forty-four (944) Class M Shares have been subscribed by CCG AV, L.L.C. - Series I, a Delaware limited
liability company, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United
States of America,
all duly represented by Yasmin Gabriel, prenamed by virtue of a proxy given in San Francisco, United States of Amer-
ica on 5 April 2005;
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in cash consisting of three million six hundred fifty-
eight thousand four hundred twenty-nine US Dollars and twenty-nine US cents (USD 3,658,429.29).
- Twelve thousand three hundred fourteen (12,314) Class M Shares have been subscribed by SUMMIT VENTURES
V, L.P., a limited partnership governed by the laws of Delaware, United States of America, having its registered office at
222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, United States of America,
- Eight hundred thirty-one (831) Class M Shares have been subscribed by SUMMIT V ADVISORS FUND (QP), L.P.,
a limited partnership governed by the laws of Delaware, United States of America, having its registered office at 222
Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, United States of America,
- Two thousand one hundred ninety-two (2,192) Class M Shares have been subscribed by SUMMIT V COMPANION
FUND, L.P., a limited partnership governed by the laws of Delaware, United States of America, having its registered
office at 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, United States of America,
- Two hundred fifty-four (254) Class M Shares have been subscribed by SUMMIT V ADVISORS FUND, L.P., a limited
partnership governed by the laws of Delaware, United States of America, having its registered office at 222 Berkeley
Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, United States of America,
- Five hundred twenty-seven (527) Class M Shares have been subscribed by SUMMIT INVESTORS III, L.P., a limited
partnership governed by the laws of Delaware, United States of America, having its registered office at 222 Berkeley
Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, United States of America,
all duly represented by Yasmin Gabriel, prenamed by virtue of a proxy given in San Francisco, United States of Amer-
ica on 5 April 2005;
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in cash consisting of three hundred forty-one thousand
five hundred seventy US Dollars and seventy US cents (USD 341,570.71).
The total contribution consists of four million US Dollars (USD 4,000,000.-), it being understood that three hundred
seventy-seven thousand four hundred eighty-two US Dollars (USD 377,482.-) will be allocated to the share capital of
the Company and three million six hundred twenty-two thousand five hundred eighteen US Dollars (USD 3,622,518.-)
will be allocated to a share premium account.
The proof of the existence and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary.
The general meeting resolves to give power to Mr Pierre Beissel, Mrs Camille Bourke, or to Ms Yasmin Gabriel, all
maître en droit, residing in Luxembourg, each acting individually, to duly amend the register of registered shares of the
Company in order to reflect the aforementioned capital increase.
After the aforementioned capital increase, the new shareholders of the Company enter the meeting and participate
in the vote relating to items 3) to 5) of the agenda, and thus take part in the following resolutions:
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to reduce the share capital from four hundred twenty-two thousand four hundred
eighty-two US Dollars (USD 422,482.-) to three hundred seventy-seven thousand four hundred eighty-two US Dollars
(USD 377,482.-) through the cancellation of the twenty-two thousand four hundred ninety-nine (22,499) Ordinary
Shares initially issued by the Company upon its incorporation and reimbursement to the shareholders of the Company
of an amount of forty-four thousand nine hundred ninety-eight US Dollars (USD 44,998.-).
<i>Fourth resolutioni>
Further to the adoption of the aforementioned resolutions the general meeting resolves to fully restate the articles
of incorporation of the Company, without changing the corporate purpose or legal form of the Company, so as to read
as follows:
A. Name - Registered office - Duration - Object
«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the fu-
ture, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of INFOR GLOBAL SOLUTIONS
TopCo II (hereinafter the «Company»).
43453
Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within
the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager (as defined
in Article 8). It may be transferred to any other, place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a general meeting
of the shareholders. Branches, Subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxem-
bourg or abroad by decision of the Manager.
In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments have oc-
curred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg Company.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
B. Shareholders’ liability
Art. 5. The General Partner (associé commandité) is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid
out of the assets of the Company. The Limited Partner or the Limited Partners, as the case may be, being the holder(s)
of ordinary shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising
its (their) rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of its (their) contributions to
the Company.
C. Share capital - Shares
Art. 6. Corporate capital
(a) The Company has a share capital of three hundred seventy-seven thousand four hundred eighty-four US Dollars
(USD 377,484.-), divided into (i) one hundred eighty-eight thousand seven hundred forty-one (188,741) shares, desig-
nated as «Class M Ordinary Shares», having a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share and (ii) one (1) manage-
ment share, designated as the «Management Share», having a par value of two US dollars (USD 2.-);
(b) The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at two billion US Dollars (USD 2,000,000,000)
consisting of one billion (1,000,000,000) Ordinary Shares with a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share, which
may be issued in any of the following designated classes, each having the rights and privileges specified in these Articles:
(i) Class M Ordinary Shares;
(ii) «Class L-1 Ordinary Shares», having a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share;
(iii) «Class P Ordinary Shares», having a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share;
(iv) «Class L Ordinary Shares», having a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share;
(v) «Class A Ordinary Shares», having a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share;
(vi) «Class B Ordinary Shares», having a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share;
(vii) «Class C Ordinary Shares», having a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share; and
(viii) «Class D Ordinary Shares», having a par value of two US Dollars (USD 2.-) per share.
The Class M Ordinary Shares, Class L-1 Ordinary Shares, Class P Ordinary Shares, Class L Ordinary Shares, Class A
Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares, Class C Ordinary Shares and Class D Ordinary Shares are hereafter together
referred to as an «Ordinary Share» or the «Ordinary Shares». The Ordinary Shares and the Management Share are
hereafter together referred to as a «share» or the «shares».
During the period of five years from the date of the publication of these articles of incorporation, the Manager of the
Company is hereby authorised to issue Ordinary Shares and to grant options to subscribe for Ordinary Shares, to such
persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
shareholders a preferential right to subscribe to the Ordinary Shares issued. The subscribed capital and the authorised
capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of incorporation.
(c) Within the authorized capital, the Manager is authorized to withdraw the preferential right to subscribe to any
shares of the Company, except as may be provided in any separate written agreement between the Company and the
holder of such shares. The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares;
provided that (i) any such redemption shall be based upon the then prevailing fair market value of such shares and (ii)
any redemption of any particular class of shares shall be done on a pro rata basis according to the number of shares of
such class then outstanding.
Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register
will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify
43454
the Company by registered letter of its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the
last address so communicated.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by the Manager upon the request of the relevant share-
holder. Such signatures shall either be made by hand, printed, or in facsimile.
Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register.
During the period of ten years from the date of the publication of these articles of incorporation, no holder of shares
of the Company may sell, transfer, assign, pledge or otherwise dispose of (whether directly or indirectly, whether with
or without consideration and whether voluntarily or involuntarily or by operation of law) any interest (legal or benefi-
cial) in any shares of the Company, except pursuant to and in accordance with the provisions of any separate written
agreement between the Company and such shareholder or except as otherwise agreed to by the Manager.
Transfers of registered shares shall be executed by a written declaration of transfer to be registered in the register
of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee or by persons holding suitable powers of attorney
to act on their behalf. The transfers of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of
claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Furthermore, the Company may accept and register in
the shareholders’ register any transfer referred to in any correspondence or other document showing the consent of
the transferor and the transferee.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such
address shall also be entered into the register of shareholders. Shareholders may, at any time, change their address as
entered into the register of shareholders by way of a written notification sent to the Company’s registered office, or to
such other address indicated by the Company.
The Management Share held by the Manager is not transferable except to a successor manager to be appointed in
accordance with article 8 of these articles of incorporation.
The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of
such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single representative to rep-
resent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all
rights attached to such share(s).
D. Management
Art. 8. The Company shall be managed by INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo S.A., a société anonyme existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as general partner (associé commandité) and sole
manager of the Company (herein referred to as the «Manager»).
In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as man-
ager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board,
as provided for in article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect
urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within
fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accord-
ance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles. Failing such appointment, the Company
shall be dissolved and liquidated.
Any appointment of a successor manager pursuant to this article 8 shall not be subject to the approval of the Manager.
Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the
Company’s stated purpose.
All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders
or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.
Art. 10. The Company shall be bound by the signature of the Manager represented by duly appointed representa-
tives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager in its sole
discretion.
E. Supervision
Art. 11. The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts, shall be super-
vised by a Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members. For the carrying out
of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article
62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The Supervisory Board may
be consulted by the Manager on such matters as he may determine and may authorise any actions taken by the Manager
that may, pursuant to law or regulation or under the articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.
The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
which may not exceed six years and shall hold office until their successors are elected. The members of the supervisory
board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by
the general meeting of shareholders. The Supervisory Board shall elect one of its members as chairman.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board
must be convened if any of two of its members so request.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least twenty-four hours
prior to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency
shall be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the, place of the meeting and it will contain the agenda
thereof. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of com-
munication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.
43455
The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory
Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority of mem-
bers present at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing,
by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may rep-
resent several of his colleagues.
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or rep-
resented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Cop-
ies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chair-
man of the meeting or any two members.
Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as
resolutions voted at the boards’ meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex,
telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. Such approval shall be confirmed in writing
and all such documents shall together form the document which proves that such resolution has been taken.
Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected
or invalidated by the fact that the Manager or any other shareholder or their respective affiliates or any one or more
of their respective officers, directors, employees, agents or representatives has any interest in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director,
officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting
upon any matters with respect to such contract or other business.
F. General meetings of shareholders
Art. 13. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest
powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present articles of incorporation, a resolution shall be validly adopted only if approved
by the Manager.
The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Super-
visory Board. It shall also be convened by the Manager upon the request of shareholders representing at least twenty
per cent (20%) of the Company’s share capital.
The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other,
place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the first Monday of November at 10 a.m.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day in Luxembourg.
Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening
notices. The general meetings of shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent by registered
mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Company at the address indicated
in the share register. The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders
of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The Manager
may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of share-
holders. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
G. Accounting year - Balance sheet
Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first of June of each year (other than the year of
formation, which shall commence upon the date of the Company’s formation) and shall terminate on the thirty first of
May of the following year.
Art. 15. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten per
cent (10%) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon the recommendation of the Man-
ager, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distrib-
uted by observing the terms and conditions provided for by law.
H. Amendment of the articles of incorporation
Art. 16. These articles of incorporation may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meet-
ing of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies as amended, unless otherwise provided herein.
I. Liquidation
Art. 17. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out
the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which decided the dissolution
and which shall determine their powers and compensation. In the event of any voluntary or involuntary liquidation, dis-
43456
solution or winding up of the Company, the assets of the Company available for distribution to the shareholders shall
be applied to the extent permitted by law in the following order of priority:
(a) first, to the holders of the Class M Ordinary Shares pursuant to Article 19(a) and 19(b),
(b) second, to the holders of the Class L-1 Ordinary Shares pursuant to Article 19(c), 19(d) and 19(e),
(c) third, in payment to the holders of the Class P Ordinary Shares an amount in respect of each Class P Ordinary
Share held equivalent to Unreturned Preference Amount plus the Unpaid Preferred Yield of each such Class P Ordinary
Share plus, if required, the Applicable Premium; provided that if the assets available for distribution to holders of the
Class P Ordinary Shares are not sufficient to pay to such holders the aforesaid amount, the available assets shall be dis-
tributed to holders of the Class P Ordinary Shares pro rata according to the number of Class P Ordinary Shares held
by them, and
(d) fourth, to the holders of the Ordinary Shares in accordance with Article 19(f) through 19(m).
J. Dividends
Art. 18. The Manager may declare interim dividends on Ordinary Shares in issue and authorise payment of the div-
idends out of the funds of the Company lawfully available. The funds the Company may décide to distribute pursuant to
this Article 18 in respect of any financial year or other period for which its accounts are made up shall be applied in
paying to each holder of an Ordinary Share a dividend which shall constitute a Distribution and be paid in accordance
with the provisions of Article 19 below.
Art. 19. Except as set forth in Article 17 with respect to any Distribution made in connection with any liquidation,
dissolution or winding up of the Company, at the time of each Distribution, such Distribution shall be made to the hold-
ers of the Class M Ordinary Shares, the Class L-1 Ordinary Shares, the Class L Ordinary Shares, the Class A Ordinary
Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Ordinary Shares and the Class D Ordinary Shares in the following
priority:
(a) The holders of the Class M Ordinary Shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion of
such Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unpaid Yield of the Class M Ordinary Shares
held by each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unpaid Yield on the issued Class M
Ordinary Shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion thereof shall be made under
any other paragraph of this Article 19 below until the entire amount of the Unpaid Yield on the issued Class M Ordinary
Shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Distributions made pursuant to this Article 19(a) to
the holders of the Class M Ordinary Shares shall constitute a payment of Yield on the Class M Ordinary Shares.
(b) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, the holders of the Class M Ordinary Shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion
of such Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unreturned Original Cost of the Class M
Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unreturned Orig-
inal Cost of the issued Class M Ordinary Shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion
thereof shall be made under any other paragraph of this Article 19 below until the entire amount of the Unreturned
Original Cost of the issued Class M Ordinary Shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Dis-
tributions made pursuant to this Article 19(b) to holders of the Class M Ordinary Shares shall constitute a return of
Original Cost of the Class M Ordinary Shares.
(c) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, the holders of the Class L-1 Ordinary Shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion
of such Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unpaid Primary Yield of the Class L-1 Or-
dinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unpaid Primary Yield
on the issued Class L-1 Ordinary Shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion thereof
shall be made under any other paragraph of this Article 19 below until the entire amount of the Unpaid Primary Yield
on the issued Class L-1 Ordinary Shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Distributions made
pursuant to this Article 19(c) to holders of the Class L-1 Ordinary Shares shall constitute a payment of Primary Yield
on the Class L-1 Ordinary Shares.
(d) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, the holders of the Class L-1 Ordinary Shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion
of such Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unpaid Secondary Yield of the Class L-1
Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unpaid Secondary
Yield on the issued Class L-1 Ordinary Shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion
thereof shall be made under any other paragraph of this Article 19 below until the entire amount of the Unpaid Second-
ary Yield on the issued Class L-1 Ordinary Shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Distri-
butions made pursuant to this Article 19(d) to holders of the Class L-1 Ordinary Shares shall constitute a payment of
Secondary Yield on the Class L-1 Ordinary Shares.
(e) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, the holders of the Class L-1 Ordinary Shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion
of such Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unreturned Original Cost of the Class L-1
Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unreturned Orig-
inal Cost of the issued Class L-1 Ordinary Shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion
thereof shall be made under any other paragraph of this Article 19 below until the entire amount of the Unreturned
Original Cost of the issued Class L-1 Ordinary Shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Dis-
tributions made pursuant to this Article 19(e) to holders of the Class L-1 Ordinary Shares shall constitute a return of
Original Cost of the Class L-1 Ordinary Shares.
43457
(f) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, the holders of the Class L Ordinary Shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion of
such Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unpaid Yield of the Class L Ordinary Shares
held by each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unpaid Yield on the issued Class L
Ordinary Shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion thereof shall be made under
any other paragraph of this Article 19 below until the entire amount of the Unpaid Yield on the issued Class L Ordinary
Shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Distributions made pursuant to this Article 19(f) to
holders of the Class L Ordinary Shares shall constitute a payment of Yield on the Class L Ordinary Shares.
(g) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, the holders of the Class L Ordinary Shares, as a separate class, shall be entitled to receive all or a portion of
such Distribution (ratably among such holders based upon the aggregate Unreturned Original Cost of the Class L Or-
dinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution) equal to the aggregate Unreturned Original
Cost of the issued Class L Ordinary Shares as of the time of such Distribution, and no Distribution or any portion there-
of shall be made under any other paragraph of this Article 19 below until the entire amount of the Unreturned Original
Cost of the issued Class L Ordinary Shares as of the time of such Distribution has been paid in full. The Distributions
made pursuant to this Article 19(g) to holders of the Class L Ordinary Shares shall constitute a return of Original Cost
of the Class L Ordinary Shares.
(h) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, the holders of Class L Ordinary Shares, the holders of Class A Ordinary Shares and the holders of Class D
Ordinary Shares, as a group, shall be entitled to receive all or a portion of such Distribution (ratably among such holders
based upon the number of Class L Ordinary Shares, Class A Ordinary Shares and Class D Ordinary Shares held by each
such holder as of the time of such Distribution) until and to the extent either (a) the L-1 Catchup Return has been
achieved or (b) the Three Times Target Return has been achieved, and no Distribution or any portion thereof shall be
made under any other paragraph of this Article 19 below until either (a) the holders of Class L Ordinary Shares, the
holders of Class A Ordinary Shares and the holders of Class D Ordinary Shares have received Distributions pursuant
to this Article 19(h) in an amount equal in the aggregate to the L-1 Catchup Return or (b) each Golden Gate Security-
holder has received Distributions in respect of such Golden Gate Securityholder’s Company Securities in an amount
equal to the Three Times Target Return.
(i) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, and only if the Three Times Target Return has not been achieved, the holders of Class M Ordinary Shares,
the holders of Class L-1 Ordinary Shares, the holders of Class L Ordinary Shares, the holders of Class A Ordinary Shares
and the holders of Class D Ordinary Shares, as a group, shall be entitled to receive all or a portion of such Distribution
(ratably among such holders based upon the number of Class M Ordinary Shares, Class L-1 Ordinary Shares, Class L
Ordinary Shares, Class A Ordinary Shares and Class D Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such
Distribution) until and to the extent the Three Times Target Return has been achieved and no Distribution or any por-
tion thereof shall be made under any other paragraph of this Article 19 below until each Golden Gate Securityholder
has received Distributions in respect of such Golden Gate Securityholder’s Company Securities in an amount equal to
the Three Times Target Return. For avoidance of doubt, no Distributions shall be made pursuant to this Article 19(i) if
the Three Times Target Return has already been achieved.
(j) After the required amount of Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this Ar-
ticle 19, the holders of Class L Ordinary Shares, the holders of Class A Ordinary Shares, the holders of Class B Ordinary
Shares and the holders of Class D Ordinary Shares, as a group, shall be entitled to receive all or a portion of such Dis-
tribution (ratably among such holders based upon the number of Class L Ordinary Shares, Class A Ordinary Shares,
Class B Ordinary Shares and Class D Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution) until
and to the extent either (a) the L-1 Catchup Return has been achieved or (b) the Five Times Target Return has been
achieved, and no Distribution or any portion thereof shall be made under any other paragraph of this Article 19 below
until (a) the holders of Class L Ordinary Shares, the holders of Class A Ordinary Shares, the holders of Class B Ordinary
Shares and the holders of Class D Ordinary Shares have received Distributions pursuant to Article 19(h) and this Article
19(j) in an amount equal in the aggregate to the L-1 Catchup Return or (b) each Golden Gate Securityholder has re-
ceived Distributions in respect of such Golden Gate Securityholder’s Company Securities in an amount equal to the Five
Times Target Return.
(k) After the required amount of a Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, and only if the Five Times Target Return has not been achieved, the holders of Class M Ordinary Shares, the
holders of Class L-1 Ordinary Shares, the holders of Class L Ordinary Shares, the holders of Class A Ordinary Shares,
the holders of Class B Ordinary Shares and the holders of Class D Ordinary Shares, as a group, shall be entitled to
receive all or a portion of such Distribution (ratably among such holders based upon the number of Class M Ordinary
Shares, Class L-1 Ordinary Shares, Class L Ordinary Shares, Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares and Class
D Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution) until and to the extent the Five Times
Target Return has been achieved and no Distribution or any portion thereof shall be made under any other paragraph
of this Article 19 below until each Golden Gate Securityholder has received Distributions in respect of such Golden
Gate Securityholder’s Company Securities in an amount equal to the Five Times Target Return. For avoidance of doubt,
no Distributions shall be made pursuant to this Article 19(k) if the Five Times Target Return has already been achieved.
(l) After the required amount of Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this Ar-
ticle 19, the holders of the Ordinary Shares other than the Class M Ordinary Shares, the Class L-1 Ordinary Shares and
the Class P Ordinary Shares, as a group, shall be entitled to receive all or a portion of such Distribution (ratably among
such holders based upon (i) the number of Class L Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such
43458
Distribution, (ii) the number of Class A Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution,
(iii) the number of Class B Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution, (iv) the number
of Class C Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution and (v) the number of Equivalent
Class D Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution) until and to the extent the L-1
Catchup Return has been achieved, and no Distribution or any portion thereof shall be made under any other paragraph
of this Article 19 below until the holders of the Ordinary Shares other than the Class M Ordinary Shares, the Class L-
1 Ordinary Shares and Class P Ordinary Shares have received Distributions pursuant to Article 19(h) and 19(j) and this
Article 19(l) in an amount equal in the aggregate to the L-1 Catchup Return.
(m) After the required amount of Distribution has been made in full pursuant to the preceding paragraphs of this
Article 19, the holders of the Ordinary Shares other than the Class P Ordinary Shares, as a group, shall be entitled to
receive the remaining portion of such Distribution (ratably among such holders based upon (i) the number of Class M
Ordinary Shares held by each such holder as of the time of such Distribution, (ii) the number of Class L-1 Ordinary
Shares held by each such holder as of the time of such Distribution, (iii) the number of Class L Ordinary Shares held by
each such holder as of the time of such Distribution, (iv) the number of Class A Ordinary Shares held by each such
holder as of the time of such Distribution, (v) the number of Class B Ordinary Shares held by each such holder as of
the time of such Distribution, (vi) the number of Class C Ordinary Shares held by each such holder as of the time of
such Distribution and (viii) the number of Equivalent Class D Ordinary Shares held by each such holder as of the time
of such Distribution).
For purposes of this Article 19 and Articles 20 through 25, all references to Class M Ordinary Shares, Class L-1 Or-
dinary Shares, Class P Ordinary Shares, Class L Ordinary Shares, Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares,
Class C Ordinary Shares and Class D Ordinary Shares shall be deemed to refer to such Ordinary Shares and to the
Series M CPECs, the Series L-1 CPECs, the Series P CPECs, the Series L CPECs, the Series A CPECs, the Series B
CPECs, the Series C CPECs and the Series D CPECs, respectively.
K. Redemption of Class P Ordinary Shares
Art. 20. Upon the occurrence of the Mandatory Redemption Date, the Company shall redeem each outstanding
Class P Ordinary Share for cash, at a price per share equal to the Unreturned Preference Amount plus the Unpaid Pre-
ferred Yield of each such Class P Ordinary Share plus, if required, the Applicable Premium. The Company may at any
time prior to the occurrence of the Mandatory Redemption Date redeem all or any portion of the Class P Ordinary
Shares then outstanding for cash at a price per share equal to the Unreturned Preference Amount plus the Unpaid Pre-
ferred Yield of each such Class P Ordinary Share, plus the Applicable Premium. Upon the occurrence of an Event of
Default (A) in the case of Golden Gate Securityholders, the Majority Golden Gate Securityholders or (B) in the case of
Summit Securityholders, the Majority Summit Securityholders may, upon written notice to the Company, demand that
the Class P Ordinary Shares held by the Golden Gate Securityholders or the Summit Securityholders, as the case may
be, be redeemed (within five (5) business days of delivery of such written notice) for cash, at a price per share equal to
the Unreturned Preference Amount plus the Unpaid Preferred Yield of each such Class P Ordinary Share, plus the Ap-
plicable Premium. Any redemption of the Class P Ordinary Shares shall be subject to the limitations that the Company
will not be Insolvent after making such redemption payments and that such redemption payments are made out of Le-
gally Available Funds. If the funds of the Company legally available for redemption of Class P Ordinary Shares on any
redemption date are insufficient to redeem the total number of Class P Ordinary Shares to be redeemed on such date,
those funds which are legally available shall be used to redeem the maximum possible number of Class P Ordinary Shares
pro rata among the holders of the shares to be redeemed based upon the aggregate Unreturned Preference Amount
and Unpaid Preferred Yield of such shares held by each such holder. At any time thereafter when additional funds of
the Company are legally available for the redemption of Class P Ordinary Shares, such funds shall immediately be used
to redeem the balance of the Class P Ordinary Shares which the Company has become obligated to redeem on any
redemption date but which it has not redeemed.
Art. 21. Except as otherwise provided herein, the Company shall mail written notice of each redemption of any Class
P Ordinary Shares to each record holder of such Class P Ordinary Shares not more than 60 days nor less than 10 days
prior to the date on which such redemption is to be made. In case fewer than the total number of Class P Ordinary
Shares as reflected in the Company’s shareholder register are to be redeemed, the Company’s shareholder register shall
be revised accordingly.
Art. 22. The number of Class P Ordinary Shares to be redeemed from each holder thereof in redemption hereunder
shall be the number of shares determined by multiplying the total number of Class P Ordinary Shares to be redeemed
times a fraction, the numerator of which shall be the total number of Class P Ordinary Shares then held by such holder
and the denominator of which shall be the total number of Class P Ordinary Shares then outstanding.
Art. 23. No Class P Ordinary Share shall be entitled to any dividends accruing after the date on which the Unre-
turned Preference Amount of such share plus all Unpaid Preferred Yield thereon and, if applicable, the Applicable Pre-
mium is paid to the holder thereof. On such date all rights of the holder of such Class P Ordinary Share shall cease, and
such Class P Ordinary Share shall be cancelled and the Company’s issued share capital shall be diminished accordingly
(without prejudice to the Company’s authorised share capital).
Art. 24. Any Class P Ordinary Shares which are redeemed (or otherwise acquired by the Company) and cancelled
shall not be reissued, sold or transferred.
Art. 25. The Manager shall provide to each holder of Class P Ordinary Shares, immediately upon receipt thereof,
any written notice of an event of default received by the Company or any of its Subsidiaries under any senior loan agree-
ment to which any of them is a party.
43459
L. Sale of the company, Public offering
Art. 26. If the holders of the Ordinary Shares held by the Golden Gate Securityholders approve (i) by a majority
vote, a sale of all or substantially all of the Company’s outstanding share capital and/or securities (whether by merger,
recapitalization, consolidation, reorganization, combination or otherwise) or (ii) in accordance with the quorum and ma-
jority requirements provided by law, a sale of all or substantially all (as defined in the Revised Model Business Corpora-
tion Act) of the Company’s assets determined on a consolidated basis (such holders, in the respective case of (i) and
(ii), the «Requisite Holders») to any Independent Third Party or group of Independent Third Parties (such sale, in the
respective case of (i) and (ii) an «Approved Sale»), each holder of Ordinary Shares will (y) with respect to (i) and (ii)
above, be deemed to have consented to and agrees to raise no objections against such Approved Sale and (z) with re-
spect to (ii) above, agrees to vote in favour of such Approved Sale at any general meeting of shareholders held for that
purposes, and, with respect to (i) and (ii) above, and hereby agrees to take all corporate action necessary and consents
to allow the Manager to take such action on such holder’s behalf to the extent permissible under applicable laws, in-
cluding, among other things, the consent for the Manager to take all actions necessary to effect a transfer of securities
of the Company in the applicable share or CPEC register. If the Approved Sale is structured as (i) a merger or consol-
idation, each holder of Ordinary Shares will waive any dissenter’s rights, appraisal rights or similar rights in connection
with such merger or consolidation or (ii) a sale of share capital and/or securities, each holder of Ordinary Shares will
agree to sell all of its Ordinary Shares and rights to acquire Ordinary Shares on the terms and conditions approved by
the Manager and the Requisite Holders. For avoidance of doubt, whenever reference is made in Article 26 through 31
to holders of Ordinary Shares, such references shall also include holders of CPECs which are convertible into Ordinary
Shares.
Art. 27. The obligations of the holders of Ordinary Shares with respect to an Approved Sale are subject to the sat-
isfaction of the following conditions: (i) upon the consummation of the Approved Sale, each holder of Ordinary Shares
will receive the same form of consideration and the same portion of the aggregate consideration that such holders of
Ordinary Shares would have received if such aggregate consideration had been distributed by the Company in complete
liquidation pursuant to the rights and preferences set forth in these articles of incorporation as in effect immediately
prior to such Approved Sale, (ii) if any holder of a class of Ordinary Shares is given an option as to the form and amount
of consideration to be received, each holder of such class of Ordinary Shares will be given the same option, (iii) each
holder of then currently exercisable rights to acquire shares of a class of Ordinary Shares will be given an opportunity
to exercise such rights prior to the consummation of the Approved Sale and participate in such sale as holders of such
class of Ordinary Shares, (iv) each shareholder’s obligation to indemnify the purchaser in any Approved Sale for any
representations and warranties concerning the Company and its Subsidiaries shall be several (and not joint) obligations
among the Company’s shareholders and shall either be pro-rated according to the total proceeds received by such
shareholder in connection with the Approved Sale or provision will be made among the Company’s shareholders for
such a pro rata sharing of indemnification obligations, (v) each shareholder’s obligation to indemnify the purchaser in
any Approved Sale shall be limited to the net (pre-tax) proceeds distributed to such shareholder in connection with
such transaction and (vi) none of the shareholders that are not members of the Company’s senior management at the
time of such Approved Sale shall be required as a condition of any such Approved Sale to enter into a non-competition
agreement.
Art. 28. If the Company or the holders of the Company’s securities enter into any negotiation or transaction for
which Rule 506 (or any similar rule then in effect) promulgated by the Securities and Exchange Commission of the Unit-
ed States may be available with respect to such negotiation or transaction (including a merger, consolidation or other
reorganization), the holders of Ordinary Shares who are not «accredited investors» will, at the request of the Company,
appoint a purchaser representative (as such term is defined in Rule 501 promulgated by the Securities and Exchange
Commission of the United States) reasonably acceptable to the Company. If any holder of Ordinary Shares appoints a
purchaser representative designated by the Company, the Company will pay the fees of such purchaser representative,
but if any holder of Ordinary Shares declines to appoint the purchaser representative designated by the Company, such
holder will appoint another purchaser representative, and such holder will be responsible for the fees of the purchaser
representative so appointed.
Art. 29. Each holder of Ordinary Shares will bear a pro-rata share (based upon the aggregate consideration to be
received by such holder in connection with such Approved Sale upon the closing thereof) of the costs paid to any third
party retained by the shareholders of the Company in connection with any sale of Ordinary Shares pursuant to an Ap-
proved Sale to the extent such costs are incurred for the benefit of all holders of Ordinary Shares and are not otherwise
paid by the Company or the acquiring party. Costs incurred by holders of Ordinary Shares on their own behalf will not
be considered costs of the transaction hereunder.
Art. 30. The provisions of Article 26 through Article 29 will terminate upon the earlier to occur of (i) the consum-
mation of an IPO and (ii) the consummation of a Change of Control.
Art. 31. If (i) the Manager approves an IPO and (ii) the IPO is an underwritten offering and the managing underwriters
advise the Company in writing that in their opinion the Company’s capital structure will adversely affect the marketa-
bility of the offering, each holder of Ordinary Shares will consent to and vote for a recapitalization, reorganization and/
or exchange of the Ordinary Shares into securities that the managing underwriters, the Manager and holders of a ma-
jority of the Ordinary Shares then outstanding find acceptable and will take all necessary or desirable actions in connec-
tion with the consummation of the recapitalization, reorganization and/or exchange; provided that all holders of the
same class or series of Ordinary Shares and CPECs are treated in the same manner in connection with the foregoing
and the resultant securities reflect and are consistent with the rights and preferences set forth in these articles imme-
43460
diately prior to the IPO (assuming for purposes hereof, conversion of all then outstanding CPECs). The provisions of
this Article 31 will terminate upon the consummation of a Change of Control. The provisions of this Article 31 and all
references to the defined term «IPO» in these Articles will apply, mutatis mutandis, to (i) any initial public offering and
sale of any ordinary shares or common stock of any Subsidiary of the Company and the liquidation of the Company into
any such Subsidiary in connection therewith and (ii) any Solvent Reorganization approved by the Manager. In connection
with any such public offering and sale of any ordinary shares or common stock of any Subsidiary of the Company, the
Company shall liquidate into such Subsidiary or take other appropriate action to distribute the securities of such Sub-
sidiary.
M. Definitions
Art. 32. For purposes of these articles of incorporation:
«Affiliate» of a Person means any other Person, entity or investment fund controlling, controlled by or under com-
mon control with the Person and, in the case of a Person which is a partnership or a limited liability company, any partner
or member, respectively, of the Person.
«Applicable Premium» means, subject to the terms of any separate written agreement among the Company and some
or all of its shareholders, a premium to be paid in connection with any redemption of Class P Ordinary Shares, other
than the mandatory redemption of the Class P Ordinary Shares on December 31, 2007. Such redemption premium shall
be equal to 13.5% of the sum of (i) the aggregate Unpaid Preferred Yield and (ii) the aggregate Unreturned Preference
Amount, in each case on any such Class P Ordinary Share so redeemed, subject in any event to the elimination of such
premium pursuant to the terms of any separate written agreement among the Company and some or all of its share-
holders.
«Change of Control» means (i) any sale or transfer by the Company or its Subsidiaries of all or substantially all (as
defined in the Revised Model Business Corporation Act) of their assets on a consolidated basis, (ii) any consolidation,
merger or reorganization of the Company with or into any other entity or entities as a result of which the holders of
the Company’s outstanding capital stock (including, for purposes of determining whether a Change of Control has oc-
curred, any of their respective affiliated investment funds or any other Affiliate thereof) possessing the voting power
(under ordinary circumstances) to elect a majority of the board of directors (or equivalent managing body) immediately
prior to such consolidation, merger or reorganization cease to own the outstanding capital stock of the surviving cor-
poration possessing the voting power (under ordinary circumstances) to elect a majority of the surviving corporation’s
board of directors (or equivalent managing body) or (iii) issuance by the Company or sale or transfer to any third party
of shares of the Company’s capital stock by the holders thereof as a result of which the holders of the Company’s out-
standing capital stock (including, for purposes of determining whether a Change of Control has occurred, any of their
respective affiliated investment funds or any other Affiliate thereof) possessing the voting power (under ordinary cir-
cumstances) to elect a majority of the board of directors (or equivalent managing body) immediately prior to such sale
or transfer cease to own the outstanding capital stock of the Company possessing the voting power (under ordinary
circumstances) to elect a majority of the board of directors (or equivalent managing body).
«Company Group» means the Company and its Subsidiaries.
«Company Securities» means any securities (including any convertible preferred equity certificates) of the Company
or any of its Subsidiaries (including any securities of one class exchanged for any securities of another class), other than
(a) any securities issued in exchange for the equity securities issued pursuant to any senior subordinated loan agreement
which may have been entered into among certain Affiliates of the Company and certain of the Golden Gate Security-
holders, as the same may be amended, modified or restated from time to time, (b) any securities issued in exchange for
the equity securities issued pursuant to any share purchase agreements which may have been entered into, respectively,
among INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo LTD. and the purchasers named therein, (c) any Class P Ordinary Shares,
(d) any Class L-1 Ordinary Shares or (e) any Class M Ordinary Shares.
«CPECs» means the Series A CPECs, the Series B CPECs, the Series C CPECs, the Series D CPECs, the Series L
CPECs, the Series L-1 CPECs, Series M CPECs, Series P CPECs and any other series of convertible preferred equity
certificates that may be authorized and issued by the Company from time to time.
«Distribution» means each dividend or distribution made by the Company to the holders of Ordinary Shares (includ-
ing such Ordinary Shares issuable upon conversion of any CPECs), whether in cash, property, or securities of the Com-
pany and whether by dividend, liquidating distribution or otherwise; provided that neither of the following shall be a
Distribution: (a) any redemption, conversion or purchase by the Company of any Ordinary Shares or CPECs for any
reason solely from the Company’s or its Subsidiaries’ former employees, directors or consultants or (b) any recapital-
ization or exchange of any Ordinary Shares, or any consolidation or division (by way of stock split, stock dividend or
otherwise) or any combination (by way of stock split, stock dividend or otherwise) of any Ordinary Shares.
«Equivalent Class D Ordinary Shares» means, as of any date of determination, the total number of Class D Ordinary
Shares held by such holder multiplied by a fraction, the numerator of which is the total number of issued Class D Or-
dinary Shares minus the total number of issued Class C Ordinary Shares (provided the numerator shall be zero if such
value is negative), and the denominator of which is the total number of issued Class D Ordinary Shares.
«Event of Default» means any of the following events: (1) the Company shall fail to pay any amount due and owing
with respect to the Class P Ordinary Shares, when the same becomes due and payable; or (2) any default or event of
default shall have occurred under any indebtedness of the Company or any of its Subsidiaries resulting in the acceleration
of such indebtedness, whether by having become due and payable by its terms or by having been declared due and pay-
able prior to its stated maturity; or (3) the Company or the Manager, as the case may be, shall fail or neglect to perform,
keep or observe the provisions of any of Articles 20-25 or any term or condition of any separate written agreement
among the Company and the holders of Class P Ordinary Shares in their capacity as such; or (4) one or more judgments
or decrees shall be entered against the Company or any of its Subsidiaries involving a liability (to the extent not ade-
43461
quately paid or covered by insurance) in excess of USD 2,500,000 in aggregate for all such judgments and decrees and
all such judgments or decrees shall not have been vacated, discharged or stayed or bonded pending appeal within sixty
(60) days from the entry thereof; or (5) a Change of Control shall have occurred.
«Five Times Target Return» means the actual receipt by each Golden Gate Securityholder of cash payments with
respect to and/or in exchange for its Company Securities (whether such payments are received from the Company or
a third party, but excluding, for avoidance of doubt, any fees or other amounts paid or payable to the Golden Gate
Securityholders or their affiliates or any Distribution made pursuant to Article 19(f)) equal to five times such Golden
Gate Securityholder’s aggregate investment in Company Securities. For purposes hereof, the «investment» of the Gold-
en Gate Securityholders means the aggregate purchase price originally paid to the Company or its predecessors for all
Company Securities. A determination will be made hereunder each time a Golden Gate Securityholder actually receives
cash payments with respect to and/or in exchange for its Company Securities, and each Golden Gate Securityholder
will cooperate with the Company and provide the Company with all reasonably requested information to determine
whether the Five Times Target Return has been achieved.
«General Partner» means INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo S.A.
«Golden Gate Securityholders» means, for so long as they are shareholders of the Company, any investment fund
managed by Golden Gate Capital and any of their respective transferees of any shares.
«Independent Third Party» means any Person who (together with its Affiliates), immediately prior to the contemplat-
ed transaction, does not own in excess of ten percent (10%) of the Ordinary Shares on a fully-diluted basis (assuming
conversion of all then outstanding CPECs) (a «10% Owner»), who is not controlling, controlled by or under common
control with any such 10% Owner and who is not the spouse, descendant (by birth or adoption), parent or dependent
of any such 10% Owner or a trust for the benefit of such 10% Owner and/or such other Persons.
«Insolvent» means that (i) the aggregate amount of the Company’s obligations exceeds the then fair market value of
the Company’s assets, or (ii) the Company is unable to pay its obligations as they mature, to the extent that the Com-
pany would not already be considered insolvent under article 437 of the Luxembourg Commercial Code.
«IPO» means an initial public offering and sale of the shares of the Company or any of its Subsidiaries pursuant to an
effective registration statement under the United States Securities Act of 1933, as amended, or any similar law of any
other jurisdiction.
«L-1 Catchup Return» means the receipt by the holders of Ordinary Shares other than the Class M Ordinary Shares,
Class L-1 Ordinary Shares and Class P Ordinary Shares of Distributions pursuant to Article 19(h), 19(j) and 19(l) equal
to the sum of (A) the product of (i) USD 17,321 (as proportionally adjusted for all stock splits, stock dividends and other
recapitalizations affecting the Ordinary Shares) multiplied by (ii) the number of Ordinary Shares other than the Class P
Ordinary Shares, Class M Ordinary Shares, Class L-1 Ordinary Shares and the Class C Ordinary Shares issued and out-
standing (assuming the conversion in full of all CPECs) as of the date that the determination of whether the L-1 Catchup
Return has been achieved is made plus (B) the amount such holders would have been entitled to receive pursuant to
Articles 19(h), 19(j) and 19(l) assuming (i) no prior Distributions had been paid pursuant to Article 19(d) (and that such
amounts were further distributed pursuant to Article 19(e) through 19(m) hereof), (ii) that the holders of Class M Or-
dinary Shares and Class L-1 Ordinary Shares were then eligible to participate in Distributions pursuant to Article 19(h),
19(j) and 19(l) ratably based upon the number of Class M Ordinary Shares and Class L-1 Ordinary Shares held by such
holders (it being understood that, in fact, no holder of Class M Ordinary Shares or Class L-1 Ordinary Shares shall be
entitled to participate in the L-1 Catchup Return) and (iii) the Distribution pursuant to Articles 19(h), 19(j) and 19(l)
continued only until and to the extent that the holders of the Class L-1 Ordinary Shares received an amount pursuant
to such Distribution equal to the amount of the Distribution that was actually made pursuant to Article 19(d).
«Legally Available Funds» means the amount available for distributions, as defined by article 72-1 of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended from time to time.
«Limited Partner(s)» means the limited partner(s) from time to time of the Company.
«Majority Golden Gate Securityholders» means the holders of more than 50% of the aggregate Class P Ordinary
Shares then outstanding held by the Golden Gate Securityholders.
«Majority Summit Securityholders» means the holders of more than 50% of the aggregate Class P Ordinary Shares
then outstanding held by the Summit Securityholders.
«Mandatory Redemption Date» means December 31, 2007.
«Original Cost» of each Class M Ordinary Share, each Class L-1 Ordinary Share and each Class L Share shall be equal
to the purchase price originally paid to the Company or its predecessor in interest therefor (as proportionally adjusted
for all stock splits, stock dividends, share exchanges and other recapitalizations affecting the Class M Ordinary Shares,
the Class L-1 Ordinary Shares and the Class L Ordinary Shares).
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock
company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization or other entity, or a government or any branch, de-
partment, agency, political subdivision or official thereof.
«Preference Amount» of any Class P Ordinary Share shall be equal to USD 1,000 (as proportionally adjusted for all
share splits, share dividends and other recapitalizations affecting the Class P Ordinary Shares).
«Preferred Yield» means, with respect to each Class P Ordinary Share, the amount accruing on such Ordinary Share
(from the original date of issuance of such share or any security exchanged for such Class P Ordinary Share) each day
during such quarter at the rate of 18.5% per annum compounded on the last day of each calendar quarter on the sum
of (a) such Ordinary Share’s Unreturned Preference Amount, plus (b) Unpaid Preferred Yield thereon for all prior quar-
ters; provided that, upon the occurrence of any Event of Default, the Preferred Yield shall increase immediately by an
increment of two percentage points (2%), and any such 2% increase of the Preferred Yield therefrom shall cease as of
the close of business on the date on which the Event of Default ceases to exist, subject to subsequent increases as a
43462
result of the occurrence (or re-occurrence) of any subsequent Event of Default. In calculating the amount of any pay-
ment to be made in connection with any redemption of a Class P Ordinary Share during a calendar quarter, the portion
of a Class P Ordinary Share’s Preferred Yield for such portion of such quarter elapsing before such redemption payment
is made shall be taken into account.
«Primary Yield» means, with respect to each Class L-1 Ordinary Share for each calendar quarter, the amount accruing
on such share (from the original date of issuance of such share or any security exchanged for such Class L-1 Ordinary
Share) each day during such quarter at the rate of 12.5% per annum of the sum of (i) such share’s Unreturned Original
Cost, plus (ii) Unpaid Primary Yield thereon for all prior quarters. In calculating the amount of any Distribution to be
made during a calendar quarter, the portion of a Class L-1 Ordinary Share’s Primary Yield for such portion of such quar-
ter elapsing before such Distribution is made shall be taken into account.
«Secondary Yield» means, with respect to each Class L-1 Ordinary Share for each calendar quarter, the amount ac-
cruing on such share (from the original date of issuance of such share or any security exchanged for such Class L-1 Or-
dinary Share) each day during such quarter at the rate of 6% per annum of the sum of (i) such share’s Unreturned
Original Cost, plus (ii) Unpaid Secondary Yield thereon for all prior quarters. In calculating the amount of any Distribu-
tion to be made during a calendar quarter, the portion of a Class L-1 Ordinary Share’s Secondary Yield for such portion
of such quarter elapsing before such Distribution is made shall be taken into account.
«Series A CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series A) issued by the Company.
«Series B CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series B) issued by the Company.
«Series C CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series C) issued by the Company.
«Series D CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series D) issued by the Company.
«Series L CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series L) issued by the Company.
«Series L-1 CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series L-1) issued by the Company.
«Series M CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series M) issued by the Company.
«Series P CPECs» means the convertible preferred equity certificates (Series P) issued by the Company.
«Solvent Reorganization» means any solvent reorganization of the Company, the Manager or any Subsidiary of the
Company, including by merger, consolidation, recapitalization, transfer or sale of shares or assets, or contribution of
assets and/or liabilities, or any liquidation, exchange of securities, conversion of entity, migration of entity, formation of
new entity, or any other transaction or group of related transactions (in each case other than to or with a third party
that is not a member of the Company Group or its Affiliates (which may included an entity formed for the purpose of
such Solvent Reorganization)), in which:
(i) all holders of the same class or series of Ordinary Shares and CPECs are offered the same consideration in respect
of such Ordinary Shares and CPECs;
(ii) the pro rata indirect economic interests of the holders of Ordinary Shares and CPECs in the business of INFOR
GLOBAL SOLUTIONS AG, a limited liability company formed pursuant to the laws of Switzerland, and its Subsidiaries,
relative to each other and all other holders, directly or indirectly, of equity securities in the Company Group (other
than those held by entities within the Company Group), are preserved; and
(iii) the rights of the holders of Ordinary Shares and CPECs under any agreement between the Company and such
holders with respect to such Ordinary Shares and CPECs are preserved in all material respects (it being understood by
way of illustration and not limitation that the relocation of a covenant or restriction from one instrument to another
shall be deemed a preservation if the relocation is necessitated, by virtue of any law or regulations applicable to the
Company Group following such Solvent Reorganization, as a result of any change in jurisdiction or form of entity in
connection with the Solvent Reorganization; provided that such covenants and restrictions are retained in instruments
that are, as nearly as practicable and to the extent consistent with business and transactional objectives, equivalent to
the instruments in which such restrictions or covenants were contained prior to the Solvent Reorganization).
«Subsidiary» means with respect to any Person, any corporation, partnership, limited liability company, association
or other business entity of which (i) if a corporation, a majority of the total voting power of shares of stock entitled
(without regard to the occurrence of any contingency) to vote in the election of directors is at the time owned or con-
trolled, directly or indirectly, by that Person or one or more of the other Subsidiaries of that Person or a combination
thereof or (ii) if a partnership, association, limited liability company or other business entity, a majority of the partner-
ship, membership or other similar ownership interests thereof is at the time owned or controlled, directly or indirectly,
by any Person or one or more Subsidiaries of that Person or a combination thereof. For purposes hereof, a Person or
Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a partnership, association or other business entity if
such Person or Persons shall be allocated a majority of partnership, association or other business entity gains or losses
or shall be or control the managing director or general partner of such partnership, association or business entity.
«Summit Securityholders» means, for so long as they are securityholders of the Company, the following securityhold-
ers of the Company and any of their respective transferees of any Ordinary Shares of the Company: Summit Ventures
V, L.P.; Summit V Advisors Fund (QP), L.P.; Summit V Companion Fund, L.P.; Summit V Advisors Fund, L.P.; Summit
Investors III, L.P.; Randolph Street Partners; and Randolph Street Partners DIF, L.L.C.
«Three Times Target Return» means the actual receipt by each Golden Gate Securityholder of cash payments with
respect to and/or in exchange for its Company Securities (whether such payments are received from the Company or
a third party, but excluding, for avoidance of doubt, any fees or other amounts paid or payable to the Golden Gate
Securityholders or their affiliates or any Distribution made pursuant to Article 19(f)) equal to three times such Golden
Gate Securityholder’s aggregate investment in Company Securities. For purposes hereof, the «investment» of the Gold-
en Gate Securityholders means the aggregate purchase price originally paid to the Company or its predecessors for all
Company Securities. A determination will be made hereunder each time a Golden Gate Securityholder actually receives
cash payments with respect to and/or in exchange for its Company Securities, and each Golden Gate Securityholder
43463
will cooperate with the Company and provide the Company with all reasonably requested information to determine
whether the Three Times Target Return has been achieved.
«Unpaid Preference Amount» of any Class P Ordinary Share means an amount equal to the excess, if any, of (A) the
Preference Amount of such share, over (B) the aggregate amount of payments made by the Company that constitute a
return of Preference Amount of such share.
«Unpaid Preferred Yield» of any Class P Ordinary Share means an amount equal to the excess, if any, of (a) the ag-
gregate Preferred Yield accrued on such share, over (b) the aggregate amount of payments made by the Company that
constitute payment of Preferred Yield on such share.
«Unpaid Primary Yield» of any Class L-1 Ordinary Share means an amount equal to the excess, if any, of (a) the ag-
gregate Primary Yield accrued on such share, over (b) the aggregate amount of Distributions made by the Company that
constitute payment of Primary Yield on such share.
«Unpaid Secondary Yield» of any Class L-1 Ordinary Share means an amount equal to the excess, if any, of (a) the
aggregate Secondary Yield accrued on such share, over (b) the aggregate amount of Distributions made by the Company
that constitute payment of Secondary Yield on such share.
«Unpaid Yield» of any Class M Ordinary Share and any Class L Ordinary Share means an amount equal to the excess,
if any, of (a) the aggregate Yield accrued on such share, over (b) the aggregate amount of Distributions made by the
Company that constitute payment of Yield on such share.
«Unreturned Original Cost» of any Class M Ordinary Share, Class L-1 Ordinary Share and any Class L Ordinary Share
means an amount equal to the excess, if any, of (a) the Original Cost of such share, over (b) the aggregate amount of
Distributions made by the Company that constitute a return of Original Cost of such share.
«Yield» means, with respect to each Class M Ordinary Share and Class L Ordinary Share for each calendar quarter,
the amount accruing on such Ordinary Share (from the original date of issuance of such share or any security exchanged
for any such share) each day during such quarter at the rate of 12.5% per annum of the sum of (i) such share’s Unre-
turned Original Cost, plus (ii) Unpaid Yield thereon for all prior quarters. In calculating the amount of any Distribution
to be made during a calendar quarter, the portion of a such Ordinary Share’s Yield for such portion of such quarter
elapsing before such Distribution is made shall be taken into account.
N. Final dispositions - Applicable law
Art. 33. For all matters not governed by these articles of incorporation the parties shall refer to the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended.»
<i>Estimate of costsi>
For the purpose of registration the amount of USD 4,000,000.- is estimated at EUR 3,095,735.75.
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately thirty-five thousand
euro.
There being no further business, the meeting is closed.
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately six thousand two
hundred euros.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, these persons signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundfünf, den achten April.
Vor dem unterzeichneten Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Maît-
re Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg) welch Letzterer Verwahrer der vorliegenden Urkunde
bleibt.
Fand eine außerordentliche Versammlung der Aktionäre von INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II S.C.A., einer
société en commandite par actions mit eingetragenem Sitz in, rue Mathias Hardt 8-10, L-1717 Luxemburg (nachfolgend
die «Gesellschaft»), gegründet gemäß einer Urkunde des verhinderten Notars am 24. März 2005, welche noch nicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde, statt. Die Statuten der Gesellschaft wurden noch
nicht geändert.
Die Versammlung wurde um 18.00 Uhr mit Camille Bourke, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg, als Vorsitzen-
dem, eröffnet,
welcher als Sekretär Saskia Konsbruck, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg, ernannte.
Die Versammlung wählt Yasmin Gabriel, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg, zum Wahlprüfer.
Nachdem der Versammlungsvorstand hiermit eingesetzt wurde, erklärte der Vorsitzende Folgendes und ersuchte
den Notar zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1) Einführung von acht neuen Aktienkategorien, aufgeteilt in Klasse M-Stammaktien, Klasse L-1-Stammaktien, Klasse
P-Stammaktien, Klasse L-Stammaktien, Klasse A-Stammaktien, Klasse B-Stammaktien, Klasse C-Stammaktien und Klasse
D-Stammaktien.
43464
2) Erhöhung des Aktienkapitals um dreihundertsiebenundsiebzigtausendvierhundertzweiundachtzig US Dollar (USD
377.482,-), vom gegenwärtigen Betrag von fünfundvierzigtausend US Dollar (USD 45.000,-) auf einen Betrag von vier-
hundertzweiundzwanzigtausendvierhundertzweiundachtzig US Dollar (USD 422.482,-) durch die Ausgabe von hunder-
tachtundachtzigtausendsiebenhunderteinundvierzig (188.741) neuen Klasse M-Stammaktien, mit einem Nennwert von
zwei US Dollar (USD 2,-) pro Aktie.
3) Reduktion des Aktienkapitals auf dreihundertsiebenundsiebzigtausendvierhundertvierundachtzig US Dollar (USD
377.484,-) durch Annullierung der zweiundzwanzigtausendvierhundertneunundneunzig (22.499) Stammaktien, die durch
die Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung ausgegeben wurden.
4) Anschließende vollständige Neufassung der Statuten der Gesellschaft, ohne Änderung des Gesellschaftszwecks
oder der Rechtsform der Gesellschaft.
5) Sonstiges.
II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer
Aktien sind in der Anwesenheitsliste aufgeführt; diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre und vom Vorstand der Aktionärsversammlung unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden
Urkunde beigefügt und gleichzeitig mit ihr bei der Registrierungsbehörde eingereicht. Die Vollmachten der vertretenen
Aktionäre, die ne varietur von den betreffenden Parteien unterzeichnet wurden, werden ebenfalls der vorliegenden Ur-
kunde beigefügt.
III. Das gesamte Aktienkapital, das auf der gegenwärtigen Sitzung anwesend ist oder vertreten wird, sowie alle anwe-
senden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie fristgerecht vor dieser Versammlung über die Tagesordnung in-
formiert wurden und keine Einladung notwendig war.
IV. Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Aktienkapital repräsentiert, wurde ordnungsgemäß einberufen
und ist berechtigt, sämtliche Tagesordnungspunkte rechtskräftig zu beschließen.
Die ersten drei Beschlüsse werden von INFOR GLOBAL SOLUTIONS TOPCO S.A., GOLDEN GATE SHARE CA-
PITAL INVESTMENT FUND II (BVI), L.P. und CCG INVESTMENTS (BVI), L.P., den gegenwärtigen Aktionären der Ge-
sellschaft, gefasst. Der dritte, vierte und fünfte Beschluss wird von den gegenwärtigen Aktionären sowie allen anderen
natürlichen oder juristischen Personen gefasst, die nach Annahme des dritten Beschlusses Aktionäre der Gesellschaft
werden.
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, acht neue Aktienkategorien einzuführen, die in Klasse M-Stammaktien, Klasse L-
1-Stammaktien, Klasse P-Stammaktien, Klasse L-Stammaktien, Klasse A-Stammaktien, Klasse B-Stammaktien, Klasse C-
Stammaktien und Klasse D Stammaktien unterteilt sind.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, das Aktienkapital um einen Betrag von dreihundertsiebenundsiebzigtausendvier-
hundertzweiundachtzig US Dollar (USD 377.482,-) vom gegenwärtigen Betrag von fünfundvierzigtausend US Dollar
(USD 45.000,-) auf einen Betrag von vierhundertzweiundzwanzigtausendvierhundertzweiundachtzig US Dollar (USD
422.482,-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von hundertachtundachtzigtausendsiebenhunderteinundvierzig (188.741)
neuen Klasse M-Stammaktien, mit einem Nennwert von zwei US Dollar (USD 2,-) pro Aktie.
Die bestehenden Aktionäre haben soweit dies erforderlich ist auf ihr Vorzugsrecht verzichtet und die neuen Aktien
wurden wie folgt gezeichnet:
Fünfzehntausendvierhundertfünfundfünfzig (15.455) Klasse M Stammaktien wurden von CCG INVESTMENT (BVI)
L.P. gezeichnet, einer Gesellschaft nach dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in One Embarcadero Center, 33rd
Floor, San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Siebenhundertsiebenundsiebzig (777) Klasse M Stammaktien wurden von CCG ASSOCIATES - QP, L.L.C., gezeich-
net, einer Gesellschaft nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco,
CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zweiundsiebzig (72) Klasse M Stammaktien wurden von CCG ASSOCIATES-AI, L.L.C. gezeichnet, einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Fran-
cisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zweihundertsieben (207) Klasse M Stammaktien wurden von CCG INVESTMENT FUND-AI, L.P. gezeichnet, einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarcadero Center, 33rd Floor,
San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Hundertelftausendvierhundertundzwölf (111.412) Klasse M Stammaktien wurden von GOLDEN GATE CAPITAL IN-
VESTMENTS II (BVI), L.P. gezeichnet, ein limited partnership nach dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in One
Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Einunddreißigtausenddreihundertvierundvierzig (31.344) Klasse M Stammaktien wurden von GOLDEN GATE CAPI-
TAL INVESTMENTS II-A ADJUNCT (BVI), L.P. gezeichnet, ein limited partnership nach dem Recht der British Virgin
Islands, mit Sitz in One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zweitausendsiebenhundertachtundsiebzig (2.778) Klasse M Stammaktien wurden von GOLDEN GATE CAPITAL IN-
VESTMENTS II (AI), L.P. gezeichnet, ein limited partnership nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarcadero
Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Siebenhundertzweiundachtzig (782) Klasse M Stammaktien wurden von GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS
II A (AI), L.P. gezeichnet, ein limited partnership nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarcadero Center,
33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
43465
Dreitausenddreihundertvierzehn (3.314) Klasse M Stammaktien wurden von GOLDEN GATE CAPITAL INVEST-
MENT FUND II-QP, L.L.C gezeichnet, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit
Sitz in One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zweiundfünfzig (52) Klasse M Stammaktien wurden von GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENT FUND II-AI,
L.L.C. gezeichnet, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarca-
dero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Viertausenddreizehn (4.013) Klasse M Stammaktien wurden von CCG AV, L.L.C. - Series C gezeichnet, eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarcadero Center, 33rd Floor, San
Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Eintausendvierhundertdreiundsiebzig (1.473) Klasse M Stammaktien wurden von CCG AV, L.L.C. - Series D gezeich-
net, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarcadero Center,
33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
Neunhundertvierundvierzig (944) Klasse M Stammaktien wurden von CCG AV, L.L.C. - Series I gezeichnet, eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit Sitz in One Embarcadero Center, 33rd Floor,
San Francisco, CA 94111, Vereinigte Staaten von Amerika,
alle rechtmäßig vertreten durch Yasmin Gabriel, aufgrund einer Vollmacht, die am 5. April 2005 in San Francisco aus-
gestellt wurde;
Die so gezeichneten Aktien wurden durch eine Bareinlage von drei Millionen sechshundertachtundfünfzigtausendvier-
hundertneunundzwanzig US Dollar und neunundzwanzig Cent (USD 3.658.429,29) vollständig bezahlt.
Zwölftausenddreihundertvierzehn (12.314) Klasse M Stammaktien wurden von SUMMIT VENTURES V, L.P., L.P. ge-
zeichnet, einem limited partnership nach dem Recht von Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit eingetragenem
Sitz in 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, Vereinigte Staaten von Amerika,
Achthunderteinunddreißig (831) Klasse M Stammaktien wurden von SUMMIT V ADVISORS FUND (QP) L.P. gezeich-
net, einem limited partnership nach dem Recht von Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit eingetragenem Sitz
in 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zweitausendeinhundertzweiundneunzig (2.192) Klasse M Stammaktien wurden von SUMMIT V COMPANION
FUND L.P. gezeichnet, einem limited partnership nach dem Recht von Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit
eingetragenem Sitz in 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zweihundertvierundfünfzig (254) Klasse M Stammaktien wurden von Summit V ADVISORS FUND L.P. gezeichnet,
einem limited partnership nach dem Recht von Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit eingetragenem Sitz in
222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, Vereinigte Staaten von Amerika,
Fünfhundertsiebenundzwanzig (527) Klasse M Stammaktien wurden von SUMMIT INVESTORS III FUND L.P. gezeich-
net, einem limited partnership nach dem Recht von Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit eingetragenem Sitz
in 222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, MA 02116, Vereinigte Staaten von Amerika,
alle rechtmäßig vertreten durch Yasmin Gabriel, aufgrund einer Vollmacht, die am 5 April 2005 in San Francisco, Ver-
einigte Staaten von Amerika ausgestellt wurde;
Die so gezeichneten Aktien wurden durch eine Bareinlage von dreihunderteinundvierzigtausendfünfhundertsiebzig
US Dollar und einundsiebzig Cent (USD 341.570,71) vollständig bezahlt
Die gesamte Einlage besteht aus vier Millionen US Dollar (USD 4.000.000,-), wobei dreihundertsiebenundsiebzigtau-
sendvierhundert-zweiundachtzig US Dollar (USD 377.482,-) dem Aktienkapital der Gesellschaft, und drei Millionen
sechshundertzweiundzwanzigtausendfünfhundertachtzehn US Dollar (USD 3.622.518,-) einem Aktienprämienkonto zu-
gewiesen werden.
Der Nachweis des Bestehens und des Werts der Einlage wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
Die Hauptversammlung bevollmächtigt, Herrn Pierre Beissel, Frau Camille Bourke, oder Frau Yasmin Gabriel, alle
maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, individuell handlungsfähig, das Aktienregister der Gesellschaft entsprechend
der oben genannten Kapitalerhöhung ordnungsgemäß zu ändern.
Nach der hier genannten Kapitalerhöhung treten die neuen Aktionäre der Gesellschaft der Versammlung bei und neh-
men an den Abstimmungen zu den Beschlüssen 3) bis 5) teil:
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, das Aktienkapital von vierhundertzweiundzwanzigtausendvierhundertzwei-
undachtzig US Dollar (USD 422.482,-) auf einen Betrag von dreihundertsiebenundsiebzigtausendvierhundertvie-
rundachtzig US Dollar (USD 377.484,-) zu reduzieren, durch Annullierung der zweiundzwanzigtausend-
vierhundertneunundneunzig (22.499) Stammaktien, die durch die Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung ausgegeben
wurden und Rückzahlung an die Aktionäre der Gesellschaft von einem Betrag in Höhe von vierundvierzigtausendneun-
hundertachtundneunzig US Dollar (USD 44.998,-).
<i>Vierter Beschlussi>
Nach Annahme der oben genannten Beschlüsse beschließt die Hauptversammlung, die Statuten der Gesellschaft voll-
ständig neu zu formulieren, ohne den Gesellschaftszweck oder die Rechtsform der Gesellschaft zu ändern. Die Statuten
lauten nunmehr wie folgt:
A. Name - Eingetragener Sitz - Dauer - Ziel
Art. 1. Hiermit wird durch die Zeichner und alle zukünftigen Zeichner der Aktien eine Gesellschaft mit der Rechts-
form einer société en commandite par actions unter dem Namen INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II (nachfolgend
die «Gesellschaft»), gegründet.
43466
Art. 2. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der eingetragene Sitz der
Gesellschaft kann aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführers (wie in Artikel 8 definiert) innerhalb des gleichen Or-
tes verlegt werden. Zur Verlegung an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg ist eine Hauptversammlung
der Aktionäre notwendig. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder andere Geschäftsstellen können auf
Grundlage einer Entscheidung des Geschäftsführers im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
Wenn der Geschäftsführer feststellt, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen
eingetreten sind oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die
Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland behindern würden, kann der eingetragene Sitz bis zum
Ende der außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; diese temporären Maßnahmen ha-
ben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die auch bei einer zeitweiligen Verlegung des eingetragenen
Sitzes eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Gesellschaftszweck ist der Besitz von Beteiligungen in jedweder Form an luxemburgischen und an ausländi-
schen Gesellschaften und anderen Investitionsformen, der Erwerb von Wertpapieren jedweder Form in Form von Kauf,
Zeichnung oder Sonstigem sowie die Veräußerung von Wertpapieren jedweder Form durch Verkauf, Austausch oder
Sonstigem und die Verwaltung, Steuerung und Entwicklung seines Portfolios.
Die Gesellschaft kann außerdem den Gesellschaften, an denen es direkt oder indirekt beteiligt ist oder die zur glei-
chen Gesellschaftergruppe wie die Gesellschaft gehören, Darlehen zusichern oder gewähren und sie anderweitig unter-
stützen.
Die Gesellschaft kann kommerzielle, industrielle oder finanzielle Aktivitäten ausführen, die zur Erfüllung seines
Zwecks nützlich erscheinen.
B. Haftung der Aktionäre
Art. 5. Der Persönlich Haftende Gesellschafter (associé commandité) ist für alle Verbindlichkeiten, die nicht durch
die Aktiva der Gesellschaft beglichen werden können, gesamtschuldnerisch haftbar. Der oder die Kommanditisten als
Inhaber von Stammaktien dürfen auf keine Art und Weise im Namen der Gesellschaft handeln, ausgenommen in Aus-
übung ihrer Rechte als Aktionäre auf Hauptversammlungen. Sie sind nur bis zum Maße ihrer Einlagen in die Gesellschaft
haftbar.
C. Aktienkapital - Aktien
Art. 6. Gesellschaftskapital
(a) Die Gesellschaft verfügt über ein Aktienkapital von dreihundertsiebenundsiebzigtausendvierhundertvierundacht-
zig US-Dollar (USD 377.484,-), eingeteilt in (i) einhundertachtundachtzigtausendsiebenhunderteinundvierzig (188.741)
Aktien, als «Klasse M-Stammaktien» bezeichnet, mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,00) pro Aktie und (ii)
eine (1) eine (1) Geschäftsführungsaktie, als «Geschäftsführungsaktie» bezeichnet, mit einem Nennwert von zwei US-
Dollar (USD 2,-).
(b) Das bewilligte Kapital, einschließlich des ausgegebenen Aktienkapitals, wird auf zwei Milliarden US-Dollar (USD
2.000.000.000,-) festgelegt, bestehend aus einer Milliarde (1.000.000.000) Stammaktien mit einem Nennwert von zwei
US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie, eingeteilt wie folgt:
(i) «Klasse M Stammaktien», mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie,
(ii) «Klasse L-1-Stammaktien», mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie,
(iii) «Klasse P-Stammaktien», mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie,
(iv) «Klasse L-Stammaktien», mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie,
(v) «Klasse A-Stammaktien», mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie,
(vi) «Klasse B-Stammaktien», mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie,
(vii) «Klasse C-Stammaktien», mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie, und
(viii) «Klasse D-Stammaktien», mit einem Nennwert von zwei US-Dollar (USD 2,-) pro Aktie.
Auf die Stammaktien der Klassen M, L-1, P, L, A, B, C und D wird im Folgenden als «Stammaktie» bzw. «Stammaktien»
Bezug genommen. Auf die Stammaktien und die Geschäftsführungsaktie wird im Folgenden als «Aktie» bzw. «Aktien»
Bezug genommen.
Innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab der Veröffentlichung dieser Gründungsurkunde ist der Geschäftsführer
der Gesellschaft hiermit bevollmächtigt, Stammaktien auszugeben und Vorkaufsrechte für Stammaktien zu gewähren,
und zwar an die Personen und unter den Bedingungen, die er für geeignet hält. Insbesondere kann eine solche Ausgabe
erfolgen, ohne dass bestehenden Aktionären ein Vorkaufsrecht zur Zeichnung der ausgegebenen Klasse M Stammaktien
eingeräumt werden muss. Das gezeichnete Kapital und das bewilligte Kapital der Gesellschaft können auf Grundlage ei-
nes Aktionärsbeschlusses, der entsprechend der Bestimmungen zur Änderung dieser Gründungsurkunde beschlossen
wurde, erhöht oder herabgesetzt werden.
(c) Innerhalb des bewilligten Kapitals ist der Geschäftsführer berechtigt, das Vorkaufsrecht auf Aktien der Gesellschaft
zu entziehen, sofern dies nicht anders in einem gesonderten schriftlichen Vertrag zwischen der Gesellschaft und dem
betreffenden Aktionär vereinbart wurde. Die Gesellschaft kann in dem vom Gesetzgeber zugelassenen Maße und zu den
gesetzlich festgelegten Bedingungen seine eigenen Aktien zurückkaufen, vorausgesetzt dass (i) jeder Rückkauf zu dem an
diesem Zeitpunkt geltenden fairen Marktwert solcher Aktien erfolgt und (ii) jeder Rückkauf einer besonderen Klasse
von Aktien auf einer pro-rata Basis der Anzahl der ausgegebenen Aktien solcher Klasse erfolgt.
Art. 7. Alle Aktien der Gesellschaft werden nur als Namensaktien ausgegeben.
Im eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Aktionärsregister geführt, das von jedem Aktionär eingesehen werden
kann. Das Verzeichnis enthält die genaue Beschreibung des Aktionärs und gibt die Anzahl der gezeichneten Aktien, die
43467
für die Aktien geleisteten Zahlungen sowie die Veräußerungen von Aktien und deren Datum an. Jeder Aktionär ist ver-
pflichtet, der Gesellschaft seine Adresse oder Änderungen derselben per Einschreiben mitzuteilen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, auf die so zuletzt mitgeteilte Adresse zu vertrauen.
Bescheinigungen dieser Eintragungen können auf Antrag des betreffenden Aktionärs vom Geschäftsführer ausgestellt
und unterzeichnet werden. Diese Unterschriften können entweder per Hand, in Druck oder als Kopie geleistet werden.
Das Eigentum der Namensaktien resultiert aus den Eintragungen im Aktionärsregister.
Innerhalb einer Dauer von zehn Jahren nach Veröffentlichung dieser Satzung, darf kein Aktionär der Gesellschaft sein
(juristisches oder Nutzungs-) Recht an den Aktien der Gesellschaft verkaufen, übertragen, abtreten, verpfänden oder
anderweitig veräußern (egal ob direkt oder indirekt, mit oder ohne Gegenleistung, freiwillig oder unfreiwillig oder kraft
Gesetzes), außer gemäß und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung
zwischen der Gesellschaft und dem betreffenden Aktionär oder mit Zustimmung des Geschäftsführers.
Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die vom Übertragenden
und vom Erwerber oder deren Handlungsbevollmächtigten datiert und unterzeichnet wurde und in das Aktionärsregi-
ster eingetragen wird. Die Übertragung von Aktien kann ebenfalls im Einklang mit den Bestimmungen für die Übertra-
gung von Forderungen nach Art. 1690 des Luxemburger Bürgerlichen Gesetzbuches erfolgen. Außerdem kann die
Gesellschaft eine Übertragung akzeptieren und in das Aktionärsregister eintragen, die durch Briefe oder andere Doku-
mente belegt wird, die die Zustimmung des Übertragenden und des Erwerbers bestätigen.
Die Aktionäre geben der Gesellschaft eine Adresse an, an die alle Benachrichtigungen und Ankündigungen gesendet
werden. Diese Adresse wird ebenfalls in das Aktionärsregister eingetragen. Aktionäre können ihre im Aktionärsregister
eingetragene Adresse jederzeit durch eine schriftliche Benachrichtigung an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder
eine andere von der Gesellschaft angegebene Adresse ändern.
Die Geschäftsführungsaktie des Geschäftsführers ist nicht übertragbar, ausgenommen an den Nachfolger des Ge-
schäftsführers, der im Einklang mit Artikel 8 dieser Statuten ernannt wurde.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Wenn sich eine oder mehrere Aktien in Gemeinschaftsei-
gentum befinden oder das Eigentum der Aktie(n) umstritten ist, müssen alle Personen, die Ansprüche auf diese Aktie(n)
geltend machen, einen einzigen Vertreter ernennen, der diese Aktie(n) vor der Gesellschaft vertritt. Wenn dieser Ver-
treter nicht ernannt wird, werden alle Rechte, die mit dieser Aktie (diesen Aktien) verbunden sind, ausgesetzt.
D. Geschäftsführung
Art. 8. Die Geschäftsführung der Gesellschaft übernimmt INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo S.A., eine société
anonyme nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in seiner Eigenschaft als Persönlich Haftender Gesellschaf-
ter (associé commandité) und einziger Geschäftsführer der Gesellschaft (nachfolgend, der «Geschäftsführer»).
Im Falle von Geschäftsunfähigkeit, Konkurs oder einer anderen dauerhaften Situation, die den Geschäftsführer daran
hindert, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen, wird die Gesellschaft nicht sofort aufgelöst und liquidiert, sofern der
Aufsichtsrat nach Artikel 11 dieser Statuten einen Verwalter, der kein Aktionär sein muss, bestimmt, um dringliche Auf-
gaben der Geschäftsführung auszuführen, bis eine Hauptversammlung der Aktionäre stattgefunden hat, die dieser Ver-
walter innerhalb von fünfzehn Tagen nach seiner Ernennung einberufen muss. Auf dieser Hauptversammlung können die
Aktionäre entsprechend des Quorums und der Mehrheitsanforderungen zur Änderung der Gründungsurkunde einen
Nachfolger des Geschäftsführers ernennen. Wenn diese Ernennung nicht erfolgt, wird die Gesellschaft aufgelöst und
liquidiert.
Die Ernennung eines Nachfolgers des Geschäftsführers auf Grundlage dieses Artikels 8 muss nicht vom Geschäfts-
führer genehmigt werden.
Art. 9. Dem Geschäftsführer wird die größtmögliche Befugnis erteilt, alle Handlungen zur Verwaltung und Veräuße-
rung im Rahmen des genannten Gesellschaftszweckes auszuführen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch diese Statuten der Hauptversammlung der Aktionäre
oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, unterliegen der Befugnis des Geschäftsführers.
Art. 10. Die Gesellschaft ist gebunden durch die Unterschrift des Geschäftsführers, vertreten durch ordnungsgemäß
ernannte Vertreter, oder durch die Unterschrift(en) anderer Personen, an die der Geschäftsführer die Zeichnungsbe-
fugnis nach seinem Ermessen abgegeben hat.
E. Aufsicht
Art. 11. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, insbesondere ihre Buchführung und ihre Kon-
ten, werden von einem Conseil de Surveillance (dem «Aufsichtsrat») überwacht, der aus mindestens drei Mitgliedern
besteht. Für die Ausführung seiner Aufsichtspflicht besitzt der Aufsichtsrat die Befugnisse eines gesetzlichen Wirtschafts-
prüfers nach Art. 62 des Gesetzes vom 10. August 1915, über Handelsgesellschaften, in der geltenden Fassung. Der Ge-
schäftsführer kann sich mit dem Aufsichtsrat über von ihm bestimmte Angelegenheiten beraten. Der Aufsichtsrat
genehmigt Handlungen des Geschäftsführers, die gemäß Gesetzen, Verordnungen oder dieser Statuten die Befugnisse
des Geschäftsführers übersteigen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum,
der sechs Jahre nicht übersteigt, gewählt, und bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt wurden. Die Mitglieder des
Aufsichtsrates sind wiederwählbar und können durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit
mit oder ohne Grund abgewählt werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Aufsichtsrat wird von seinem Vorsitzenden oder vom Geschäftsführer einberufen. Eine Sitzung des Aufsichtsra-
tes muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Mitglieder dies fordern.
Eine Aufsichtsratssitzung muss allen Mitgliedern des Aufsichtsrates mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem für
diese Sitzung festgelegten Datum schriftlich mitgeteilt werden. Eine Ausnahme bilden Notfälle; in diesem Fall muss die
43468
Art des Notfalls in der Einladung zur Sitzung ausführlich dargelegt werden. Die Einladung muss Ort und Tagesordnung
der Sitzung enthalten. Auf diese Einladung kann durch Zustimmung in Schriftform, per Telegramm, Telex, Telefax oder
andere Kommunikationsmittel verzichtet werden, wobei die Vorlage einer Kopie ausreicht. Für Sitzungen, deren Ort
und Zeit in einem vom Aufsichtsrat angenommenen Terminkalender festgelegt sind, müssen keine gesonderten Einla-
dungen versendet werden.
Der Aufsichtsratsvorsitzende sitzt allen Sitzungen des Aufsichtsrates vor; in seiner Abwesenheit ernennt der Auf-
sichtsrat durch Mehrheitsbeschluss der auf der Sitzung anwesenden Mitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied zum
Vorsitzenden pro tempore. Jedes Mitglied kann für jede Sitzung ein anderes Mitglied als Stellvertreter ernennen; diese
Ernennung kann schriftlich, per Telegramm, Telex oder Telefax oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erfolgen,
wobei die Vorlage einer Kopie ausreicht. Ein Mitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann nur dann beraten oder rechtskräftig handeln, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend sind oder vertreten werden. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder ver-
tretenen Mitglieder gefasst.
Aufsichtsratsbeschlüsse müssen in einem Protokoll festgehalten und vom Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet wer-
den. Kopien von Auszügen aus diesen Protokollen, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden, müssen
in gültiger Form vom Sitzungsvorsitzenden oder zwei Mitgliedern unterzeichnet sein.
Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Aufsichtsrates angenommen und unterzeichnet wurden, haben
die selbe Wirksamkeit wie Beschlüsse, die auf einer Aufsichtsratssitzung gefasst wurden; jedes Mitglied muss einem sol-
chen Beschluss schriftlich, per Telegramm, Telex oder Telefax oder durch ähnliche Kommunikationsmittel zustimmen,
wobei die Vorlage einer Kopie ausreicht. Diese Zustimmung muss schriftlich bestätigt werden; alle diese Dokumente
zusammen bilden das Dokument, das belegt, dass dieser Beschluss gefasst wurde.
Alle Aufsichtsratsmitglieder können an allen Aufsichtsratssitzungen per Konferenzschaltung oder anderen Kommuni-
kationsmitteln teilnehmen, bei denen alle Teilnehmer einander hören können. Die Teilnahme an einer Sitzung über diese
Kommunikationsmittel entspricht der persönlichen Teilnahme an der Sitzung.
Art. 12. Verträge oder andere Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unter-
nehmen werden durch die Tatsache, dass der Geschäftsführer oder ein anderer Aktionär oder deren jeweilige angeglie-
derte Unternehmen oder einer oder mehrere ihrer jeweiligen Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Angestellten,
Handelsvertreter oder Vertreter an dieser Gesellschaft oder dieses Unternehmens beteiligt sind oder deren Geschäfts-
führer, Gesellschafter, Vorstandsmitglied oder Angestellte sind, nicht beeinträchtig oder außer Kraft gesetzt. Der Ge-
schäftsführer oder die Vorstandsmitglieder des Geschäftsführers der Gesellschaft, die als Geschäftsführer,
Vorstandsmitglieder oder Angestellte einer Gesellschaft oder eines Unternehmens, mit der die Gesellschaft Verträge
abschließt oder anderweitig Geschäfte tätigt, dürfen aufgrund dieser geschäftlichen Verbindung zu dieser Gesellschaft
oder diesem Unternehmen nicht von der Abstimmung oder von Handlungen in Bezug auf diese Verträge oder andere
Geschäfte ausgeschlossen werden.
F. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 13. Die Hauptversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die größten Befugnis-
se, jedwede Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, fortzusetzen oder zu genehmigen, un-
ter dem Vorbehalt, dass ihre Beschluss nur dann seine Gültigkeit erlangen, wenn der Geschäftsführer ihnen zugestimmt
hat, sofern nichts anderes in diesen Statuten festgelegt wurde.
Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft tritt zusammen, wenn sie vom Geschäftsführer oder vom Auf-
sichtsrat einberufen wird. Sie wird ebenfalls auf Antrag von Aktionären, die zusammen mindestens zwanzig Prozent
(20%) des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, durch den Geschäftsführer einberufen.
Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an
einem anderen Ort in Luxemburg, der in der Einladung angegeben wird, am ersten Montag im November um 10.00 Uhr
statt.
Wenn dieser Tag in Luxemburg auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, findet die Hauptversammlung am folgenden Lu-
xemburger Werktag statt.
Andere Hauptversammlungen der Aktionäre finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der jeweiligen Einladung
vermerkt sind. Die Hauptversammlungen der Aktionäre werden durch eine Mitteilung mit der Tagesordnung einberu-
fen, die jedem Aktionär der Gesellschaft per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an die
im Aktionärsregister angegebene Adresse zugesandt wird. Das Quorum und die Mehrheitsverhältnisse bei der Durch-
führung der Aktionärsversammlung entsprechen den gesetzlichen Regelungen, sofern hier nichts anderes festgelegt wur-
de.
Jede Aktie entspricht einer Stimme. Jeder Aktionär kann für jede Aktionärsversammlung eine andere Person als Stell-
vertreter ernennen; diese Ernennung kann schriftlich, per Telegramm, Telex oder Telefax oder durch andere Kommu-
nikationsmittel erfolgen, wobei die Vorlage einer Kopie ausreicht. Der Geschäftsführer kann alle übrigen Bedingungen
festlegen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, damit sie an den Aktionärsversammlungen teilnehmen können.
Wenn alle Aktionäre auf einer Aktionärsversammlung anwesend sind oder vertreten werden und erklären, dass sie mit
der Tagesordnung vertraut gemacht wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Ankündigung oder Bekanntma-
chung abgehalten werden.
G. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juni jeden Jahres (außer dem Gründungsjahr, das mit dem
Datum der Gesellschaftsgründung beginnt) und endet am 31. Mai des nächsten Jahres.
43469
Art. 15. Von den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) in gesetzlich vorgeschriebene
Rücklagen überführt. Die Rücklagenbildung wird beendet, wenn der Betrag der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen
zehn Prozent (10%) des gezeichneten Aktienkapitals beträgt. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf
Grundlage der Empfehlung des Geschäftsführers, wie über den Rest der jährlichen Nettogewinne verfügt wird. Vor-
schussdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
H. Änderung der Gründungsurkunde
Art. 16. Diese Statuten können vorbehaltlich der Zustimmung des Geschäftsführers von der Hauptversammlung der
Aktionäre gemäß der [im Gesetz vom 10. August 1915, über Handelsgesellschaften, neue Fassung, festgelegten Anfor-
derungen an Quorum und Mehrheiten geändert werden, sofern dies hier nicht anders festgelegt wurde.
I. Liquidation
Art. 17. Wenn die Gesellschaft aufgelöst wird, führen ein oder mehrere Liquidatoren (natürliche oder juristische
Personen) die Liquidation durch. Die Liquidatoren werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, die die
Auflösung beschlossen hat. Die Hauptversammlung legt ihre Befugnisse und ihr Entgelt fest. Im Falle einer freiwilligen
oder unfreiwilligen Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft werden die Aktiva der Gesellschaft, die zur
Verteilung zur Verfügung stehen, im gesetzlich zulässigen Maße in folgender Prioritätenreihenfolge aufgeteilt:
(a) als erstes an die Inhaber von Klasse M-Stammaktien nach Artikel 19(a) und 19(b),
(b) als zweites an die Inhaber von Klasse L-1-Stammaktien nach Artikel 19(c), 19(d) und 19(e),
(c) als drittes wird an die Inhaber von Klasse P-Stammaktien ein Betrag für jede gehaltenen Klasse P-Stammaktie aus-
gezahlt, der dem Betrag der nicht zurückgegebenen Vorzugsaktien plus der Nicht Gezahlten Vorzugsrendite jeder dieser
Klasse P-Stammaktien [plus, wenn notwendig, die Anwendbare Prämie, entspricht; vorausgesetzt, dass wenn die Aktiva,
die zur Verteilung an die Aktionäre mit Klasse P-Stammaktien zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, um diese Aktio-
näre mit der genannten Summe auszuzahlen, die zur Verfügung stehenden Aktiva an die Aktionäre mit Klasse P-Stamm-
aktien anteilig entsprechend der Anzahl der von ihnen gehaltenen Klasse P-Stammaktien verteilt werden, und
(d) als viertes an die Inhaber von Stammaktien nach Artikel 19(f) bis 19(m).
J. Dividenden
Art. 18. Der Geschäftsführer kann Vorschussdividenden für ausgegebene Stammaktien festsetzen und die Auszah-
lung der Dividenden aus den Mitteln der Gesellschaft, die hierfür nach dem Gesetz zur Verfügung stehen, genehmigen.
Die Mittel, die die Gesellschaft nach diesem Artikel 18 bezüglich eines Geschäftsjahres oder eines anderen Abrechnungs-
zeitraums verteilen kann, werden zur Auszahlung einer Dividende, die eine Ausschüttung darstellt und im Einklang mit
den Bestimmungen in Artikel 19 ausgezahlt wird, an jeden Stammaktionär verwendet.
Art. 19. Ausgenommen die in Artikel 17 bezüglich der Ausschüttung im Zusammenhang mit einer Liquidation, Auf-
lösung oder Abwicklung der Gesellschaft festgelegten Regelungen erfolgt eine Ausschüttung zum Zeitpunkt dieser Aus-
schüttung an die Inhaber von Klasse M-Stammaktien, Klasse L-1-Stammaktien, Klasse L-Stammaktien, Klasse A-
Stammaktien, Klasse B-Stammaktien, Klasse C-Stammaktien und Klasse D-Stammaktien in folgender Reihenfolge:
(a) Die Inhaber von Klasse M-Stammaktien als gesonderte Kategorie haben Anspruch auf den vollen Umfang oder
einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf Grundlage der gesamten
Nicht Gezahlten Rendite der Klasse M-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung
gehalten werden), die der gesamten Nicht Gezahlten Rendite auf die ausgegebenen Klasse M-Stammaktien zum Zeit-
punkt dieser Ausschüttung entspricht; bevor diese Ausschüttung des gesamten Betrages der zum Zeitpunkt dieser Aus-
schüttung Nicht Gezahlten Rendite auf die ausgegebenen Klasse M-Stammaktien nicht vollständig ausgezahlt wurde, wird
keine Ausschüttung oder teilweise Ausschüttung nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels
19 vorgenommen. Die Ausschüttung nach Artikel 19(a) an die Inhaber von Klasse M-Stammaktien stellt eine Rendite-
zahlung für Klasse M-Stammaktien dar.
(b) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß dem vorhergehenden Absatz dieses Artikels 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, haben die Inhaber von Klasse M-Stammaktien als gesonderte Kategorie Anspruch auf den
vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf Grund-
lage der gesamten Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen Kosten der Klasse M-Stammaktien, die von jedem dieser In-
haber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden), die den gesamten Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen
Kosten für die ausgegebenen Klasse M-Stammaktien zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung entspricht; bevor diese Aus-
schüttung des gesamten Betrages der zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen Ko-
sten für die ausgegebenen Klasse M-Stammaktien nicht vollständig ausgezahlt wurde, wird keine Ausschüttung oder
teilweise Ausschüttung nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels 19 vorgenommen. Die Aus-
schüttung nach Artikel 19(b) an die Inhaber von Klasse M-Stammaktien stellt eine Rückzahlung der Ursprünglichen Ko-
sten für Klasse M-Stammaktien dar.
(c) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, haben die Inhaber von Klasse L-1-Stammaktien als gesonderte Kategorie Anspruch auf den
vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf Grund-
lage der gesamten Nicht Gezahlten Primärrendite der Klasse L-1-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeit-
punkt dieser Ausschüttung gehalten werden), die der gesamten Nicht Gezahlten Primärrendite für die ausgegebenen
Klasse L-1-Stammaktien zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung entspricht; bevor diese Ausschüttung des gesamten Betra-
ges der zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung Nicht Gezahlten Primärrendite für die ausgegebenen Klasse L-1-Stammak-
tien nicht vollständig ausgezahlt wurde, wird keine Ausschüttung oder teilweise Ausschüttung nach einem anderen,
weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels 19 vorgenommen. Die Ausschüttung nach Artikel 19(c) an die Inhaber
von Klasse L-1-Stammaktien stellt eine Primärrenditezahlung für Klasse L-1-Stammaktien dar.
43470
(d) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, haben die Inhaber von Klasse L-1-Stammaktien als gesonderte Kategorie Anspruch auf den
vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf Grund-
lage der gesamten Nicht Gezahlten Sekundärrendite der Klasse L-1-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum
Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden), die der gesamten Nicht Gezahlten Sekundärrendite für die ausgege-
benen Klasse L-1-Stammaktien zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung entspricht; bevor diese Ausschüttung des gesamten
Betrages der zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung Nicht Gezahlten Sekundärrendite für die ausgegebenen Klasse L-1-
Stammaktien nicht vollständig ausgezahlt wurde, wird keine Ausschüttung oder teilweise Ausschüttung nach einem an-
deren, weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels 19 vorgenommen. Die Ausschüttung nach Artikel 19(d) an die
Inhaber von Klasse L-1-Stammaktien stellt eine Sekundärrenditezahlung für Klasse L-1-Stammaktien dar.
(e) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, haben die Inhaber von Klasse L-1-Stammaktien als gesonderte Kategorie Anspruch auf den
vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf Grund-
lage der gesamten Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen Kosten der Klasse L-1-Stammaktien, die von jedem dieser In-
haber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden), die den gesamten Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen
Kosten für die ausgegebenen Klasse L-1-Stammaktien zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung entspricht; bevor diese Aus-
schüttung des gesamten Betrages der zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen Ko-
sten für die ausgegebenen Klasse L-1-Stammaktien nicht vollständig ausgezahlt wurde, wird keine Ausschüttung oder
teilweise Ausschüttung nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels 19 vorgenommen. Die Aus-
schüttung nach Artikel 19(e) an die Inhaber von Klasse L-1-Stammaktien stellt eine Rückzahlung der Ursprünglichen Ko-
sten für Klasse L-1-Stammaktien dar.
(f) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, haben die Inhaber von Klasse L-Stammaktien als gesonderte Kategorie Anspruch auf den
vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf Grund-
lage der gesamten Nicht Gezahlten Rendite der Klasse L-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt die-
ser Ausschüttung gehalten werden), die der gesamten Nicht Gezahlten Rendite für die ausgegebenen Klasse L-
Stammaktien zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung entspricht; bevor diese Ausschüttung des gesamten Betrages der zum
Zeitpunkt dieser Ausschüttung Nicht Gezahlten Rendite für die ausgegebenen Klasse L-Stammaktien nicht vollständig
ausgezahlt wurde, wird keine Ausschüttung oder teilweise Ausschüttung nach einem anderen, weiter unten stehenden
Absatz dieses Artikels 19 vorgenommen. Die Ausschüttung nach Artikel 19(f) an die Inhaber von Klasse L-Stammaktien
stellt eine Renditezahlung für Klasse L-Stammaktien dar.
(g) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, haben die Inhaber von Klasse L-Stammaktien als gesonderte Kategorie Anspruch auf den
vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf Grund-
lage der gesamten Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen Kosten der Klasse L-Stammaktien, die von jedem dieser In-
haber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden), die den gesamten Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen
Kosten für die ausgegebenen Klasse L-Stammaktien zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung entspricht; bevor diese Aus-
schüttung des gesamten Betrages der zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen Ko-
sten für die ausgegebenen Klasse L-Stammaktien nicht vollständig ausgezahlt wurde, wird keine Ausschüttung oder
teilweise Ausschüttung nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels 19 vorgenommen. Die Aus-
schüttung nach Artikel 19(g) an die Inhaber von Klasse L-Stammaktien stellt eine Rückzahlung der Ursprünglichen Ko-
sten für Klasse L-Stammaktien dar.
(h) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels 19 aus-
gezahlt wurde, haben die Inhaber von Klasse L-Stammaktien, Klasse A-Stammaktien und Klasse D-Stammaktien als
Gruppe Anspruch auf den vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen
diesen Inhabern auf Grundlage der Anzahl der Klasse L-, A- bzw. D-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum
Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden), bis entweder (a) die L-1-Ausgleichsrendite erreicht wurde oder (b)
die Dreifache Zielrendite erreicht wurde; bevor (a) an alle Inhaber von Klasse L-Stammaktien, Klasse A-Stammaktien
und Klasse D-Stammaktien der nach diesem Artikel 19(h) gesamte Betrag der L-1-Ausgleichsrendite ausgeschüttet wur-
de oder (b) jeder Golden-Gate-Wertpapierinhaber eine Ausschüttung entsprechend der sich in seinem Eigentum be-
findlichen Wertpapiere der Gesellschaft, in Höhe des Betrages, der der Dreifachen Zielrendite entspricht, erhalten hat,
wird keine Ausschüttung oder teilweise Ausschüttung nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses Ar-
tikels 19 vorgenommen.
(i) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels 19 aus-
gezahlt wurde, jedoch nur, wenn die Dreifache Zielrendite noch nicht erreicht wurde, haben die Inhaber von Klasse M-
Stammaktien, Klasse L-1-Stammaktien, Klasse L-Stammaktien, Klasse A-Stammaktien und Klasse D-Stammaktien als
Gruppe Anspruch auf den vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen
den Inhabern auf Grundlage der Anzahl der Klasse M-, L-1-, L-, A- bzw. D-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber
zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten wird), bis die Dreifache Zielrendite erreicht wurde; bevor jeder Golden-
Gate-Wertpapierinhaber eine Ausschüttung entsprechend der sich in seinem Eigentum befindlichen Wertpapiere der
Gesellschaft, in Höhe des Betrages, der dem Dreifachen der Zielrendite entspricht, erhalten hat, wird keine Ausschüt-
tung oder teilweise Ausschüttung nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels 19 vorgenom-
men. Um Zweifelsfälle zu vermeiden, werden keine Ausschüttungen nach diesem Artikel 19(i) vorgenommen, wenn die
Dreifache Zielrendite bereits erreicht wurde.
(j) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels 19 aus-
gezahlt wurde, haben die Inhaber von Klasse L-Stammaktien, Klasse A-Stammaktien, Klasse B-Stammaktien und Klasse
43471
D-Stammaktien als Gruppe Anspruch auf den vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional
aufgeteilt zwischen den Inhabern auf Grundlage der Anzahl der Klasse L-, A-, B-bzw. D-Stammaktien, die von jedem die-
ser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten wird, aufgeteilt), bis entweder (a) die L-1-Ausgleichsrendite
erreicht wurde oder (b) die Fünffache Zielrendite erreicht wurde; bevor (a) an alle Inhaber von Klasse L-Stammaktien,
Klasse A-Stammaktien, Klasse B-Stammaktien und Klasse D-Stammaktien der nach Artikel 19(h) und diesem Artikel
19(j) gesamte Betrag der L-1-Ausgleichsrendite ausgeschüttet wurde oder (b) jeder Golden-Gate-Wertpapierinhaber
eine Ausschüttung entsprechend der sich in seinem Eigentum befindlichen Wertpapiere der Gesellschaft, in Höhe des
Betrages, der der Fünffachen Zielrendite entspricht, erhalten hat, wird keine Ausschüttung oder teilweise Ausschüttung
nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels 19 vorgenommen.
(k) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikel 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, und nur wenn die Fünffache Zielrendite nicht erreicht wurde, haben die Inhaber der Klasse
M-Stammaktien, die Inhaber der Klasse L-1-Stammaktien, die Inhaber der Klasse L-Stammaktien, die Inhaber der Klasse
A-Stammaktien, die Inhaber der Klasse B-Stammaktien und die Inhaber der Klasse D-Stammaktien, als Gruppe Anspruch
auf den vollen Umfang oder einen Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf
Grundlage der Anzahl von Klasse M-Stammaktien, Klasse L-1-Stammaktien, Klasse L-Stammaktien, Klasse A-Stammak-
tien, Klasse B-Stammaktien und Klasse D-Stammaktien, die zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung von jedem dieser Inha-
ber gehalten wird) zu erhalten, bis und in dem Maß, in dem die Höhe der Fünffachen Zielrendite erreicht wurde; und
keine Ausschüttung oder eine teilweise Ausschüttung wird nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses
Artikels 19 vorgenommen, bis jeder Golden-Gate-Wertpapierinhaber Ausschüttungen entsprechend der sich in seinem
Eigentum befindlichen Wertpapiere der Gesellschaft in Höhe der Fünffachen Zielrendite erhalten hat. Um Zweifel zu
vermeiden, sind keine Ausschüttungen in Übereinstimmung mit diesem Artikel 19(k) vorzunehmen, wenn die Fünffache
Zielrendite bereits erreicht wurde.
(l) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikel 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, haben die Inhaber der Stammaktien, ausgenommen der Klasse M-Stammaktien, der Klasse
L-1-Stammaktien und der Klasse P-Stammaktien, als Gruppe Anspruch auf den vollen Umfang oder einen Teil einer sol-
chen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf Grundlage (i) der Anzahl der Klasse L-Stamm-
aktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden, (ii) der Anzahl der Klasse A-
Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden, (iii) der Anzahl von
Klasse B-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden, (iv) die An-
zahl von Klasse C-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten werden und
(v) der Anzahl von gleichwertigen Klasse D-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüt-
tung gehalten wird) zu erhalten, bis die Höhe der L-1-Aufhol-Rendite erreicht wurde; und keine Ausschüttung oder teil-
weise Ausschüttung wird nach einem anderen, weiter unten stehenden Absatz dieses Artikels 19 vorgenommen, bis die
Inhaber der Stammaktien, ausgenommen der Klasse M-Stammaktien, der Klasse L-1-Stammaktien und der Klasse P-
Stammaktien Ausschüttungen in Übereinstimmung mit Artikel 19(h) und 19(j) and diesem Artikel 19(l) in Höhe der Ge-
samtsumme der L-1-Aufhol-Rendite erhalten haben.
(m) Nachdem die entsprechende Ausschüttungssumme gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses Artikel 19 voll-
ständig ausgeschüttet wurde, haben die Inhaber der Stammaktien, ausgenommen der Klasse P-Stammaktien, als Gruppe
Anspruch auf den verbleibenden Teil einer solchen Ausschüttung (proportional aufgeteilt zwischen diesen Inhabern auf
Grundlage (i) der Anzahl von Klasse M-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung
gehalten wird, (ii) der Anzahl von Klasse L-1-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüt-
tung gehalten wird, (iii) der Anzahl von Klasse L-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Aus-
schüttung gehalten wird, (iv) der Anzahl der Klasse A-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser
Ausschüttung gehalten wird, (v) der Anzahl von Klasse B-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeitpunkt
dieser Ausschüttung gehalten wird, (vi) der Anzahl der Klasse C-Stammaktien, die von jedem dieser Inhaber zum Zeit-
punkt dieser Ausschüttung gehalten wird und (viii) der Anzahl von gleichwertigen Klasse D-Stammaktien, die von jedem
dieser Inhaber zum Zeitpunkt dieser Ausschüttung gehalten wird).
Zum Zwecke dieses Artikels 19, sowie der Artikel 20 bis 25 gelten sämtliche Bezugnahmen auf Klasse M-Stammak-
tien, Klasse L-1-Stammaktien, Klasse P-Stammaktien, Klasse L-Stammaktien, Klasse A-Stammaktien, Klasse B-Stammak-
tien, Klasse C-Stammaktien und Klasse D-Stammaktien als Bezugnahmen auf diese Stammaktien und, in dieser
Reihenfolge, auf die Serie M-CPECs, Serie L-1-CPECs, Serie P-CPECs, Serie L-CPECs, Serie A-CPECs, Serie B-CPECs,
Serie C-CPECs und die Serie D-CPECs.
K. Rückkauf von Klasse P-Stammaktien
Art. 20. Zum Zeitpunkt des Zwingenden Rückkaufdatums sind durch die Gesellschaft sämtliche ausstehende Klasse
P-Stammaktien gegen Barzahlung zu einem Preis pro Aktie in Höhe des Nicht Zurückerstatteten Vorzugsbetrages zu-
züglich der Nicht Gezahlte Vorzugsrendite jeder dieser Klasse P-Stammaktien plus, wenn erforderlich, die anwendbare
Prämie zurückzunehmen. Die Gesellschaft kann jederzeit vor dem Zeitpunkt des Zwingenden Rückkaufdatums alle oder
einen Teil der dann ausstehenden Klasse P-Stammaktien gegen Barzahlung zu einem Preis pro Aktie in Höhe des Nicht
Zurückerstatteten Vorzugsbetrages zuzüglich der Nicht Gezahlten Vorzugsrendite von jeder Klasse P-Stammaktie plus
die anwendbare Prämie zurückkaufen. Beim Eintreten von einem Versäumnis dürfen (A) im Fall von Golden-Gate-Wert-
papierinhabern, die Mehrheit der Golden-Gate-Wertpapierinhaber oder (B) im Fall von Summit-Wertpapierinhabern,
die Mehrheit der Summit-Wertpapierinhaber, anhand schriftlicher Ankündigung an die Gesellschaft, beanspruchen, dass
die Klasse P-Stammaktien, die durch die Golden-Gate-Wertpapierinhaber oder, je nachdem, die Aktionäre von Summit,
gehalten werden, gegen Barzahlung zu einem Preis pro Aktie in Höhe des nicht zurückerstatteten Vorzugsbetrages zu-
züglich der Nicht Gezahlten Vorzugsrendite von jeder dieser Klasse P-Stammaktien plus die anwendbare Prämie zurück-
genommen werden (innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Aushändigung einer solchen schriftlichen Ankündigung).
43472
Jeder Rückkauf von Klasse P-Stammaktien unterliegt der Bedingung, dass die Gesellschaft nach Ausführung der Rück-
kaufzahlungen nicht Insolvent wird and dass solche Rückkaufzahlungen aus Rechtlich Vorhandenen Mitteln erfolgen. Soll-
ten die zum Rückkauf Rechtlich Vorhandenen Mittel der Gesellschaft nicht ausreichen, um die gesamte Anzahl der zu
diesem Zeitpunkt zurückzukaufenden Klasse P-Stammaktien zurückzukaufen, sind die Rechtlich Vorhandenen Mittel
zum Rückkauf der höchstmöglichen Anzahl an Klasse P-Stammaktien zu gebrauchen, pro rata zwischen den Besitzern
der zurückzukaufenden Aktien, basierend auf dem gesamten Nicht Zurückgezahlten Vorzugsbetrag und der Nicht Ge-
zahlten Vorzugsrendite. Sämtliche weiteren Mittel, welche der Gesellschaft rechtlich zu einem späterem Zeitpunkt zum
Rückkauf der Klasse P-Stammaktien zur Verfügung stehen, sind unverzüglich zum Rückkauf der ausstehenden Anzahl an
Klasse P-Stammaktien zu gebrauchen, zu welchem die Gesellschaft an jedem Rückkaufdatum verpflichtet ist, welche sie
jedoch noch nicht zurückgekauft hat.
Art. 21. Sofern hierin nicht anders bestimmt, hat die Gesellschaft nicht mehr als 60 Tage und nicht weniger als 10
Tage vor dem Datum, an dem ein solcher Rückkauf auszuführen ist, schriftliche Ankündigungen von jedem Rückkauf von
Klasse P-Stammaktien an jeden eingetragenen Inhaber solcher Klasse P-Stammaktien zu senden. Falls weniger als die Ge-
samtanzahl der im Aktionärsregister der Gesellschaft angezeigten Klasse P-Stammaktien zurückgenommen werden, ist
das Aktionärsregister der Gesellschaft dementsprechend zu ändern.
Art. 22. Die Anzahl von Klasse P-Stammaktien, die von einem Inhaber solcher Klasse P-Stammaktien beim Rückkauf
nach diesen Bestimmungen zurückzunehmen ist, ist die Anzahl von Aktien, die bestimmt wird durch die Multiplikation
von der Gesamtanzahl von zurückzukaufenden Klasse P-Stammaktien und einem Bruchteil, dessen Zähler die Gesamt-
anzahl von Klasse P-Stammaktien ist, die zu diesem Zeitpunkt von einem solchen Inhaber gehalten werden, und dessen
Nenner die Gesamtanzahl der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Klasse P-Stammaktien ist.
Art. 23. Keiner Klasse P-Stammaktie ist ein Anrecht auf Dividenden zu gewähren, die nach dem Datum anfallen, an
dem der Nicht Zurückerstattete Vorzugsbetrag, zuzüglich der Nicht Gezahlten Vorzugsrendite und, wenn anwendbar,
die anwendbare Prämie an den Inhaber der Klasse P-Stammaktie gezahlt wird. Zu diesem Zeitpunkt enden sämtliche
Rechte des Inhabers dieser Klasse P-Stammaktie und diese Klasse P-Stammaktie ist zu entwerten und das ausgegebene
Aktienkapital ist dementsprechend zu verringern (ohne Schaden für das bewilligte Kapital der Gesellschaft).
Art. 24. Klasse P-Stammaktien, die zurückgenommen (oder anderweitig durch die Gesellschaft erworben) und ent-
wertet werden, dürfen nicht wieder ausgegeben, verkauft oder übertragen werden.
Art. 25. Der Geschäftsführer hat jedem Inhaber von Klasse P-Stammaktien unmittelbar nach Erhalt einer schriftliche
Mitteilung eines Versäumnisses durch die Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften unter einem vorrangigen
Darlehensvertrag, in dem eine von ihnen eine Partei ist, eine solche zukommen zu lassen.
L. Verkauf der Gesellschaft
Art. 26. Wenn die Inhaber von Stammaktien, die durch die GOLDEN-GATE-Wertpapierinhaber gehalten werden,
(i) durch Mehrheitsbeschluss einem Verkauf des ganzen oder im Wesentlichen ganzen Betrages des ausstehenden Ak-
tienkapitals und/oder der Wertpapiere der Gesellschaft, (ob durch Fusion, Rekapitalisierung, Konsolidierung, Reorgani-
sation, Zusammenschluss oder durch anderes) zustimmen oder (ii) unter Beachtung der hierfür erforderlichen
gesetzlichen Quorums- und Mehrhheitsbestimmungen, einem Verkauf von allen oder im Wesentlichen allen Vermögens-
werten der Gesellschaft (wie im Revised Model Business Corporation Act definiert), (solche Inhaber, im Falle von (i)
und beziehungsweise (ii), die «Erforderlichen Inhaber») an eine Unabhängige Dritte Partei oder Gruppe von Unabhän-
gigen Dritten Parteien (solcher Verkauf, im Falle von (i) beziehungsweise (ii) ein «Genehmigter Verkauf») zustimmen,
so wird jeder Inhaber von Stammaktien (y) bezüglich (i) und (ii), als zustimmend angesehen und derselbe willigt ein, keine
Einwände gegen einen solchen Genehmigten Verkauf vorzubringen und (z) bezüglich (ii), willigt ein solchem Genehmig-
ten Verkauf anlässlich jeder Generalversammlung der Aktionäre welche zu diesem Zwecke abgehalten wird zuzustim-
men und bezüglich (i) und (ii), willigt hierbei ein, alle notwendigen gesellschaftsrechtlichen Schritte zu unternehmen und
Genehmigungen zu erteilen, die es dem Geschäftsführer ermöglichen, solche Handlungen vorzunehmen für einen sol-
chen Inhaber, soweit es das Gesetz erlaubt, einschließlich, unter anderem, die Genehmigung für den Geschäftsführer,
alle notwendigen Handlungen vorzunehmen in Bezug auf die Eintragung der Übertragung eines Wertpapieres der Ge-
sellschaft in das zutreffende Aktien-oder CPECs-Register. Wenn der Genehmigte Verkauf strukturiert ist als eine (i) Fu-
sion oder Konsolidierung, verzichtet jeder Inhaber von Stammaktien auf sämtliche Widerspruchsrechte,
Abfindungsrechte oder gleichartige Rechte in Verbindung mit einer solchen Fusion oder Konsolidierung oder (ii) ein
Verkauf von Aktienkapital und/oder Wertpapieren, stimmt jeder Inhaber von Stammaktien zu, seine sämtlichen Stamm-
aktien und Rechte zu verkaufen, um Stammaktien zu den durch den Geschäftsführer und die Erforderlichen Inhaber ge-
nehmigten Bedingungen zu erwerben. Um Zweifel zu vermeiden, wenn in den Artikeln 26 bis einschließlich Artikel 31
Bezug auf Inhaber von Stammaktien genommen wird, beinhalten diese Bezugnahmen ebenfalls Inhaber von CPECs, die
in Stammaktien umgewandelt werden können.
Art. 27. Die Pflichten der Inhaber von Stammaktien in Bezug auf einen Genehmigten Verkauf unterliegen nachfol-
genden Bedingungen: (i) beim Vollzug des Genehmigten Verkaufs erhält jeder Inhaber von Stammaktien die gleiche Form
von Entschädigung und den gleichen Anteil der Gesamtentschädigung, die diese Inhaber von Stammaktien erhalten hät-
ten, wenn eine solche Gesamtentschädigung durch die Gesellschaft bei einer vollständigen Liquidation in Übereinstim-
mung mit den Rechten und Vorrechten, die in diesen Artikeln der Statuten der Gesellschaft festgelegt sind, tatsächlich
unmittelbar vor einem solchen Genehmigten Verkauf verteilt geworden wäre, (ii) wenn einem Inhaber von einer Klasse
von Stammaktien eine Wahlmöglichkeit bezüglich der Form und des Umfanges der zu erhaltenen Entschädigung gegeben
wird, wird jedem Inhaber einer Stammaktie dieser Klasse die gleiche Wahlmöglichkeit gegeben, (iii) jedem Inhaber von
zu diesem Zeitpunkt ausübbaren Rechten zum Kauf von Aktien einer Klasse von Stammaktien wird eine Möglichkeit
43473
gewährt, diese Rechte vor dem Vollzug des Genehmigten Verkaufs auszuüben und als Inhaber dieser Klasse von Stamm-
aktien bei diesem Verkauf teilzunehmen, (iv) die Verpflichtungen von jedem Aktionär, den Käufer in einem Genehmigten
Verkauf für etwaige Zusicherungen und Garantien bezüglich der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften zu ent-
schädigen, sind eigene, nicht gesamtschuldnerische Verpflichtungen der Aktionäre der Gesellschaft, und werden entwe-
der pro rata gemäß dem Gesamterlös, der durch diesen Inhaber in Verbindung mit dem Genehmigten Verkauf erhalten
wird, aufgeteilt; oder es werden Rückstellungen von den Aktionären der Gesellschaft vorgenommen für eine solche Pro-
Rata-Verteilung der Entschädigungsverpflichtungen, (v) die Verpflichtung von jedem Aktionär, den Käufer in einem Ge-
nehmigten Verkauf zu entschädigen, ist begrenzt auf den Nettoerlös (vor Steuerzahlung), der an diesen Aktionär in Ver-
bindung mit dieser Transaktion verteilt wurde und (vi) von keinem der Aktionäre, die zum Zeitpunkt dieses
Genehmigten Verkaufs nicht Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft sind, kann als eine Bedingung für diesen Ge-
nehmigten Verkauf der Eintritt in eine Konkurrenzverbotsvereinbarung verlangt werden.
Art. 28. Wenn die Gesellschaft oder die Inhaber der Aktien der Gesellschaft in Verhandlungen oder Transaktionen
eintreten, für die die durch die Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten bekannt gegebene Rule
506 (oder eine andere gleichartige Regel, die zu diesem Zeitpunkt in Kraft ist) hinsichtlich einer solchen Verhandlung
oder Transaktion (einschließlich einer Fusion, Konsolidierung oder einer anderen Reorganisation) verfügbar ist, ernen-
nen die Inhaber von Stammaktien, die keine «zugelassenen Anleger» sind, auf Anfrage der Gesellschaft einen Vertreter
des Käufers (so, wie dieser Begriff in der durch die Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten be-
kannt gegebenen Regel 501 definiert ist), der für die Gesellschaft vernünftigerweise akzeptabel ist. Wenn ein Inhaber
von Stammaktien einen Vertreter des Käufers, der durch die Gesellschaft bestimmt wurde, ernennt, wird die Gesell-
schaft die Honorare dieses Vertreters des Käufers bezahlen, aber wenn ein Inhaber von Stammaktien es ablehnt, einen
solchen Vertreter des Käufers, der durch die Gesellschaft bestimmt wurde, zu ernennen, wird dieser Inhaber einen an-
deren Vertreter des Käufers ernennen und dieser Inhaber wird für das Honorar des so ernannten Vertreters des Käu-
fers aufkommen.
Art. 29. Jeder Inhaber von Stammaktien wird einen Pro-Rata-Anteil (auf Grundlage der Gesamtentschädigung, die
durch diesen Inhaber in Verbindung mit einem solchen Genehmigten Verkauf beim Abschluss desselben zu erhalten ist)
der Kosten tragen, die an eine dritte Partei, die durch die Gesellschaft anlässlich eines Verkaufes von Stammaktien in
Übereinstimmung mit einem Genehmigten Verkauf engagiert wird, gezahlt werden, in dem Maß, in dem diese Kosten
zum Nutzen aller Inhaber von Stammaktien anfallen und nicht anders durch die Gesellschaft oder die Partei des Käufers
bezahlt werden. Kosten, die für die Inhaber von Stammaktien in deren eigenen Namen anfallen, werden nicht als Kosten
der Transaktion hierunter angesehen.
Art. 30. Die Bestimmungen von Artikel 26 bis einschließlich Artikel 29 enden beim Eintreten eines der nachfolgenden
Ereignisse (i) die Vollendung eines IPO und (ii) die Vollendung eines Kontrollwechsels.
Art. 31. Wenn (i) der Geschäftsführer ein IPO genehmigt und (ii) das IPO ein unterschriebenes Angebot ist und die
geschäftsführenden Unterzeichner die Gesellschaft schriftlich benachrichtigen dass in ihrer Meinung die Kapitalstruktur
der Gesellschaft die Vermarktung des Angebots gefährden, wird jeder Inhaber von Stammaktien zu einer Kapitalum-
schichtung, einer Umstrukturierung und/oder einem Tausch aller Stammaktien in Wertpapiere zustimmen, die den ge-
schäftsführenden Unterzeichnern, dem Geschäftsführer und den Inhabern der Mehrheit der ausgeschütteten
Stammaktien als akzeptabel erscheinen und wird alle notwendigen oder gewünschten Schritte in Zusammenhang mit der
Durchführung der Kapitalumschichtung, der Umstrukturierung und/oder dem Tausch unternehmen; unter der Bedin-
gung dass alle Inhaber derselben Klasse oder Serie von Stammaktien und CPECs hierbei auf die gleiche Art und Weise
behandelt werden und die restlichen Wertpapiere stellen die in diesen Statuten beschriebenen Rechte und Vorrechte
unmittelbar vor dem IPO (hierbei wird von der Umwandlung aller CPECs ausgegangen). Die Bestimmungen dieses Ar-
tikels 31 und alle Verweise zur Bezeichnung 'IPO' in diesen Statuten, sind ebenfalls mutatis mutandis anwendbar auf (i)
jede ursprüngliche öffentliche Erstemission und jeden Verkauf von Stammaktien oder einer Tochtergesellschaft der Ge-
sellschaft und die Auflösung der Gesellschaft in eine solche Tochtergesellschaft in diesem Zusammenhang und (ii) jede
Solvente Umstrukturierung genehmigt durch den Geschäftsführer. Im Zusammenhang mit einem solchen Börsengang
und Verkauf von Stammaktien einer Tochtergesellschaft, wird die Gesellschaft sich in eine solche Tochtergesellschaft
auflösen oder jede notwendige Handlung unternehmen, um die Wertpapiere dieser Tochtergesellschaft zu verteilen.
M. Definitionen
Art. 31. Zum Zwecke dieser Statuten:
«Angegliederte Gesellschaft» einer Person bedeutet eine andere Person, Organisation oder einen anderen Investiti-
onsfonds, die oder der die Person kontrolliert, von ihr oder gemeinsam mit der Person kontrolliert wird und, im Falle
einer Person, die ein Personengesellschaft (partnership) oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liabi-
lity company) darstellt, ein Partner oder Mitglied, je nachdem, der Person.
«Anwendbare Prämie» bedeutet, dass vorbehaltlich der Bedingungen einer separaten schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen der Gesellschaft und einigen oder all ihren Aktionäre in Verbindung mit der Rückzahlung der Klasse P-Stammak-
tien eine Prämie zahlbar ist, mit Ausnahme der obligatorischen Rückzahlung der Klasse P-Stammaktien am 31. Dezember
2007. Eine solche Rückzahlungsprämie entspricht 13,5% der Summe (i) der gesamten Nicht Gezahlten Vorzugsrendite
und (ii) des gesamten Nicht Gezahlten Vorzugsbetrages, in jedem Falle für eine so zurückgezahlte Klasse P-Stammaktie,
auf jeden Fall vorbehaltlich der Beseitigung einer solchen Prämie gemäß den Bestimmungen einer separaten schriftlichen
Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und einigen oder all ihren Aktionäre.
«Kontrollwechsel» bedeutet (i) den Verkauf oder die Übertragung durch die Gesellschaft oder eine ihrer Beteili-
gungsgesellschaften, ihres gesamten oder im Wesentlichen gesamten Vermögens (wie im US-amerikanischen Gesetz
«Revised Model Business Corporation Act» (RMBCA) definiert) auf konsolidierter Basis, (ii) die Konsolidierung, Fusion
43474
oder Reorganisation der Gesellschaft mit oder zu einer anderen Organisation oder anderen Organisationen, mit dem
Ergebnis, dass die Inhaber des ausstehenden Kapitalvermögens der Gesellschaft (einschließlich, zum Zwecke der Fest-
stellung, ob ein Kontrollwechsel stattgefunden hat, ihrer jeweiligen angeschlossenen Investitionsfonds oder irgendeiner
anderen Angegliederten Gesellschaft derselben), welches (unter normalen Umständen) das Stimmrecht besitzt, eine
Mehrheit des Vorstandes (oder gleichwertigen Führungsorganes), zu wählen, unmittelbar vor einer solchen Konsolidie-
rung, Fusion oder Reorganisation, nicht mehr das ausstehende Kapitalvermögen der überlebenden Gesellschaft besitzen,
welches (unter normalen Umständen) das Stimmrecht besitzt, eine Mehrheit des Vorstandes der überlebenden Gesell-
schaft (oder gleichwertigen Führungsorganes) zu wählen oder (iii) die Ausgabe durch die Gesellschaft oder der Verkauf
oder die Übertragung an eine dritte Partei von Aktien des Kapitalvermögens der Gesellschaft durch dessen Inhaber, mit
dem Ergebnis, dass die Inhaber des ausstehenden Kapitalvermögens der Gesellschaft (einschließlich, zum Zwecke der
Feststellung, ob ein Kontrollwechsel stattgefunden hat, ihrer jeweiligen angeschlossenen Investitionsfonds oder einer
anderen angegliederten Gesellschaft derselben), welches (unter normalen Umständen), das Stimmrecht besitzt, unmit-
telbar vor einem solchen Verkauf oder einer solchen Übertragung eine Mehrheit des Vorstandes (oder gleichwertigen
Führungsorganes) zu wählen, das ausstehende Kapitalvermögen der Gesellschaft nicht mehr besitzen, welches (unter
normalen Umständen) das Stimmrecht besitzt, um eine Mehrheit des Vorstandes (oder gleichwertigen Leitungsorganes)
zu wählen.
«Gruppe» bedeutet die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften.
«Wertpapiere der Gesellschaft» bedeutet Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihzertifikate (convertible preferred
equity certificates) der Gesellschaft oder einer ihrer Beteiligungsgesellschaften (einschließlich Wertpapiere einer Klasse,
die gegen Wertpapiere einer anderen Klasse eingetauscht werden), mit Ausnahme von (a) Wertpapieren, die zum
Tausch gegen Dividendenpapiere (equity securities) gemäß jedem zwischen der Gesellschaft und seinen Tochtergesell-
schaften, sowie bestimmten Golden-Gate-Wertpapierinhabern möglicherweise abgeschlossenen senior subordinated
loan agreement ausgegeben werden, in geänderter oder neuformulierter werden, (b) Wertpapieren, die zum Tausch
gegen die gemäß jeden Aktienkaufvereinbarungen, die möglicherweise zwischen INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo
LTD. und anderen Käufern geschlossen wurden, ausgegebenen Dividendenpapieren (equity securities) ausgegeben wer-
den, zwischen INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo LTD. und den in diesen Verträgen genannten Käufern, (c) P-Klas-
se-Stammaktien, (d) L-1-Klasse-Stammaktien oder (e) M-Klasse-Stammaktien.
«CPECs» bedeutet die Serie A-CPECs, die Serie B-CPECs, die Serie C-CPECs, die Serie D-CPECs, die Serie L-CPECs,
die Serie L-1-CPECs, die Serie M-CPECs, die Serie P-CPECs und alle anderen Serien von Wandelanleihzertifikate (con-
vertible preferred equity certificates), die von der Gesellschaft möglicherweise mitunter bewilligt und herausgegeben
werden.
«Ausschüttung» bedeutet jede von der Gesellschaft ausgezahlte Dividende oder Ausschüttung an die Inhaber der
Stammaktien (einschließlich auszugebende Stammaktien nach Wandlung jedes CPECs), sei es in bar, in Sachanlagen oder
Wertpapieren der Gesellschaft und sei es durch Dividenden, Liquidationsausschüttung oder auf andere Art und Weise;
vorausgesetzt, dass keiner der folgenden Punkte eine Ausschüttung darstellt: (a) eine Rückzahlung, Einlösung oder ein
Kauf der Gesellschaft von Stammaktien oder CPECs aus irgendeinem Grund, einzig von den ehemaligen Arbeitnehmern,
Direktoren oder Beratern der Gesellschaft oder ihrer Beteiligungsgesellschaften oder (b) eine Rekapitalisierung oder
ein Tausch von Stammaktien oder eine Konsolidierung oder Teilung (durch Kapitalteilung, Dividendenauszahlung durch
Aktien oder anderweitig) oder eine Kombination (durch Kapitalteilung, Dividendenauszahlung durch Aktien oder ander-
weitig) von Stammaktien.
«Gleichwertige Klasse D-Stammaktien» bedeutet, für jeden Feststellungsdatum, die Gesamtanzahl der sich im Besitz
eines solchen Inhabers befindlichen Klasse D-Stammaktien, multipliziert mit einem Bruchteil, dessen Zähler die Gesamt-
anzahl der ausgegebenen Stammaktien darstellt, abzüglich der Gesamtanzahl der ausgegebenen Klasse C-Stammaktien
(vorausgesetzt, dass der Zähler Null ist, wenn ein solcher Wert negativ ist), und dessen Nenner die Gesamtanzahl der
ausgegebenen Klasse D-Stammaktien ist.
«Versäumnis» bedeutet einen der folgenden Fälle: (1) die Gesellschaft versäumt es, einen fälligen und geschuldeten
Betrag in Bezug auf die Klasse P-Stammaktien zu zahlen, wenn dieser fällig und zahlbar wird; oder (2) ein Versäumnis
oder Versäumnisfall, der im Rahmen einer Verbindlichkeit der Gesellschaft oder einer ihrer Beteiligungsgesellschaften
aufgetreten ist und zur vorzeitigen Fälligstellung einer solchen Verbindlichkeit führt, sei es dadurch, dass er durch seine
Zahlungsbedingungen fällig und zahlbar geworden ist oder dass er vor seiner vorgegebenen Fälligkeit als fällig und zahlbar
vereinbart wurde; oder (3) die Gesellschaft oder der Geschäftsführer hält, den Umständen entsprechend, die Bestim-
mungen eines der Artikel 20-25 oder einer Bestimmung oder Vertragsbedingung einer separaten schriftlichen Verein-
barung zwischen der Gesellschaft und den Inhabern der Klasse P-Stammaktien in ihrer Kapazität als solche nicht ein oder
unterlässt ihre Erfüllung, Einhaltung oder Befolgung; oder (4) ein oder mehrere Urteile oder Verfügungen werden gegen
die Gesellschaft oder eine ihrer Beteilungsgesellschaften erlassen, bei dem/denen die Haftsumme (in einem Umfang, der
nicht ausreichend von der Versicherung abgedeckt wird) größer als insgesamt US Dollar 2.500.000 ist, für alle solche
Urteile und Verfügungen, und alle solche Urteile oder Verfügungen sind nicht aufgehoben, entlastet oder eingestellt oder
abgesichert, abhängig von der Einlegung eines Rechtsmittels innerhalb von sechzig (60) Tagen ab der Anmeldung eines
solchen; oder (5) wenn ein Kontrollwechsel eingetreten ist.
«Fünffache Zielrendite» bedeutet den tatsächlichen Empfang durch jeden Golden-Gate-Wertpapierinhaber von Bar-
zahlungen in Verbindung mit und/oder im Tausch gegen seine Wertpapiere der Gesellschaft (ob solche Zahlungen von
der Gesellschaft oder einer dritten Partei in Empfang genommen werden, jedoch, um Zweifel zu vermeiden, auschließ-
lich Gebühren oder anderen, an die Golden-Gate-Wertpapierinhaber oder ihre angeschlossenen Gesellschaften gezahl-
ten oder zahlbaren Summen oder eine Ausschüttung gemäß Absatz 19 (f)), die dem fünffachen Betrag einer solchen
Investitionssumme der Golden-Gate-Wertpapierinhaber in Wertpapiere der Gesellschaft entsprechen. Zu diesem
Zwecke ist die «Investition» der Golden-Gate-Wertpapierinhaber der Gesamtkaufpreis, der der Gesellschaft für alle
43475
Wertpapiere der Gesellschaft ursprünglich gezahlt wurde. Jedes Mal wenn ein Golden-Gate-Wertpapierinhaber Bar-
geldzahlungen in Verbindung mit und/oder im Tausch gegen seine Wertpapiere der Gesellschaft erhält, wird eine Ent-
scheidung hierunter getroffen, und jeder Golden-Gate-Wertpapierinhaber arbeitet mit der Gesellschaft zusammen und
liefert der Gesellschaft auf Anforderung alle angemessen Informationen zur Entscheidung, ob die Fünffache Zielrendite
erreicht worden ist.
«Persönlich Haftender Gesellschafter» bedeutet INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo S.A.
«Golden-Gate-Wertpapierinhaber» bedeutet für den Zeitraum, in dem sie Aktionäre der Gesellschaft sind, ein von
Golden Gate Capital verwalteter Investitionsfonds und ihre entsprechenden Erwerber von Aktien.
«Unabhängige Dritte Partei» bedeutet eine Person, die (zusammen mit ihren Angegliederten Gesellschaften) unmit-
telbar vor der beabsichtigten Transaktion nicht mehr als zehn Prozent (10%) aller gegenwärtig ausstehenden Stammak-
tien (nach Wandlung aller zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen CPECs (ein «10% Inhaber») besitzt, die einen solchen 10%-
Inhaber nicht überwacht, von ihm kontrolliert wird oder gemeinsam mit einem solchen 10%- Inhaber kontrolliert wird
und die kein Ehepartner, Nachkomme (durch Geburt oder Adoption), Elternteil oder Abhängiger eines solchen 10%-
Inhabers ist oder einen Trust zum Nutzen eines solchen 10%- Inhabers und/oder solcher anderen Personen darstellt.
«IPO» bedeutet ein anfängliches öffentliches Angebot und den Verkauf der Aktien der Gesellschaft oder einer ihrer
Beteiligungsgesellschaften entsprechend einer geltenden Registrierungsserklärung gemäß dem Gesetz «United States Se-
curities Act» von 1933, neue Fassung.
«Insolvent» bedeutet dass (i) die gesamten Verpflichtungen der Gesellschaft den fairen Marktwert ihrer Aktiva über-
schreiten, oder (ii) die Gesellschaft nicht imstande ist, ihre Verpflichtungen zum Fälligkeitstermin zu begleichen, sofern
die Gesellschaft nicht schon als insolvent im Sinne von Artikel 437 des Luxemburgischen Handelsgesetzes anzusehen ist.
«L-1-Aufhol-Rendite» bedeutet den Empfang durch die Inhaber der Stammaktien, ausgenommen der Klasse M-
Stammaktien, Klasse L-1-Stammaktien und Klasse P-Stammaktien, von Ausschüttungen gemäß der Absätze 19(h), 19(j)
und 19(l), gleich der Summe von (A) dem Produkt von (i) USD 17.321 (anteilsmäßig angepasst für alle Aktienaufteilungen,
Dividenden durch Auszahlung von Aktien und sonstige Rekapitalisierungen, die sich auf die Stammaktien auswirken),
multipliziert mit (ii) der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien, ausgenommen der Klasse P-Stamm-
aktien, Klasse M-Stammaktien, Klasse L-1-Stammaktien und Klasse C-Stammaktien, (unter der Annahme, dass alle
CPECs vollständig gewandelt wurden), ab dem Datum, an dem die Entscheidung, ob die L-1-Aufhol-Rendite erreicht
wurde, getroffen wird, zuzüglich (B) der Summe, auf die solche Inhaber gemäß der Absätze 19(h), 19(j) und 19(l) ein
Anrecht hätten, unter der Annahme, dass (i) gemäß Absatz 19(d) keine vorherigen Ausschüttungen ausgezahlt worden
sind (und dass solche Summen gemäß der Absätze 19(e) bis 19(m) dieser Statuten weiter ausgeschüttet wurden), (ii) die
Inhaber von Klasse M-Stammaktien und Klasse L-1-Stammaktien dann berechtigt waren, an Ausschüttungen gemäß der
Absätze 19(h), 19(j) und 19(l) teilzunehmen, anteilmäßig auf Grundlage der Anzahl der Klasse M-Stammaktien, Klasse L-
1-Stammaktien solcher Inhaber (es wird davon ausgegangen, dass, in der Tat, kein Inhaber von Klasse M-Stammaktien
und Klasse L-1-Stammaktien ein Anrecht auf Teilnahme an der L-1-Aufhol-Rendite hat) und (iii) die Ausschüttung gemäß
der Absätze 19(h), 19(j) und 19(l) nur solange bis und in dem Ausmaß fortgeführt wird, in dem die Inhaber der Klasse
L-1-Stammaktien eine Summe gemäß einer solchen Ausschüttung erhalten haben, die der Summe der Ausschüttungen
entspricht, die gemäß Absatz 19(d) tatsächlich vorgenommen wurde.
«Rechtlich Vorhandene Mittel» bedeutet die zur Ausschüttung vorhandenen Mittel, wie definiert in Artikel 72-1 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, neue Fassung.
«Kommanditist(en)» bedeutet den(die) jeweiligen Kommanditisten der Gesellschaft.
«Golden-Gate-Mehrheitswertpapierinhaber» sind die Inhaber von mehr als 50% der Summe der Klasse P-Stammak-
tien, die zu diesem Zeitpunkt ausstehen und sich im Besitz der Golden-Gate-Wertpapierinhaber befinden.
«Summit-Mehrheitswertpapierinhaber» sind die Inhaber von mehr als 50% der Summe der Klasse P-Stammaktien, die
zu diesem Zeitpunkt ausstehen und sich im Besitz der Summit-Wertpapierinhaber befinden.
«Zwingender Rückzahlungstermin» ist der 31. Dezember 2007.
«Ursprüngliche Kosten» jeder Klasse M-Stammaktie, jeder Klasse L-1-Stammaktie und jeder Klasse L-Stammaktie,
entsprechend dem ursprünglich der Gesellschaft oder ihrem Vorgänger als Anteil gezahlten Kaufpreis (anteilsmäßig an-
gepasst für alle Aktienaufteilungen, Dividendenauszahlung durch Aktien, Aktientauschgeschäfte und sonstige Rekapitali-
sierungen, die sich auf die Klasse M-Stammaktien, Klasse L-1-Stammaktien und Klasse C-Stammaktien auswirken)
«Person» bedeutet eine Einzelperson, eine Personengesellschaft (partnership), eine Aktiengesellschaft (corporation),
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) (LLC), eine Vereinigung, eine Aktiengesellschaft
(joint stock company), eine Treuhandgesellschaft (trust), ein Gemeinschaftsunternehmen (joint venture), eine nicht ein-
getragene Organisation oder eine andere juristische Person oder eine Regierung oder eine Filiale, Abteilung, Behörde,
politisch untergeordnete Abteilung oder ein Beamter einer solchen.
«Vorzugsbetrag» von einer Klasse P-Stammaktie entspricht USD 1.000,- (anteilsmäßig angepasst für alle Aktienauftei-
lungen, Dividenden durch Auszahlung von Aktien und sonstige Rekapitalisierungen, die sich auf die Klasse P-Stammaktien
auswirken).
«Vorzugsrendite» bedeutet mit Bezug auf jede Klasse P-Stammaktie, den in einem solchen Quartal täglich auf diese
Klasse P-Stammaktie anfallenden Betrag, zu einem Zinssatz von 18,5% pro Jahr (ab dem ursprünglichen Ausgabetermin
einer solchen Aktie oder einem Wertpapier, das gegen eine solche Klasse P-Stammaktie eingetauscht wurde), der am
letzten Tag jedes Kalenderquartals berechnet wird auf die Summe des (a) Nicht Gezahlten Vorzugsbetrages der Stamm-
aktie zuzüglich (b) die für alle vorherigen Quartale Nicht Gezahlte Vorzugsrendite darauf; vorausgesetzt, dass beim Ein-
treten eines Versäumnisses die Vorzugsrendite sofort um einen Zuwachs von zwei Prozentpunkten (2%) steigt, und alle
solche 2% Zuwächse der Vorzugsrendite daher ab dem Datum, an dem das Versäumnis nicht mehr existiert, ab Ge-
schäftsschluss, enden, vorbehaltlich nachfolgender Zuwächse als Ergebnis des Eintretens (oder Wiedereintretens) eines
nachfolgenden Versäumnisses. Bei der Berechnung der Höhe von Zahlungen in Verbindung mit Rückzahlungen einer
43476
Klasse P-Stammaktie während eines Kalenderquartals muss der Anteil der Vorzugsrendite einer Klasse P-Stammaktie
für denjenigen Teil eines solchen Quartals, der abläuft, bevor eine solche Rückzahlung gemacht wird, mit berücksichtigt
werden.
«Primärrendite» bedeutet im Hinblick auf jede Klasse L-1-Stammaktie bezüglich jedes Kalenderquartals, für jeden Tag
des Quartals den auf eine solche Aktie entfallenden Betrag (ab dem ursprünglichen Datum der Ausgabe einer solchen
Aktie oder jeglichem für eine solche Klasse P-Stammaktie eingetauschten Wertpapieres), mit einem Prozentsatz von
12,5% per annum über die Summe von (i) der Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen Kosten für eine solche Aktie, zu-
züglich (ii) der hierauf entfallenden Nicht Gezahlten Primärrendite für alle vorherigen Quartale. Bei der Berechnung des
Betrages einer während eines Kalenderquartals vorzunehmenden Ausschüttung ist der Anteil der Primärrendite einer
Klasse L-1-Stammaktie für den vor dieser Ausschüttung verstrichenen Teil des Quartals zu berücksichtigen.
«Sekundärrendite» bedeutet im Hinblick auf jede L-1-Klasse-Stammaktie der in jedem Kalenderquartal für jeden Tag
des Quartals auf eine solche Aktie entfallende Betrag (ab ursprünglichen Datum der Ausgabe einer solchen Aktie oder
jeglicher gegen eine solche P-Klasse-Stammaktie eingetauschtes Wertpapier) mit einem Prozentsatz von 6% per annum
über die Summe von (i) der Nicht Zurückgezahlten Ursprünglichen Kosten für eine solche Aktie, zuzüglich (ii) des hier-
auf entfallenden Nicht Gezahlten Sekundärgewinns für alle vorherigen Quartale. Bei der Berechnung des Betrages einer
während eines Kalenderquartals vorzunehmenden Ausschüttung ist der Anteil der Sekundärrendite einer Klasse L-1-
Stammaktie für den vor dieser Ausschüttung verstrichenen Teil des Quartals zu berücksichtigen.
«Serie A CPEC» bedeutet die Wandelanleihzertifikate der Serie A, die die Gesellschaft ausgibt.
«Serie B CPEC» bedeutet die Wandelanleihzertifikate der Serie B, die die Gesellschaft ausgibt.
«Serie C CPEC» bedeutet die Wandelanleihzertifikate der Serie C, die die Gesellschaft ausgibt.
«Serie D CPEC» bedeutet die Wandelanleihzertifikate der Serie D, die die Gesellschaft ausgibt.
«Serie L CPEC» bedeutet die Wandelanleihzertifikate der Serie L, die die Gesellschaft ausgibt.
«Serie L-1 CPEC» bedeutet die Wandelanleihzertifikate der Serie L-1, die die Gesellschaft ausgibt.
«Serie M CPEC» bedeutet die Wandelanleihzertifikate der Serie A, die die Gesellschaft ausgibt.
«Serie P CPEC» bedeutet die Wandelanleihzertifikate der Serie A, die die Gesellschaft ausgibt.
«Solvente Umstrukturierung» bedeutet jede solvente Umstrukturierung der Gesellschaft, des Geschäftsführers oder
einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft, einschließlich durch Fusion, Verschmelzung, Kapitalumschichtung, Übertra-
gung von Aktien oder Sachvermögen, oder Einlagen von Eigentum und/oder Sachvermögen, oder jede Auflösung, Tausch
von Wertpapieren, Umwandlung von Kapital, Übernahme von Kapital, Gründung neuer Gesellschaften, oder jede ande-
re Transaktion oder Gruppe von verwandten Transaktionen (jeweils andere als solche zu Gunsten oder mit einer drit-
ten Person, welche nicht Mitglied der Gesellschaftsgruppe oder seiner angegliederten Gesellschaften ist (was eine
Gesellschaft einschließen kann, die zum Zwecke der Umstrukturierung gegründet worden ist)), in welcher:
(i) alle Inhaber derselben Klasse oder Serie von Stammaktien oder CPECs das selbe Entgelt bekommen in Bezug auf
diese Stammaktien oder CPECs;
(ii) die anteiligen indirekten wirtschaftlichen Interessen der Inhaber der Stammaktien und CPECs in den Geschäften
der INFOR GLOBAL SOLUTIONS AG, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht der
Schweiz, und seiner Tochtergesellschaften, in Bezug aufeinander und alle Inhaber, auf direkte oder indirekte Weise, von
Kapital-Wertpapieren der Gesellschaftsgruppe (andere als solche die durch die Gesellschaften innerhalb der Gesell-
schaftsgruppe gehalten werden), gewahrt werden; und
(iii) die Rechte der Inhaber von Stammaktien und CPECs anhand eines Vertrages zwischen der Gesellschaft und die-
sen Inhabern in Bezug auf diese Stammaktien und CPECs in allen Hinsichten gewahrt werden (beispielhaft und nicht aus-
schließlich sei hierbei zu verstehen, dass die Verschiebung einer Vereinbarung oder Beschränkung von einem Instrument
zu einem anderen als Wahrung der Rechte zu verstehen ist, falls die Verschiebung notwendig ist, anhand Gesetze oder
Verordnungen, die auf die Gesellschaft anwendbar sind nach einer solchen Umstrukturierung, als Resultat eines Wech-
sels der Nationalität oder der Gesellschaftsform einer Gesellschaft in Verbindung mit der Solventen Umstrukturierung;
unter der Bedingung dass solche Vereinbarungen oder Beschränkungen in Instrumenten festgehalten sind, die so weit
wie möglich, und im Einklang mit den Geschäfts- und Transaktionszielen, den Instrumenten entsprechen in welchen sol-
che Beschränkungen oder Vereinbarungen enthalten waren vor der Solventen Umstrukturierung).
«Tochtergesellschaft» bedeutet im Hinblick auf jede Person, jede Aktiengesellschaft (corporation), Personengesell-
schaft (partnership), Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Vereinigung oder andere Geschäftseinheit von welcher (i)
im Fall einer Aktiengesellschaft, die Mehrheit aller Stimmrechte der Aktien, welche (ohne Hinblick auf ein unvorherseh-
bares Ereignis) das Recht gewähren, für die Wahl der Geschäftsführer zu stimmen, zu diesem Zeitpunkt durch diese
Person oder eine oder mehrere Tochtergesellschaften dieser Person oder beide zusammen auf direkte oder indirekte
Art und Weise gehalten oder kontrolliert wird, (ii) im Falle einer Personengesellschaft, Vereinigung, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung oder einer anderen Geschäftseinheit, die Mehrheit der Personengesellschaft, seiner Mitglieder
oder andere auf ähnliche Art Beteiligte an der Personengesellschaft zu diesem Zeitpunkt durch eine Person oder eine
oder mehrere Tochtergesellschaften dieser Person oder beide zusammen auf direkte oder indirekte Weise gehalten
oder kontrolliert wird. Hierbei geht man davon aus, dass eine Person oder mehrere Personen die Mehrheit einer Per-
sonengesellschaft, Vereinigung oder einer anderen Geschäftseinheit halten, wenn die Mehrheit der Verluste und Gewin-
ne der Personengesellschaft, Vereinigung oder der anderen Geschäftseinheit einer solchen Person oder solche Personen
zugeteilt wird oder wenn letztere der Managing Director oder der General Partner einer solchen Personengesellschaft,
Vereinigung oder Geschäftseinheit ist oder diesen kontrolliert.
«Summit-Wertpapierinhaber» bedeutet, solange, wie sie die Inhaber der Wertpapiere der Gesellschaft sind, die nach-
folgenden Inhaber der Wertpapiere der Gesellschaft, und jeden, der von ihnen Stammaktie der Gesellschaft erhält: Sum-
mit Ventures V, L.P.; Summit V Advisors Fund (QP), L.P.; Summit V Companion Fund, L.P.; Summit V Advisors Fund,
L.P.; Summit Investors III, L.P.; Randolph Street Partners; und Randolph Street Partners DIF, L.L.C.
43477
«Dreifache Rendite» bedeutet die derzeitigen Einnahmen jedes Golden-Gate-Wertpapierinhabers aus Cashzahlungen
im Hinblick auf und/oder im Austausch für seine Wertpapiere der Gesellschaft (ob solche Zahlungen bei der Gesellschaft
oder einer dritten Partei eingegangen sind, wohlverstanden ausgenommen alle Gebühren oder sonstige an den Golden-
Gate-Wertpapierinhaber oder Tochtergesellschaften gezahlten oder zu zahlenden Beträge oder Ausschüttungen gemäß
Artikel 19 (f)) in Höhe des dreifachen Betrages der Gesamtinvestition des Golden-Gate-Wertpapierinhabers in Wert-
papiere der Gesellschaft. Zu diesem Zweck bedeutet die «Investition» des Golden-Gate-Wertpapierinhabers den Ge-
samtkaufpreis, der ursprünglich für alle Wertpapiere der Gesellschaft an die Gesellschaft oder ihre Vorgänger gezahlt
worden ist. Jedes Mal, wenn ein Golden-Gate-Wertpapierinhaber tatsächlich Cashzahlungen erhält, wird eine Entschei-
dung hierüber im Hinblick auf und/oder im Austausch für seine Wertpapiere der Gesellschaft getroffen, und jeder Gol-
den-Gate-Wertpapierinhaber kooperiert mit der Gesellschaft und stellt der Gesellschaft alle vernünftigerweise
verlangten Informationen zur Verfügung, um zu entscheiden, ob die «Dreifache Rendite» erzielt worden ist.
«Nicht Gezahlter Vorzugsbetrag» bedeutet im Hinblick auf jede Klasse P-Stammaktie einen Betrag in Höhe des Über-
schusses, sollte es einen solchen geben, nach Vergleich des (A) Vorzugsbetrages auf eine solche Aktie gegenüber (B)
dem Gesamtbetrag der an die Gesellschaft geleisteten Zahlungen, die eine Rückzahlung des Vorzugsbetrages auf eine
solche Aktie darstellen.
«Nicht Gezahlter Vorzugsgewinn» bedeutet im Hinblick auf jede Klasse P-Stammaktie einen Betrag in Höhe des
Überschusses, sollte es einen solchen geben, nach Vergleich der (a) auf eine solche Aktie insgesamt anfallenden Vorzugs-
rendite gegenüber (b) den insgesamt von der Gesellschaft geleisteten Zahlungen, die Zahlungen der Vorzugsrendite auf
eine solche Aktie darstellen.
«Nicht Gezahlte Primärrendite» bedeutet im Hinblick auf jede Klasse L-1-Stammaktie einen Betrag in Höhe des Über-
schusses, sollte es einen solchen geben, nach Vergleich der (a) auf eine solche Aktie anfallenden Primärrendite gegenüber
(b) dem insgesamt von der Gesellschaft geleisteten Betrag an Ausschüttungen, die Zahlungen der Primärrendite auf eine
solche Aktie darstellen.
«Nicht Gezahlte Sekundärrendite» bedeutet im Hinblick auf jede Klasse L-1-Stammaktie einen Betrag in Höhe des
Überschusses, sollte es einen solchen geben, nach Vergleich der (a) auf eine solche Aktie anfallenden Sekundärrendite
gegenüber (b) dem insgesamt von der Gesellschaft geleisteten Betrag an Ausschüttungen, die Zahlungen der Sekundär-
rendite auf eine solche Aktie darstellen.
«Nicht Gezahlte Rendite» bedeutet im Hinblick auf jede Klasse M-Stammaktie und jede Klasse L-Stammaktie einen
Betrag in Höhe des Überschusses, sollte es einen solchen geben, nach Vergleich der (a) auf eine solche Aktie anfallende
Rendite und (b) dem insgesamt von der Gesellschaft geleisteten Betrag an Ausschüttungen, die Zahlungen der Rendite
auf eine solche Aktie darstellen.
«Nicht Zurückgezahlte Ursprüngliche Kosten» bedeutet im Hinblick auf Stammaktien der Klassen M, L-1 und L einen
Betrag in Höhe des Überschusses, sollte es einen solchen geben, nach Vergleich der (a) Ursprünglichen Kosten für eine
solche Aktie und (b) dem von der Gesellschaft insgesamt geleisteten Betrag an Ausschüttungen, die die Rückerstattung
der Ursprünglichen Kosten für eine solche Aktie darstellen.
«Rendite» bedeutet für jede Stammaktie der Klassen M und L, den in Hinblick auf jedes Kalenderquartal für jeden Tag
des Quartals auf eine solche Stammaktie anfallenden Betrag (ab dem ursprünglichen Datum der Ausgabe einer solchen
Aktie oder jedes für eine solche Aktie eingetauschten Wertpapieres) mit einem Prozentsatz von 12,5% per annum über
die Summe von (i) der Nicht Zurückerstatteten Ursprünglichen Kosten für eine solche Aktie zuzüglich (ii) der hierauf
entfallenden Nicht Zurückerstatteten Rendite für alle vorherigen Quartale. Bei der Berechnung des Betrages einer wäh-
rend eines Kalenderquartals vorzunehmenden Ausschüttung ist der Anteil der Rendite einer Stammaktie für den vor
dieser Ausschüttung verstrichenen Teil des Quartals zu berücksichtigen.
N. Geltendes Gesetz
Art. 32. Für alle Tatbestände, die nicht durch diese Statuten geregelt werden, verweisen die Parteien auf das Gesetz
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Kosteni>
Zwecks Einregistrierung wird die Summe von USD 4.000.000,- auf EUR 3.095.735,75 abgeschätzt.
Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf
fünfunddreißigtausend Euro geschätzt.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte offen stehen, gilt die Hauptversammlung als beendet.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass das Dokument in englischer
Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Version; auf Verlangen der erschienenen Person ist bei Unterschieden
zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version maßgebend.
Das Dokument wurde den Personen, die vor dem Notar erschienen und diesem mit Nachnamen, Vornamen, Fami-
lienstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen. Diese Personen unterzeichneten gemeinsam mit dem Notar das vor-
liegende Dokument.
Gezeichnet: C. Bourke, S. Konsbruck, Y. Gabriel, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 12 avril 2005, vol. 431, fol. 24, case 5. – Reçu 30.957,36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Verröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(036649.3/242/1758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
Mersch, den 13. April 2005.
H. Hellinckx.
43478
FLOTS YACHTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.163.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 28
février 2005 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes
suivantes:
Mademoiselle Florence Durual, responsable commerciale, demeurant à F-77127 Lieusant, Ferme de Villepècle, allée
Royale.
Monsieur Pierre Durual, Président Directeur Général, demeurant à F-77550 Moissy Cramayel, 63, rue Bajot.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-
2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux
Comptes la personne suivante:
Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 28 février
2005 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire du qui s’est tenu au siège social à
Luxembourg, en date du 28 février 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou de la contre valeur en devise) et sous réserve de la
limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que les gros travaux sur le
navire devront requérir la signature de deux administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06168. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036852.3/2329/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
IMMOBILIERE CENTURIA LUXEMBOURG 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 96.854.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00768, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037024.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
GO-SOFT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 98.794.
—
La société GO-SOFT, S.à r.l., représentée par Madame Urusla Gorbauch a pris la décision de transférer son siège
social de chez Maître Bicard, 100, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg vers Maître Scott, 2A, place de Paris, L-2314
Luxembourg, avec effet le 15 avril 2005.»
Fait à Luxembourg, le 11 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03350. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(037094.3/203/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Signature.
<i>Pour IMMOBILIERE CENTURIA LUXEMBOURG 2 S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
U. Gorbauch
<i>La gérante i>
43479
CHATKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 86.293.
—
EXTRAIT
II résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 21 avril
2005 que:
- la démission de Monsieur Lex Benoy de ses fonctions de commissaire aux comptes a été acceptée;
- la société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxem-
bourg a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036854.3/317/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
INTERFUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 8.074.
—
Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 29 mars 2005, par-devant M
e
Jacques
Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n
o
170, que:
- Ont été nommés administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire en l’an 2006:
1. Monsieur Luigi Cappugi, né à Florence (Italie) le 10 avril 1936, résidant à Florence, 20, Vicolo del Cionfo, Professeur
à l’Université «la Tuscia» de Viterbo, Administrateur;
2. Mme Franca Cirri Fignagnani, née à Ravenna (Italie) le 4 septembre 1942, résidant à Bologne, 103, Via Santo Stefano
I-40125, Administrateur de Sociétés, Administrateur;
3. Monsieur Claudio Sozzini, né le 8 novembre 1943 à Crema (Italie), Vice Directeur Général, BANCA FIDEURAM
S.p.A., résidant à I-20122 Milan, Corso di Porta Romana 16, Administrateur;
4. M. Tommaso Corcos, né le 5 janvier 1962 à Rome (Italie), Administrateur-délégué de FIDEURAM INVESTIMENTI
SGR SpA, résidant à 1-00192 Rome, 43, via del Serafico, Administrateur;
5. M. Alex Schmitt, né le 24 mars 1953 à Luxembourg, avocat, résidant à Luxembourg, 44, rue de la Vallée, Adminis-
trateur.
- A été nommé Réviseur d’entreprises jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2006:
ERNST & YOUNG, Luxembourg.
L’assemblée donne pleine et entière décharge aux Administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036881.3/208/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
ATELIER DE RESTAURATION TAILLEFERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 146, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.343.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00839, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2005.
(036943.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>J. Delvaux
<i>Notairei>
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
43480
PER INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.115.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 mars 2005i>
1. Le mandat d’Administrateur-Délégué de:
- Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
et les mandats d’Administrateur de:
- Monsieur Paul Depuydt, directeur financier, demeurant au 6 Kolveniersstraat, B-2000 Amtwerpen,
- Madame Margriet Jacobs, Manager de fonds de pension, 194 Bijlokstraat, B-3020 Herent,
sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny,
L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05788. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036882.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2005.
TRIDAMD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3926 Mondercange, 2A, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 101.457.
—
<i>Cession de parts sous seing du 21 mai 2004i>
Entre les soussignés:
1. La société à responsabilité limitée TRIDAMD, S.à r.l., avec siège social à L-3926 Mondercange, 2A, Grand-rue, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 mai 2004, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
ici représentée par son gérant unique:
Monsieur Claude Zanardelli, indépendant, demeurant à F-54590 Hussigny-Godbrange, 13, rue Marie Curie.
Fonction à laquelle ils ont été nommés suite à l’assemblée générale extraordinaire des associés, prise à la suite de
l’acte constitutif prédit et déclarant engager la prédite société sous sa seule signature.
2. Monsieur Claude Zanardelli, prénommé, agissant en nom personnel.
3. Monsieur Angelo Rosa, commerçant, demeurant à F-54620 Joppecourt (F), 2, rue du Pont.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter leurs déclarations comme suit:
- les parts sociales de la société TRIDAMD, S.à r.l., se trouvent actuellement réparties comme suit:
Par les présentes, Monsieur Claude Zanardelli, prénommé, déclare céder et transporter quarante-neuf (49) parts so-
ciales qu’il détient dans la prédite société à Monsieur Angelo Rosa, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour
et moyennant le prix de six mille soixante-seize euros (EUR 6.076,-), somme que le cédant déclare avoir reçu de la ces-
sionnaire, avant la passation des présentes directement, ce dont il en donne quittance titre et décharge pour solde.
La société TRIDAMD, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d’être dit, déclare accepter les cessions ci-
avant mentionnées conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui
signifier et n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.
A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société TRIDAMD, S.à r.l., se trouve réparti de la manière
suivante:
Telles sont les conventions des parties.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2005, réf. LSO-BD00922. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037096.3/203/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Certifié sincère et conforme
<i>PER INVESTMENTS HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Monsieur Claude Zanardelli, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Monsieur Angelo Rosa, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 parts
Monsieur Claude Zanardelli, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Fait en trois originaux à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2004.
Signatures.
43481
CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 104.817.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales daté du 29 décembre 2004i>
Il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu en date du 29 décembre 2004 que Monsieur Luigi Lanari, en
tant que cédant, a cédé 32 parts sociales qu’il détenait dans la Société à CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED, en tant
que cessionnaire.
Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de la Société sont les suivants:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01034. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036964.3/1035/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
LUBIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.707.
—
RECTIFICATIF
<i>de l’extrait enregistré à Luxembourg le 9 février 2005, référence LSO-BB02048, déposé au registre de commercei>
<i>et des sociétés de Luxembourg le 11 février 2005i>
Il y a lieu de lire:
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 31 janvier 2005
que:
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005:
* Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
* Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg.
A été élu Administrateur, en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur, dont le mandat a pris fin,
pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005:
* Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg.
Nom des associés
Nombre de parts qu’ils possèdent
FUTURELINE HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316
PURVAL INVESTMENTS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
Bruce Hardy McLain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Helle Elisabeth McLain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
STEFLOT HOLDING, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
NEWLIGHT LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
CASSIOPEIA HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Alexander Donald Mackenzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
MOURANT & CO TRUSTEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Corinne Ingeborg Beatrice Koltes-Sulzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Francisco Javier de Jaime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Mark Alan Ross Grizzelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Robert Richard Lucas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Marc Boughton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Jonathan Philip Feuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Nicholas James Archer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Philippe Paul Pierre Gleize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Daniel Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Ute Wera Monika Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Stefan Germanus Maria Jozef Oostvogels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600
Signature
<i>Un mandatairei>
43482
Et:
A été élu Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Commissaire aux Comptes,
dont le mandat a pris fin, pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005:
* H.R.T. REVISION, S.à r.l., sise 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Au lieu de:
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 31 janvier 2005
que:
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005:
* Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
* Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg.
Est élu Administrateur pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005:
* Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg.
Et:
Est élue Commissaire aux Comptes, pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005:
* H.R.T. REVISION, S.à r.l., sise 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04752. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037237.3/802/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00752, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037008.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 20.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037012.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
PRIMAFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 32, place Guillaume II.
R. C. Luxembourg B 83.156.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00300, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037226.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
Luxembourg, le 9 mai 2005.
Signature.
43483
REGAIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.811.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00762, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037019.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
REGAIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.811.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00764, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037020.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
REGAIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 39.811.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00765, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037022.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
GECIS INTERNATIONAL HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500
Siège social: L-13711 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 104.549.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé unique de la société le 4 avril 2005i>
L’associé unique de la Société (l’Associé Unique) a constaté et accepté la démission de LUXEMBOURG
INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg de son poste
de gérant de la Société avec effet au 30 décembre 2004.
L’Associé Unique a nommé les personnes suivantes aux postes de gérants de la Société avec effet au 30 décembre
2004 pour une durée indéterminée:
* Monsieur Denis Nayden, associé d’OAK HILL CAPITAL PARTNER LP, demeurant au 65 East 55th Street, 36th
Floor, New York, NY 10022 (Etats-Unis d’Amérique);
* Monsieur J. Taylor Crandall, associé d’OAK HILL CAPITAL PARTNER LP, demeurant au 2775 Sand Hill Road, Suite
220, Menlo Park, CA 94025 (Etats-Unis d’Amérique);
* Monsieur Mark Dzialga, associé de GENERAL ATLANTIC PARTNERS LLC, demeurant au 15, Vineyard Lane,
Greenwich, CT 06831 (Etats-Unis d’Amérique);
* Monsieur Steven A. Denning, associé de GENERAL ATLANTIC PARTNERS LLC, avec adresse professionnelle au
3 Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06831 (Etats-Unis d’Amérique);
* Monsieur Keith Sherin, directeur général des finances de GENERAL ELECTRIC COMPANY, avec adresse profes-
sionnelle au 3135 Easton Purnpike, Fairfiled, CT 0683USD (Etats-Unis d’Amérique);
* Monsieur Charles Alexander, président de GE EUROPE, avec adresse professionnelle au 3135 Easton Purnpike,
Fairfiled, CT 06831 (Etats-Unis d’Amérique); et
<i>Pour REGAIN S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour REGAIN S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour REGAIN S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
43484
* Monsieur Pramod Bhasin, président et directeur général de GECIS GLOBAL, avec adresse professionnelle à GE
Towers, Sector Road, Sector 53, DLF Phase 5, Gurgaon 122002 (Inde).
L’Associé Unique a nommé KPMG AUDIT, S.à r.l. réviseur d’entreprises de la Société à compter du 4 avril 2005 jus-
qu’à la prochaine assemblée générale des associés qui approuvera les comptes annuels clos au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01354. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(037053.2/253/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
IMMOBILIERE CENTURIA LUXEMBOURG 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 96.853.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00770, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037027.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
SISL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 53.407.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00777, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037039.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
PARTSANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 91.901.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE01236, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037230.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
RECEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.044.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00691, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037289.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour IMMOBILIERE CENTURIA LUXEMBOURG 1 S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour SISL S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
Luxembourg, le 3 mai 2005.
Signature.
Signature.
43485
PEIPERLECK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00774, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037035.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
PEIPERLECK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 47.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00773, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037030.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
PEIPERLECK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 47.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00772, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037029.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
ANSWER SYSTEMS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 80.569.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2005i>
L’an deux mille cinq, le 20 avril.
S’est réunie au siège social, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANSWER SYSTEMS GROUP, constituée suivant acte reçu par
M
e
Jean Seckler, notaire en résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2000 et enregistrée au registre du commer-
ce sous le N
o
B 80.569 le 20 février 2001.
L’Assemblée est présidée par M. Daniel Beuchée, administrateur-délégué, domicilié 15, rue Georges Brassens à F-
91590 La Ferté Alais (France) qui désigne en qualité de secrétaire la société anonyme VENI INVESTMENT ayant son
siège social 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.
Monsieur le Président expose:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jouri>
- révocation & nomination de commissaire aux comptes;
- mandat au conseil d’administration pour la révocation d’un administrateur-délégué.
II. Que les actionnaires ont été convoqués par courrier du 20 avril 2005; que le nombre d’actions représentées est
indiqué sur une liste de présence laquelle après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres
du bureau restera annexée au présent procès-verbal.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que la majorité du capital social est représenté.
<i>Pour PEIPERLECK S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour PEIPERLECK S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour PEIPERLECK S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
43486
III. Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière après délibération prend à l’unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée révoque, à dater de ce jour, le Commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE FMV, S.p.r.l., ayant son siège
social à 38, rue des Vennes à B-4020 Liège (Belgique).
Elle nomme, à dater de ce jour, la S.à r.l. FIDUCIAIRE FMV ayant son siège social à 25A, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-1331 Luxembourg au poste de Commissaire aux comptes pour terminer le mandat de la Sprl FIDUCIAIRE
FMV.
<i>Deuxième résolutioni>
Elle donne mandat au Conseil d’administration, qui se réunira directement après la présente assemblée, de révoquer
l’administrateur-délégué et d’élire un nouvel administrateur-délégué, en son sein.
L’ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a levé la séance
à 11.00 heures.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00263. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(037272.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
VALCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 84.735.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00778, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037042.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
ORBI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 31.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00780, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037044.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 85.107.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2005, réf. LSO-BD06286, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(037546.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.
Signature / Signature
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei>
<i>Pour VALCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour ORBI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour HELIO CHARLEROI FINANCE S.A.
i>Signature
43487
ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.734.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05581, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2005.
(037173.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
ADPARTNERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 69.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00781, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037045.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
SI.TO.FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 44.390.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00784, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
(037047.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.
VVR, Société Anonyme Holding,
(anc. VVR, Société Anonyme).
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 56.752.
—
L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de VVR, Société Anonyme Holding (anc. Société
Anonyme), établie et ayant son siège à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.752, constituée suivant acte Frank Baden de Luxembourg
en date du 28 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 19 du 20 janvier 1997,
modifiée lors de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg extraordinairement le 10 septembre 2001, dont
un extrait a été publié au dit Mémorial, Numéro 308 du 23 février 2002, modifiée suivant acte Paul Bettingen de Nie-
deranven du 8 juin 2004, publié au dit Mémorial, Numéro 813 du 7 août 2004.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant
professionnellement à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée privé, demeurant à Mondorf-les-Bains.
L’Assemblée choisit comme scrutateur James Junker, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange;
- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts;
- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 12 des statuts;
- Fixation de la nouvelle adresse.
<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS, Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour ADPARTNERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>Pour SI.TO.FINANCIERE S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
43488
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-
lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim à L-8080
Bertrange, 36, route de Longwy.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts comme suit:
«Art. 3, premier alinéa. Le siège de la société est établi à Bertrange.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer également le premier alinéa de l’article 12 des statuts comme suit:
«Art. 12, premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois de février à dix heures
à Bertrange, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocations. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Y. Wallers, D. Risch, J. Junker, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 25 avril 2005, vol. 469, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036621.3/218/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
VVR, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 56.752.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036622.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.
Mondorf-les-Bains, le 3 mai 2005.
R. Arrensdorff.
Mondorf-les-Bains, le 3 mai 2005.
R. Arrensdorff.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Securicor Luxembourg S.A.
GM Inter-Est
Classic Line S.A.
Alliance Capital (Luxembourg) S.A.
Jarcam Soparfi S.A.
Sorrilux S.A.
North European Financial Reinsurance S.A.
I.E.D.I. S.A.
Bidrolu S.A.
Robinia Holding S.A.
Atlantis Investment S.A.
IMR International S.A.
Kamea S.A.
Compagnie Aéronautique du Grand-Duché de Luxembourg S.A.
Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
Saipem (Luxembourg) S.A.
Chelsfield (Global Switch), S.à r.l.
BBVA Durbana International Fund
ACM International Health Care Fund
Malerbetrieb Esch, GmbH
Eurotecnica Melamine
Columbus Charter S.A.
New Land S.A.
New Land S.A.
Horizont Marine S.A.
I.O.C. International Overseas Company S.A.
Propper, S.à r.l.
Infor Global Solutions TopCo II S.C.A.
Flots Yachting S.A.
Immobilière Centuria Luxembourg 2 S.A.
Go-Soft
Chatka International S.A.
Interfund Sicav
Atelier de Restauration Taillefert S.A.
Per Investments Holding S.A.
Tridamd, S.à r.l.
CVC Capital Partners Group, S.à r.l.
Lubia S.A.
Granite Invest S.A.
Venture Holding S.A.
Primafin Luxembourg S.A.
Regain S.A.
Regain S.A.
Regain S.A.
Gecis International Holdings
Immobilière Centuria Luxembourg 1 S.A.
SISL S.A.
Partsana S.A.
Recem S.A.
Peiperleck S.A.
Peiperleck S.A.
Peiperleck S.A.
Answer Systems Group S.A.
Valco Investment S.A.
Orbi Investments S.A.
Helio Charleroi Finance S.A.
Italfortune International Advisors
Adpartners International S.A.
SI.TO.Financière S.A.
VVR
VVR S.A.