This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
30625
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 639
1
er
juillet 2005
S O M M A I R E
ABN Amro K Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
30653
Geficar S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30664
Ampax S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30664
Giroflex Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30633
Aurum Dental, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30638
Grid Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30663
Balfrin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30661
Grid Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30663
Cardazzo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30653
Immobilière du Port S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
30665
CDL Expertise, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30657
Intereuropean Finance & Energy Holding S.A.,
Ciments Français International S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30662
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30629
International Flavors & Fragrances Global Holding,
Ciments Français International S.A., Luxem-
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30631
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30630
International Technology Investments S.A., Lu-
Compagnie Européenne de Commerce et de
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30627
Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30638
International Technology Investments S.A., Lu-
Constructions Aveirense, S.à r.l., Esch-sur-Al-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30628
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30660
Intesa Holding International S.A., Luxembourg . .
30653
Cover Fin. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30654
ISCE Investors In Sapient and Cuneo Europe S.A.,
DAB Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30626
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30646
Dasco, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30651
ITS Team S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30658
Dominican Entertainment (Luxembourg), S.à r.l.,
(Les) Jardins de la Musique, S.à r.l., Luxembourg .
30660
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30659
Kenson Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
30664
Duplitape S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30640
Kent International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
30663
Durama Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30643
Lassale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30626
Durama Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30646
LGI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30657
Dutchdelta Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
30652
Magnolia Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30626
Europack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30655
Mas Luc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30660
Europack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30655
Moselle Bois, S.à r.l., Berbourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30636
Europack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30656
Motor Car Leasing S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . .
30647
F.E.T. S.A., Finances Europe Tourisme, Luxem-
Motor Car Leasing S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . .
30649
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30649
Nature-Santé-Beauté (N.S.B.), S.à r.l., Luxem-
F.R.A.L. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30630
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30659
Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30665
Observer New Media, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
30626
Fidelity Funds, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30669
Philos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30635
Fidia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30653
Powergen Australia Investments Limited, S.à r.l.,
Fingesty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30636
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30652
FKI Lusparthree, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
30628
ProLogis Directorship, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
30659
Fundland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30649
ProLogis Moscow II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
30658
Gasberry Natural Resources S.A., Luxembourg . . .
30642
ProLogis Poland XXVII, S.à r.l., Luxembourg . . . .
30639
Gasberry Natural Resources S.A., Luxembourg . . .
30642
ProLogis Poland XXVIII, S.à r.l., Luxembourg . . .
30640
GCE Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30641
ProLogis Poland XXX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
30641
GCE Luxco Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30639
ProLogis Poland XXXI, S.à r.l., Luxembourg . . . .
30641
Geficar S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30664
ProLogis Poland XXXII, S.à r.l., Luxembourg. . . .
30643
30626
DAB INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.243.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020085.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
MAGNOLIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RB HOLDING, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 106.252.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020087.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
OBSERVER NEW MEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LIMRA LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 101.299.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020088.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
LASSALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.306.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020076.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
ProLogis Poland XXXIII, S.à r.l., Luxembourg . . .
30643
Tech Pacific Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
30655
ProLogis Poland XXXIV, S.à r.l., Luxembourg . . .
30647
Thiel Eurologistics Services, S.à r.l., Munsbach . . .
30629
ProLogis Spain II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30649
Universal Air Charter, S.à r.l. - CHARTAIR,
ProLogis Spain III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30657
Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30650
ProLogis Spain IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30658
Veroma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30660
Reflexes Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30659
Vertime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30651
S.C.I. Les Cadenières, Bettembourg. . . . . . . . . . . .
30636
Viatrix Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30661
Société Européenne Répartition Investissements
Viavia Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30661
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30650
Violon Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30661
Somaphi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30652
Viwolari Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30662
Somaphi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30652
Vulcano Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30662
Somaphi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30652
Washington Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
30664
Sopor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30654
Xipidis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30656
(Le) Strasbourg Hôtel Restaurant Brasserie, S.à r.l.,
Xyzalux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30650
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30634
Xyzalux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30650
Sumaho S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30651
Xyzalux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30650
Tasaco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30665
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
30627
INTERNATIONAL TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 31.610.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de INTERNATIONAL TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B
31.610 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire
de résidence à Pétange, en date du 28 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
numéro 40 du 1
er
février 1990.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instru-
mentaire, en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 826 du 10 no-
vembre 2000.
La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les huit cents (800) actions
ordinaires de type A avec droit de vote et les sept mille deux cents (7.200) actions ordinaires de type B avec droit de
vote, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de huit cent
mille euros (EUR 800.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de l’institution du commissaire aux comptes au sein de la Société et remplacement par l’institution
d’un réviseur d’entreprises.
2. Modification afférente de l’article 7 des statuts.
3. Modification de la date de clôture de l’année sociale.
4. Modification afférente de l’article 8 des statuts.
5. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
6. Modification afférente de l’article 9 des statuts.
7. Nomination du réviseur d’entreprises de la Société.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’institution du commissaire aux comptes au sein de la Société est supprimée et remplacée par l’institution d’un ré-
viseur d’entreprises.
Le réviseur d’entreprises, auquel sera confié le contrôle des comptes annuels de la Société, sera désigné par l’assem-
blée générale parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
<i>Deuxième rsolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’article 7 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 7. Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un réviseur d’entreprises, désigné par l’assemblée
générale parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’année sociale du 31 juillet au 31 décembre, de sorte
que la précédente année sociale qui a commencé le 1
er
août 2004 s’est terminée le 31 décembre 2004, l’année sociale
en cours commencée le 1
er
janvier 2005 se terminera le 31 décembre 2005 et les prochaines années sociales commen-
ceront le 1
er
janvier et se termineront le 31 décembre de chaque année.
En conséquence, l’article 8 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Quatrième résolutioni>
La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 1
er
décembre à 9.00 heures au 3 mai à 10.30 heures, laquelle
sera reportée au premier jour ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.
En conséquence, l’article 9 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
30628
«Art. 9. L’assemblée générale se réunit de plein droit le 3 mai à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Cinquième résolutioni>
La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD & KLEIN, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Nu-
méro B 63.706, ayant son siège social au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommée aux fonctions de réviseur
d’entreprises aux fins de contrôle des comptes annuels de la Société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-
res trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, vol. 147S, fol. 22, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019394.3/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
INTERNATIONAL TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 31.610.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
207 du 23 février 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019395.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
FKI LUSPARTHREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 94.954.880,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 103.685.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une convention de cession de parts sociales du 1
er
mars 2005 entre FKI US HOLDING BV, une société
de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à Ringdijk 390B, 2983GS Ridderkerk, Pays-Bas, inscrite au registre
de commerce néerlandais sous le numéro 34128218 et FKI MONDIALE HOLDING BV, une société de droit néerlan-
dais, établie et ayant son siège social à De Boelelaan 7, Officia I, 1083HJ Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de
commerce néerlandais sous le numéro 33121380 que FKI U.S. HOLDING BV a transféré cinq cent quatre-vingt-treize
mille quatre cent soixante-huit (593.468) parts sociales de la société FKI LUSPARTHREE, S.à r.l. à FKJ MONDIALE HOL-
DING BV.
Il ressort d’une convention de cession de parts sociales du 1
er
mars 2005 entre FKI MONDIALE HOLDING BV, une
société de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à De Boelelaan 7, Officia I, 1083HJ Amsterdam, Pays-Bas,
inscrite au registre de commerce néerlandais sous le numéro 33121380 et FKI LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de
droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce luxembourgeois sous le numéro B 70.557 que FKI U.S. HOLDING BV a transféré cinq cent quatre-vingt-treize
mille quatre cent soixante-huit (593.468) parts sociales de la société FKI LUSPARTHREE, S.à r.l. à FKI LUXEMBOURG,
S.à r.l.
Ces cessions de parts sociales ont été dûment acceptées par la société FKI LUSPARTHREE, S.à r.l.
Il résulte de tous ces transferts de parts sociales que la société FKI LUXEMBOURG, S.à r.l., est l’associé unique de la
société FKI LUXEMBOURG, S.à r.l. et détient toutes les cinq cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-huit
(593.468) parts sociales de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019505.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Luxembourg, le 1
er
mars 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 1
er
mars 2005.
M. E. Isaac.
30629
THIEL EUROLOGISTICS SERVICES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Munsbach.
H. R. Luxemburg B 22.938.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 20. Januar 2004i>
Es geht aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der THIEL EUROLOGISTICS
SERVICES S.à r.l. vom 20. Januar 2004 hervor:
Zum Geschäftsführer wird Herr Lutz Enderlein, geboren am 16. September 1955 in Brieselang, wohnhaft in D-14656
Brieselang, Falkenseerweg 4, bestellt.
Zwecks Hinterlegung beim Luxemburgischen Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05071. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020139.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
CIMENTS FRANÇAIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.270.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-trois février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de CIMENTS FRANCAIS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
121 du 31 mars 1994.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître Marthe
Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N
o
1120 du 28 octobre 2003.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, 10, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Mangin, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg.
Le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-cinq mille
sept cent quatorze (35.714) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) euros (EUR) chacune, repré-
sentant l’intégralité du capital social de huit millions neuf cent vingt-huit mille cinq cents (8.928.500,-) euros (EUR) sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La Société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de tou-
tes espèces, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.
Elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés appartenant au même groupe et leur prêter
tous concours.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant avec ou sans
garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émission d’obligations ou par toute autre voie et en prêtant à moyen ou à
long terme aux sociétés dont il est question à l’alinéa qui précède, en restant dans les limites tracées par la loi du trente
et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.»
2. Modification afférente de l’article 4 des statuts en vue de l’adapter à la décision prise.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé du Président et reconnu qu’elle était régulièrement constituée, prend,
après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’article 4 des statuts concernant l’objet social est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de valeurs mobilières
de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.
Unterschrift.
30630
Elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés appartenant au même groupe et leur prêter
tous concours.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant avec ou sans
garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émission d’obligations ou par toute autre voie et en prêtant à moyen ou à
long terme aux sociétés dont il est question à l’alinéa qui précède, en restant dans les limites tracées par la loi du trente
et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: J. Bonnier, S. Mangin, J.-M. Noël, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, vol. 147S, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019401.3/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
CIMENTS FRANÇAIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.270.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
204 du 23 février 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019403.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
F.R.A.L. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.502.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 13 janvier 2005, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
27 mai 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs
suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président
du Conseil d’Administration,
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, Administrateur,
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 30 juin 2004.
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019608.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Luxembourg, le 1
er
mars 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
F.R.A.L. HOLDING S.A.
D. Murari / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateurs i>
30631
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES GLOBAL HOLDING, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8081 Bertrange, 6, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 79.233.
—
In the year two thousand and four, on the sixteenth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of Partners of INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES GLOBAL
HOLDING, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» (limited liability company), having its registered office at L-8081
Luxembourg, 6, rue de Marner, inscribed at Luxembourg trade register section B under number 79.233, incorporated
by deed dated on November 30, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 456
page 21856 of June 19, 2001 and whose Articles of Association have been amended for the last time by deed drawn up
on January 10, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 292 page 13993 of
March 19, 2003.
The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to certify that:
I.- The Partners present or represented and the number of shares held by each partner or representative is shown
on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed
to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 13,150,418 (thirteen million one hundred and fifty thousand four hundred
and eighteen) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the Partners have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- To adopt the legal and fiscal status of a finance holding company and to change accordingly the purpose of the
Company, by giving it the following wording:
The Company’s purpose, requesting expressly the billionaire finance Luxembourg holding 1929 status, is to take par-
ticipations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises;
to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them.
The Company is allowed to participate to the setting-up and to the development of all companies belonging to the
same group and to grant to them any assistance, loans, advances or guarantees. Companies belonging to the same group
are companies in which the Company participate itself directly or indirectly as well as companies belonging or depending
directly or indirectly to the group whose it is itself part.
The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment and development of its purposes, remaining always, however, strictly within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies.
2.- To determine the Luxembourg laws governing the Company.
3.- To amend the articles of Incorporation in order to reflect the decision taken.
4.- To file with the official Luxembourg gazette the shareholding of the Company
After approval of the foregoing, it is unanimously decided as follows:
<i>First resolutioni>
It is decided to adopt the legal and fiscal status of a billionaire finance holding company as governed by the Luxem-
bourg Law of July 31, 1929 and the Grand Duke Order of December 17, 1938, and to change accordingly the purpose
of the Company.
All powers are conferred to the management of the Company in order to carry out the useful and necessary steps
and to make any requests to the competent and concerned administrative authorities for the granting of the special fiscal
status of a billionaire finance holding.
<i>Second resolutioni>
It is decided to determine that the reference Luxembourg laws governing the Company are the Luxembourg Law of
July 31, 1929, of August 10, 1915, of September 18, 1933, of December 28, 1992 and the Grand Duke Order of De-
cember 17, 1938.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the following Articles of Incorporation to read
as follows:
Art. 3. The Company’s purpose, requesting expressly the billionaire finance Luxembourg holding 1929 status, is to
take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them.
30632
The Company is allowed to participate to the setting-up and to the development of all companies belonging to the
same group and to grant to them any assistance, loans, advances or guarantees. Companies belonging to the same group
are companies in which the Company participate itself directly or indirectly as well as companies belonging or depending
directly or indirectly to the group whose it is itself part.
The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful, to the accom-
plishment and development of its purposes, remaining always, however, strictly within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to file the shareholding of the Company with the Mémo-
rial. The shareholding of the Company is composed as follows:
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL
FLAVORS & FRAGRANCES (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social à L-8081 Luxembourg, 6, rue
de Mamer, constituée suivant acte reçu le 30 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 456, page 21856, du 19 juin 2002 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois selon acte reçu le
15 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 292, page 13993, du 19 Mars 2003.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à
L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 13.150.418 (treize millions cent cinquante mille quatre cent dix-huit) parts
sociales, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été
préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Adopter le statut légal et fiscal d’une société holding de financement et changer en conséquence l’objet social de
la Société, pour lui donner la teneur suivante:
L’objet de la Société, qui sollicite expressément le statut de société holding milliardaire de financement au sens de la
loi luxembourgeoise de 1929, est la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entrepri-
ses ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition
de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur.
La Société pourra participer à la création et au développement de toutes les sociétés faisant partie du même groupe
de société ainsi qu’elle pourra octroyer à ces même entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. Les sociétés
faisant partie du même groupe de société sont des sociétés dans lesquelles la société a une participation directe ou in-
directe ainsi que les sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont la société fait
elle-même partie.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement de son objet.
Enfin la Société pourra réaliser toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, tout en bénéficiant du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés de participations financières.
2.- Déterminer les lois luxembourgeoises de référence régissant la Société.
3.- Modifier les statuts de manière à refléter les décisions prises.
Name of the shareholder
Number of
shares
IFF INTERNATIONAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,430,418
IFF (GIBRALTAR) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,720,000
30633
4.- Publier l’actionnariat de la société au Mémorial
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’adopter le statut légal et fiscal d’une société holding milliardaire de financement telles que régie par la
loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 et par l’Arrêté Grand-Ducal du 17 décembre 1938 et de modifier en conséquence
l’objet social de la société.
Tous pouvoirs sont conférés à la gérance de la Société de manière à mener à bien toutes démarches utiles et néces-
saires et pour présenter toutes demandes auprès des autorités administratives compétentes et concernées pour l’octroi
du statut fiscal particulier de holding milliardaire de financement.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de déterminer que les lois luxembourgeoises de référence régissant la Société sont les lois du 31 juillet
1929, du 10 août 1915, du 18 septembre 1933, du 28 décembre 1992 ainsi que l’Arrêté Grand Ducal du 17 Décembre
1938.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier les articles
suivants statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. L’objet de la Société, qui sollicite expressément le statut de société holding milliardaire de financement au
sens de la loi luxembourgeoise de 1929, est la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres
entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation,
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment
l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur.
La Société pourra participer à la création et au développement de toutes les sociétés faisant partie du même groupe
de société ainsi qu’elle pourra octroyer à ces mêmes entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. Les sociétés
faisant partie du même groupe de société sont des sociétés dans lesquelles la société a une participation directe ou in-
directe ainsi que les sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-
même partie.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement de son objet.
Enfin la Société pourra réaliser toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, tout en bénéficiant du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés de participations financières.
<i>Quatrième résolution i>
En conséquence des résolutions précédentes, il est décidé de publier la composition de l’actionnariat de la société.
L’actionnariat se compose comme suit:
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 13, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019519.3/211/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.762.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2005, réf. LSO-BC00075, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019471.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Nom de l’actionnaire
Nombre de parts
sociales
IFF INTERNATIONAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.430.418
IFF (GIBRALTAR) LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.720.000
Luxembourg, le 5 janvier 2005.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 2 mars 2005.
Signature.
30634
LE STRASBOURG HOTEL RESTAURANT BRASSERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 17, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 106.313.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le dix-huit février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.
A comparu:
Monsieur Dominique Olivier Molena, cuisinier, demeurant à L-2561 Luxembourg, 17, rue de Strasbourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de restauration avec débit de boissons alcooliques et
non alcooliques avec l’achat et la vente des articles de la branche. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscrip-
tion, de fusion ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de LE STRASBOURG HOTEL RESTAURANT BRASSERIE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé
unique.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent parts sociales (100)
de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les cent parts sociales (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associée unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui
le constate expressément.
Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2005.
30635
<i>Fraisi>
L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-
combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Décisionsi>
Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Dominique Olivier Molena, prédit.
2- La société est gérée par l’associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-2561 Luxembourg, 17, rue de Strasbourg.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-AIzette, en l’étude du notaire instrumentant date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D.-O. Molena, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 23 février 2005, vol. 904, fol. 90, case 7. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019511.3/203/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
PHILOS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.180.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le lundi 20 décem-
bre 2004 que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date lundi
7 avril 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 30 juin 2004.
L’Assemblée prend acte de la demande de Monsieur Vincent Thill de ne pas renouveler son mandat de Commissaire.
L’Assemblée décide de nommer GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.
Le Commissaire ainsi nommé se chargera de la révision des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003 et 30
juin 2004.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06054. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019611.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Esch-sur-AIzette, le 22 février 2005.
A. Biel.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateurs i>
30636
FINGESTY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 75.841.
—
Par la présente, FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL S.A., 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
dénonce avec effet immédiat en date du 10 février 2005 la domiciliation du siège de la société FINGESTY S.A., enregis-
trée au registre du commerce, section B 75.841 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05843. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018162.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.
MOSELLE BOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6830 Berbourg, 1A, Neie Wee.
R. C. Luxembourg B 61.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05804, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2005.
(019462.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
S.C.I. LES CADENIERES, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3266 Bettembourg, 10, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg E 601.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. Monsieur François Bichel, maître-opticien, né à Dudelange, le 25 août 1953, demeurant à L-3266 Bettembourg, 10,
rue Michel Rodange.
2. Madame Danielle Hipp, épouse Bichel, employée privée, née à Dudelange, le 28 février 1959, demeurant à L-3266
Bettembourg, 10, rue Michel Rodange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile
particulière familiale, qu’ils déclarent constituer entre eux:
Titre I
er
.- Forme et objet, Dénomination, Siège et durée
Art. 1
er
. La société, qui est une société civile particulière familiale, a pour objet la détention, l’acquisition, la vente,
la gestion, la location et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières situées tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, sans préjudice de toutes mesures susceptibles de favoriser soit directement soit indirectement la
réalisation de cet objet.
Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. LES CADENIERES, société civile particulière.
Art. 3. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Bettembourg.
La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert une décision unanime des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II.- Apports en numéraire, Attributions de parts d’intérêts
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 3.000,- (trois mille Euros) représenté par trente (30) parts d’intérêts d’une
valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune.
Les trente (30) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit:
Les souscripteurs ont procédé à la libération des parts par l’apport de EUR 3.000,- (trois mille Euro) en numéraire
de sorte que ladite somme est désormais à la disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instru-
mentant.
Art. 6. Chaque part d’intérêt confère à l’associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à
une fraction proportionnelle au nombre de parts d’intérêts existantes.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
1. M. Bichel, prénommé, quinze parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Mme Hipp, prénommée, quinze parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Total: trente parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30637
Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.
Vis-à-vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l’article 1863 du
Code civil.
Art. 7. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des
associés représentant au moins les trois quarts des parts d’intérêts.
Les parts d’intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément
d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n’est toutefois
pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d’héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en
ligne directe, soit au conjoint survivant.
Les cessions entre vifs s’opèrent par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux
tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société par exploit d’huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément à l’article 1690 du Code civil.
Art. 8. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que
l’indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.
Les héritiers et légataires de parts d’intérêts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, pour l’exercice de leurs droits,
sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.
Titre III.- Administration
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs associé, nommé par les associés, pour un terme déterminé ou
indéterminé. Même nommé pour un terme déterminé, l’administrateur est révocable à tout moment par décision des
associés.
Art. 10. Le ou les administrateurs est/sont investi des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus
pour la réalisation de l’objet social.
A l’égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par la signature de l’administrateur unique qui
n’a pas à apporter la preuve d’une délibération préalable du conseil ou des associés ou par la signature conjointe de deux
administrateurs en cas de pluralité.
L’administrateur peut conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.
Titre IV.- Décision des associés
Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d’une convocation émanant soit de l’admi-
nistrateur, soit de deux associés.
Les avis de convocation contiennent obligatoirement l’ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux
associés, huit jours au moins à l’avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d’un pouvoir
spécial.
Chaque part d’intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants.
Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n’est
régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d’intérêt sont dûment représentées. La décision
requiert une majorité des 3/4 des parts présentes ou représentées.
Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l’universalité des associés et les décisions qu’elles
prennent valablement obligent tous les associés.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont
signés par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par un administrateur.
Titre V.- Année sociale
Art. 12. L’année sociale s’étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Titre VI.- Dissolution
Art. 13. Ni le décès, ni l’interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un associé ou d’un
administrateur n’entraînent la dissolution de la société.
Art. 14. En cas de dissolution anticipée de la société la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur alors
en fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.
Titre VII.- Divers
Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1832 et suivants du Code civil sont
applicables.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties déclarent que la société ci-avant constituée est une société familiale entre les époux seuls prénommés.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille euros.
30638
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris la résolution suivante:
1) Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée avec pouvoir de signature conjointe:
1. Monsieur François Bichel, maître-opticien, né à Esch-sur-Alzette, le 25 août 1953, demeurant à L-3266 Bettem-
bourg, 10, rue Michel Rodange.
2. Madame Danielle Hipp, épouse Bichel, employée privée, née à Dudelange, le 28 février 1959, demeurant à L-3266
Bettembourg, 10, rue Michel Rodange.
2) L’adresse de la société est fixée à L-3266 Bettembourg, 10, rue Michel Rodange.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Bichel, D. Hipp, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, vol. 146S, fol. 97, case 1. – Reçu 15 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019515.3/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
AURUM DENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1858 Luxembourg, 57, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 67.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05808, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2005.
(019468.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMMERCE ET DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 90.070.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 novembre 2004i>
Révocation d’un administrateur:
L’Assemblée révoque M. Jean Michel Cesbron comme administrateur de la société.
Nomination de deux administrateurs:
L’Assemblée décide de nommer aux postes d’administrateur:
- Monsieur Patrice Jedrzejewski, né le 5 juillet 1959 à Paris (F), demeurant 19, place Molière à F-49000 Angers;
- Monsieur Pascal Robinet, né le 21 mai 1950 à Charleville (F), demeurant 5, rue d’Arlon, L-7412 Bour.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2009.
Révocation du commissaire:
L’Assemblée révoque CICL SOCIETE DE CONSEILS S.A. comme commissaire de la société.
Nomination d’un commissaire:
L’Assemblée décide de nommer au poste de commissaire:
- ABAX AUDIT, S.à r.l., inscrite au RCS Luxembourg B 27.761 établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg,
6, place de Nancy.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00555. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019513.3/1185/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Luxembourg, le 28 février 2005.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
30639
ProLogis POLAND XXVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.955.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019449.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
GCE LUXCO TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 206.214.500,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 99.586.
—
EXTRAIT
TRITON MANAGERS LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, enregistrée sous le numéro 71.499, ayant
son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX, a transféré, en date du 10
février 2005, 350 parts sociales qu’elle détenait dans GCE LUXCO TWO S.à r.l. aux sociétés suivantes:
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
1. TRITON FUND (N
o
1) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 parts sociales
2. TRITON FUND (N
o
2) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
3. TRITON FUND (N
o
3) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
4. TRITON FUND (N
o
4) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
5. TRITON FUND (N
o
5) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 parts sociales
6. TRITON FUND (N
o
6) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
7. TRITON FUND (N
o
7) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 parts sociales
8. TRITON FUND (N
o
8) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
9. TRITON FUND (N
o
9) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMI-
TED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier,
Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
10. TRITON FUND (N
o
10) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hé-
lier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 parts sociales
11. TRITON FUND (N
o
11) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hé-
lier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 parts sociales
12. TRITON FUND (EXECUTIVE) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANA-
GERS LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street,
St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 parts sociales
30640
et
BGLD MANAGERS LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, enregistrée sous le numéro 76.995, ayant son
siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX, a transféré, en date du 10 février
2005, 150 parts sociales qu’elle détenait dans GCE LUXCO TWO S.à r.l. à BGLD CO-INVEST L.P., représenté par son
General Partner, BGLD MANAGERS LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22,
Greenville Street, St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03610. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019669.3/267/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ProLogis POLAND XXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.973.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03711. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019451.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
DUPLITAPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 13.613.
Constituée par acte sous seing privé sous la dénomination de WORLD COMPUTER CORPORATION en date du 25
octobre 1972, publié au Mémorial C N
o
208 du 29 décembre 1972, modifiée par acte de M
e
Tom Metzler, notaire
alors de résidence à Rédange maintenant à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 20 novembre 1975, publié au
Mémorial C N
o
40 du 27 février 1976, modifiée par acte de M
e
Lucien Schuman, notaire alors de résidence à
Luxembourg, en date du 31 juillet 1979, publié au Mémorial C N
o
252 du 30 octobre 1979, modifiée par acte de
M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange en date du 17 octobre 1986,
publié au Mémorial C N
o
358 du 27 décembre 1986, modifiée par acte de même notaire, en date du 12 septembre
2000, publié au Mémorial C N
o
245 du 4 avril 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05825, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2005.
(019473.3/1261/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
13. FUND 1A, représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, une société
régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-
Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 parts sociales
14. BREDERODE INTERNATIONAL S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 99.271, ayant son siège social à 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4 parts sociales
<i>Pour GCE LUXCO TWO, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
<i>Pour DUPLITAPE S.Ai>.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
30641
ProLogis POLAND XXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.033.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03712. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019452.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ProLogis POLAND XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.034.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03713. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019457.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
GCE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 2.446.750,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.011.
—
EXTRAIT
TRITON MANAGERS LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, enregistrée sous le numéro 71.499, ayant
son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX, a transféré, en date du 10
février 2005, 1.876 parts sociales qu’elle détenait dans GCE HOLDCO S.à r.l. aux sociétés suivantes:
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
1. TRITON FUND (N
o
1) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 parts sociales
2. TRITON FUND (N
o
2) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 parts sociales
3. TRITON FUND (N
o
3) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 parts sociales
4. TRITON FUND (N
o
4) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 parts sociales
5. TRITON FUND (N
o
5) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 parts sociales
30642
et
BGLD MANAGERS LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, enregistrée sous le numéro 76.995, ayant son
siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX, a transféré, en date du 10 février
2005, 804 parts sociales qu’elle détenait dans GCE HOLDCO S.à r.l. à BGLD CO-INVEST L.P., représenté par son Ge-
neral Partner, BGLD MANAGERS LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Green-
ville Street, St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03612. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019679.3/267/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
GASBERRY NATURAL RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.376.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06036, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019485.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
GASBERRY NATURAL RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.376.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06035, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019484.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
6. TRITON FUND (N
o
6) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 parts sociales
7. TRITON FUND (N
o
7) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 parts sociales
8. TRITON FUND (N
o
8) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 parts sociales
9. TRITON FUND (N
o
9) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LI-
MITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 parts sociales
10. TRITON FUND (N
o
10) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS
LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 parts sociales
11. TRITON FUND (N
o
11) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS
LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St.
Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 parts sociales
12. TRITON FUND (EXECUTIVE) L.P., représentée par son General Partner, TRITON MANA-
GERS LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street,
St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE4 8PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 parts sociales
13. FUND 1A, représentée par son General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, une société
régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22, Greenville Street, St. Hélier, Jersey, Iles Anglo-
Normandes, JE4 8PX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 parts sociales
14. BREDERODE INTERNATIONAL S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B99.271, ayant son siège social à 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21 parts sociales
<i>Pour GCE HOLDCO, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 2 mars 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 mars 2005.
Signature.
30643
ProLogis POLAND XXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.035.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03714. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019461.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ProLogis POLAND XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.036.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03715. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019463.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
DURAMA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 105.002.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-fourth day of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
STICHTING DURAMA, a Dutch foundation (Stichting) incorporated under the laws of the Netherlands, having its
official seat in the municipality of Rotterdam, the Netherlands,
here represented by Mr. Luke Muchamore, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 23 February 2005.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it is sole share-
holder of DURAMA LUX, S.à r.l. (hereafter the Company), R.C.S. Luxembourg B 105.002, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary, dated 3 December 2004, which has not yet been published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
This having been declared, the sole shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 12 of the Company’s articles of association, which shall henceforth
read in its English version as follows:
«Art. 12.
12.1. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board
of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed, removed and replaced by a
resolution adopted by shareholders representing more than half of the subscribed share capital. The general meeting of
shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) appoint, remove and replace the man-
ager(s). The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appoint-
ment of each of the managers.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
30644
12.2. The board of managers may elect from among its members a chairman. The chairman will preside at all general
meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any two
members of the board. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice, at least eight days’
written notice of board meetings shall be given. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers
are present or duly represented. The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening
notice. The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication
means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule
previously adopted by a resolution of the board of managers.
The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-
resented. Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast. If several classes of
managers exist, a decision of the board of managers is validly taken only if approved by a positive vote expressed by at
least a majority of managers in each class.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his col-
leagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
In case of urgency, circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed
at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an iden-
tical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.
12.3. In case of plurality of managers, each manager will receive an A or B signatory power. In case of a single manager,
the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint
signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power. However, for matters not
exceeding EUR 10,000 the Company is validly bound by the sole signature of any A or B manager.
12.4. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the law of 10th August, 1915 on commercial compa-
nies, as amended, or by the present articles to the general meeting of shareholders are vested in the manager or, in the
case of plurality of managers, in the board of managers.
12.5. The manager or, in the case of plurality of managers, the board of managers, may subdelegate his/its powers for
specific tasks to one or several individual agents. The manager or, in the case of plurality of managers, the board of man-
agers will determine the agent’s responsibilities and his/their remuneration (if any) the duration of the period of repre-
sentation and any other relevant conditions of his/their agency.»
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to appoint Mr. Sam Reckinger, company director, residing at 9, rue Jean-Pierre
Brasseur, L-1258 Luxembourg, as manager of the Company vested with an A signatory power. The sole shareholder
further resolves to vest Mr. Bodo Demisch with a B signatory power.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 17 of the Company’s articles of association, which shall henceforth
read in its English version as follows:
«Art. 17. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment
of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. In-
terim dividends may be declared and paid by the general meeting of shareholders or by the manager/board of managers
at any time out of distributable profits.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves to change the registered office of the Company from 9, avenue Guillaume, L-1651 Lux-
embourg to 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg with retroactive effect from 20 January 2005.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxy of the appearing party, he signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Folgt eine deutsche Übersetzung dieser Urkunde:
Im Jahre zweitausendundfünf, den vierundzwanzigsten Februar.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erscheinen:
STICHTING DURAMA, eine Stiftung holländischen Rechts (Stichting), mit Sitz in Rotterdam, Niederlande,
hier vertreten durch Herrn Luke Muchamore, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Luxemburg, am 23. Februar 2005.
30645
Welche Erschienene den unterzeichneten Notar gebeten hat zu beurkunden, dass sie die alleinige Gesellschafterin
der Gesellschaft DURAMA LUX, S.à r.l. ist (hiernach die Gesellschaft), R.C.S. Luxemburg B 105.002, gegründet gemäß
Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 3. Dezember 2004, welche noch nicht veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde.
Nach dieser Erklärung, hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um demselben, in seiner
deutschen Fassung, folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 12.
12.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Sollte es mehrere Geschäftsführer
geben, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss/müssen kein(e) Gesellschafter sein. Der (die)
Geschäftsführer ist/sind ernannt, entlassen oder ersetzt durch einen Beschluss der Gesellschafter die mehr als die Hälfte
der Gesellschaftskapitals vertreten. Die Generalversammlung der Gesellschafter kann zu jeder Zeit und ad nutum (ohne
einem Grund angeben zu müssen) Geschäftsführer bestellen, absetzen und ersetzen. Die Generalversammlung der Ge-
sellschafter entscheidet über die Entlohnung und die Bedingungen der Ernennung eines jeden Geschäftsführers.
12.2. Der Geschäftsführerrat kann innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden bestimmen. Der Vorsitzende des
Geschäftsführerrats präsidiert alle Sitzungen des Geschäftsführerrats. Die Sitzungen des Geschäftsführerrats werden
vom Vorsitzenden des Geschäftsführerrats oder von zwei Geschäftsführern einberufen. Außer in Notfällen, welche in
der Einladung angemerkt werden, wird mindestens acht Kalendertage vor der Sitzung eine schriftliche Einberufung des
Geschäftsführerrats verschickt. Die Sitzung des Geschäftsführerrats ist ordnungsgemäß abgehalten ohne vorherige Ein-
berufung, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind. Die Sitzungen
des Geschäftsführerrats finden an dem Ort, zu dem Termin, und zu der Uhrzeit statt, die in dem Einberufungsschreiben
angegeben ist. Auf dieses Einberufungsschreiben kann mit der Zustimmung jedes einzelnen Mitglieds des Geschäftsfüh-
rerrats schriftlich oder per Fax oder jegliches andere gültige Telekommunikationsmittel verzichtet werden. Für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrats, die zu Terminen und an Orten abgehalten werden, die in einem Arbeitsplan, der vorher
durch Beschluss des Geschäftsführerrats angenommen worden ist, ist kein separates Einberufungsschreiben erforder-
lich.
Der Geschäftsführerrat kann nur gültiger Beschlüsse nehmen, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder ver-
treten sind. Jeder Beschluss verlangt die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Geschäftsführerrats. Wenn es
mehrere Geschäftsführerklassen gibt, bedarf es einer Mehrheit in jeder Klasse um gültige Beschlüsse zu nehmen.
Jeder Geschäftsführer kann für jeden Geschäftsführerrat schriftlich, durch Telefax oder durch jeglich anderes gültige
Telekommunikationsmittel, einen anderen Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigten ernennen. Ein Mitglied des Ge-
schäftsführerrats kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrats vertreten insofern in der Sitzung mindestens
zwei Geschäftsführer anwesend sind.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats, per Telefon oder Video-Kon-
ferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen erlaubt, die an der
Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören und miteinander zu reden. Auf diese Weise getroffene Beschlüsse sind
genauso gültig und genauso bindend, als ob die Geschäftsführer persönlich an der Sitzung des Geschäftsführerrats teil-
genommen hätten.
In Dringlichkeitsfällen sind Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrats unterzeichnet sind, ge-
nauso gültig und genauso bindend als wären diese Beschlüsse in einer ordnungsgemäßen einberufenen und abgehaltenen
Sitzung genommen worden. Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien
eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief, Telefax oder Telex bestätigt werden.
12.3. Gibt es mehrere Geschäftsführer, bekommt jeder Geschäftsführer entweder ein Unterschriftsbefugnis A oder
eine Unterschriftsbefugnis B. Wenn es nur einen einzelnen Geschäftsführer gibt, ist die Gesellschaft durch die alleinige
Unterschrift von dem alleinigen Geschäftsführer verpflichtet. Gibt es mehrere Geschäftsführer, wird die Gesellschaft
durch die gemeinsamen Unterschriften von einem Geschäftsführer mit einer Unterschriftsbefugnis A und von einem Ge-
schäftsführer mit einer Unterschriftsbefugnis B verpflichtet. Jedoch ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift
von einem A oder B Geschäftsführer für Angelegenheiten, die EUR 10.000 nicht überschreiten, gebunden.
12.4. Der Geschäftsführerrat hat alle Vollmacht um jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der
Gesellschaft auszuführen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften oder durch die Satzung der Gesellschaft der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die
Kompetenz des Geschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, des Geschäftsführerrats.
12.5. Der Geschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat kann einen oder meh-
rere Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen. Der Geschäftsführer oder,
falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat wird die Verantwortlichkeiten und Vergütung, die Tätig-
keitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt, Herrn Sam Reckinger, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 9, rue Jean-Pierre
Brasseur, L-1258 Luxembourg, mit Unterschriftsbefugnis A zu ernennen. Der alleinige Gesellschafter beschließt deswei-
teren Herrn Bodo Demisch eine Unterschriftsbefugnis B zu geben.
<i>Dritter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikels 17 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um demselben, in seiner
deutschen Fassung, folgenden Wortlaut zu geben:
30646
«Art. 17. Ein Betrag von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird dazu benutzt, eine statutarische
Reserve zu bilden, bis diese Reserve zehn Prozent (10%) vom Nominalgesellschaftskapital der Gesellschaft ausmacht.
Der Restbetrag kann an den/die Gesellschafter proportional seines/ihres Anteils in der Gesellschaft ausgeschüttet
werden. Interimsdividenden können jederzeit von der Generalversammlung der Gesellschafter oder von dem Ge-
schäftsführer/ dem Geschäftsführerrat von dem auschüttbaren Gewinn ausgeschüttet werden.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Gesellschaftssitz rückwirkend zum 20. Januar 2005 von 9, avenue Guil-
laume, L-1651 Luxemburg, nach 44, route d’Esch, L-1470 Luxemburg zu verlegen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde
auf Wunsch der Erschienenen in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Fall von
Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat letzterer mit
Uns, dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Muchamore, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, vol. 147S, fol. 27, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recuei des Sociétés et Associations.
(019736.3/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
DURAMA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 105.002.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
226 du 24 février 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019737.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ISCE INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.504.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 février 2005i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée ratifie les cooptations de MM. Patrick Ehrhardt et Jean-Marc Leonard décidée par le conseil d’adminis-
tration en ses réunions du 10 janvier 2001 et du 1
er
juillet 2002.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire
le nombre des administrateurs de quatre à trois et de les élire pour la période expirant à l’assemblée générale extraor-
dinaire statuant sur la mise en liquidation comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
HRT REVISION, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06157. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019576.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Luxemburg, den 3. März 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
MM. Gianfilippo Cuneo, entrepreneur dirigeant, demeurant à Finale Ligure (Italie), administrateur-délégué;
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signature
30647
ProLogis POLAND XXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.025.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03716. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019466.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
MOTOR CAR LEASING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 99.919.
—
In the year two thousand and five, on the fifteenth day of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the Meeting) of MOTOR CAR LEASING S.A., a com-
pany limited by shares (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 99.919, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1818 Luxembourg, 4, rue des Joncs,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 26 March 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N
o
521 of 18 May 2004.
The Articles of Association have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary,
dated 28 October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
28 of 12 January 2005.
The Meeting begins at 3.00 p.m. and is chaired by Maître Gérard Neiens, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints Mr. Frank Stolz-Page, notary’s clerk, residing at Mamer, as Secretary of the meeting.
The Meeting elects Mr. Marc Prospert, notary’s clerk, residing at Bertrange, as Scrutineer of the Meeting (the Chair-
man, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 300 ordinary
shares with a nominal value of EUR 1,000 representing the entirety of the share capital of the Company of EUR 300,000
are duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on
the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed
to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the
notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
<i>Agenda:i>
1. Decision to increase the share capital by an amount of EUR 600,000 to an amount of EUR 900,000.
2. Amendment of Article 5 of the Articles of Association.
The meeting then passes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 600,000 in order to
raise it from its current amount of EUR 300,000 to a total amount of EUR 900,000 by the issuance of 600 new shares
with a par value of EUR 1,000 each.
The other Shareholder having waived his preferential subscription right, all the 600 new shares have been fully sub-
scribed by AIGUILLE LTD, a company incorporated as a private company limited by shares under the laws of Mauritius
on 4th February, 2004, and having its registered office at 3rd Floor, Suite 340-345, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront,
P.O. Box 1070, Port Louis,
here duly represented by Maître Gérard Neiens, prenamed, by virtue of a power of attorney, given on 7 February,
2005.
The said power of attorney, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
These new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 600,000 is at the free disposal of the
Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
30648
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders of the Company decide to amend Article 5, para-
graph 1 of the Articles of Association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:
«Art. 5. (Paragraph 1). The Company’s subscribed share capital is fixed at nine hundred thousand euro (EUR
900,000) represented by nine hundred (900) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.»
There being no further business on the agenda, the meeting is closed at 3.30 p.m.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quinze février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de MOTOR CAR LEASING S.A. (la
Société), société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le nu-
méro B 99.919, ayant son siège social à L-1818 Luxembourg, 4, rue des Joncs, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 26 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
521 du 18 mai
2004.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 28 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
28 du 12 janvier 2005.
La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Maître Gérard Neiens, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant à Mamer.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, clerc de notaire, demeurant à Bertrange (le Prési-
dent, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le Bureau).
Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que les 300 actions d’une valeur
nominale de EUR 1.000 chacune, représentant la totalité du capital social de la Société de EUR 300.000 sont dûment
représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant
à l’ordre du jour, repris ci-dessous, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à cette Assemblée ayant
décidé de se réunir après examen de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le
notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregis-
trement.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Agenda:i>
1. Décision d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de EUR 600.000 à un montant de EUR 900.000.
2. Modification de l’article 5 des statuts.
L’Assemblée prend ensuite les résolutions suivantes à l’unanimité.
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 600.000 en
vue de le porter de son montant actuel de EUR 300.000 à un montant total de EUR 900.000 par l’émission de 600 nou-
velles actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 chacune.
L’autre Actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, toutes les 600 nouvelles actions ont été
intégralement souscrites par AIGUILLE LTD, une société établie comme une «private company limited by shares» sous
le droit mauritien en date du 4 février 2004, avec siège social au 3
ième
étage, Suite 340-345, Barkly Wharf, Le Caudan
Waterfront, B.P. 1070, Port Louis, ici dûment représentée par Maître Gérard Neiens, préqualifié, en vertu d’une pro-
curation émise le 7 février 2005.
Ladite procuration après signature ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au pré-
sent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Ces nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de EUR 600.000 est à la libre
disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, les Actionnaires décident de modifier l’Article 5, alinéa 1
er
des statuts de la
Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
«Art. 5. (Alinéa 1
er
). Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de neuf cent mille euros (EUR
900.000) représenté par neuf cents (900) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
30649
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Neiens, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, vol. 147S, fol. 14, case 10. – Reçu 6.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019391.3/230/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
MOTOR CAR LEASING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 99.919.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
173 du 15 février 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019392.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
F.E.T. S.A., FINANCES EUROPE TOURISME, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06038, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019474.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
FUNDLAND, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.053.
—
Le bilan au 31 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2005, réf. LSO-BC00060, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019486.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ProLogis SPAIN II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.261.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03717. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019507.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Luxembourg, le 1
er
mars 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 3 mars 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 mars 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
30651
DASCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 41.131.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 août 1992, acte publié au
Mémorial C N
o
572 du 5 décembre 1992, modifiée par-devant M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 19 janvier 1993, acte publié au Mémorial C N
o
213 du 11 mai 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05824, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019475.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
VERTIME S.A., Société Anonyme,
(anc. VERSACE S.A.).
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 50.977.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 3 février 2005i>
En date du 3 février 2005, le Conseil d’Administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société
vers l’adresse suivante: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00810. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019476.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
SUMAHO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.061.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1
er
février 2005 de la Société que les
actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée Générale
Annuelle:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.;
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.;
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
2. Election du nouvel Administrateur-Délégué pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée Générale
Annuelle:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3. Election du nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée
Générale Annuelle:
EURAUDIT, S.à r.l.
4. Démission du Commissaire aux Comptes suivant:
DELOITTE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04487. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019849.3/683/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
<i>Pour DASCO, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
VERTIME S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>SUMAHO S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
30652
SOMAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04088, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019477.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
SOMAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04090, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019496.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
SOMAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04092, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019497.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
POWERGEN AUSTRALIA INVESTMENTS LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 530.000,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 80.940.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2005.
(019501.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
DUTCHDELTA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 99.077.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00699, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2005.
(019502.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour POWERGEN AUSTRALIA INVESTMENTS LIMITED, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour DUTCHDELTA FINANCE, S.à r.l.
i>Signature
30653
INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.318.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social en date du 2 mars 2005i>
<i>Résolutioni>
(...) Avant de clôturer la réunion, le Président propose au conseil de coopter M. Norbert Becker, domicilié profes-
sionnellement à Senningerberg (Luxembourg), en qualité de nouvel administrateur de la Société avec effet à compter de
ce jour.
Le conseil, après délibération et sous bénéfice d’une présentation du Président, décide de coopter M. Norbert Becker
préqualifié, en qualité de nouvel administrateur de la Société avec effet à compter du 2 mars 2005. Son mandat viendra
à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 2004. Ladite cooptation sera ratifiée
lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et aux statuts (...)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00813. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019526.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
FIDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00777, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019542.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
CARDAZZO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.930.
—
<i>Rectificatif à l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>tenue de manière extraordinaire le 31 décembre 2004i>
Une erreur s’est glissée dans la modification au registre de commerce et des sociétés, enregistrée le 20 janvier 2005,
référence: LSO-BA05422, en voie de publication: le texte à publier aurait dû être celui-ci:
«Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 décembre 2004.»
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2005, réf. LSO-BC00039. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019568.3/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ABN AMRO K FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 95.469.
—
Le bilan arrêté au 27 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00790, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019654.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour extrait conforme
INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signature
Signature.
30654
COVER FIN. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.342.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le lundi 20 décem-
bre 2004 que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-
ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat
ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date lundi
3 mars 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à ce jour.
L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 30 juin 2004.
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 30 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2005, réf. LSO-BC00007. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019585.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
SOPOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.493.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 24 février 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2009:
- Monsieur Paul Egerton-Vernon, demeurant à Oak Walk, St Peter, Jersey JE3 7EF.
- Madame Louise Walker, demeurant à Oak Walk, St Peter, Jersey JE3 7EF.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg.
- Monsieur Claude Schmitz demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
- Monsieur Marc Lamesch demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2009:
- DELOITTE S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06031. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019796.2/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / O. Piccinelli
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 24 février 2005.
Signatures.
30655
TECH PACIFIC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 94.066.
—
Il résulte d’une décision du conseil de gérance de la Société en date du 28 octobre 2004, que le siège social de la
Société est transféré, avec effet au 10 novembre 2004, au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 1
er
mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2005, réf. LSO-BC00219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019504.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
EUROPACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.393.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 6 décembre 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social 400, rou-
te d’Esch, L-1014 Luxembourg et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer WOOD, APPLETON, OLIVER AUDIT S.à r.l., 9B, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2003 à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019950.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
EUROPACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.393.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 décembre 2003i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003/2004 comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
PricewaterhouseCoopers, 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00818. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019943.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S. A.
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
MM. Michael J. Maillis, Mechanical Engineer, demeurant en Grèce, administrateur;
Michael Panagis, Chemical Engineer, demeurant en Grèce, administrateur;
Charalampos Stavrinoudakis, demeurant en Grèce, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S. A.
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
30656
EUROPACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.393.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 décembre 2004i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2004 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
WOOD, APPLETON, OLIVER AUDIT S.à r.l., 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00816. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019961.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
XIPIDIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 97.442.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 28 décembre 2004, que l’Assemblée a pris, entre
autres, les résolutions suivantes:
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d’Administrateur de la
société, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du
25 juin 2004.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci en qualité d’Administrateur de la société. Le
mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
18 juin 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06052. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019586.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
MM. Michael J. Maillis, demeurant à Athènes (Grèce), administrateur;
Michael Panagis, demeurant à Athènes (Grèce), administrateur;
Charalampos Stavrinoudakis, demeurant à Athènes (Grèce), administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S. A.
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
30657
CDL EXPERTISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
R. C. Luxembourg B 86.604.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société fixé au 13, avenue du Bois à L-1251 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 2 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019506.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ProLogis SPAIN III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 375.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.787.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019523.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
LGI, Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 31.757.
—
Le mandat d’Administrateur de M. Guillaume Dard a pris fin en date du 14 février 2002.
Le mandat d’Administrateur de Mme Cécile Barjak a pris fin en date du 6 janvier 2003.
Le mandat d’Administrateur de M. Hugues Riché a pris fin en date du 15 janvier 2004.
Le mandat d’Administrateur de M. Alain Béguin a pris fin en date du 17 juin 2004.
M. Hugues Riché n’est plus délégué à la gestion journalière depuis le 15 janvier 2004.
La première nomination de M. Wladimir Taittinger en tant qu’Administrateur a eu lieu le 14 décembre 1992. Son
mandat à été renouvelé le 3 juin 1998 puis le 5 février 2003 et viendra à échéance lors de l’A.G. de 2008.
La première nomination de M. Christian Guilloux en tant qu’Administrateur a eu lieu le 7 octobre 1998. Son mandat
à été renouvelé le 5 février 2003 et viendra à échéance lors de l’A.G. de 2008.
La première nomination de M. Olivier Hériard-Dubreuil en tant qu’Administrateur a eu lieu le 4 février 2004 et
viendra à échéance lors de l’A.G. de 2008.
Le mandat de réviseur de PricewaterhouseCoopers a pris fin le 15 janvier 2002.
KPMG AUDIT a été nommée réviseur en date du 15 janvier 2002. Son mandat viendra à échéance lors de l’A.G. de
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019839.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société domiciliataire
i>VERIGEST S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
LGI, Société Anonyme
Signature
30658
ProLogis SPAIN IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 480.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.788.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03721. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019527.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ProLogis MOSCOW II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 35.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.831.
—
Il résulte d’une décision du gérant du 1
er
février 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 1
er
février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03723. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019529.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
ITS TEAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.868.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 28 février 2005i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005, que Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 28 février 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00347. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020018.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
<i>Pour la société
i>ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
30659
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.630.
—
Il résulte d’une décision des gérants du 31 janvier 2005 que la décision suivante a été prise:
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1
er
février 2005.
Luxembourg, le 31 janvier 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03724. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019532.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
REFLEXES FINANCE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 101.570.
—
La Convention de Domiciliation conclue en date du 7 juin 2004 entre la Société Anonyme REFLEXES FINANCE S.A.,
avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 13.859, courant,
pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a
été résiliée avec effet au 10 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00778. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019565.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
NATURE-SANTE-BEAUTE (N.S.B.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Luxembourg, 35, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 50.963.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01674, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020030.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
DOMINICAN ENTERTAINMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 105.934.
—
Il résulte de l’acte de constitution de la société en date du 31 janvier 2005 que Mme Xenia Kotoula, née le 30 no-
vembre 1973 à Athènes, Grèce, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, est nommée
gérant Classe A de la société pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019652.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
<i>Pour la société
i>P. Cassells
<i>Géranti>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
FIDUCIAIRE CORFI
<i>Experts comptables
i>Signature
Pour avis conforme
J. W. van Koeverden Brouwer
<i>Gérant Ai>
30660
LES JARDINS DE LA MUSIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 163, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 58.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00793, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019653.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
VEROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.590.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 18 mars 2003, il résulte
que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-
ciales à concurrence de 99% de la société,
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de
1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01009. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019705.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
MAS LUC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.574.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01061, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019830.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
CONSTRUCTIONS AVEIRENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4062 Esch-sur-Alzette, 28, rue Clair-Chêne.
R. C. Luxembourg B 90.995.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2005i>
Lundi, le 28 février 2005 à 10.00 heures, l’associé unique de la société s’est réuni en assemblée générale extraordi-
naire au siège social.
1. Monsieur Carlos Alberto Ferriera Dos Santos, demeurant à L-4061 Esch-sur-Alzette, 28, rue Clair-Chêne,
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société dont le capital social douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) représenté par cent parts (100) d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée révoque Monsieur José Da Silva Santos, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 125, rue de l’Alzette, avec
effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00664. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(020091.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
<i>Pour compte de LES JARDINS DE LA MUSIQUE, S.à r.l.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
Luxembourg, le 21 février 2005.
Signature.
Signature.
- Monsieur Carlos Alberto Ferreira Dos Santos, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 cent parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 cent parts sociales
C. Ferreira Dos Santos.
30661
VIAVIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.403.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004, il résulte
que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-
ciales à concurrence de 99% de la société,
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de
1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01007. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019713.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
VIOLON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.498.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004, il résulte
que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-
ciales à concurrence de 99% de la société,
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de
1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019717.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
VIATRIX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.424.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004, il résulte
que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-
ciales à concurrence de 99% de la société,
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de
1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019720.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
BALFRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.332.
—
Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01064, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019832.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Luxembourg, le 21 février 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 février 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 février 2005.
Signature.
Signatures.
30662
VIWOLARI HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.803.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 8 août 2002, il résulte
que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-
ciales à concurrence de 99% de la société,
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de
1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01000. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019723.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
VULCANO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.545.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 18 mars 2003, il résulte
que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-
ciales à concurrence de 99% de la société,
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de
1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC00996. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019724.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
INTEREUROPEAN FINANCE & ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.422.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenu en date du 28 février 2005i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 28 février 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00345. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020021.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Luxembourg, le 21 février 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 février 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
30663
GRID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.546.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-
BC00825, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2005.
(020041.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
GRID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.546.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 février 2005 a appelé ELPERS & CO
REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, aux fonctions de Commissaire
aux comptes en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
de 2008.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur;
- Monsieur Koen van Baren, Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00823. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020046.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
KENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.168.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenu en date du 28 février 2005i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005, que Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 28 février 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00343. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020023.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour GRID LUXEMBOURG S.A.
C. Speecke
<i>Administrateuri>
<i>Pour GRID LUXEMBOURG S.A.
i>C. Speecke
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
30664
KENSON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 58.661.
—
Conformément à l’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxem-
bourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7
mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019926.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
WASHINGTON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.804.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 nowembre 2001,
il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-
ciales à concurrence de 99% de la société,
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de
1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC00995. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019725.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
AMPAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.954.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01141, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2005.
(019999.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
GEFICAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2005, réf. LSO-BC00337, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020192.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
GEFICAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2005, réf. LSO-BC00338, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés, le 7 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020189.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.
Luxembourg, le 3 mars 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 février 2005.
Signature.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 1
er
mars 2005.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
mars 2005.
Signature.
30665
IMMOBILIERE DU PORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.596.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00739, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019467.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
TASACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2005, réf. LSO-BC00063, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019469.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.
FIDELITY FUNDS II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.
R. C. Luxembourg B 76.939.
—
At the Extraordinary General Meeting held at the registered office of FIDELITY FUNDS II SICAV («the Fund») on
Wednesday 29 June 2005 at 9.15 a.m. (CET), a quorum was not attained. Therefore:
Notice is hereby given that the adjourned
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Fund will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on Wednesday <i>3 August
2005i> at 9.45 a.m. (CET) to consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To change the name of the Fund from FIDELITY FUNDS II SICAV to FIDELITY FUNDS II and to amend Article
1 of the Articles of Incorporation in accordance with this change.
2. Amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read: «The exclusive object of the Corporation is to
invest the funds available to it in securities of all types, money market instruments, derivative instruments, cash
and cash equivalents as well as other assets permitted by law with the purpose of spreading investment risk and
affording its shareholders the results of the management of its assets.
The Corporation may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfil-
ment and development of its purposes to the fullest extent permitted by the law of 20th December 2002 on
undertakings for collective investment (the «Law»).»
3. Amend the second sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read: «Branches or other offices
may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad...»
4. Amend the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «The minimum capital
of the Corporation shall be the equivalent in United States dollars of 1,250,000.- euro.»
5. Delete paragraph 11 of Article 5 of the Articles of Incorporation.
6. Amend the current paragraph 16 of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «... and other instru-
ments of transfer satisfactory to the Corporation on the basis of which the Corporation may record the transfer
in the Register of Shareholders or by written declaration of transfer recorded in the Register of Shareholders...»
7. Addition of the following sentence at the beginning of the current paragraph 17 of Article 5 of the current Articles
of Incorporation: «The Corporation only recognises one single owner per share.»
8. Amend the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation so as to read: «... if in the opinion of the
Corporation such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of the shareholders thereof or
of any class thereof, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as
a result thereof it may have adverse regulatory, tax or fiscal consequences, and in particular if the Corporation
may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg...»
9. Amend paragraph 2 of Article 7 D (1) of the Articles of Incorporation so as to read: «... addressed to such share-
holder at their last address known to or appearing in the Register of Shareholders of the Corporation...»
10. Amend Article 8 of the Articles of Incorporation so as to read: «Whenever used in these Articles the term «US
person» means:
(a) a citizen or resident of the United States of America;
(b) a partnership, corporation, limited liability company or similar entity, organised or incorporated under the
laws of the United States of America, or an entity taxed as such or subject to filing a tax return as such under
the United States federal income tax laws;
Luxembourg, le 2 mars 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 mars 2005.
Signature.
30666
(c) any estate or trust the executor, administrator or trustee of which is a US Person unless, in the case of trusts
of which any professional fiduciary acting as trustee is a US Person, a trustee who is not a US Person has sole or
shared investment discretion with respect of trust assets and no beneficiary of the trust (and no settler if the
trust is revocable) is a US Person;
(d) any estate or trust the income of which from sources without the United States of America is includible in
gross income for purposes of computing United States income tax payable by it;
(e) any agency or branch of a foreign entity located in the United States of America;
(f) any discretionary account or non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held
by a dealer or other fiduciary located within or outside the United States of America for the benefit or account
of a US Person;
(g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary
organised, incorporated or (if an individual) resident in the United States of America, except that any discretion-
ary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-US Person
by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated (or if an individual) resident in the United
States of America shall not be deemed a US Person;
(h) any firm, corporation or other entity, regardless of citizenship, domicile, situs or residence if, under the in-
come tax laws of the United States of America from time to time in effect, any proportion of the income thereof
would be taxable to a US Person even if not distributed, other than a passive foreign investment company;
(i) any partnership, corporation or other entity if (A) organised or incorporated under the laws of any foreign
jurisdiction; and (B) owned or formed by a US Person or Persons principally for the purpose of investing in se-
curities not registered under the US Securities Act of 1933 (including but not limited to Shares of the Fund);
(j) any employee benefit plan unless such employee benefit plan is established and administered in accordance
with the law of a country other than the United States of America and customary practices and documentation
of such country and is maintained primarily for the benefit of persons substantially all of whom are non-resident
aliens with respect to the United States of America; and
(k) any other person or entity whose ownership of Shares or solicitation for ownership of Shares in FIDELITY
INVESTMENTS INSTITUTIONAL SERVICES COMPANY Inc., FIDELITY DISTRIBUTORS INTERNATIONAL
LIMITED or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine may violate any securities law
of the United States of America or any state or other jurisdiction thereof.
US Person shall not include an Eligible Investor or any person or entity, notwithstanding the fact that such person
or entity may come within any of the categories referred to above, as to whom Fidelity Distributors International
Limited or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine that ownership of Shares or so-
licitation for ownership of Shares shall not violate any securities law of the United States of America or any state
or other jurisdiction thereof.
As used herein, United States of America includes its states, commonwealths, territories, possessions and the
District of Columbia.
Whenever used in these Articles, «three per cent owner» means any person, firm or corporate body which as
a legal or beneficial holder owns more than three per cent of the number of shares of the Corporation from time
to time outstanding.
Three per cent owner as used herein shall not include any subscriber to shares of the Corporation issued in con-
nection with organisation of the Corporation while such subscriber holds such shares or any securities dealer
who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Corporation.»
11. Amend paragraph 4 of Article 10 of the Articles of Incorporation so as to read: «If bearer shares are in issue,
notice of meeting of shareholders will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Lux-
embourg and in a Luxembourg newspaper... sent to the holders of nominative shares eight days prior to the meet-
ing...»
12. Amend the first sentence of paragraph 4 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board
of Directors from time to time shall appoint the officers and the Managing Directors of the Corporation...»
13. Amend paragraph 5 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «Notice of any meeting of the
Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, fax or by any other electronic means...
This notice may be waived by the consent in writing by telegram, telex, fax or by any other electronic means of
each director...»
14. Amend paragraph 6 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «... which appointment shall be
in writing or in the form of a telegram or telex or fax or by any other electronic means. Any Director may attend
a meeting of the Board of Directors using teleconference or video means and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting.»
15. Amend Article 15 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors shall, based upon the
principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments
relating to each class of shares and the course of conduct of the management and business affairs of the Corpor-
ation. The Board of Directors shall also have power to determine any restrictions which shall from time to time
be applicable to the investments of the Corporation’s assets, in accordance with Part I of the Law including, with-
out limitation, restrictions in respect of:
a) the borrowings of the Corporation and the pledging of its assets; and
b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum
percentage of any form or class of security which it may acquire.
30667
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made (i) in transferable se-
curities/money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law; (ii) in
transferable securities/money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European
Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public; (iii) in transferable securi-
ties/money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Europe,
Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in on another market that is regulated, in
the countries referred to above, provided that such market operates regularly and is recognised and open to the
public; (iv) in recently issued transferable securities/money market instruments provided the terms of the issue
include an undertaking that application will be made for admission to official listing on any of the stock exchanges
or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the
issue; and (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by
the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and as disclosed in the sales documents
of the Corporation.
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net
assets of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed
by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union,
as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation, or public
international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided
that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold securities from at least
six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the Cor-
poration’s total net assets.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made in financial derivative
instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the
Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange
rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in
the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation’s assets being made with the aim to
replicate certain stock indices or bond indices, provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg
supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the mar-
ket to which it refers and is published in any appropriate manner.
The Corporation will not invest more than 10% of its net assets in units of undertakings for collective investment
as defined in the Law.
When investments of the Corporation are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its
behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is lo-
cated, with regard to the redemption of units at the request of unitholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48
of the Law do not apply.»
16. Replacement of the words «law of thirtieth March one thousand nine hundred and eighty eight regarding collec-
tive investment undertakings» with «Law» in the first paragraph of Article 20 of the Articles of Incorporation.
17. Delete the words «with or without cause» from the end of the second paragraph of Article 20 of the Articles of
Incorporation.
18. Amend the third sentence of the second paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation so as to read:
«Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.»
19. Delete the words «(such fee and estimate not to exceed one per cent of such Net Asset Value)» from the end
of the second sentence of the third paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation.
20. Replace the final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation in its entirety with the following: «Fur-
ther, redemption requests may be deferred under certain circumstances and within certain thresholds as detailed
in the sales documents.»
21. Insert the following paragraph after the current final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation: «In
addition a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should
not exceed 5% of the Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses
and potential impact on security prices that may be incurred to meet redemption and conversion requests.»
22. Insert the following paragraph at the end of Article 21 of the Articles of Incorporation: «There may be deducted
from the Net Asset Value a fee payable to the Corporation with a maximum of 2%.»
23. Delete the words «, unless all such shareholders and their addresses are known to the Corporate» from the end
of the second paragraph of Article 21.bis of the Articles of Incorporation.
24. Insert the following paragraph after paragraph nine of Article 22 of the Articles of Incorporation: «(g) in the event
of the convening of an extraordinary general meeting of the shareholders for the purpose of winding up the Cor-
poration as from the time of such convening.»
25. Amend the last sentence of Section B (ii) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation:
«... securities are to be valued at fair market value in the opinion of the Corporation.»
26. Insert the following sentence after Section B (vi) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorpo-
ration: «The Board of Directors is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the
Corporation if the aforesaid valuation methods may not be applied or are inappropriate due to extraordinary
circumstances or events.»
30668
27. Amend the last paragraph of Article 22 Section C, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation so as
to read: «... any paying agent and permanent representatives in places of registration, directors, managing direc-
tors and officers, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, insurance,
promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and print-
ing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, preparing and filing of Articles of Incor-
poration, ...»
28. Insert the following paragraph at the end of section G of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of In-
corporation: «The Net Asset Value may be adjusted as the Board of Directors may deem appropriate to reflect
inter alia any dealing charges, including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting
from shareholder transactions.»
29. Amend the first sentence of Article 22.bis of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors
may decide that all or any part of the pool or pools of assets established for any class of shares referred to in
section F. of Article twenty-two (hereafter referred to as «Participating Fund») will be managed on a pooled basis
together with all or part of the pool or pools of assets established for another class of shares of the Corporation
or for another Luxembourg collective investment scheme where it is appropriate...»
30. Insert the following paragraph at the end of Article 23 of the Articles of Incorporation: «In addition, a dilution
levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should not exceed 5% of the
Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on
security prices that may be incurred to meet purchase requests.»
31. Amend Article 27 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Corporation shall enter into an investment
management agreement with an entity of the Fidelity group (the «Fidelity Entity»), under which agreement such
Fidelity Entity will advise upon and manage the portfolio investments of the Corporation.
In the event of the non-conclusion or the termination of the investment management agreement in any manner
whatsoever, the Corporation will at the request of the relevant Fidelity Entity change its name forthwith to a
name not resembling the one specified in Article one hereof, specifically not including the word «Fidelity» or any
similar word in any part thereof.
The investment management agreement shall contain provisions governing its amendment and termination.
This Article twenty-seven may not be amended or repealed, except by the affirmative vote of the holders of not
less than two thirds (2/3) of the shares of the Corporation present or represented at a shareholders’ meeting
called for such purpose at which the holders of not less than two thirds (2/3) of the outstanding shares of the
Corporation are present or represented and voting.
The management fee payable to the investment manager in respect of its services shall not, in respect of each
separate pool of assets, exceed the rate specified in the sales documents of the Corporation applicable to the
average of the Net Asset Value of the relevant pool of assets. Any increase of the management fee within the
limits specified herein shall become effective only upon three months’ notice given in writing to all registered
shareholders.
The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank or savings institution which shall satisfy the
requirements of the Law (the «Custodian») who shall assume towards the Corporation and its shareholders the
responsibilities provided by the Law. All securities and other assets of the Corporation are to be held by or to
the order of the Custodian. The fees payable to the Custodian will be determined in the custodian agreement.
In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall within two months appoint another
financial institution to act as custodian and upon doing so the Directors shall appoint such institution to be cus-
todian in place of the retiring Custodian. The Directors shall have power to terminate the appointment of the
Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed
in accordance with this provision to act in place thereof.
If any cash forming part of the assets of the Corporation is deposited with any investment manager or any dis-
tributor of shares in the Corporation appointed by the Corporation or any Connected Person of any of them,
interest must be granted on such deposit at a rate not below the prevailing rate for a deposit of that term and
that currency.
Neither the Custodian nor the investment manager nor any Connected Person of any of them, shall vote their
own shares in the Corporation at, or count towards the quorum for, a general meeting of shareholders at which
they have a material interest. But this restriction shall not apply to shares held in a nominee capacity only when
voting instructions are received from the owner nor in respect of any adjourned meeting where the initial meet-
ing was inquorate...»
32. Amend Article 30 of the Articles of Incorporation so as to read: «All matters not governed by these Articles of
Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on Commercial Companies
and amendments thereto, as well as the Law.»
33. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.
The resolutions require a majority in favour of at least two thirds of the votes cast. Holders present in person or by
proxy, whatever their number and the number of shares held by them, will constitute a quorum at the adjourned meet-
ing. To be valid proxies must reach the registered office of the Fund on 26 July 2005 at the latest. Proxies received at
the first meeting will be held and valid for the adjourned meeting.
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares
by US persons or of shares which constitute in aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each
share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another person
in writing to attend and vote at the meeting. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.
30669
Shareholders may vote by proxy by returning the form of proxy to the address given below:
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
Kansallis House, place de l’Etoile, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
29 June 2005.
I (03324/584/245)
<i>By Order of the Board of Directorsi>.
FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 34.036.
—
At the Extraordinary General Meeting held at the registered office of FIDELITY FUNDS («the Fund») on Wednesday
29 June 2005 at 9.00 a.m. (CET), a quorum was not attained. Therefore:
Notice of hereby given that the adjourned
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Fund will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on Wednesday <i>3 Augusti>
<i>2005i> at 9.30 a.m. (CET) to consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read: «The exclusive object of the Corporation is to
invest the funds available to it in securities of all types, money market instruments, derivative instruments, cash
and cash equivalents as well as other assets permitted by law with the purpose of spreading investment risk and
affording its shareholders the results of the management of its assets.
The Corporation may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfil-
ment and development of its purposes to the fullest extent permitted by the law of 20th December 2002 on
undertakings for collective investment (the «Law»).»
2. Amend the second sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read: «Branches or other offices
may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad ...»
3. Amend the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «The minimum capital
of the Corporation shall be the equivalent in United States dollars of 1,250,000.- euro.»
4. Delete paragraph 11 of Article 5 of the Articles of Incorporation.
5. Amend the current paragraph 16 of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «... and other instru-
ments of transfer satisfactory to the Corporation on the basis of which the Corporation may record the transfer
in the Register of Shareholders or by written declaration of transfer recorded in the Register of Shareholders ...»
6. Addition of the following sentence at the beginning of the current paragraph 17 of Article 5 of the current Articles
of Incorporation: «The Corporation only recognises one single owner per share.»
7. Amend the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation so as to read: «... if in the opinion of the
Corporation such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of the shareholders thereof or
of any class thereof, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as
a result thereof it may have adverse regulatory, tax or fiscal consequences, and in particular if the Corporation
may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg ...»
8. Amend paragraph 2 of Article 7 D (1) of the Articles of Incorporation so as to read: «... addressed to such share-
holder at their last address known to or appearing in the Register of Shareholders of the Corporation ...»
9. Amend Article 8 of the Articles of Incorporation so as to read: «Whenever used in these Articles the term «US
person» means:
(a) a citizen or resident of the United States of America;
(b) a partnership, corporation, limited liability company or similar entity, organised or incorporated under the
laws of the United States of America, or an entity taxed as such or subject to filing a tax return as such under
the United States federal income tax laws;
(c) any estate or trust the executor, administrator or trustee of which is a US Person unless, in the case of trusts
of which any professional fiduciary acting as trustee is a US Person, a trustee who is not a US Person has sole or
shared investment discretion with respect of trust assets and no beneficiary of the trust (and no settler if the
trust is revocable) is a US Person;
(d) any estate or trust the income of which from sources without the United States of America is includible in
gross income for purposes of computing United States income tax payable by it;
(e) any agency or branch of a foreign entity located in the United States of America;
(f) any discretionary account or non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held
by a dealer or other fiduciary located within or outside the United States of America for the benefit or account
of a US Person;
(g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary
organised, incorporated or (if an individual) resident in the United States of America, except that any discretion-
ary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-US Person
by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated (or if an individual) resident in the United
States of America shall not be deemed a US Person;
30670
(h) any firm, corporation or other entity, regardless of citizenship, domicile, status or residence if, under the in-
come tax laws of the United States of America from time to time in effect, any proportion of the income thereof
would be taxable to a US Person even if not distributed, other than a passive foreign investment company;
(i) any partnership, corporation or other entity if (A) organised or incorporated under the laws of any foreign
jurisdiction; and (B) owned or formed by a US Person or Persons principally for the purpose of investing in se-
curities not registered under the US Securities Act of 1933 (including but not limited to Shares of the Fund);
(j) any employee benefit plan unless such employee benefit plan is established and administered in accordance
with the law of a country other than the United States of America and customary practices and documentation
of such country and is maintained primarily for the benefit of persons substantially all of whom are non-resident
aliens with respect to the United States of America; and
(k) any other person or entity whose ownership of Shares or solicitation for ownership of Shares in Fidelity In-
vestments Institutional Services Company Inc., Fidelity Distributors International Limited or the Fund, acting
through their Officers or Directors, shall determine may violate any securities law of the United States of Amer-
ica or any state or other jurisdiction thereof.
US Person shall not include an Eligible Investor or any person or entity, notwithstanding the fact that such person
or entity may come within any of the categories referred to above, as to whom Fidelity Distributors International
Limited or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine that ownership of Shares or so-
licitation for ownership of Shares shall not violate any securities law of the United States of America or any state
or other jurisdiction thereof.
As used herein, United States of America includes its states, commonwealths, territories, possessions and the
District of Columbia.
Whenever used in these Articles, «three per cent owner» means any person, firm or corporate body which as
a legal or beneficial holder owns more than three per cent of the number of shares of the Corporation from time
to time outstanding.
Three per cent owner as used herein shall not include any subscriber to shares of the Corporation issued in con-
nection with organisation of the Corporation while such subscriber holds such shares or any securities dealer
who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Corporation.»
10. Amend paragraph 4 of Article 10 of the Articles of Incorporation so as to read: «If bearer shares are in issue,
notice of meeting of shareholders will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Lux-
embourg and in a Luxembourg newspaper ... sent to the holders of nominative shares eight days prior to the
meeting ...»
11. Amend the first sentence of paragraph 4 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board
of Directors from time to time shall appoint the officers and the Managing Directors of the Corporation ...»
12. Amend paragraph 5 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «Notice of any meeting of the
Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, fax or by any other electronic means ...
This notice may be waived by the consent in writing by telegram, telex, fax or by any other electronic means of
each director ...»
13. Amend paragraph 6 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «... which appointment shall be
in writing or in the form of a telegram or telex or fax or by any other electronic means. Any Director may attend
a meeting of the Board of Directors using teleconference or video means and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting.»
14. Amend Article 15 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors shall, based upon the
principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments
relating to each class of shares and the course of conduct of the management and business affairs of the Corpor-
ation. The Board of Directors shall also have power to determine any restrictions which shall from time to time
be applicable to the investments of the Corporation’s assets, in accordance with Part I of the Law including, with-
out limitation, restrictions in respect of:
a) the borrowings of the Corporation and the pledging of its assets; and
b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum
percentage of any form or class of security which it may acquire.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made (i) in transferable se-
curities/money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law; (ii) in
transferable securities/money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European
Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public; (iii) in transferable securi-
ties/money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Europe,
Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in on another market that is regulated, in
the countries referred to above, provided that such market operates regularly and is recognised and open to the
public; (iv) in recently issued transferable securities/money market instruments provided the terms of the issue
include an undertaking that application will be made for admission to official listing on any of the stock exchanges
or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the
issue; and (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by
the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and as disclosed in the sales documents
of the Corporation.
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net
assets of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed
by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union,
30671
as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation, or public
international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided
that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold securities from at least
six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the Cor-
poration’s total net assets.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made in financial derivative
instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the
Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange
rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in
the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation’s assets being made with the aim to
replicate certain stock indices or bond indices, provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg
supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the mar-
ket to which it refers and is published in any appropriate manner.
The Corporation will not invest more than 10% of its net assets in units of undertakings for collective investment
as defined in the Law.
When investments of the Corporation are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its
behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is lo-
cated, with regard to the redemption of units at the request of unitholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48
of the Law do not apply.»
15. Replacement of the words of «law of thirtieth March one thousand nine hundred and eighty eight regarding col-
lective investment undertakings» with «Law» in the first paragraph of Article 20 of the Articles of Incorporation.
16. Delete the words «with or without cause» from the end of the second paragraph of Article 20 of the Articles of
Incorporation.
17. Amend the third sentence of the second paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation so as to read:
«Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.»
18. Delete the words «(such fee and estimate not to exceed one per cent of such Net Asset Value)» from the end
of the second sentence of the third paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation.
19. Replace the final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation in its entirety with the following: «Fur-
ther, redemption requests may be deferred under certain circumstances and within certain thresholds as detailed
in the sales documents.»
20. Insert the following paragraph after the current final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation: «In
addition a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should
not exceed 5% of the Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses
and potential impact on security prices that may be incurred to meet redemption and conversion requests.»
21. Insert the following paragraph at the end of Article 21 of the Articles of Incorporation: «There may be deducted
from the Net Asset Value a fee payable to the Corporation with a maximum of 2%.»
22. Delete the words «, unless all such shareholders and their addresses are known to the Corporation» from the
end of the second paragraph of Article 21.bis of the Articles of Incorporation.
23. Insert the following paragraph after paragraph nine of Article 22 of the Articles of Incorporation: «(g) in the event
of the convening of an extraordinary general meeting of the shareholders for the purpose of winding up the Cor-
poration as from the time of such convening.»
24. Amend the last sentence of Section B (ii) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation:
«... securities are to be valued at fair market value in the opinion of the Corporation.»
25. Insert the following sentence after Section B (vi) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorpo-
ration: «The Board of Directors is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the
Corporation if the aforesaid valuation methods may not be applied or are inappropriate due to extraordinary
circumstances or events.»
26. Amend the last paragraph of Article 22 Section C, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation so as
to read: «... any paying agent and permanent representatives in places of registration, directors, managing direc-
tors and officers, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, insurance,
promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and print-
ing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, preparing and filing of Articles of Incor-
poration, ...»
27. Insert the following paragraph at the end of section G of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of In-
corporation: «The Net Asset Value may be adjusted as the Board of Directors may deem appropriate to reflect
inter alia any dealing charges, including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting
from shareholder transactions.»
28. Amend the first sentence of Article 22.bis of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors
may decide that all or any part of the pool or pools of assets established for any class of shares referred to in
section F. of Article twenty-two (hereafter referred to as «Participating Fund») will be managed on a pooled basis
together with all or part of the pool or pools of assets established for another class of shares of the Corporation
or for another Luxembourg collective investment scheme where it is appropriate ...»
29. Insert the following paragraph at the end of Article 23 of the Articles of Incorporation: «In addition, a dilution
levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should not exceed 5% of the
30672
Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on
security prices that may be incurred to meet purchase requests.»
30. Delete the words «and for the first time on the 30th day of April 1991» from the first paragraph of Article 25 of
the Articles of Incorporation.
31. Amend Article 27 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Corporation shall enter into an investment
management agreement with an entity of the Fidelity group (the «Fidelity Entity»), under which agreement such
Fidelity Entity will advise upon and manage the portfolio investments of the Corporation.
In the event of the non-conclusion or the termination of the investment management agreement in any manner
whatsoever, the Corporation will at the request of the relevant Fidelity Entity change its name forthwith to a
name not resembling the one specified in Article one hereof, specifically not including the word «Fidelity» or any
similar word in any part thereof.
The investment management agreement shall contain provisions governing its amendment and termination.
This Article twenty-seven may not be amended or repealed, except by the affirmative vote of the holders of not
less than two thirds (2/3) of the shares of the Corporation present or represented at a shareholders’ meeting
called for such purpose at which the holders of not less than two thirds (2/3) of the outstanding shares of the
Corporation are present or represented and voting.
The management fee payable to the investment manager in respect of its services shall not, in respect of each
separate pool of assets, exceed the rate specified in the sales documents of the Corporation applicable to the
average of the Net Asset Value of the relevant pool of assets. Any increase of the management fee within the
limits specified herein shall become effective only upon three months’ notice given in writing to all registered
shareholders.
The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank or savings institution which shall satisfy the
requirements of the Law (the «Custodian») who shall assume towards the Corporation and its shareholders the
responsibilities provided by the Law. All securities and other assets of the Corporation are to be held by or to
the order of the Custodian. The fees payable to the Custodian will be determined in the custodian agreement.
In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall within two months appoint another
financial institution to act as custodian and upon doing so the Directors shall appoint such institution to be cus-
todian in place of the retiring Custodian. The Directors shall have power to terminate the appointment of the
Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed
in accordance with this provision to act in place thereof.
If any cash forming part of the assets of the Corporation is deposited with any investment manager ...»
32. Amend Article 30 of the Articles of Incorporation so as to read: «All matters not governed by these Articles of
Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on Commercial Companies
and amendments thereto, as well as the Law.»
33. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.
The resolutions require a majority in favour of at least two thirds of the votes cast. Holders present in person or by
proxy, whatever their number and the number of shares held by them, will constitute a quorum at the adjourned meet-
ing. To be valid proxies must reach the registered office of the Fund on 26 July 2005 at the latest. Proxies received at
the first meeting will be held and valid for the adjourned meeting.
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares
by US persons or of shares which constitute in aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each
share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another person
in writing to attend and vote at the meeting. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.
Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of regis-
tered shareholder proxy sent to them.
Holders of Bearer Shares who wish to attend the Extraordinary General Meeting or vote at the meeting by proxy
should contact the Fund or one of the following institutions:
in Luxembourg:
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Kansallis House, place de l’Etoile, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
29 June 2005.
I (03321/584/241)
<i>By Order of the Board of Directorsi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
DAB Investments, S.à r.l.
Magnolia Holding, S.à r.l.
Observer New Media, S.à r.l.
Lassale S.A.
International Technology Investments S.A.
International Technology Investments S.A.
FKI Lusparthree, S.à r.l.
Thiel Eurologistics Services, S.à r.l.
Ciments Français International S.A.
Ciments Français International S.A.
F.R.A.L. Holding S.A.
International Flavors & Fragrances Global Holding, S.à r.l.
Giroflex Luxemburg S.A.
Le Strasbourg Hôtel Restaurant Brasserie, S.à r.l.
Philos S.A.H.
Fingesty S.A.
Moselle Bois, S.à r.l.
S.C.I. Les Cadenières
Aurum Dental, S.à r.l.
Compagnie Européenne de Commerce et de Services S.A.
ProLogis Poland XXVII, S.à r.l.
GCE Luxco Two, S.à r.l.
ProLogis Poland XXVIII, S.à r.l.
Duplitape S.A.
ProLogis Poland XXX, S.à r.l.
ProLogis Poland XXXI, S.à r.l.
GCE Holdco, S.à r.l.
Gasberry Natural Resources S.A.
Gasberry Natural Resources S.A.
ProLogis Poland XXXII, S.à r.l.
ProLogis Poland XXXIII, S.à r.l.
Durama Lux, S.à r.l.
Durama Lux, S.à r.l.
ISCE Investors In Sapient and Cuneo Europe S.A.
ProLogis Poland XXXIV, S.à r.l.
Motor Car Leasing S.A.
Motor Car Leasing S.A.
F.E.T. S.A., Finances Europe Tourisme
Fundland
ProLogis Spain II, S.à r.l.
Société Européenne Répartition Investissements S.A.
Universal Air Charter, S.à r.l. - CHARTAIR
Xyzalux S.A.
Xyzalux S.A.
Xyzalux S.A.
Dasco, S.à r.l.
Vertime S.A.
Sumaho S.A.
Somaphi S.A.
Somaphi S.A.
Somaphi S.A.
Powergen Australia Investments Limited, S.à r.l.
Dutchdelta Finance, S.à r.l.
Intesa Holding International S.A.
Fidia S.A.
Cardazzo S.A.
ABN Amro K Finance S.A.
Cover Fin. Holding S.A.
Sopor S.A.
Tech Pacific Holdings, S.à r.l.
Europack S.A.
Europack S.A.
Europack S.A.
Xipidis S.A.
CDL Expertise, S.à r.l.
ProLogis Spain III, S.à r.l.
LGI
ProLogis Spain IV, S.à r.l.
ProLogis Moscow II, S.à r.l.
ITS Team S.A.
ProLogis Directorship, S.à r.l.
Reflexes Finance S.A.
Nature-Santé-Beauté (N.S.B.), S.à r.l.
Dominican Entertainment (Luxembourg), S.à r.l.
Les Jardins de la Musique, S.à r.l.
Veroma, S.à r.l.
Mas Luc S.A.
Constructions Aveirense, S.à r.l.
Viavia Holding, S.à r.l.
Violon Holding, S.à r.l.
Viatrix Holding, S.à r.l.
Balfrin S.A.
Viwolari Holding, S.à r.l.
Vulcano Holding, S.à r.l.
Intereuropean Finance & Energy Holding S.A.
Grid Luxembourg S.A.
Grid Luxembourg S.A.
Kent International S.A.
Kenson Holding S.A.
Washington Holding, S.à r.l.
Ampax S.A.
Geficar S.A.
Geficar S.A.
Immobilière du Port S.A.
Tasaco, S.à r.l.
Fidelity Funds II Sicav
Fidelity Funds