logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

21553

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 450

13 mai 2005

S O M M A I R E

5 à Sec - Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

21578

EIFAN Financial Consulting S.A., Luxembourg  . . 

21596

Abroad Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21598

Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . 

21600

Actuel Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

21581

Ernster Belle Etoile, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

21599

Advitek S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21577

Ernster Concorde, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

21599

Aliena, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21571

Ernster, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21599

Allied Arthur Pierre S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . .

21600

Eurese, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21598

Alsinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21578

Euro Immo Invest & Conseil S.A., Luxembourg . . 

21595

Anyway, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21582

Euro-Assecura S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

21587

Ataraxia S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . .

21600

Euro-Assecura S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

21587

Automotive  Engineering  Holding  S.A.,  Luxem-

Europeck S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . 

21594

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21554

Eurosieur S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . 

21594

Batiste, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21584

Everlux Maritima S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

21579

Beeckesteyn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

21585

Fiduciaire   et   Expertises   (Luxembourg)   S.A., 

Beeckesteyn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

21585

Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21581

Beeckesteyn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

21585

(The)   Figleaf   Costume   House,   S.à r.l.,   Nieder-

Belgo Trade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

21579

pallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21598

Bendick Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

21570

Fitra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

21588

Big Wave S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21580

Free Style S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21581

Bijouterie Wacht, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . .

21571

Glecos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

21590

Brasserie Georges VI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

21571

Global Gateway S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

21595

Bull Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21588

Global Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21572

Bull Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21589

Global Sat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21572

Business  Development  Partners,  S.à r.l.,  Luxem-

Global Value S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

21572

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21597

Immo Vanstar Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

21580

C.M.C.,  Communication  Medias  Courtage  S.A., 

Imprimerie Albert Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

21582

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21576

Imprimerie Schomer-Turpel, S.à r.l., Remich . . . . 

21583

CED Automotive, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . .

21594

Investisseurs Réunis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

21578

Chardonnay S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

21597

JC Decaux Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

21577

(Les)  Charpentiers  d’Aujourd’hui,  S.à r.l.,  Dude-

JoMü Fenster, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . 

21575

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21583

Jordbru Investment Holding S.A., Luxembourg . . 

21593

Chrono Interim, S.à r.l., Hellange  . . . . . . . . . . . . . .

21573

Kalimera S.A., Olm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21570

Cimolux, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21575

Klinker Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

21593

Coffee Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

21580

Koremar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21580

Croydon S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . .

21590

L & P, Lange and Partner, S.à r.l., Luxembourg . . 

21597

Daleiden, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21583

Laboratoire Dentaire Pohl, S.à r.l., Howald. . . . . . 

21585

Darthman S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

21591

Langues sur mesure, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

21582

DD Trust Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . .

21589

Lawsun Group, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . 

21570

Dealing S.A., Luxembourg-Gasperich  . . . . . . . . . . .

21580

Leggett & Platt Canada Co, Luxembourg Branch, 

Design Concept S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21571

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21557

Domeric S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

21572

Leggett & Platt Canada Co, Luxembourg Branch, 

21554

AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 18.364. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04744, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(008724.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MHC DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 97.017. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 27 mai 2004

Le Conseil d’administration appelle à la fonction d’Administrateur-délégué Monsieur Michel Chevreux, administra-

teur de sociétés, né le 30 octobre 1951 à Joigny, France, demeurant allée Lenotre, La Grille Royale, F-78600 Le Mesnil
le Roi, France, qui est chargé de la gestion journalière de la société et qui a le pouvoir d’engager valablement la société
par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008794.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21558

Restaurant Mathes, S.à r.l., Ahn  . . . . . . . . . . . . . . .

21573

Lifrapos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21573

Richardson European Investments, S.à r.l., Luxem-

Logicrane Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

21592

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21579

LQMS, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . 

21582

Richardson European Investments, S.à r.l., Luxem-

Lux-Equipements, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . 

21577

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21579

Lux-Soeurs, S.à r.l., Biwer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21575

Romain Schmidt, S.à r.l., Elvange  . . . . . . . . . . . . . .

21584

M.C.F., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21592

S.S.I. Partner AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21578

Mahevia S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21598

Salon de Coiffure Groben, S.à r.l., Junglinster  . . . .

21572

Maxfin S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21581

Sanitaires &amp; Chauffage Léonard Soeurs, S.à r.l., 

MHC Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

21554

Luxembourg-Cessange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21584

Mika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

21591

Schipol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21599

Mimab S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21555

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald . . . .

21574

Motor-Center Mersch S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . 

21594

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald . . . .

21574

Nutrition Animale Luxembourg, S.à r.l., Nieder-

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald . . . .

21574

pallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21598

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald . . . .

21574

Octoplas Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

21592

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald . . . .

21574

Ombra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

21593

Scodex S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21573

P.L.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21581

Semi AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21589

Peinture Bauer, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . 

21584

Servidis S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21583

Perot   Systems   Luxembourg,   S.à r.l.,   Dommel-

Southern Cross S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21597

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21600

SP Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21586

Petrus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

21591

Star 2000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21576

Phileos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21555

Talk Finance, S.à r.l., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . .

21575

Pierre Finanz Luxembourg S.A.H., Luxembourg  . 

21592

Talons Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

21596

Portena Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

21590

Tambol Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

21556

Prefalux S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21577

Tépi S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21584

Print Products and Services S.A., Mamer  . . . . . . . 

21581

Terra Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

21596

PT Holding S.A., Packaging Technology Holding, 

Toiture de l’Est, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . . . .

21582

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21588

Transnational SBA Services, S.à r.l., Luxembourg

21597

Quality   Publishing   International   S.A.,   Luxem-

Unicum S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21571

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21595

West Grove, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21576

Quickstep S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21573

Z.I.K. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

21586

R + F Menuiserie, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21583

Z.I.K. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

21587

<i>Pour AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour le Conseil d’Administration 
Signature

21555

MIMAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.111. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06059, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008095.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

PHILEOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 105.634. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Christopher Vanderfelt, directeur, né à Bruxelles (Belgique) le 26 février 1971, demeurant à L-1511 Luxem-

bourg, 208, avenue de la Faïencerie. 

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de PHILEOS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de confection et d’accessoires, ainsi que toute autre

activité commerciale.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Christopher Vanderfelt, directeur, né à Bruxelles (Bel-

gique) le 26 février 1971, demeurant à L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faïencerie, et ont été intégralement libé-
rées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Signature.

21556

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faïencerie.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Christopher Vanderfelt, prénommé.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Vanderfelt, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, vol. 146S, fol. 79, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(008702.3/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TAMBOL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 84.066. 

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TAMBOL INVESTMENT S.A., une société

anonyme, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 84.066,
constituée suivant acte notarié du 12 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 276 du 19 février 2002, (ci-après: «la Société»). 

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social actuellement fixé à cinquante mille euros

(50.000,- EUR) divisé en cinq cents (500) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’el-
le est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société TAMBOL INVEST-

MENT S.A. et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 janvier 2005.

T. Metzler.

21557

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 43.298).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Spiroux-Jacoby, C. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2005, vol. 891, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009161.3/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

LEGGETT &amp; PLATT CANADA CO, LUXEMBOURG BRANCH.

Adresse de la Succursale: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.676. 

<i>Ouverture de succursale

- Dénomination de la succursale: LEGGETT &amp; PLATT CANADA CO, LUXEMBOURG BRANCH
- Forme: société anonyme de droit étranger
- Adresse de la succursale: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- L’indication des activités de la succursale &amp; de la maison mère:
- Détenir des actions dans les sociétés affiliées qui lui sont affectées de temps en temps par la société, exercer ses

droits d’actionnaire dans de telles sociétés affiliées et, seulement après avoir reçu l’approbation du conseil d’administra-
tion de la société, aliéner de telles actions. La succursale peut arranger et octroyer du financement à des sociétés affi-
liées, mais ne peut toutefois pas elle-même emprunter autrement qu’à d’autres sociétés du groupe.

- Dénomination de la maison mère: LEGGETT &amp; PLATT CANADA CO.
- Forme de la société mère: société anonyme
- Siège social de la maison mère: Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia, B3J2X2, Canada
- Droit de l’Etat dont la société relève: Nova Scotia, Canada
- Numéro d’immatriculation: 3095025
- Nom du registre: Registry of Joint Stock Companies, Nova Scotia
- Pays: Canada
- Représentants Légaux: 
* Succursale:
- Noella Antoine
Date de naissance: 11 janvier 1969
Lieu de naissance: Saint-Pierre, Belgique
Adresse professionnelle: rue Guillaume Kroll, 5, L-1882 Luxembourg
Fonction: gérante de sociétés
Pouvoir de signature: signature conjointe dans le cadre du pouvoir général
- Petrus Von Tol
Date de naissance: 9 janvier 1964
Lieu de naissance: Valkenburg, Pays-Bas
Adresse professionnelle: Steinackerstrasse, 9, 8700 Küsnacht, Suisse 
Fonction: gérant de sociétés
Pouvoir de signature: signature conjointe dans le cadre du pouvoir général
* Maison mère:
- Ernest Jett
Date de naissance: 10 juillet 1945
Lieu de naissance: Texas, USA
Adresse professionnelle: n

o

 1 Legget Rd. Carthage, MO 64836 USA

Fonction: gérant de sociétés

Belvaux, le 25 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

21558

Pouvoir de signature: signature individuelle dans le cadre du pouvoir général

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06028. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009370.3/581/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

LEGGETT &amp; PLATT CANADA CO, LUXEMBOURG BRANCH.

Branch address: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.676. 

<i>Articles of Association of LEGGETT &amp; PLATT CANADA Co. / SOCIETE LEGGETT &amp; PLATT CANADA

Interpretation

1. In these Articles, unless there be something in the subject or context inconsistent therewith:
(1) «Act» means the Companies Act (Nova Scotia);
(2) «Articles» means these Articles of Association of the Company and all amendments hereto;
(3) «Company» means the company named above;
(4) «director» means a director of the Company;
(5) «Memorandum» means the Memorandum of Association of the Company and all amendments thereto;
(6) «month» means calendar month;
(7) «Office» means the registered office of the Company, which office shall be located in the Province of Nova Scotia,

Canada;

(8) «person» includes a body corporate;
(9) «proxy holder» includes an alternate proxy holder;
(10) «Register» means the register of members kept pursuant to the Act, and where the context permits includes a

branch register of members;

(11) «Registrar» means the Registrar as defined in the Act;
(12) «Secretary» includes any person appointed to perform the duties of the Secretary temporarily;
(13) «shareholder» means member as that term is used in the Act in connection with an unlimited company having

share capital and as that term is used in the Memorandum;

(14) «special resolution» has the meaning assigned by the Act;
(15) «in writing» and «written» includes printing, lithography and other modes of representing or reproducing words

in visible form;

(16) words importing number or gender include all numbers and genders unless the context otherwise requires.
2. The regulations in Table A in the First Schedule to the Act shall not apply to the Company.
3. The directors may enter into and carry into effect or adopt and carry into effect any agreement made by the pro-

moters of the Company on behalf of the Company and may agree to any modification in the terms of any such agree-
ment, either before or after its execution.

4. The directors may, out of the funds of the Company, pay all expenses incurred for the amalgamation and organi-

zation of the Company.

Shares

5. The capital of the company shall consist of 100,000,000 common shares without nominal or par value with the

power to divide the shares in the capital for the time being into classes or series and to attach thereto respectively any
preferred, deferred or qualified rights, privileges or conditions, including restrictions on voting rights and including re-
demption, purchase and other acquisition of such shares, subject, however, to the provisions of the Act.

6. The directors shall control the shares and, subject to the provisions of these Articles, may allot or otherwise dis-

pose of them to such person at such times, on such terms and conditions and, if the shares have a par value, either at
a premium or at par, as they think fit.

7. The directors may pay on behalf of the Company a reasonable commission to any person in consideration of sub-

scribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares in the Company, or procuring or
agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any shares in the Company. Subject to the Act,
the commission may be paid or satisfied in shares of the Company.

8. On the issue of shares the Company may arrange among the holders thereof differences in the calls to be paid and

in the times for their payment.

9. If the whole or part of the allotment price of any shares is, by the conditions of their allotment, payable in instal-

ments, every such instalment shall, when due, be payable to the Company by the person who is at such time the regis-
tered holder of the shares.

10. Shares may be registered in the names of joint holders not exceeding three in number.
11. Joint holders of a share shall be jointly and severally liable for the payment of all instalments and calls due in respect

of such share. On the death of one or more joint holders of shares the survivor or survivors of them shall alone be
recognized by the Company as the registered holder or holders of the shares.

12. Save as herein otherwise provided, the Company may treat the registered holder of any share as the absolute

owner thereof and accordingly shall not, except as ordered by a court of competent jurisdiction or required by statute,
be bound to recognize any equitable or other claim to or interest in such share on the part of any other person.

13. The Company is a private company, and:

Fait et signé à Luxembourg, le 21 janvier 2005.

N. Antoine.

21559

(1) no transfer of any share or prescribed security of the Company shall be effective unless or until approved by the

directors;

(2) the number of holders of issued and outstanding prescribed securities or shares of the Company, exclusive of

persons who are in the employment of the Company or in the employment of an affiliate of the Company and exclusive
of persons who, having been formerly in the employment of the Company or the employment of an affiliate of the Com-
pany, were, while in that employment, and have continued after termination of that employment, to own at least one
prescribed security or share of the Company, shall not exceed 50 in number, two or more persons or companies who
are the joint registered owners of one or more prescribed securities or shares being counted as one holder; and

(3) the Company shall not invite the public to subscribe for any of its securities.
In this Article, «private company» and «securities» have the meanings ascribed to those terms in the Securities Act

(Nova Scotia), and «prescribed security» means any of the securities prescribed by the Nova Scotia Securities Commis-
sion from time to time for the purpose of the definition of «private company» in the Securities Act (Nova Scotia). 

Certificates

14. Certificates of title to shares shall comply with the Act and may otherwise be in such form as the directors may

from time to time determine. Unless the directors otherwise determine, every certificate of title to shares shall be
signed manually by at least one of the Chairman, President, Secretary, Treasurer, a vice-president, an assistant secretary,
any other officer of the Company or any director of the Company or by or on behalf of a share registrar transfer agent
or branch transfer agent appointed by the Company or by any other person whom the directors may designate. When
signatures of more than one person appear on a certificate all but one may be printed or otherwise mechanically repro-
duced. All such certificates when signed as provided in this Article shall be valid and binding upon the Company. If a
certificate contains a printed or mechanically reproduced signature of a person, the Company may issue the certificate,
notwithstanding that the person has ceased to be a director or an officer of the Company and the certificate is as valid
as if such person were a director or an officer at the date of its issue. Any certificate representing shares of a class pub-
licly traded on any stock exchange shall be valid and binding on the Company if it complies with the rules of such ex-
change whether or not it otherwise complies with this Article. 

15. Except as the directors may determine, each shareholder’s shares may be evidenced by any number of certificates

so long as the aggregate of the shares stipulated in such certificates equals the aggregate registered in the name of the
shareholder.

16. Where shares are registered in the names of two or more persons, the Company shall not be bound to issue

more than one certificate or set of certificates, and such certificate or set of certificates shall be delivered to the person
first named on the Register.

17. Any certificate that has become worn, damaged or defaced may, upon its surrender to the directors, be cancelled

and replaced by a new certificate. Any certificate that has become lost or destroyed may be replaced by a new certificate
upon proof of such loss or destruction to the satisfaction of the directors and the furnishing to the Company of such
undertakings of indemnity as the directors deem adequate.

18. The sum of one dollar or such other sum as the directors from time to time determine shall be paid to the Com-

pany for every certificate other than the first certificate issued to any holder in respect of any share or shares. 

19. The directors may cause one or more branch Registers of shareholders to be kept in any place or places, whether

inside or outside of Nova Scotia provided, however, that such place or places are located within Canada.

Calls

20. The directors may make such calls upon the shareholders in respect of all amounts unpaid on the shares held by

them respectively and not made payable at fixed times by the conditions on which such shares were allotted, and each
shareholder shall pay the amount of every call so made to the person and at the times and places appointed by the di-
rectors. A call may be made payable by instalments.

21. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the directors authorizing such call

was passed.

22. At least 14 days’ notice of any call shall be given, and such notice shall specify the time and place at which and the

person to whom such call shall be paid.

23. If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for the payment

thereof, the holder for the time being of the share in respect of which the call has been made or the instalment is due
shall pay interest on such call or instalment at the rate of 9% per year or such other rate of interest as the directors
may determine from the day appointed for the payment thereof up to the time of actual payment.

24. At the trial or hearing of any action for the recovery of any amount due for any call, it shall be sufficient to prove

that the name of the shareholder sued is entered on the Register as the holder or one of the holders of the share or
shares in respect of which such debt accrued, that the resolution making the call is duly recorded in the minute book
and that such notice of such call was duly given to the shareholder sued in pursuance of these Articles. It shall not be
necessary to prove the appointment of the directors who made such call or any other matters whatsoever and the proof
of the matters stipulated shall be conclusive evidence of the debt.

Forfeiture of shares

25. If any shareholder fails to pay any call or instalment on or before the day appointed for payment, the directors

may at any time thereafter while the call or instalment remains unpaid serve a notice on such shareholder requiring
payment thereof together with any interest that may have accrued and all expenses that may have been incurred by the
Company by reason of such non-payment.

26. The notice shall name a day (not being less than 14 days after the date of the notice) and a place or places on and

at which such call or instalment and such interest and expenses are to be paid. The notice shall also state that, in the

21560

event of non-payment on or before the day and at the place or one of the places so named, the shares in respect of
which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

27. If the requirements of any such notice are not complied with, any shares in respect of which such notice has been

given may at any time thereafter, before payment of all calls or instalments, interest and expenses due in respect thereof,
be forfeited by a resolution of the directors to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect
of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

28. When any share has been so forfeited, notice of the resolution shall be given to the shareholder in whose name

it stood immediately prior to the forfeiture and an entry of the forfeiture shall be made in the Register.

29. Any share so forfeited shall be deemed the property of the Company and the directors may sell, re-allot or oth-

erwise dispose of it in such manner as they think fit.

30. The directors may at any time before any share so forfeited has been sold, re-allotted or otherwise disposed of,

annul the forfeiture thereof upon such conditions as they think fit.

31. Any shareholder whose shares have been forfeited shall nevertheless be liable to pay and shall forthwith pay to

the Company all calls, instalments, interest and expenses owing upon or in respect of such shares at the time of the
forfeiture together with interest thereon at the rate of 9% per year or such other rate of interest as the directors may
determine from the time of forfeiture until payment. The directors may enforce such payment if they think fit, but are
under no obligation to do so.

32. A certificate signed by the Secretary stating that a share has been duly forfeited on a specified date in pursuance

of these Articles and the time when it was forfeited shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against
any person who would have been entitled to the share but for such forfeiture.

Lien on shares

33. The Company shall have a first and paramount lien upon all shares (other than fully paid-up shares) registered in

the name of a shareholder (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds from the sale thereof for debts,
liabilities and other engagements of the shareholder, solely or jointly with any other person, to or with the Company,
whether or not the period for the payment, fulfilment or discharge thereof has actually arrived, and such lien shall extend
to all dividends declared in respect of such shares. Unless otherwise agreed, the registration of a transfer of shares shall
operate as a waiver of any lien of the Company on such shares.

34. For the purpose of enforcing such lien the directors may sell the shares subject to it in such manner as they think

fit, but no sale shall be made until the period for the payment, fulfilment or discharge of such debts, liabilities or other
engagements has arrived, and until notice in writing of the intention to sell has been given to such shareholder or the
shareholder’s executors or administrators and default has been made by them in such payment, fulfilment or discharge
for seven days after such notice.

35. The net proceeds of any such sale after the payment of all costs shall be applied in or towards the satisfaction of

such debts, liabilities or engagements and the residue, if any, paid to such shareholder.

Validity of sales

36. Upon any sale after forfeiture or to enforce a lien in purported exercise of the powers given by these Articles

the directors may cause the purchaser’s name to be entered in the Register in respect of the shares sold, and the pur-
chaser shall not be bound to see to the regularity of the proceedings or to the application of the purchase money, and
after the purchaser’s name has been entered in the Register in respect of such shares the validity of the sale shall not
be impeached by any person and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against
the Company exclusively.

Transfer of shares

37. The instrument of transfer of any share in the Company shall be signed by the transferor. The transferor shall be

deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee is entered in the Register in respect thereof
and shall be entitled to receive any dividend declared thereon before the registration of the transfer.

38. The instrument of transfer of any share shall be in writing in the following form or to the following effect:

For value received, ............ hereby sell, assign, and transfer unto .............., .............. shares in the capital of the Company

represented by the within certificate, and do hereby irrevocably constitute and appoint .................... attorney to transfer
such shares on the books of the Company with full power of substitution in the premises.

Dated the ......... day of .............., .........
Witness:

39. The directors may, without assigning any reason therefor, decline to register any transfer of shares
(1) not fully paid-up or upon which the Company has a lien, or
(2) the transfer of which is restricted by any agreement to which the Company is a party.
40. Every instrument of transfer shall be left for registration at the Office of the Company, or at any office of its trans-

fer agent where a Register is maintained, together with the certificate of the shares to be transferred and such other
evidence as the Company may require to prove title to or the right to transfer the shares.

41. The directors may require that a fee determined by them be paid before or after registration of any transfer.
42. Every instrument of transfer shall, after its registration, remain in the custody of the Company. Any instrument

of transfer that the directors decline to register shall, except in case of fraud, be returned to the person who deposited
it.

21561

Transmission of shares

43. The executors or administrators of a deceased shareholder (not being one of several joint holders) shall be the

only persons recognized by the Company as having any title to the shares registered in the name of such shareholder.
When a share is registered in the names of two or more joint holders, the survivor or survivors or the executors or
administrators of the deceased shareholder, shall be the only persons recognized by the Company as having any title to,
or interest in, such share.

44. Notwithstanding anything in these Articles, if the Company has only one shareholder (not being one of several

joint holders) and that shareholder dies, the executors or administrators of the deceased shareholder shall be entitled
to register themselves in the Register as the holders of the shares registered in the name of the deceased shareholder
whereupon they shall have all the rights given by these Articles and by law to shareholders.

45. Any person entitled to shares upon the death or bankruptcy of any shareholder or in any way other than by al-

lotment or transfer, upon producing such evidence of entitlement as the directors require, may be registered as a share-
holder in respect of such shares, or may, without being registered, transfer such shares subject to the provisions of
these Articles respecting the transfer of shares. The directors shall have the same right to refuse registration as if the
transferee were named in an ordinary transfer presented for registration.

Surrender of shares

46. The directors may accept the surrender of any share by way of compromise of any question as to the holder

being properly registered in respect thereof. Any share so surrendered may be disposed of in the same manner as a
forfeited share.

Increase and reduction of capital

47. Subject to the Act, the shareholders may by special resolution amend these Articles to increase or alter the share

capital of the Company as they think expedient. Without prejudice to any special rights previously conferred on the
holders of existing shares, any share may be issued with such preferred, deferred or other special rights, or with such
restrictions, whether in regard to dividends, voting, return of share capital or otherwise, as the shareholders may from
time to time determine by special resolution. Except as otherwise provided by the conditions of issue, or by these Ar-
ticles, any capital raised by the creation of new shares shall be considered part of the original capital and shall be subject
to the provisions herein contained with reference to payment of calls and instalments, transfer and transmission, forfei-
ture, lien and otherwise.

48. The Company may, by special resolution where required, reduce its share capital in any way and with and subject

to any incident authorized and consent required by law. Subject to the Act and any provisions attached to such shares,
the Company may redeem, purchase or acquire any of its shares and the directors may determine the manner and the
terms for redeeming, purchasing or acquiring such shares and may provide a sinking fund on such terms as they think
fit for the redemption, purchase or acquisition of shares of any class or series.

Meetings and voting by class or series

49. Where the holders of shares of a class or series have, under the Act, the terms or conditions attaching to such

shares or otherwise, the right to vote separately as a class in respect of any matter then, except as provided in the Act,
these Articles or such terms or conditions, all the provisions in these Articles concerning general meetings (including,
without limitation, provisions respecting notice, quorum and procedure) shall, mutatis mutandis, apply to every meeting
of holders of such class or series of shares convened for the purpose of such vote.

50. Unless the rights, privileges, terms or conditions attached to a class or series of shares provide otherwise, such

class or series of shares shall not have the right to vote separately as a class or series upon an amendment to the Mem-
orandum or Articles to:

(1) increase or decrease any maximum number of authorized shares of such class or series, or increase any maximum

number of authorized shares of a class or series having rights or privileges equal or superior to the shares of such class
or series;

(2) effect an exchange, reclassification or cancellation of all or part of the shares of such class or series; or
(3) create a new class or series of shares equal or superior to the shares of such class or series.

Borrowing powers

51. The directors on behalf of the Company may:
(1) raise or borrow money for the purposes of the Company or any of them; 
(2) secure the repayment of funds so raised or borrowed in such manner and upon such terms and conditions in all

respects as they think fit, and in particular by the execution and delivery of mortgages of the Company’s real or personal
property, or by the issue of bonds, debentures or other securities of the Company secured by mortgage or other charge
upon all or any part of the property of the Company, both present and future including its uncalled capital for the time
being;

(3) sign or endorse bills, notes, acceptances, cheques, contracts, and other evidence of or securities for funds bor-

rowed or to be borrowed for the purposes aforesaid;

(4) pledge debentures as security for loans;
(5) guarantee obligations of any person.
52. Bonds, debentures and other securities may be made assignable, free from any equities between the Company

and the person to whom such securities were issued.

53. Any bonds, debentures and other securities may be issued at a discount, premium or otherwise and with special

privileges as to redemption, surrender, drawings, allotment of shares, attending and voting at general meetings of the
Company, appointment of directors and other matters.

21562

General meetings

54. Ordinary general meetings of the Company shall be held at least once in every calendar year at such time and

place as may be determined by the directors and not later than 15 months after the preceding ordinary general meeting.
All other meetings of the Company shall be called special general meetings. Ordinary or special general meetings may
be held either within or without the Province of Nova Scotia, provided, however, that all such ordinary or special gen-
eral meetings are held at a place within Canada.

55. The President, a vice-president or the directors may at any time convene a special general meeting, and the di-

rectors, upon the requisition of shareholders in accordance with the Act shall forthwith proceed to convene such meet-
ing or meetings to be held at such time and place or times and places as the directors determine.

56. The requisition shall state the objects of the meeting requested, be signed by the requisitionists and deposited at

the Office of the Company. It may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requi-
sitionists.

57. At least seven clear days’ notice, or such longer period of notice as may be required by the Act, of every general

meeting, specifying the place, day and hour of the meeting and, when special business is to be considered, the general
nature of such business, shall be given to the shareholders entitled to be present at such meeting by notice given as
permitted by these Articles. With the consent in writing of all the shareholders entitled to vote at such meeting, a meet-
ing may be convened by a shorter notice and in any manner they think fit, or notice of the time, place and purpose of
the meeting may be waived by all of the shareholders.

58. When it is proposed to pass a special resolution, the two meetings may be convened by the same notice, and it

shall be no objection to such notice that it only convenes the second meeting contingently upon the resolution being
passed by the requisite majority at the first meeting.

59. The accidental omission to give notice to a shareholder, or non-receipt of notice by a shareholder, shall not in-

validate any resolution passed at any general meeting.

Record dates

60. (1) The directors may fix in advance a date as the record date for the determination of shareholders
(a) entitled to receive payment of a dividend or entitled to receive any distribution;
(b) entitled to receive notice of a meeting; or
(c) for any other purpose.
(2) If no record date is fixed, the record date for the determination of shareholders
(a) entitled to receive notice of a meeting shall be the day immediately preceding the day on which the notice is given,

or, if no notice is given, the day on which the meeting is held; and

(b) for any other purpose shall be the day on which the directors pass the resolution relating to the particular pur-

pose.

Proceedings at General Meetings

61. The business of an ordinary general meeting shall be to receive and consider the financial statements of the Com-

pany and the report of the directors and the report, if any, of the auditors, to elect directors in the place of those retiring
and to transact any other business which under these Articles ought to be transacted at an ordinary general meeting.

62. No business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum is present at the commence-

ment of the business. A corporate shareholder of the Company that has a duly authorized agent or representative
present at any such meeting shall for the purpose of this Article be deemed to be personally present at such meeting.

63. One person, being a shareholder, proxy holder or representative of a corporate shareholder, present and entitled

to vote shall constitute a quorum for a general meeting, and may hold a meeting.

64. The Chairman shall be entitled to take the chair at every general meeting or, if there be no Chairman, or if the

Chairman is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, the President or, failing the
President, a vice-president shall be entitled to take the chair. If the Chairman, the President or a vice-president is not
present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or if all such persons present decline to take
the chair, the shareholders present entitled to vote at the meeting shall choose another director as chairman and if no
director is present or if all the directors present decline to take the chair, then such shareholders shall choose one of
their number to be chairman.

65. If within half an hour from the time appointed for a general meeting a quorum is not present, the meeting, if it

was convened pursuant to a requisition of shareholders, shall be dissolved; if it was convened in any other way, it shall
stand adjourned to the same day, in the next week, at the same time and place. If at the adjourned meeting a quorum
is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the shareholders present shall be a quorum
and may hold the meeting.

66. Subject to the Act, at any general meeting a resolution put to the meeting shall be decided by a show of hands

unless, either before or on the declaration of the result of the show of hands, a poll is demanded by the chairman, a
shareholder or a proxy holder; and unless a poll is so demanded, a declaration by the chairman that the resolution has
been carried, carried by a particular majority, lost or not carried by a particular majority and an entry to that effect in
the Company’s book of proceedings shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion
of the votes recorded in favour or against such resolution.

67. When a poll is demanded, it shall be taken in such manner and at such time and place as the chairman directs, and

either at once or after an interval or adjournment or otherwise. The result of the poll shall be the resolution of the
meeting at which the poll was demanded. The demand of a poll may be withdrawn. When any dispute occurs over the
admission or rejection of a vote, it shall be resolved by the chairman and such determination made in good faith shall
be final and conclusive.

21563

68. The chairman shall not have a casting vote in addition to any vote or votes that the chairman has as a shareholder.
69. The chairman of a general meeting may with the consent of the meeting adjourn the meeting from time to time

and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left un-
finished at the meeting that was adjourned.

70. Any poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith with-

out adjournment.

71. The demand of a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other

than the question on which a poll has been demanded.

Votes of shareholders

72. Subject to the Act and to any provisions attached to any class or series of shares concerning or restricting voting

rights:

(1) on a show of hands every shareholder entitled to vote present in person, every duly authorized representative

of a corporate shareholder, and, if not prevented from voting by the Act, every proxy holder, shall have one vote; and 

(2) on a poll every shareholder present in person, every duly authorized representative of a corporate shareholder,

and every proxy holder, shall have one vote for every share held;

whether or not such representative or proxy holder is a shareholder.
73. Any person entitled to transfer shares upon the death or bankruptcy of any shareholder or in any way other than

by allotment or transfer may vote at any general meeting in respect thereof in the same manner as if such person were
the registered holder of such shares so long as the directors are satisfied at least 48 hours before the time of holding
the meeting of such person’s right to transfer such shares.

74. Where there are joint registered holders of any share, any of such holders may vote such share at any meeting,

either personally or by proxy, as if solely entitled to it. If more than one joint holder is present at any meeting, personally
or by proxy, the one whose name stands first on the Register in respect of such share shall alone be entitled to vote it.
Several executors or administrators of a deceased shareholder in whose name any share stands shall for the purpose
of this Article be deemed joint holders thereof. 

75. Votes may be cast either personally or by proxy or, in the case of a corporate shareholder by a representative

duly authorized under the Act.

76. A proxy shall be in writing and executed in the manner provided in the Act. A proxy or other authority of a

corporate shareholder does not require its seal.

77. A shareholder of unsound mind in respect of whom an order has been made by any court of competent jurisdic-

tion may vote by guardian or other person in the nature of a guardian appointed by that court, and any such guardian
or other person may vote by proxy.

78. A proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified

copy of that power or authority shall be deposited at the Office of the Company or at such other place as the directors
may direct. The directors may, by resolution, fix a time not exceeding 48 hours excluding Saturdays and holidays pre-
ceding any meeting or adjourned meeting before which time proxies to be used at that meeting must be deposited with
the Company at its Office or with an agent of the Company. Notice of the requirement for depositing proxies shall be
given in the notice calling the meeting. The chairman of the meeting shall determine all questions as to validity of proxies
and other instruments of authority.

79. A vote given in accordance with the terms of a proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the

principal, the revocation of the proxy, or the transfer of the share in respect of which the vote is given, provided no
intimation in writing of the death, revocation or transfer is received at the Office of the Company before the meeting
or by the chairman of the meeting before the vote is given.

80. Every form of proxy shall comply with the Act and its regulations and subject thereto may be in the following form:

I, ................ of .................... being a shareholder of ........................... hereby appoint ....................... of ....................... (or failing

him/her .......................... of ..............................) as my proxy holder to attend and to vote for me and on my behalf at the
ordinary/special general meeting of the Company, to be held on the day of and at any adjournment thereof, or at any
meeting of the Company which may be held prior to [insert specified date or event].

[If the proxy is solicited by or behalf of the management of the Company, insert a statement to that effect.]
Dated this ................... day of .................. ................. . 
Shareholder

81. Subject to the Act, no shareholder shall be entitled to be present or to vote on any question, either personally

or by proxy, at any general meeting or be reckoned in a quorum while any call is due and payable to the Company in
respect of any of the shares of such shareholder.

82. Any resolution passed by the directors, notice of which has been given to the shareholders in the manner in which

notices are hereinafter directed to be given and which is, within one month after it has been passed, ratified and con-
firmed in writing by shareholders entitled on a poll to three-fifths of the votes, shall be as valid and effectual as a reso-
lution of a general meeting. This Article shall not apply to a resolution for winding up the Company or to a resolution
dealing with any matter that by statute or these Articles ought to be dealt with by a special resolution or other method
prescribed by statute. 

83. A resolution, including a special resolution, in writing and signed by every shareholder who would be entitled to

vote on the resolution at a meeting is as valid as if it were passed by such shareholders at a meeting and satisfies all of
the requirements of the Act respecting meetings of shareholders.

21564

Directors

84. Unless otherwise determined by resolution of shareholders, the number of directors shall not be less than one

or more than ten.

85. Notwithstanding anything herein contained the persons named in the Amalgamation Agreement pursuant to

which the Company was formed shall be the first directors of the Company.

86. The directors may be paid out of the funds of the Company as remuneration for their service such sums, if any,

as the Company may by resolution of its shareholders determine, and such remuneration shall be divided among them
in such proportions and manner as the directors determine. The directors may also be paid their reasonable travelling,
hotel and other expenses incurred in attending meetings of directors and otherwise in the execution of their duties as
directors.

87. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but if their number falls below the

minimum permitted, the directors shall not, except in emergencies or for the purpose of filling vacancies, act so long as
their number is below the minimum.

88. A director may, in conjunction with the office of director, and on such terms as to remuneration and otherwise

as the directors arrange or determine, hold any other office or place of profit under the Company or under any company
in which the Company is a shareholder or is otherwise interested.

89. The office of a director shall ipso facto be vacated, if the director: 
(1) becomes bankrupt or makes an assignment for the benefit of creditors; 
(2) is, or is found by a court of competent jurisdiction to be, of unsound mind;
(3) by notice in writing to the Company, resigns the office of director; or 
(4) is removed in the manner provided by these Articles.
90. No director shall be disqualified by holding the office of director from contracting with the Company, either as

vendor, purchaser, or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into or proposed
to be entered into by or on behalf of the Company in which any director is in any way interested, either directly or
indirectly, be avoided, nor shall any director so contracting or being so interested be liable to account to the Company
for any profit realized by any such contract or arrangement by reason only of such director holding that office or of the
fiduciary relations thereby established, provided the director makes a declaration or gives a general notice in accordance
with the Act. No director shall, as a director, vote in respect of any contract or arrangement in which the director is
so interested, and if the director does so vote, such vote shall not be counted. This prohibition may at any time or times
be suspended or relaxed to any extent by a resolution of the shareholders and shall not apply to any contract by or on
behalf of the Company to give to the directors or any of them any security for advances or by way of indemnity.

Election of directors

91. At the dissolution of every ordinary general meeting at which their successors are elected, all the directors shall

retire from office and be succeeded by the directors elected at such meeting. Retiring directors shall be eligible for re-
election.

92. If at any ordinary general meeting at which an election of directors ought to take place no such election takes

place, or if no ordinary general meeting is held in any year or period of years, the retiring directors shall continue in
office until their successors are elected.

93. The Company may by resolution of its shareholders elect any number of directors permitted by these Articles

and may determine or alter their qualification.

94. The Company may, by special resolution or in any other manner permitted by statute, remove any director before

the expiration of such director’s period of office and may, if desired, appoint a replacement to hold office during such
time only as the director so removed would have held office.

95. The directors may appoint any other person as a director so long as the total number of directors does not at

any time exceed the maximum number permitted. No such appointment, except to fill a casual vacancy, shall be effective
unless two-thirds of the directors concur in it. Any casual vacancy occurring among the directors may be filled by the
directors, but any person so chosen shall retain office only so long as the vacating director would have retained it if the
vacating director had continued as director.

Managing director

96. The directors may appoint one or more of their body to be managing directors of the Company, either for a fixed

term or otherwise, and may remove or dismiss them from office and appoint replacements.

97. Subject to the provisions of any contract between a managing director and the Company, a managing director

shall be subject to the same provisions as to resignation and removal as the other directors of the Company. A managing
director who for any reason ceases to hold the office of director shall ipso facto immediately cease to be a managing
director.

98. The remuneration of a managing director shall from time to time be fixed by the directors and may be by way of

any or all of salary, commission and participation in profits.

99. The directors may from time to time entrust to and confer upon a managing director such of the powers exer-

cisable under these Articles by the directors as they think fit, and may confer such powers for such time, and to be
exercised for such objects and purposes and upon such terms and conditions, and with such restrictions as they think
expedient; and they may confer such powers either collaterally with, or to the exclusion of, and in substitution for, all
or any of the powers of the directors in that behalf; and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or
any of such powers.

21565

Chairman of the board

100. The directors may elect one of their number to be Chairman and may determine the period during which the

Chairman is to hold office. The Chairman shall perform such duties and receive such special remuneration as the direc-
tors may provide.

President and vive-presidents

101. The directors shall elect the President of the Company, who need not be a director, and may determine the

period for which the President is to hold office. The President shall have general supervision of the business of the Com-
pany and shall perform such duties as may be assigned from time to time by the directors.

102. The directors may also elect vice-presidents, who need not be directors, and may determine the periods for

which they are to hold office. A vice-president shall, at the request of the President or the directors and subject to the
directions of the directors, perform the duties of the President during the absence, illness or incapacity of the President,
and shall also perform such duties as may be assigned by the President or the directors.

Secretary and treasurer

103. The directors shall appoint a Secretary of the Company to keep minutes of shareholders’ and directors’ meetings

and perform such other duties as may be assigned by the directors. The directors may also appoint a temporary substi-
tute for the Secretary who shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be the Secretary.

104. The directors may appoint a treasurer of the Company to carry out such duties as the directors may assign.

Officers

105. The directors may elect or appoint such other officers of the Company, having such powers and duties, as they

think fit.

106. If the directors so decide the same person may hold more than one of the offices provided for in these Articles.

Proceedings of directors

107. The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings

and proceedings, as they think fit, and may determine the quorum necessary for the transaction of business. Until oth-
erwise determined, one director shall constitute a quorum and may hold a meeting.

108. If all directors of the Company entitled to attend a meeting either generally or specifically consent, a director

may participate in a meeting of directors or of a committee of directors by means of such telephone or other commu-
nications facilities as permit all persons participating in the meeting to hear each other, and a director participating in
such a meeting by such means is deemed to be present at that meeting for purposes of these Articles.

109. Meetings of directors may be held either within or without the Province of Nova Scotia, provided, however,

that all such meetings of directors are held at a place within Canada, and the directors may from time to time make
arrangements relating to the time and place of holding directors’ meetings, the notices to be given for such meetings
and what meetings may be held without notice. Unless otherwise provided by such arrangements:

(1) A meeting of directors may be held at the close of every ordinary general meeting of the Company without notice.
(2) Notice of every other directors’ meeting may be given as permitted by these Articles to each director at least 48

hours before the time fixed for the meeting.

(3) A meeting of directors may be held without formal notice if all the directors are present or if those absent have

signified their assent to such meeting or their consent to the business transacted at such meeting.

110. The President or any director may at any time, and the Secretary, upon the request of the President or any

director, shall summon a meeting of the directors to be held at the Office of the Company. The President, the Chairman
or a majority of the directors may at any time, and the Secretary, upon the request of the President, the Chairman or
a majority of the directors, shall summon a meeting to be held elsewhere.

111. (1) Questions arising at any meeting of directors shall be decided by a majority of votes. The chairman of the

meeting may vote as a director but shall not have a second or casting vote.

(2) At any meeting of directors the chairman shall receive and count the vote of any director not present in person

at such meeting on any question or matter arising at such meeting whenever such absent director has indicated by tel-
egram, letter or other writing lodged with the chairman of such meeting the manner in which the absent director desires
to vote on such question or matter and such question or matter has been specifically mentioned in the notice calling
the meeting as a question or matter to be discussed or decided there at. In respect of any such question or matter so
mentioned in such notice any director may give to any other director a proxy authorizing such other director to vote
for such first named director at such meeting, and the chairman of such meeting, after such proxy has been so lodged,
shall receive and count any vote given in pursuance thereof notwithstanding the absence of the director giving such
proxy.

112. If no Chairman is elected, or if at any meeting of directors the Chairman is not present within five minutes after

the time appointed for holding the meeting, or declines to take the chair, the President, if a director, shall preside. If the
President is not a director, is not present at such time or declines to take the chair, a vice-president who is also a di-
rector shall preside. If no person described above is present at such time and willing to take the chair, the directors
present shall choose some one of their number to be chairman of the meeting.

113. A meeting of the directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the author-

ities, powers and discretions for the time being vested in or exercisable by the directors generally.

114. The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such number of directors as they

think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that
may be imposed on them by the directors.

21566

115. The meetings and proceedings of any committee of directors shall be governed by the provisions contained in

these Articles for regulating the meetings and proceedings of the directors insofar as they are applicable and are not
superseded by any regulations made by the directors.

116. All acts done at any meeting of the directors or of a committee of directors or by any person acting as a director

shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the appointment of the director or
person so acting, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly ap-
pointed and was qualified to be a director.

117. A resolution in writing and signed by every director who would be entitled to vote on the resolution at a meeting

is as valid as if it were passed by such directors at a meeting.

118. If any one or more of the directors is called upon to perform extra services or to make any special exertions in

going or residing abroad or otherwise for any of the purposes of the Company or the business thereof, the Company
may remunerate the director or directors so doing, either by a fixed sum or by a percentage of profits or otherwise.
Such remuneration shall be determined by the directors and may be either in addition to or in substitution for remu-
neration otherwise authorized by these Articles.

Registers

119. The directors shall cause to be kept at the Company’s Office located in the Province of Nova Scotia in accord-

ance with the provisions of the Act a Register of the shareholders of the Company, a register of the holders of bonds,
debentures and other securities of the Company and a register of its directors. Branch registers of the shareholders
and of the holders of bonds, debentures and other securities may be kept elsewhere, either within or without the Prov-
ince of Nova Scotia, provided, however, that all such branch registers are kept at a location within Canada.

Minutes

120. The directors shall cause minutes to be entered in books designated for the purpose:
(1) of all appointments of officers;
(2) of the names of directors present at each meeting of directors and of any committees of directors;
(3) of all orders made by the directors and committees of directors; and
(4) of all resolutions and proceedings of meetings of shareholders and of directors.
Any such minutes of any meeting of directors or of any committee of directors or of shareholders, if purporting to

be signed by the chairman of such meeting or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be receivable as
prima facie evidence of the matters stated in such minutes.

Powers of directors

121. The management of the business of the Company is vested in the directors who, in addition to the powers and

authorities by these Articles or otherwise expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such
acts and things as may be exercised or done by the Company and are not hereby or by statute expressly directed or
required to be exercised or done by the shareholders, but subject nevertheless to the provisions of any statute, the
Memorandum or these Articles. No modification of the Memorandum or these Articles shall invalidate any prior act of
the directors that would have been valid if such modification had not been made.

122. Without restricting the generality of the terms of any of these Articles and without prejudice to the powers

conferred thereby, the directors may:

(1) take such steps as they think fit to carry out any agreement or contract made by or on behalf of the Company;
(2) pay costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment, and reg-

istration of the Company;

(3) purchase or otherwise acquire for the Company any property, rights or privileges that the Company is authorized

to acquire, at such price and generally on such terms and conditions as they think fit;

(4) pay for any property, rights or privileges acquired by, or services rendered to the Company either wholly or par-

tially in cash or in shares (fully paid-up or otherwise), bonds, debentures or other securities of the Company; 

(5) subject to the Act, secure the fulfilment of any contracts or engagements entered into by the Company by mort-

gaging or charging all or any of the property of the Company and its unpaid capital for the time being, or in such other
manner as they think fit;

(6) appoint, remove or suspend at their discretion such experts, managers, secretaries, treasurers, officers, clerks,

agents and servants for permanent, temporary or special services, as they from time to time think fit, and determine
their powers and duties and fix their salaries or emoluments and require security in such instances and to such amounts
as they think fit;

(7) accept a surrender of shares from any shareholder insofar as the law permits and on such terms and conditions

as may be agreed;

(8) appoint any person or persons to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Com-

pany, or in which it is interested, execute and do all such deeds and things as may be required in relation to such trust,
and provide for the remuneration of such trustee or trustees;

(9) institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by and against the Company, its directors

or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company, and also compound and allow time for payment or
satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company;

(10) refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards;
(11) make and give receipts, releases and other discharges for amounts payable to the Company and for claims and

demands of the Company;

21567

(12) determine who may exercise the borrowing powers of the Company and sign on the Company’s behalf bonds,

debentures or other securities, bills, notes, receipts, acceptances, assignments, transfers, hypothecations, pledges, en-
dorsements, cheques, drafts, releases, contracts, agreements and all other instruments and documents;

(13) provide for the management of the affairs of the Company abroad in such manner as they think fit, and in par-

ticular appoint any person to be the attorney or agent of the Company with such powers (including power to sub-del-
egate) and upon such terms as may be thought fit;

(14) invest and deal with any funds of the Company in such securities and in such manner as they think fit; and vary

or realize such investments;

(15) subject to the Act, execute in the name and on behalf of the Company in favour of any director or other person

who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company such mortgages of the Com-
pany’s property, present and future, as they think fit;

(16) give any officer or employee of the Company a commission on the profits of any particular business or transac-

tion or a share in the general profits of the Company;

(17) set aside out of the profits of the Company before declaring any dividend such amounts as they think proper as

a reserve fund to meet contingencies or provide for dividends, depreciation, repairing, improving and maintaining any
of the property of the Company and such other purposes as the directors may in their absolute discretion think in the
interests of the Company; and invest such amounts in such investments as they think fit, and deal with and vary such
investments, and dispose of all or any part of them for the benefit of the Company, and divide the reserve fund into such
special funds as they think fit, with full power to employ the assets constituting the reserve fund in the business of the
Company without being bound to keep them separate from the other assets;

(18) make, vary and repeal rules respecting the business of the Company, its officers and employees, the shareholders

of the Company or any section or class of them;

(19) enter into all such negotiations and contracts, rescind and vary all such contracts, and execute and do all such

acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they consider expedient for or in relation to any
of the matters aforesaid or otherwise for the purposes of the Company;

(20) provide for the management of the affairs of the Company in such manner as they think fit.

Solicitors

123. The Company may employ or retain solicitors any of whom may, at the request or on the instruction of the

directors, the Chairman, the President or a managing director, attend meetings of the directors or shareholders, wheth-
er or not the solicitor is a shareholder or a director of the Company. A solicitor who is also a director may nevertheless
charge for services rendered to the Company as a solicitor.

The seal

124. The directors shall arrange for the safe custody of the common seal of the Company (the «Seal»). The Seal may

be affixed to any instrument in the presence of and contemporaneously with the attesting signature of (i) any director
or officer acting within such person’s authority or (ii) any person under the authority of a resolution of the directors
or a committee thereof. For the purpose of certifying documents or proceedings the Seal may be affixed by any director
or the President, a vice-president, the Secretary, an assistant secretary or any other officer of the Company without the
authorization of a resolution of the directors.

125. The Company may have facsimiles of the Seal which may be used interchangeably with the Seal.
126. The Company may have for use at any place outside the Province of Nova Scotia, as to all matters to which the

corporate existence and capacity of the Company extends, an official seal that is a facsimile of the Seal of the Company
with the addition on its face of the name of the place where it is to be used; and the Company may by writing under its
Seal authorize any person to affix such official seal at such place to any document to which the Company is a party.

Dividends

127. The directors may from time to time declare such dividend as they deem proper upon shares of the Company

according to the rights and restrictions attached to any class or series of shares, and may determine the date upon which
such dividend will be payable and that it will be payable to the persons registered as the holders of the shares on which
it is declared at the close of business upon a record date. No transfer of such shares registered after the record date
shall pass any right to the dividend so declared.

128. Dividends may be paid as permitted by law and, without limitation, may be paid out of the profits, retained earn-

ings or contributed surplus of the Company. No interest shall be payable on any dividend except insofar as the rights
attached to any class or series of shares provide otherwise.

129. The declaration of the directors as to the amount of the profits, retained earnings or contributed surplus of the

Company shall be conclusive. 

130. The directors may from time to time pay to the shareholders such interim dividends as in their judgment the

position of the Company justifies. 

131. Subject to these Articles and the rights and restrictions attached to any class or series of shares, dividends may

be declared and paid to the shareholders in proportion to the amount of capital paid-up on the shares (not including
any capital paid-up bearing interest) held by them respectively.

132. The directors may deduct from the dividends payable to any shareholder amounts due and payable by the share-

holder to the Company on account of calls, instalments or otherwise, and may apply the same in or towards satisfaction
of such amounts so due and payable.

133. The directors may retain any dividends on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards

satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.

21568

134. The directors may retain the dividends payable upon shares to which a person is entitled or entitled to transfer

upon the death or bankruptcy of a shareholder or in any way other than by allotment or transfer, until such person has
become registered as the holder of such shares or has duly transferred such shares.

135. When the directors declare a dividend on a class or series of shares and also make a call on such shares payable

on or before the date on which the dividend is payable, the directors may retain all or part of the dividend and set off
the amount retained against the call.

136. The directors may declare that a dividend be paid by the distribution of cash, paid-up shares (at par or at a pre-

mium), debentures, bonds or other securities of the Company or of any other company or any other specific assets held
or to be acquired by the Company or in any one or more of such ways.

137. The directors may settle any difficulty that may arise in regard to the distribution of a dividend as they think

expedient, and in particular without restricting the generality of the foregoing may issue fractional certificates, may fix
the value for distribution of any specific assets, may determine that cash payments will be made to any shareholders
upon the footing of the value so fixed or that fractions may be disregarded in order to adjust the rights of all parties,
and may vest cash or specific assets in trustees upon such trusts for the persons entitled to the dividend as may seem
expedient to the directors. 

138. Any person registered as a joint holder of any share may give effectual receipts for all dividends and payments

on account of dividends in respect of such share.

139. Unless otherwise determined by the directors, any dividend may be paid by a cheque or warrant delivered to

or sent through the post to the registered address of the shareholder entitled, or, when there are joint holders, to the
registered address of that one whose name stands first on the register for the shares jointly held. Every cheque or war-
rant so delivered or sent shall be made payable to the order of the person to whom it is delivered or sent. The mailing
or other transmission to a shareholder at the shareholder’s registered address (or, in the case of joint shareholders at
the address of the holder whose name stands first on the register) of a cheque payable to the order of the person to
whom it is addressed for the amount of any dividend payable in cash after the deduction of any tax which the Company
has properly withheld, shall discharge the Company’s liability for the dividend unless the cheque is not paid on due pres-
entation. If any cheque for a dividend payable in cash is not received, the Company shall issue to the shareholder a re-
placement cheque for the same amount on such terms as to indemnity and evidence of non-receipt as the directors may
impose. No shareholder may recover by action or other legal process against the Company any dividend represented
by a cheque that has not been duly presented to a banker of the Company for payment or that otherwise remains un-
claimed for 6 years from the date on which it was payable.

Accounts

140. The directors shall cause proper books of account to be kept of the amounts received and expended by the

Company, the matters in respect of which such receipts and expenditures take place, all sales and purchases of goods
by the Company, and the assets, credits and liabilities of the Company.

141. The books of account shall be kept at the head office of the Company or at such other place or places as the

directors may direct provided, however, that all such books of account are kept at a location within Canada.

142. The directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and

under what conditions the accounts and books of the Company or any of them shall be open to inspection of the share-
holders, and no shareholder shall have any right to inspect any account or book or document of the Company except
as conferred by statute or authorized by the directors or a resolution of the shareholders.

143. At the ordinary general meeting in every year the directors shall lay before the Company such financial state-

ments and reports in connection therewith as may be required by the Act or other applicable statute or regulation
thereunder and shall distribute copies thereof at such times and to such persons as may be required by statute or reg-
ulation.

Auditors and audit

144. Except in respect of a financial year for which the Company is exempt from audit requirements in the Act, the

Company shall at each ordinary general meeting appoint an auditor or auditors to hold office until the next ordinary
general meeting. If at any general meeting at which the appointment of an auditor or auditors is to take place and no
such appointment takes place, or if no ordinary general meeting is held in any year or period of years, the directors shall
appoint an auditor or auditors to hold office until the next ordinary general meeting.

145. The first auditors of the Company may be appointed by the directors at any time before the first ordinary general

meeting and the auditors so appointed shall hold office until such meeting unless previously removed by a resolution of
the shareholders, in which event the shareholders may appoint auditors.

146. The directors may fill any casual vacancy in the office of the auditor but while any such vacancy continues the

surviving or continuing auditor or auditors, if any, may act.

147. The Company may appoint as auditor any person, including a shareholder, not disqualified by statute.
148. An auditor may be removed or replaced in the circumstances and in the manner specified in the Act.
149. The remuneration of the auditors shall be fixed by the shareholders, or by the directors pursuant to authoriza-

tion given by the shareholders, except that the remuneration of an auditor appointed to fill a casual vacancy may be fixed
by the directors.

150. The auditors shall conduct such audit as may be required by the Act and their report, if any, shall be dealt with

by the Company as required by the Act.

Notices

151. A notice (including any communication or document) shall be sufficiently given, delivered or served by the Com-

pany upon a shareholder, director, officer or auditor by personal delivery at such person’s registered address (or, in the

21569

case of a director, officer or auditor, last known address) or by prepaid mail, telegraph, telex, facsimile machine or other
electronic means of communication addressed to such person at such address.

152. Shareholders having no registered address shall not be entitled to receive notice.
153. All notices with respect to registered shares to which persons are jointly entitled may be sufficiently given to all

joint holders thereof by notice given to whichever of such persons is named first in the Register for such shares.

154. Any notice sent by mail shall be deemed to be given, delivered or served on the earlier of actual receipt and the

third business day following that upon which it is mailed, and in proving such service it shall be sufficient to prove that
the notice was properly addressed and mailed with the postage prepaid thereon. Any notice given by electronic means
of communication shall be deemed to be given when entered into the appropriate transmitting device for transmission.
A certificate in writing signed on behalf of the Company that the notice was so addressed and mailed or transmitted
shall be conclusive evidence thereof.

155. Every person who by operation of law, transfer or other means whatsoever becomes entitled to any share shall

be bound by every notice in respect of such share that prior to such person’s name and address being entered on the
Register was duly served in the manner herein before provided upon the person from whom such person derived title
to such share.

156. Any notice delivered, sent or transmitted to the registered address of any shareholder pursuant to these Arti-

cles, shall, notwithstanding that such shareholder is then deceased and that the Company has notice thereof, be deemed
to have been served in respect of any registered shares, whether held by such deceased shareholder solely or jointly
with other persons, until some other person is registered as the holder or joint holder thereof, and such service shall
for all purposes of these Articles be deemed a sufficient service of such notice on the heirs, executors or administrators
of the deceased shareholder and all joint holders of such shares.

157. Any notice may bear the name or signature, manual or reproduced, of the person giving the notice written or

printed.

158. When a given number of days’ notice or notice extending over any other period is required to be given, the day

of service and the day upon which such notice expires shall not, unless it is otherwise provided, be counted in such
number of days or other period.

Indemnity

159. Every director or officer, former director or officer, or person who acts or acted at the Company’s request, as

a director or officer of the Company, a body corporate, partnership or other association of which the Company is or
was a shareholder, partner, member or creditor, and the heirs and legal representatives of such person, in the absence
of any dishonesty on the part of such person, shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of
the directors out of the funds of the Company to pay, all costs, losses and expenses, including an amount paid to settle
an action or claim or satisfy a judgment, that such director, officer or person may incur or become liable to pay in respect
of any claim made against such person or civil, criminal or administrative action or proceeding to which such person is
made a party by reason of being or having been a director or officer of the Company or such body corporate, partner-
ship or other association, whether the Company is a claimant or party to such action or proceeding or otherwise; and
the amount for which such indemnity is proved shall immediately attach as a lien on the property of the Company and
have priority as against the shareholders over all other claims.

160. No director or officer, former director or officer, or person who acts or acted at the Company’s request, as a

director or officer of the Company, a body corporate, partnership or other association of which the Company is or was
a shareholder, partner, member or creditor, in the absence of any dishonesty on such person’s part, shall be liable for
the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer or such person, or for joining in any receipt or other
act for conformity, or for any loss, damage or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency
of title to any property acquired for or on behalf of the Company, or through the insufficiency or deficiency of any se-
curity in or upon which any of the funds of the Company are invested, or for any loss or damage arising from the bank-
ruptcy, insolvency or tortious acts of any person with whom any funds, securities or effects are deposited, or for any
loss occasioned by error of judgment or oversight on the part of such person, or for any other loss, damage or misfor-
tune whatsoever which happens in the execution of the duties of such person or in relation thereto.

Execution of documents and instruments

161. Deeds, transfers, assignments, contracts, obligations, certificates and other instruments and documents of any

description whatsoever shall be effectively authorized by and signed on behalf of the Company if signed by any director
or officer acting within such person’s authority, whether under seal or otherwise as such signatories may see fit. In ad-
dition, the board of directors or the shareholders may from time to time by resolution direct the manner in which and
the person or persons by whom any particular document or instrument or class of documents or instruments may or
shall be signed. Any articles, notice, resolution, requisition, statement or other document or instrument required or
permitted to be executed by more than one person may be executed in several documents or instruments of like form
each of which is executed by one or more of such persons, and such documents or instruments, when duly executed
by all persons required or permitted, as the case may be, to do so, shall be deemed to constitute one document for all
relevant purposes. The secretary or any other officer or any director may sign certificates and similar instruments on
the Company’s behalf with respect to any factual matters relating to the Company’s business and affairs, including cer-
tificates verifying copies of the constating documents, resolutions and minutes of meetings of the Company.

21570

Reminders

162. The directors shall comply with the following provisions of the Act or the Corporations Registration Act (Nova

Scotia) where indicated:

(1) Keep a current register of shareholders (Section 42).
(2) Keep a current register of directors, officers and managers, send to the Registrar a copy thereof and notice of all

changes therein (Section 98).

(3) Keep a current register of holders of bonds, debentures and other securities (Section 111 and Third Schedule).
(4) Call a general meeting every year within the proper time (Section 83). Meetings must be held not later than 15

months after the preceding general meeting.

(5) Send to the Registrar copies of all special resolutions (Section 88). 
(6) Send to the Registrar notice of the address of the Company’s Office and of all changes in such address (Section 79).
(7) Keep proper minutes of all shareholders’ meetings and directors’ meetings in the Company’s minute book kept

at the Company’s Office (Sections 89 and 90).

(8) Obtain a certificate under the Corporations Registration Act (Nova Scotia) as soon as business is commenced.
(9) Send notice of recognized agent to the Registrar under the Corporations Registration Act (Nova Scotia).

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06031. – Reçu 68 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009374.2//775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

BENDICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.878. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05791, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

(008320.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LAWSUN GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7249 Bereldange, 13, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 71.195. 

Constituée par-devant M

e

 Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 22 juillet 1999, acte publié au

Mémorial C n

o

 816 du 3 novembre 1999, modifié par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 7 février 2001, acte publié au Mémorial C n

o

 764 du 15 septembre 2001, modifié par acte

sous seing privé en date du 16 mai 2001, acte publié au Mémorial C n

o

 907 du 14 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05269, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005. 

(008432.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

KALIMERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8341 Olm, 1, rue J.A. Zinnen.

R. C. Luxembourg B 76.355. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008434.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour LAWSUN GROUP, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

21571

BRASSERIE GEORGES VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 5, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 30.012. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06049, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008443.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

UNICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 40.483. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04182, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008456.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ALIENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 195, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 60.908. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04188, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008459.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BIJOUTERIE WACHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 9, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 78.518. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04193, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008462.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

DESIGN CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5801 Luxembourg, 281, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 44.528. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04197, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008464.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

21572

DOMERIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 63.820. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04200, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008467.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

GLOBAL NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.135. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04202, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008468.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

GLOBAL SAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.218. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04205, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008469.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

GLOBAL VALUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.136. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04208, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008470.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SALON DE COIFFURE GROBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6134 Junglinster, 12A, rue de Lauterbour.

R. C. Luxembourg B 78.615. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04213, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008476.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

21573

SCODEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang.

R. C. Luxembourg B 84.017. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04216, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008478.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

QUICKSTEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 86.860. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04210, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008471.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

CHRONO INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 13, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 62.864. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03443, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008491.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RESTAURANT MATHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CITY HOTEL).

Siège social: L-5401 Ahn, 37, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 18.210. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03442, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008494.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LIFRAPOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.788. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05814, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008667.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Signature.

21574

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05306, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008496.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05304, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008500.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05302, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008503.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05300, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008505.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05295, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008506.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

21575

CIMOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CIMOLUX SCI).

Siège social: L-8030 Strassen, 6, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 86.478. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05291, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008508.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

JoMü FENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R. C. Luxembourg B 64.728. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05288, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008510.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TALK FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 88.106. 

<i>Constatation de cession de parts sociales 

Suite à une cession de parts sous seing privé du 20 décembre 2004, acceptée par le gérant au nom de la société, il

résulte que le capital social de la société TALK FINANCE, S.à r.l. se répartit désormais comme suit: 

Fait à Steinfort, le 20 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008514.3/4185/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LUX-SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 80, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 77.958. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03450, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008520.3/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

- Monsieur Martial Mernier

demeurant au 87, rue du Serpont à B-6800 Libramont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65 parts

- Monsieur Mario Chiarello

demeurant au 129, La Chavée à B-6717 Thiaumont   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts

- Monsieur Stéphane Didier

demeurant au 66, rue des Quatre Vents à B-6700 Arlon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts

Lu et approuvé
Signatures
Pour acceptation au nom de la société 
Signature
<i>Gérant

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES

21576

C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1159 Luxembourg, 1, rue d’Avalon.

R. C. Luxembourg B 58.221. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 décembre 2004

Les actionnaires constatent que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a pris fin. Ils décident

à l’unanimité de nommer aux fonctions d’administrateur:

- Monsieur Christophe Louis, producteur de films, né le 20 août 1963 a Liège (B), demeurant 1, rue d’Avalon à L-1159

Luxembourg 

- Madame Vinciane Louis, indépendante, née le 27 mars 1965 à Liège (B), demeurant 4A, rue Saint Roch à B-1330

Rixensart.

- La société relevant du droit du Delaware LION PRODUCTIONS INC. avec siège 15, Loockerman Street, 19904

Dover (USA), représentée par son Président Monsieur Christophe Louis. 

Monsieur Christophe Louis est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signa-

ture.

Monsieur Eric Delfosse, gérant de société, né le 23 avril 1959 à Uccle (B), demeurant 132, rue du Ham à B-1180

Bruxelles est nommé commissaire aux comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02378. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008516.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

STAR 2000 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.247. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03451, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008517.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

WEST GROVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.698. 

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 31 décembre 2004

En vertu de l’acte de transfert de parts, daté du 31 décembre 2004, Madame Halina Ruta, résidant au 7, avenue des

Papalins, MC 98 000 Monaco, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante: 

- 2.964 parts sociales d’une valeur de 25 EUR chacune, à la fondation EVO FOUNDATION, avec siège social à 79,

Kirchstrasse, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Ainsi, les parts de la société WEST GROVE, S.à r.l. sont réparties comme suit:
- EVO FOUNDATION: 2.964 parts 
- Monsieur Malgorzata Zak: 16.796 parts

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008751.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

21577

JC DECAUX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 23.212. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03448, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008523.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LUX-EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 20.740. 

<i>Décisions collectives des associés en date du 14 décembre 2004

Les associés composant l’intégralité du capital social de la société LUX-EQUIPEMENTS, S.à r.l., avec siège social à

Esch-sur-Alzette, se sont réunis au siège social afin de délibérer sur les points ci-après et ont pris à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:

1) La démission de Monsieur Edouard Jund de son poste de gérant technique est acceptée avec effet immédiat.
Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour. 
2) Il résulte de deux cessions de parts sous seing privé que: 
- Monsieur Edouard Jund a cédé ses treize (13) parts à la société anonyme G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL

LUXEMBOURGEOIS S.A.

- La société anonyme G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A. a cédé une (1) part à Monsieur

Serge Soive, demeurant à F-57140 La Maxe.

Suite à ces cessions de parts, le capital de la société est réparti comme suit: 

Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008524.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PREFALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.

R. C. Luxembourg B 12.558. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05451, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008710.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ADVITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 23, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

Il résulte d’une lettre recommandée adressée à la société par Monsieur Vincent Desmadrille, en date du 10 janvier

2005, que ce dernier démissionne avec effet immédiat de son poste d’administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008531.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

- Monsieur Serge Soive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part sociale

- G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

174 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

175 parts sociales

<i>Pour <i>G.I.L. S.A.
F. Soive
E. Jund / S. Soive

Le 25 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

V. Desmadrille.

21578

5 A SEC - LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 10.842. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03446, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008527.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

INVESTISSEURS REUNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.295. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 8

juillet 1987, acte publié au Mémorial C no 327 du 16 novembre 1987. Le capital social a été converti en euros par
acte sous seing privé le 13 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C no 793 du 24 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05761, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008541.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ALSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.900. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre 1987, acte publié

au Mémorial C, n

o

 29 du 2 février 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 janvier 1988, acte publié

au Mémorial C, no 99 du 14 avril 1988, en date du 10 mars 1989, acte publié au Mémorial C, no 205 du 26 juillet
1989, en date du 19 mars 1992, acte publié au Mémorial C, no 370 du 29 août 1992, modifiée par acte sous seing
privé le 4 décembre 2000, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C, no 589 du 31 juillet 2001. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04921, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008542.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

S.S.I. PARTNER AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 56.724. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 15 octobre 1996, acte publié

au Mémorial C n

o

 6 du 8 janvier 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juin 1998, acte publié

au Mémorial C n

o

 661 du 17 septembre 1998, en date de 6 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 989 du 23

décembre 1999 et en date du 20 octobre 2000, acte publié au Mémorial C 398 du 31 mai 2001. Les statuts ont été
modifiés par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 décembre 2001, acte publié

au Mémorial C 737 du 15 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04917, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008544.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour INVESTISSEURS REUNIS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour ALSINVEST S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

<i>Pour S.S.I. PARTNER AG
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

21579

RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.771. 

Constituée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 14 novembre 2001, acte publié 

au Mémorial C n

o

 462 du 22 mars 2002. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06035, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008547.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.771. 

Constituée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 14 novembre 2001, acte publié 

au Mémorial C n

o

 461 du 22 mars 2002. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06037, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008549.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

EVERLUX MARITIMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 34.859. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 août 1990, acte publié au

Mémorial C n

o

 81 du 21 février 1991. Le capital a été converti en euros en date du 15 octobre 2001, acte publié

au Mémorial C n

o

 390 du 11 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04922, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008555.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BELGO TRADE, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 77.550. 

<i>Extrait d’une des résolutions écrites prises par le Conseil d’Administration

ad 1) Monsieur Vincent Maréchal avec adresse professionnelle au 18-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

est nommé directeur de la société en remplacement de Monsieur Roland Schroeder, directeur démissionnaire.

La signature du directeur, conjointement avec celle d’un administrateur ou d’un fondé de pouvoir engagera valable-

ment la société pour toutes les affaires.

Cette résolution a été prise avec effet au 4 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05955. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008721.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

<i>Pour RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour EVERLUX MARITIMA S.A. 
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

Pour extrait conforme
L. David
<i>Président

21580

COFFEE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.459. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date 

du 19 février 2002, acte publié au Mémorial C n

o

 913 du 14 juin 2002. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04925, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008559.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

KOREMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.842. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 6

décembre 1991, acte publié au Mémorial C n

o

 210 du 19 mai 1992. Le capital a été converti en euro par acte sous

seing privé le 21 décembre 2001, dont un avis a été publié au Mémorial C n

o

 749 du 19 mai 2002. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04919, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008561.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

IMMO VANSTAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.658. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05833, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008546.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

DEALING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg-Gasperich, 204, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.327. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05828, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008550.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BIG WAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.644. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02407, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008565.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

<i>Pour COFFEE INVESTMENTS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour KOREMAR S.A. 
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Pétange le, 26 janvier 2005.

Signature.

Pétange le, 26 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

21581

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.663. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02423, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008566.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ACTUEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.197. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02422, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008571.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FREE STYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.664. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02420, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008574.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ET EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.909. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA-02419, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008575.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PRINT PRODUCTS AND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.017. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02418, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008576.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MAXFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.083. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02414, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008577.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

21582

IMPRIMERIE ALBERT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 13, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 61.077. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03945, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(008594.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TOITURE DE L’EST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Wormeldange, 48, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 54.874. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03946, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wormeldange, le 16 décembre 2004.

(008596.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ANYWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 28, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 90.057. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03950, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

(008598.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LANGUES SUR MESURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 94.127. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03952, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

(008600.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LQMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 47.048. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03954, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 20 janvier 2005.

(008602.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

21583

LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3487 Dudelange, 39, route de Hellange.

R. C. Luxembourg B 53.455. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03961, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 19 janvier 2005.

(008605.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

IMPRIMERIE SCHOMER-TURPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5561 Remich, 29, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 63.350. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03956, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

(008615.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

DALEIDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 63, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 62.072. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03958, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(008618.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

R + F MENUISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl, 70, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 35.943. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03963, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(008621.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SERVIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.921. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02413, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008579.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

21584

SANITAIRES &amp; CHAUFFAGE LEONARD SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Cessange, 12, rue Luc Housse.

R. C. Luxembourg B 45.403. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03965, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

(008626.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BATISTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 97.043. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires du 5 janvier 2005 tenue à Luxembourg 

Il résulte dudit procès-verbal que l’intégralité des parts de la société a été cédée à Monsieur Stig Lindégren, demeurant

à Grönviksvägen 52, S-167 71 Bromma. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008627.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ROMAIN SCHMIDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Elvange, 3, rue de Wintrange.

R. C. Luxembourg B 51.711. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03966, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Elvange, le 17 novembre 2004.

(008630.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TEPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.263. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02412, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008585.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PEINTURE BAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7565 Mersch, 26, rue Servais.

R. C. Luxembourg B 84.403. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03967, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 5 août 2004.

(008632.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature
<i>Le Gérant

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Signature
<i>Le gérant

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

Signature
<i>Le gérant

21585

LABORATOIRE DENTAIRE POHL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Howald, 117, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 29.124. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 octobre 1988,

acte publié au Mémorial C n

o

 8 du 11 janvier 1989, modifié par-devant M

e

 Paul Decker, notaire de résidence à

Luxembourg-Eich en date du 8 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n

o

 140 du 4 mars 1999, modifié par-

devant le même notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 18 mai 2000, acte publié au Mémorial C n

o

726 du 5 octobre 2000, capital converti en euro suivant avis publié au Mémorial C n

o

 768 du 21 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05774, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008880.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BEECKESTEYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.624. 

Constituée par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, acte 

publié au Mémorial C n

o

 438 du 20 juin 2001.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04900, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008883.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BEECKESTEYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.624. 

Constituée par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, acte 

publié au Mémorial C n

o

 438 du 20 juin 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04904, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008884.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BEECKESTEYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.624. 

Constituée par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, acte 

publié au Mémorial C n

o

 438 du 20 juin 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04914, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008891.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

<i>Pour <i>LABORATOIRE DENTAIRE POHL, S.à r.l. 
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour BEECKESTEYN HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

<i>Pour <i>BEECKESTEYN HOLDING S.A. 
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

<i>Pour BEECKESTEYN HOLDING S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

21586

Z.I.K. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.391. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 5

juillet 1991, acte publié au Mémorial C n

o

 4 du 6 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 6

août 1992, acte publié au Mémorial C n

o

 570 du 4 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date

du 28 mai 1996, acte publié au Mémorial C n

o

 475 du 24 septembre 1996. Le capital a été converti en euros en

date du 21 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n

o

 816 du 29 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06032, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008893.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SP LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 229.363.050,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.152. 

EXTRAIT

L’intégralité des parts sociales de la société, consistant en 1.002.680 parts sociales détenues par TRITON

MANAGERS LIMITED ET BGLD MANAGERS LIMITED, ont été cédées en date du 12 janvier 2005 aux sociétés suivan-
tes:

1. TRITON FUND (No. 1) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (53.113 parts sociales);

2. TRITON FUND (No. 2) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (52.563 parts sociales);

3. TRITON FUND (No. 3) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (52.651 parts sociales);

4. TRITON FUND (No. 4) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (52.651 parts sociales);

5. TRITON FUND (No. 5) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (52.917 parts sociales);

6. TRITON FUND (No. 6) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (52.775 parts sociales);

7. TRITON FUND (No. 7) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (54.442 parts sociales);

8. TRITON FUND (No. 8) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (52.563 parts sociales);

9. TRITON FUND (No. 9) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company go-

verned by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (52.864 parts sociales);

10. TRITON FUND (No. 10) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company

governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (55.041 parts sociales);

11. TRITON FUND (No. 11) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company

governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (23.481 parts sociales);

12. TRITON FUND (Executive) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company

governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands, JE4 8 PX (14.981 parts sociales);

13. FUND 1A, represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws

of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX
(124.723 parts sociales);

<i>Pour <i>Z.I.K. LUXEMBOURG, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST ENGINEERING S.A. 
Signature

21587

14. BREDERODE INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Luxem-

bourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 99.271, having its regis-
tered address located at L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II (7.827 parts sociales);

15. BGLD CO-INVEST L.P., represented by its General Partner, BGLD MANAGERS LIMITED, a company incorpo-

rated in accordance with and governed by the laws of Jersey, with registered office at 22 Grenville Street, St Helier,
Jersey, JE 4 8PX, Channel Islands (300.088 parts sociales).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05372. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008885.3/267/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Z.I.K. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.391. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 5

juillet 1991, acte publié au Mémorial C n

o

 4 du 6 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 6

août 1992, acte publié au Mémorial C n

o

 570 du 4 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date

du 28 mai 1996, acte publié au Mémorial C n

o

 475 du 24 septembre 1996. Le capital a été converti en euros en

date du 21 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n

o

 816 du 29 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06033, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008896.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

EURO-ASSECURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.976. 

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 1992, acte publié 

au Mémorial C n

o

 391 du 10 septembre 1992

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06046, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008901.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

EURO-ASSECURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.976. 

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 1992, acte publié 

au Mémorial C n

o

 391 du 10 septembre 1992.

Le bilan au 31 décembre2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06048, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008904.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

<i>Pour SP LUXCO, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>Z.I.K. LUXEMBOURG, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour <i>EURO-ASSECURA S.A. 
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

<i>Pour <i>EURO-ASSECURA S.A. 
MeesPierson INTERNATIONAL FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

21588

FITRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 45.552. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre 1993, acte publié 

au Mémorial C n

o

 4 du 5 janvier 1994.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04871, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008906.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BULL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 91.846. 

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration du 27 avril 2004

Le 16 avril 2004, le Conseil a été informé de la démission de Monsieur Philippe Meloni de ses fonctions d’Adminis-

trateur avec effet au 16 avril 2004.

Le 16 avril 2004, le Conseil a été informé de la démission de Madame Simona Bortolazzi de ses fonctions d’Adminis-

trateur avec effet au 16 avril 2004.

Le Conseil a décidé de coopter Messieurs Pietro Tasca et Jean-Louis Catrysse en remplacement de Monsieur Meloni

et Madame Bortolazzi.

Après avoir considéré ce qui précède, le Conseil décide à l’unanimité:
A. Après avoir noté que Monsieur Pietro Tasca, Directeur, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a déjà été

approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

De coopter Monsieur Pietro Tasca, Directeur, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouvel Admi-

nistrateur de la SICAV en remplacement de Monsieur Philippe Meloni, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires, laquelle procédera à l’élection définitive.

B. Après avoir noté que Monsieur Jean Louis Catrysse Directeur Adjoint, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG

S.A. a déjà été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

De coopter Monsieur Jean Louis Catrysse, Directeur Adjoint, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.comme

nouvel Administrateur de la SICAV en remplacement de Madame Simona Bortolazzi, jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale des Actionnaires, laquelle procédera à l’élection définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signée le 27 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008934.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

PT HOLDING S.A., PACKAGING TECHNOLOGY HOLDING,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 59.671. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06087, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008726.3/813/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

<i>Pour <i>FITRA HOLDING S.A. 
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur-Délégué

21589

BULL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 91.846. 

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration du 25 novembre 2004

Attendu que le Conseil a été informé le 23 septembre 2004 de la démission de Monsieur Jean Louis Catrysse de ses

fonctions d’Administrateur avec effet immédiat.

Attendu que le Conseil a été informé le 7 octobre 2004 de la démission de Monsieur Pietro Tasca de ses fonctions

d’Administrateur avec effet immédiat.

Attendu que le Conseil a décidé de coopter Madame Alessandra Degiugno, Responsable de Service, IBL

INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. et Monsieur Fabrizio Montanari, Responsable de Service, IBL INVESTMENT
BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouveaux Administrateurs de la Sicav.

Après avoir considéré ce qui précède, le Conseil décide à l’unanimité:
A. Après avoir noté que Madame Alessandra Degiugno, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a déjà été

approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

De coopter Madame Alessandra Degiugno, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouvel Adminis-

trateur de la SICAV en remplacement de Monsieur Jean-Louis Catrysse, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires, laquelle procédera à l’élection définitive.

B. Après avoir noté que Monsieur Fabrizio Montanari, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a déjà été ap-

prouvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

De coopter Monsieur Fabrizio Montanari, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouvel Adminis-

trateur de la Sicav en remplacement de Monsieur Pietro Tasca, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnai-
res, laquelle procédera à l’élection définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signée le 25 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008938.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

DD TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.624. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07915, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008588.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SEMI AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 22.915. 

AUFLÖSUNG

<i>Auszug

Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 20. Dezember

2004, einregistriert in Luxemburg A.C., am 22. Dezember 2004, Band 146S, Blatt 24, Fach 10, wurde die Aktiengesell-
schaft SEMI AG, mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt, aufgelöst.

Die Liquidation ist erfolgt und die Dokumente und Schriftstücke der Gesellschaft werden während fünf Jahren am

ehemaligen Gesellschaftssitz aufbewahrt.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 20. Januar 2005.

(009081.3/227/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

S. Delonnoy.

E. Schlesser
<i>Notar

21590

GLECOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.064. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-dé-

légué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06174. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008973.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

PORTENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 96.085. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-Dé-

légué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008975.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CROYDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 63.481. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06036, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

(008641.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l. 
Signature

21591

PETRUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 94.257. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-dé-

légué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06170. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008976.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.614. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-dé-

légué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008977.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

DARTHMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 59.032. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06038, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(008642.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

21592

LOGICRANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 102.916. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06166. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008978.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

M.C.F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.202. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05740, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008611.4/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

OCTOPLAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.335. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06145 a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008617.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PIERRE FINANZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 23.546. 

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05754, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(008728.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Signature.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur-Délégué

21593

JORDBRU INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 100.842. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth

Donkersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec
adresse professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions
pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06165. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008979.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

KLINKER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 89.317. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth

Donkersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec
adresse professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions
pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008981.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

OMBRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.301. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06157, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008622.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Signature.

21594

CED AUTOMOTIVE, Société à responsabilité limitée.

(Succursale de CED BELGIË B.V., société néerlandaise)

Adresse: L-8211 Mamer, 2, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 105.652. 

<i>Ouverture de succursale

Suite à la réunion spéciale de la Direction de CED BELGIË B.V. du 8 décembre 2004, il résulte qu’une succursale sera

ouverte à Luxembourg:

- Nom: CED AUTOMOTIVE
- Adresse: 2, rue des Champs, L-8211 Mamer
- Activités: Estimation et règlement des dommages de biens mobiliers
- Représentant légal: Monsieur Gérard, né le 27 mai 1970 à Libramont, Belgique et résidant au 9A, rue Fosse Mory à

B-6800 Saint-Pierre, Belgique.

Il pourra opérer comme représentant légal de CED AUTOMOTIVE et conclure des accords, qui sont en relation

avec la direction de l’entreprises CED AUTOMOTIVE; signer les contrats et les documents financiers aussi bien auto-
nomes que collectifs.

- Personnes pouvant engager la société:
* Monsieur Johannes Jacobus Waaijer, né le 1

er

 mars 1946 à Amsterdam, Pays-Bas et résidant au 33, rue Stade de

Colombes à NL– 1098 VS Amsterdam, Pays-Bas.

* Monsieur Wilhelmus Cornelis Johannes Van der Helm, né le 14 juin 1951 à Alphen aan den Rijn, Pays-Bas et résidant

au 159, Jeltje de Bosch Kemperstraat à NL-2401 KD Alphen aan den Rijn, Pays-Bas.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008993.3/1026/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

EUROPECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 95.350. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier, réf. LSO-BA06039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

(008643.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

EUROSIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 95.351. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06040, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

(008644.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MOTOR-CENTER MERSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7525 Mersch, 63, rue de Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 47.591. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04303, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008645.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Fait à Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

21595

EURO IMMO INVEST &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.694. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire rectificative

<i> tenue extraordinairement le 5 janvier 2005

<i>Première résolution

L’Assemblée nomme Monsieur Christophe Davezac au poste d’administrateur de la société pour une durée de six

ans avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Gilmont de son poste d’administrateur de la société avec effet

immédiat et décharge à lui donner jusqu’à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement du mandat de Monsieur Benoît Georis à ses fonctions d’administrateur de la

société pour une durée de six ans avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement du mandat de Monsieur Fabio Mazzoni à ses fonctions d’administrateur-

délégué de la société pour une durée de six ans avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucun actionnaire n’ayant demandé la parole, le Président lève la séance à 12

heures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009082.3/587/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

QUALITY PUBLISHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 79.410. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04305, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008646.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

GLOBAL GATEWAY, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 103.254. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2004 

Le Conseil d’Administration constate la libération supplémentaire de toutes les actions de la société GLOBAL GA-

TEWAY S.A. à concurrence de 100% du capital souscrit. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008780.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

21596

EIFAN FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.972. 

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale des actionnaires du 25 novembre 2004

La séance est ouverte à 15.00 heures.
L’Assemblée procède à l’installation de son bureau.
Sont nommés:
Président: Monsieur Anthony J. Nightingale
Secrétaire: Monsieur Christian Genard
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
qu’il apparaît de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que tous les actionnaires

sont présents ou représentés, détenant 7.000 actions.

que les actionnaires étant connus, reconnaissant avoir été dûment convoqués, ont renoncés, pour autant que besoin,

à toute publication.

que pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires.
que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le point figurant à

l’ordre du jour destiné à publication.

<i>Ordre du jour:

- Nomination d’un Commissaire aux Comptes.
Après avoir délibéré l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
- Madame Giovanna Craighero, 16, rue Hamen, L-5219 Sandweiler est nomm´é Commissaire aux Comptes en rem-

placement de EIFAN.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07354. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009112.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

TERRA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.118. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société TERRA CAPITAL S.A. qui s’est tenue en

date du 25 janvier 2005 que:

1) Monsieur Richard Wright a été nommé administrateur de la société jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se

tiendra en 2011 en remplacement de Mademoiselle Amélie Jurin démissionnaire avec effet immédiat.

2) Les mandats des administrateurs Monsieur Graham J. Wilson et Cindy Reiners sont reconduits jusqu’à l’issue de

l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

3) Le mandat du Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE EUROLUX est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009113.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

TALONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 92.190. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04176, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008647.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

A. J. Nightingale / C. Genard
<i>Président / <i>Secrétaire

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

21597

SOUTHERN CROSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 96.193. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04170, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008648.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

CHARDONNAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 64.561. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04162, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008649.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BUSINESS DEVELOPMENT PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 88.179. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04268, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008651.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

L &amp; P, LANGE AND PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 89.344. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04225, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008653.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TRANSNATIONAL SBA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.806. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04217, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008654.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

21598

ABROAD CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.617. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04184, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008658.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MAHEVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 78, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 79.805. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04264, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008663.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichelange.

R. C. Luxembourg B 98.907. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04267, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008672.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

EURESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 95.764. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04232, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008674.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

THE FIGLEAF COSTUME HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichlange.

R. C. Diekirch B 97.002. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04181, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008675.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

21599

ERNSTER BELLE ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 29.015. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06485, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(008684.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ERNSTER CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 71.099. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06484, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(008686.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ERNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 29.547. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06483, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(008688.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHIPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.702. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 15 décembre 2004 au siège social de la société que:

1. Madame Dominique Kohl, a été élue comme nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur

Graham J. Wilson démissionnaire avec effet au 15 décembre 2004 jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra
en 2010.

2. BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire

est nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. avec effet au 15
décembre 2004 jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008690.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

21600

ATARAXIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 78.348. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06481, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008689.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 112-114, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 24.402. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05822, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008635.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1466 Dommeldange, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 69.893. 

Acte constitutif publié aux pages 27539-27543 du Mémorial C n

o

 574 du 26 juillet 1999.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05825, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008664.3/1026/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 9.634. 

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05817, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008668.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

M. Gouverneur.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Automotive Engineering Holding S.A.

MHC Distribution S.A.

Mimab S.A.

Phileos, S.à r.l.

Tambol Investment S.A.

Leggett &amp; Platt Canada Co, Luxembourg Branch

Leggett &amp; Platt Canada Co, Luxembourg Branch

Bendick Holding S.A.

Lawsun Group, S.à r.l.

Kalimera S.A.

Brasserie Georges VI, S.à r.l.

Unicum S.A.

Aliena, S.à r.l.

Bijouterie Wacht, S.à r.l.

Design Concept S.A.

Domeric S.A.

Global Net S.A.

Global Sat S.A.

Global Value S.A.

Salon de Coiffure Groben, S.à r.l.

Scodex S.A.

Quickstep S.A.

Chrono Interim, S.à r.l.

Restaurant Mathes, S.à r.l.

Lifrapos, S.à r.l.

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l.

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l.

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l.

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l.

Schnell-Fein Building Service, S.à r.l.

Cimolux, S.à r.l.

JoMü Fenster, S.à r.l.

Talk Finance, S.à r.l.

Lux-Soeurs, S.à r.l.

C.M.C., Communication Medias Courtage S.A.

Star 2000 Holding S.A.

West Grove, S.à r.l.

JC Decaux Luxembourg S.A.

Lux-Equipements, S.à r.l.

Prefalux S.A.

Advitek S.A.

5 à Sec - Luxembourg S.A.

Investisseurs Réunis S.A.

Alsinvest S.A.

S.S.I. Partner AG

Richardson European Investments, S.à r.l.

Richardson European Investments, S.à r.l.

Everlux Maritima S.A.

Belgo Trade

Coffee Investments S.A.

Koremar S.A.

Immo Vanstar Luxembourg S.A.

Dealing S.A.

Big Wave S.A.

P.L.A. S.A.

Actuel Invest S.A.

Free Style S.A.

Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A.

Print Products and Services S.A.

Maxfin S.A.

Imprimerie Albert Lux, S.à r.l.

Toiture de l’Est, S.à r.l.

Anyway, S.à r.l.

Langues sur mesure, S.à r.l.

LQMS, S.à r.l.

Les Charpentiers d’Aujourd’hui, S.à r.l.

Imprimerie Schomer-Turpel, S.à r.l.

Daleiden, S.à r.l.

R + F Menuiserie, S.à r.l.

Servidis S.A.

Sanitaires &amp; Chauffage Léonard Soeurs, S.à r.l.

Batiste, S.à r.l.

Romain Schmidt, S.à r.l.

Tépi S.A.

Peinture Bauer, S.à r.l.

Laboratoire Dentaire Pohl, S.à r.l.

Beeckesteyn Holding S.A.

Beeckesteyn Holding S.A.

Beeckesteyn Holding S.A.

Z.I.K. Luxembourg, S.à r.l.

SP Luxco, S.à r.l.

Z.I.K. Luxembourg, S.à r.l.

Euro-Assecura S.A.

Euro-Assecura S.A.

Fitra Holding S.A.

Bull Fund

PT Holding S.A., Packaging Technology Holding

Bull Fund

DD Trust Holding S.A.

Semi AG

Glecos Holding S.A.

Portena Holding S.A.

Croydon S.A.

Petrus Holding S.A.

Mika Holding S.A.

Darthman S.A.

Logicrane Holding S.A.

M.C.F., S.à r.l.

Octoplas Invest S.A.

Pierre Finanz Luxembourg S.A.

Jordbru Investment Holding S.A.

Klinker Invest Holding S.A.

Ombra Investments S.A.

CED Automotive

Europeck S.A.

Eurosieur S.A.

Motor-Center Mersch S.A.

Euro Immo Invest &amp; Conseil S.A.

Quality Publishing International S.A.

Global Gateway

EIFAN Financial Consulting S.A.

Terra Capital S.A.

Talons Luxembourg S.A.

Southern Cross S.A.

Chardonnay S.A.

Business Development Partners, S.à r.l.

L &amp; P, Lange and Partner, S.à r.l.

Transnational SBA Services, S.à r.l.

Abroad Consulting S.A.

Mahevia S.A.

Nutrition Animale Luxembourg, S.à r.l.

Eurese, S.à r.l.

The Figleaf Costume House, S.à r.l.

Ernster Belle Etoile, S.à r.l.

Ernster Concorde, S.à r.l.

Ernster, S.à r.l.

Schipol S.A.

Ataraxia S.A.

Allied Arthur Pierre

Perot Systems Luxembourg, S.à r.l.

Entreprise Poeckes, S.à r.l.