logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

18145

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 379

26 avril 2005

S O M M A I R E

FARMIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 44.359. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02793, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(005219.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Albi Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

18177

HVB  Alternative  Program  Index,  Sicav,  Luxem-

Alexandre Loc., S.à r.l., Lamadelaine. . . . . . . . . . . .

18146

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18188

Almeezan Luxembourg, S.à r.l., Senningerberg . . .

18149

Key Plastics Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

18150

Amell International Lux. S.A., Luxembourg . . . . . .

18187

Leruth Réalisations S.A., Bettembourg . . . . . . . . . 

18148

Amikaba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18190

Libelle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18178

Baixas Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

18188

Maat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18186

Ballard Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

18188

Mille-Services   Luxembourg,   S.à r.l.,   Esch-sur-

Beech International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

18191

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18146

Bergon S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

18155

Moog Hydrolux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

18149

Bergon S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

18156

(The) Navigation Company S.A., Luxembourg . . . 

18190

Blumenthal, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18153

Rain Man S.A., Alzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18153

CGD Luxemburgo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

18179

Scania Luxembourg S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . 

18147

Cornel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18154

Société   Financière   Industrielle   S.A.,   Luxem-

Corsica Paradise S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . .

18147

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18157

CSN Export, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . .

18179

St. George’s School, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

18154

Expandos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18150

Telematica Bedrijven S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

18189

Farmipart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18145

Telluris S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18178

Fashion One Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . .

18157

(Les) Thermes du Beauregard S.A., Luxembourg  

18148

Fashion One Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . .

18177

Trio Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18189

Frust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

18187

Verdiam Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

18191

Gadd   Capital   Management   Ltd   (Luxembourg 

Vincal Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

18192

Branch), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

18156

Wawelux Logistics S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . 

18146

Geodesia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18187

Wemaes Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

18192

Gustav 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

18190

<i>Pour FARMIPART S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

18146

ALEXANDRE LOC., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.103. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09084, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

MILLE-SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 5, rue Lankels.

R. C. Luxembourg B 33.014. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé du 6 janvier 2005 

A comparu: 

Monsieur Pasquale Strillacci, monteur-électricien, demeurant à Esch-sur-Alzette. 
Lequel comparant a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée MILLE-SERVICES LUXEM-

BOURG S.à r.l. avec siège social à L-4205 Esch-sur-Alzette, 5, rue Lankels, constituée suivant acte reçu par Maître Chris-
tine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 6 février 1990, publié au Mémorial C, numéro 299 du 28
août 1990, 

modifié suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Capellen, en date du 21 novembre 2001,

publié au Mémorial C, numéro 538 du 6 avril 2002, 

<i>Première résolution 

L’associé décide d’accepter à compter de ce jour la démission de Monsieur Bruno Sardou, électricien, demeurant à

F-57100 Thionville, 24, boucle des Frères Lumières de sa fonction de gérant technique de la prédite société, et lui ac-
corde décharge pour l’accomplissement de son mandat. 

<i>Deuxième résolution 

L’associé décide de nommer à compter de jour comme gérant unique de la prédite société pour une durée indéter-

minée: Monsieur Pasquale Strillacci, prédit. 

<i>Troisième résolution 

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l’engager valablement par sa seule signature. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01905. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004598.3/203/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

WAWELUX LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.533. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 2004 

En date du 13 décembre 2004, les actionnaires de la Société Anonyme WAWELUX LOGISTICS S.A., se sont réunis

en Assemblée Générale Ordinaire au siège social et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1. L’Assemblée des actionnaires, constatant que les mandats des administrateurs et des administrateurs-délégués sont

arrivés à échéance, décident à l’unanimité de renouveler leurs mandats pour une durée d’une année, c’est-à-dire jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2005. Ainsi, le conseil d’administration de la société est composé
des membres suivants: 

- Monsieur Armand Distave, Conseiller économique et fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg,

4, rue Henri Schnadt. 

- Monsieur Frantz Wallenborn, Entrepreneur de transports, demeurant à L-8606 Bettborn, 31, rue Principale. 
- Monsieur Camille Weis, Entrepreneur de transports, demeurant à L-8398 Roodt/Eisch, 18, lotissement des Roses. 
Les nouveaux administrateurs déclarent accepter leur mandat. 
2. Les administrateurs-délégués, à savoir: 
- Monsieur Frantz Wallenborn, Entrepreneur de transports, demeurant à L-8606 Bettborn, 31, rue Principale. 
- Monsieur Camille Weis, Entrepreneur de transports, demeurant à L-8398 Roodt/Eisch, 18, lotissement des Roses, 
acceptent leurs nouveaux mandats. 
3. Monsieur Armand Distave, Conseiller économique et fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg,

4, rue Henri Schnadt, est reconduit à son poste de Président du conseil d’administration pour une année. 

Lamadelaine, le 18 janvier 2005.

Signature.

18147

4. De même, l’Assemblée des actionnaires, constatant que le mandat du commissaire aux comptes est arrivé à

échéance, décide à l’unanimité de nommer commissaire aux comptes pour une durée d’une année, c’est-à-dire jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2005: 

LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 25.797. 
Le nouveau commissaire aux comptes déclare accepter son mandat. 

Munsbach, le 13 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04493. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004599.3/503/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

CORSICA PARADISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 92.785. 

EXTRAIT 

Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 29 avril 2004 que les personnes suivantes ont démis-

sionné de leurs fonctions d’administrateurs de la Société, comme suit: 

Administrateur de catégorie A: 
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz, Grand-Duché de

Luxembourg, et demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand Duché de Luxembourg. 

Administrateur de catégorie B:
- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié et maître en sciences économiques, né le 7 septembre 1951 à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, et demeurant au 4, rue J.-B. Schartz, L-7342 Heisdorf, Grand-Duché de Luxembourg.

Décharge a été donnée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat au jour de leur démission. 
Il résulte également de ladite assemblée que les personnes suivantes ont été nommées aux fonctions d’administra-

teurs de la Société, comme suit: 

Administrateur de catégorie A:
- Monsieur Ohad Shapira, C.F.O., né le 6 janvier 1955 à Jérusalem, Israël, et demeurant au 24, Kanfei, Nesrahim, Jé-

rusalem, Israël.

Administrateur de catégorie B:
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz, Grand-Duché de

Luxembourg, et demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 13 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03189. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004608.3/556/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

SCANIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, zone d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.044. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale du 1

<i>er

<i> juin 2004 

Les actionnaires de la société anonyme, SCANIA LUXMBOURG S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au

siège social, en date du 1

er

 juin 2004, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes: 

Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué arrivant à échéance, ils sont reconduits pour une pé-

riode d’une année, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2005. 

Sont donc reconduit au poste d’administrateurs: 
- Monsieur Peter Janssens, administrateur de société, demeurant à B-1315 Incourt (Belgique), 24, rue Baron Bouvier. 
- Monsieur André De Valck, administrateur de société, demeurant à B-3078 Everberg (Belgique), 51, Vinkenlaan. 
- Monsieur Jacques Mouligneau, administrateur de société, demeurant à B-3018 Wijgmaal (Belgique), 44, Hambos-

straat. 

- Monsieur Peter Martens, administrateur de société, demeurant à B-3010 Leuven, 14/3, Holsbeeksesteenweg. 
- Monsieur Jean-Marc Pirotte, administrateur de société, demeurant à L-6930 Mensdorf, 18, rue de Uebersyren. 
Les administrateurs nouvellement nommés déclarent accepter leur mandat. 
Est reconduit au poste d’administrateur-délégué: 

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES 
Signature

18148

- Monsieur Peter Janssens, administrateur de société, demeurant à B-1315 Incourt (Belgique), 24, rue Baron Bouvier. 
L’administrateur-délégué nouvellement nommé déclare accepter son mandat. 
De même, le mandat du commissaire-réviseur étant arrivé à échéance, il est reconduit pour une période d’une année,

c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2005. 

Est donc reconduit au poste de commissaire-réviseur de la société: 
- La société ERNST &amp; YOUNG S.A. avec siège à L-5365 Munsbach, 7, parc d’Activité Syrdall, R.C.S. Luxembourg B

47.771. 

Le commissaire-réviseur de la société nouvellement nommé déclare accepter son mandat. 

Munsbach, le 1

er

 juin 2004.

(004612.3/503/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

LES THERMES DU BEAUREGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 38.891. 

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 novembre 2004 

Les actionnaires de la société LES THERMES DU BEAUREGARD S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire,

au siège social, le 11 novembre 2004, ont décidé, à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes: 

- Acceptation de la démission de Monsieur Norry Rippinger, directeur de société, demeurant à L-3360 Leudelange,

80, route de Luxembourg, de son mandat d’Administrateur-délégué de la société. 

- Pleine et entière décharge est donnée à Monsieur Norry Rippinger pour l’exercice de son mandat d’Administrateur-

délégué. Monsieur Norry Rippinger conserve son poste d’administrateur. 

- Nomination de Monsieur Emile Rippinger, industriel, demeurant à L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg

comme Administrateur-délégué jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2006, en remplacement de
l’Administrateur-délégué démissionnaire, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature. 

- Le nouvel administrateur déclare accepter son mandat 
En conséquence, les actionnaires rappellent la composition du conseil d’administration en place jusqu’à l’Assemblée

Générale Annuelle de 2006: 

- Monsieur Emile Rippinger, industriel, demeurant à L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg (Président du Con-

seil d’Administration et Administrateur-délégué). 

- Monsieur Norry Rippinger, directeur de société, demeurant à L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg. 
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4,

rue Henri Schnadt. 

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004617.3/503/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

LERUTH REALISATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3261 Bettembourg, 9B, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 80.023. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 5 novembre 2004 

L’an deux mille quatre, le cinq novembre à dix heures. 
Les actionnaires de la Société LERUTH REALISATIONS S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire an-

nuelle, au siège de la société, sur convocation faite par le Conseil d’Administration, et ont pris, à l’unanimité, les réso-
lutions suivantes: 

1. Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes étant arrivés à

échéance, les actionnaires décident, à l’unanimité, de les renouveler pour une période de six ans à compter de ce jour.

Sont ainsi nommés au conseil d’administration:
- Monsieur Gérard Leruth, employé privé, demeurant à L-3490 Dudelange, 59, rue Jean-Jaurès (également adminis-

trateur-délégué); 

- Madame Marianne Koenig, agent immobilier, demeurant à L-3261 Bettembourg, 11, rue du Nord; 
- Monsieur Pierre Leruth, retraité, demeurant à L-3261 Bettembourg, 11, rue du Nord. 
Les nouveaux administrateurs ainsi que l’administrateur-délégué, ainsi nommés, déclarent accepter leur mandat qui

prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010. 

2. De même est nommé commissaire aux comptes: 
- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. 

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

18149

Le nouveau commissaire aux comptes ainsi nommé, déclare accepter son nouveau mandat qui prendra fin à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010. 

Bettembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07724. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004623.3/503/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

MOOG HYDROLUX, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.831.200,-.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 1, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 19.826. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés du 12 décembre 2004 

L’Assemblée Générale des Associés tenue le 12 décembre 2004 a décidé de renouveler le mandat des gérants sui-

vants: 

- Monsieur Gary Parks, né le 17 juillet 1955 à New York (USA), Director-International Financial Controller, MOOG

INTERNATIONAL, demeurant à Ashchurch, Tewkessbury, Glos, GL20 8NA, Royaume-Uni. 

- Monsieur Harald Seiffer, né le 7 mai 1959 à Sindelfingen (Allemagne), Managing Director, MOOG HOLDING

GmbH, demeurant à William Moog Street 28, Böblingen, Allemagne. 

- Monsieur Nigel Cottell, né le 23 février 1954 à Swindon (Royaume-Uni), General Manager MOOG HYDROLUX,

demeurant à Green Farm, Badgeworth Lane, Badgeworth, Cheltenham,Glos, GL51 4UJ, Royaume-Uni. 

Il a été également décidé de renouveler le mandat du réviseur d’entreprises ERNST &amp; YOUNG, 6, rue Jean Monnet

L-2010 Luxembourg. 

Les mandats prendront fin lors de l’Assemblée des Associés qui approuvera les comptes annuels clôturés au 30 sep-

tembre 2005. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 15 décembre 2004 

- Monsieur Harald Seiffer est nommé président du Conseil de gérance. 
- Pouvoirs de signatures: 
Signature A: Monsieur Gary Parks, Monsieur Harald Seiffer et Monsieur Nigel Cottell. 
Signature B: Monsieur Didier Lang (Finance Manager) et Monsieur Manfred Loewe (Site Manager). 
Tous les membres du conseil de gérance (signature A) peuvent signer et engager la société conjointement avec une

autre signature A ou une signature B. 

Les détenteurs de signature B ont un pouvoir de signature conjoint pour les opérations courantes relevant de la ges-

tion journalière de la société jusqu’à un montant de 100.000,- euros. 

Les détenteurs de signature B doivent requérir la signature d’un détenteur de signature A pour toutes les opérations

dont le montant excède 100.000,- euros. 

Toutes les opérations requièrent la présence de deux signatures. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004626.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

ALMEEZAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.306.800,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 97.638. 

EXTRAIT 

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 18 novembre 2004 que la démission de Monsieur Ahmed El-

Sayyad de ses fonctions de gérant de Catégorie A de la Société, a été acceptée avec effet immédiat. 

Les associés ont nommé le Professeur Abdullatif A. Almeer, General Manager, avec adresse professionnelle à Grand

Hameed Street, P.O. Box 559, Doha, Qatar en tant que nouveau gérant de Catégorie A de la Société en remplacement
de Monsieur Ahmed El-Sayyad, précité. 

Il résulte desdites résolutions que le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit: 
Gérants de Catégorie A: 
- Pr. Abdullatif A. Almeer, General Manager, avec adresse professionnelle à Grand Hameed Street, P.O. Box 559,

Doha, Qatar. 

- Monsieur Hassan Al Ammari, General Manager, CEO, avec adresse professionnelle à Dallah Tower, Palestine Street,

P.O. Box 6854 Jeddah 21452, Arabie Saoudite. 

Pour extrait conforme
Signatures

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Signature.

18150

Gérant de Catégorie B: 
- Monsieur Marcel Stephany, conseiller fiscal et expert comptable, demeurant au 23, cité Aline Mayrisch, L-7268 Be-

reldange. 

Senningerberg, le 12 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03054. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004633.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

EXPANDOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.074. 

DISSOLUTION 

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 21 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2005, volume 530, folio 34, case 5; 

I. Que la société anonyme «EXPANDOS S.A.», ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 54.074, a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire
de résidence à Pétange, en date du 15 février 1996, publié au Mémorial C numéro 254 du 23 mai 1996, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 356 du 5
mars 2002. 

II. Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme «EXPANDOS S.A.». 
III. Qu’en tant qu’actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société

anonyme «EXPANDOS S.A.». 

IV. Que sa mandante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société. 

V. Qu’il a été procédé à l’annulation des titres au porteur de la société dissoute. 
VI. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats. 

VII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 janvier 2005.

(004636.4/231/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 86,241,500.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.568. 

In the year two thousand and four, on the twentieth day of the month of December. 
Before us, Me Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

Was held an extraordinary general meeting of members (the «Meeting») of KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l., a société

à responsabilité limitée (the «Company»), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
incorporated pursuant to a notarial deed on 16th February 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Mémorial») of 12th May 1999. 

The articles of association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary, on 16th December

2004, not yet published in the Mémorial.

The Meeting was presided by M

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg. 

The chairman appointed as secretary and as scrutineer M

e

 Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg. 

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that: 

I. The only member of the Company represented at the Meeting with all the issued shares is shown on an attendance

list which is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Such
attendance list will, together with the proxy of the represented member, initialled ne varietur by the appearing parties
and the undersigned notary, remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.

II. As appears from the attendance list, all 862,415 shares in issue in the Company are represented at the present

Meeting so that the Meeting is validly constituted. Furthermore the represented members declare having had prior

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Pour extrait conforme
J. Seckler 
<i>Notaire

18151

knowledge of the agenda so that the Meeting may validly decide on all the items of the agenda, without any obligation
to justify the accomplishment of any formalities. 

III. The agenda of the Meeting is as follows: 
1) Reduction of the share capital of the Company by a total amount of thirty-five million four hundred and sixty-three

thousand Euros (EUR 35,463,000.-), in order to reduce it from eighty-six million two hundred forty-one thousand five
hundred Euro (EUR 86,241,500.-) to fifty million seven hundred and seventy-eight thousand five hundred Euro (EUR
50,778,500.-) by absorption of reported negative retained earnings in an amount of one hundred and fifty-nine thousand
Euro (EUR 159,000.-) and the consequential cancellation of one thousand five hundred and ninety (1,590) shares and by
means of the repurchase from the sole member of an aggregate number of three hundred and fifty-three thousand and
forty (353,040) shares at the nominal value of EUR 100.- per share and by the subsequent cancellation of the three hun-
dred and fifty-three thousand and forty Euro (353,040) repurchased shares.

2) Amendment of article seven of the articles of association of the Company to reflect the reduction in the issued

share capital to fifty million seven hundred and seventy-eight thousand five hundred Euro (EUR 50,778,500.-) represent-
ed by five hundred and seven thousand seven hundred and eighty-five Euro (507,785) shares of one hundred Euro (EUR
100.-) each. 

3) Authorisation and instruction to the board of managers to pay the repurchase amount of thirty-five million three

hundred and four thousand Euro (EUR 35,304,000.-) to the sole member KEY PLASTICS L.L.C. by a payment in kind by
the transfer 290,776 shares representing 76.52% of the interests in KEY PLASTICS FRANCHE COMTE (estimated at
fair market value by the board of managers of the Company at thirty-five million three hundred and four thousand Euro
(EUR 35,304,000.-) as appropriate. 

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The Meeting resolved to reduce the issued share capital of the Company by an amount of thirty-five million four hun-

dred and sixty-three thousand Euro (EUR 35,463,000.-), in order to reduce it from eighty-six million two hundred forty-
one thousand five hundred Euro (EUR 86,241,500.-) to fifty million seven hundred and seventy-eight thousand five hun-
dred Euro (EUR 50,778,500.-) by absorption of reported negative retained earnings in an amount of one hundred and
fifty-nine thousand Euro (EUR 159,000.-) and consequential cancellation of one thousand five hundred and ninety (1,590)
shares and via the repurchase of an aggregate of three hundred and fifty-three thousand and forty (353,040) shares at
an amount of one hundred Euro (100.- EUR) per share and subsequent cancellation of the three hundred and fifty-three
thousand and forty (353,040) shares repurchased. 

Pursuant to the cancellation of such shares the member acknowledges and approves the new shareholding of the

member as set out hereafter:  

<i>Second resolution

As a result of the first resolution, the Meeting resolved to amend article seven first paragraph of the articles of asso-

ciation of the Company so as to read as follows: 

«Art. 7. The issued share capital of the Company is set at fifty million seven hundred seventy-eight thousand five

hundred Euro (EUR 50,778,500.-) represented by five hundred and seven thousand seven hundred and eighty-five
(507,785) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

<i>Third resolution

The Meeting resolved to authorise and instruct the board of managers to pay the repurchase amount of thirty-five

million three hundred and four thousand Euro (EUR 35,304,000.-) to the sole member KEY PLASTICS L.L.C., in kind by
the transfer of 290,776 shares representing 76.52% of the interests in KEY PLASTICS FRANCHE COMTE, a French
société par actions simplifiées, with registered office at ZI Route du Mans, F-61130 Belleme, France and registered with
the Registre du Commerce et des Sociétés de Alençon under number n° 413 178 524 (estimated at fair market value
by the board of managers of the Company at thirty-five million three hundred and four thousand Euro (EUR
35,304,000)) as appropriate. 

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at two thousand Euro. 

There being no further business for the meeting, the same was thereupon closed. 
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named in the beginning of this document. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in the case of divergence between the English and French text, the English version of it will prevail. 

Done in Luxembourg on the date before mentioned. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed, no other member expressing the request to sign. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingtième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg.

Shareholder

Total Number of shares repurchased and cancelled

Total shareholding after cancellation

KEY PLASTICS L.L.C.

354,630

507,785

18152

A été tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés («l’Assemblée») de KEY PLASTICS EUROPE, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée (la «Société»), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, constituée selon acte notarié du 16 février 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial»), du 12 mai 1999. 

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant le 16 dé-

cembre 2004, non encore publié dans le Mémorial. 

La séance est présidée par M

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur M

e

 Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 

Le bureau de l’Assemblée étant constitué, le président déclare et requiert le notaire de constater que: 
I. L’associé unique de la Société représenté à l’Assemblée avec toutes les parts sociales en émission sont renseignés

sur une liste de présence qui est signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instru-
mentant. Cette liste de présence restera, ensemble avec la procuration de l’associé représenté, paraphés ne varietur
par les parties comparantes et le notaire instrumentant, annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux for-
malités de l’enregistrement. 

II. Il apparaît de la liste de présence que toutes les 862.415 parts sociales en émission dans la Société sont représen-

tées à la présente Assemblée de la manière à ce que l’Assemblée est valablement constituée. Par ailleurs, l’associé re-
présenté déclare avoir antérieurement eu connaissance de l’ordre du jour de la manière à ce que l’Assemblée pourra
décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour, sans obligation de justifier de l’accomplissement des formalités. 

III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1) Réduire le capital social de la Société de trente-cinq millions quatre cent soixante-trois mille euros (EUR

35.463.000,-), de manière à le réduire de quatre-vingt-six millions deux cent quarante et un mille cinq cents euros (EUR
86.241.500,-) à cinquante millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros (EUR 50.778.500,-) par l’absorption
de pertes reportées d’un montant de cent cinquante-neuf mille euros (159.000,- EUR) et l’annulation conséquente de
mille cinq cent quatre-vingt-dix (1.590) parts sociales et par le biais du rachat du seul associé d’un nombre total de trois
cent cinquante-trois mille et quarante (353.040) parts sociales à une valeur nominale de 100,- EUR par part sociale et
par l’annulation subséquente des trois cent cinquante-trois mille et quarante (353.040) parts sociales rachetées. 

2) Modification de l’article sept des statuts de la Société afin de refléter la réduction dans le capital social émis à cin-

quante millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros (EUR 50.778.500,-), représenté par cinq cent sept mille
sept cent quatre-vingt-cinq parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune. 

3) Autorisation et instruction au conseil de gérance de payer le prix de rachat d’un montant de trente-cinq millions

trois cent quatre mille euros (35.304.000,- EUR) à l’associé unique KEY PLASTICS L.L.C, par un paiement en nature par
le transfert de 290.776 actions représentant 76,52% des intérêts dans KEY PLASTICS FRANCHE COMTE (estimées à
la valeur du marché par le conseil de gérance de la Société à 35.304.000,- EUR) comme approprié. 

Après avoir approuvé ce qui précède, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société de trente-cinq millions quatre cent soixante-trois mille

euros (EUR 35.463.000,-), de manière à le réduire de quatre-vingt-six millions deux cent quarante et un mille cinq cents
euros (EUR 86.241.500,-) à cinquante millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros (EUR 50.778.500,-) par
l’absorption de perte reportée d’un montant de cent cinquante-neuf mille euros (159.000,- EUR) et l’annulation consé-
quente de mille cinq cent quatre-vingt-dix (1.590) parts sociales et par le biais du rachat du seul associé d’un nombre
total de trois cent cinquante-trois mille et quarante (353.040) parts sociales à une valeur nominale de 100,- EUR par
part sociale et par l’annulation subséquente des trois cent cinquante-trois mille et quarante (353.040) parts sociales ra-
chetées. 

Suite à l’annulation de ces parts sociales l’associé unique note et approuve la détention des parts sociales telles que

décrites ci-après:  

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article sept, premier paragraphe, des sta-

tuts de la Société de la manière à lire: 

«Art. 7. Le capital émis de la Société est fixé à cinquante millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros

(EUR 50.778.500,-), représenté par cinq cent sept mille sept cent quatre-vingt-cinq (507.785) parts sociales d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.» 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’autoriser et d’instruire le conseil de gérance de payer le prix de rachat de trente-cinq millions

trois cent quatre mille euros (35.304.000,- EUR) à l’associé unique KEY PLASTICS L.L.C. en nature par le transfert de
290.776 actions représentant 76,52% des intérêts dans KEY PLASTICS FRANCHE COMTE, une société par actions sim-
plifiées de droit français, avec siège social au ZI Route du Mans, F-61130 Belleme, France et enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Alençon sous le numéro n

o

 413 178 524 (estimée à la valeur du marché par le conseil de

gérance de la Société à trente-cinq millions trois cent quatre mille euros (35.304.000,- EUR)) comme approprié.

Associé

Nombre de parts sociales rachetées et annulées

 Détention totale après annulation

KEY PLASTICS L.L.C.

354.630

507.785

18153

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront dus par la Société sont es-

timés à deux mille euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée. 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes com-
parantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux personnes comparantes, elles ont ensemble avec le notaire signé le présent acte, aucun

autre associé n’ayant exprimé la volonté de signer. 

Signé: K. Panichi, A. Schaus, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003411.3/211/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

BLUMENTHAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, zone Industrielle Beschmonts Bongert.

R. C. Luxembourg B 29.658. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juillet 2004 

Les associés de la société à responsabilité limitée BLUMENTHAL S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordi-

naire le 23 juillet 2004, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes: 

La démission de Monsieur Dirk Westerdijk, jardinier-paysagiste, demeurant à L-7639 Blumenthal, 1, Dikkrechers-

troos de son poste de gérant technique de la société est acceptée. 

Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat. 
Madame Hendrika Cornelia Westerdijk, fleuriste, demeurant à L-7639 Blumenthal (Bech), 2, Dikkrecherstrooss, est

nommée gérante technique pour une durée indéterminée en remplacement du gérant technique démissionnaire.

La nouvelle gérante technique déclare accepter son mandat. 
Madame Hendrika Cornelia Westerdijk susvisée étant déjà gérante administrative, la société ne comptera désormais

qu’une seule et même gérante en la personne de Madame Cornelia Westerdijk susvisée. 

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique. 

Mersch, le 23 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004638.3/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

RAIN MAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 80.418. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 septembre 2004 

L’an deux mille quatre, le trois septembre à 10.00 heures. 
Les actionnaires de la société RAIN MAN S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur

convocation faite par le Conseil d’Administration et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

- La démission de Monsieur Nico Lanter, ingénieur-technicien, demeurant à Luxembourg de son poste d’administra-

teur et d’administrateur-délégué de la société, est acceptée à l’unanimité. Pleine et entière décharge lui est donnée pour
l’exercice de ses mandats. 

- La démission de Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg de son poste

d’administrateur de la société, est acceptée à l’unanimité. Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de
son mandat. 

Les actionnaires ont donc procédé à de nouvelles élections statutaires et ont décidé de nommer administrateurs: 
- Monsieur Marc Hobscheit, demeurant à L-2531 Luxembourg, 11, rue Frantz Seimetz. 
- Monsieur Michel Dakessian, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération. 
- Madame Martine Schaffard, demeurant à L-8021 Strassen, 28, rue de l’Indépendance. 
- Monsieur Marc Hobscheit, sus-dénommé, est également nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la

société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

18154

Les nouveaux administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leurs mandats qui viendront à échéance à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010. 

Le mandat du commissaire aux comptes, LUX-AUDIT S.A. avec siège à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïen-

cerie, est renouvelé pour une période d’un an, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2005. 

Alzingen, le 3 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06041. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004644.3/503/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

ST. GEORGE’S SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2127 Luxembourg, rue des Marguerites.

R. C. Luxembourg B 34.048. 

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 13 décembre 2004, numéro 2004/1933 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 15 décembre 2004, volume 431,
folio 39, case 3, que la société à responsabilité limitée «ST. GEORGE’S SCHOOL, S.à r.l.», avec siège social à L-2127
Luxembourg, rue des Marguerites, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 10 mai 1990, publié
au Mémorial C, numéro 423 du 19 novembre 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alex
Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 15 septembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 5 du 5 janvier
1995 et suivant résolution prise par l’associée unique en date du 21 janvier 2002, publiée au Mémorial C, numéro 1026
du 5 juillet 2002, 

a été dissoute avec effet au 13 décembre 2004. 
La société n’a plus d’activités. 
Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société Messieurs Roger Hamer, John Jackson et John

Boyce. 

La société «ROPHIL FRANC LIMITED», seul associée, a déclaré que la liquidation de la société a été achevée et qu’il

assume tous les éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute. 

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années au dernier siège

social de la société à L-2127 Luxembourg, rue des Marguerites.

Bascharage, le 5 janvier 2005.

(004801.4/236/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

CORNEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.656. 

Suite à la cession de parts intervenue en date du 22 décembre 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOL-

DINGS (LUXEMBOURG) S.A. et INVESTINDUSTRIAL L.P. représentée par son General Partner INVESTINDUSTRIAL
GENERAL PARTNER LIMITED, les 125 parts sociales de la Société sont détenues comme suit: 

 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005162.3/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait 
A. Weber 
<i>Notaire

- INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part sociale

- ALETTI MERCHANT SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 parts sociales

- INVESTINDUSTRIAL L.P. représentée par son General Partner INVESTINDUSTRIAL GE-

NERAL PARTNER LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 parts sociales

<i>CORNEL, S.à r.l. 
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant 
Signatures

18155

BERGON S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 34.763. 

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BERGON S.A. HOLDING»

avec siège social à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le
numéro B 34.763, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en
date du 3 août 1990, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, page 3295 de l’année 1991. 

L’Assemblée est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean Reicherts, employé privé, demeurant pro-

fessionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal
Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame May-Lis Eriksson, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter, 

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que: 
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour: 

1. Conversion du capital social, en euros, et augmentation du capital social. 
2. Modification de l’article cinq des statuts. 
3. Renouvellement du mandat des administrateurs et administrateur-délégué. 
4. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. 
5. Engagement de la société vis-à-vis des tiers. 
6. Et transfert de l’adresse du siège social. 
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, et le notaire instrumentant, sera enregistrée avec le présent acte. 

III. Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée. 

IV. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide: 
a) de convertir le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en

euros au taux de conversion de 40,3399, soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69); 

b) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme de treize euros trente et un cents (EUR 13,31) pour le

porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Cette augmentation est effectuée par incorporation d’un même
montant à prélever sur les réserves de la prédite société. 

c) de supprimer les cent (100) actions existantes de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) et

de créer Cent (100) actions nouvelles, d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, qui seront
attribuées aux actionnaires actuels au prorata des actions anciennes leur appartenant dans la prédite société. 

d) Cette augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires actuels et il n’y a pas de rompus. 

<i>Deuxième résolution 

De ce qui précède, L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide de modifier l’article cinq des

statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent actions (100), d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune. 

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide de renouveler pour une durée de six années à

compter de ce jour: 

a) le mandat des administrateurs: 
- Monsieur Jean Reicherts, prénommé; 
- Monsieur Robert Reicherts, employé privé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas

Welter; 

- et Madame May-Lis Eriksson, prénommée. 
b) et le mandat de l’administrateur-délégué, Monsieur Jean Reicherts, prénommé; 
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2010. 

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide de renouveler pour une durée de six années à

compter de ce jour le mandat du commissaire aux comptes, savoir: 

La FIDUCIAIRE EUROPEENNE avec siège social à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter. 
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2010. 

18156

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société confirme que conformément à l’article 12 des statuts vis-

à-vis des tiers la société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature
conjointe de deux administrateurs. 

<i>Sixième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de transférer l’adresse du siège social de la prédite

société, savoir: 

- Ancien siège: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris. 
- Nouveau siège: L-2741 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter. 

<i>Evaluation des frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à six cents euros (EUR 600,-). Plus rien ne figurant à l’ordre du jour,
la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ont signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: J. Reicherts, J-P. Cambier, M-L. Eriksson, A. Biel 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2004, vol. 904, fol. 26, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(004591.3/203/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

BERGON S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 34.763. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004593.3/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

GADD CAPITAL MANAGEMENT Ltd (Luxembourg Branch), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 105.402. 

<i>Ouverture de succursale 

II a été créé, depuis le 1

er

 juillet 2004, à Luxembourg, une succursale de la société de droit de Gibraltar GADD CA-

PITAL MANAGEMENT Ltd, dont les locaux sont situés au 4, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg. 

GADD CAPITAL MANAGEMENT Ltd (Luxembourg Branch) aura pour activité la gestion de fortune. 
GADD CAPITAL MANAGEMENT Ltd, avec siège social sis à Portland House - Suite 10 - 1st Floor - Glacis Road -

PO Box 721 - Gibraltar, est une société de type «Limited Private Company», immatriculée au «Companies House Re-
gistration» de Gibraltar sous le numéro 60381. 

Les personnes habilitées à représenter la société sont: 
- Cristofer Gelli, administrateur-délégué, né le 18 septembre 1956 à Stockholm (S), adresse professionnelle: c/o

GADD &amp; Cie S.A., 20, route de Pré Bois à CH-1215 Genève 15 

- Christer Hegardt, administrateur-délégué, né le 8 mai 1953 à Stockholm (S), adresse professionnelle: c/o GADD &amp;

Cie S.A., 20, route de Pré Bois à CH-1215 Genève 15 

- Richard Amey, administrateur-délégué, né le 12 mars 1959 à Lausanne (Switzerland), adresse professionnelle: Suite

10, 1st Floor, Portland House Glacis Road, PO Box 131, Gibraltar 

- Marco Daescher, administrateur, né le 10 novembre 1964 à Chur (Suisse), adresse professionnelle: Suite 10, 1st

floor, Portland House Glacis Road, PO Box 131, Gibraltar 

Les personnes habilitées à représenter la succursale vis-à-vis des tiers et de l’administration sont: 
- Birgitta Margaretha Maria Thonning, gérante, née le 5 septembre 1954 à Västerås (S), adresse professionnelle: 4,

rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg 

- Mats Ove Midhamre, gérant, né le 19 décembre 1961 à Järna (S), adresse professionnelle: 4, rue de l’Eau à L-1449

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2005.

A. Biel.

A. Biel
<i>Notaire

<i>Pour la succursale
Signature

18157

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004843.3/607/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 74.565. 

<i>Decisions prises lors de la reunion du conseil d’administration du 14 décembre 2004 

L’an deux mille quatre, le quatorze décembre. 
Le Conseil d’Administration s’est réuni au siège de la Société sur convocation de son Président. 
Après délibérations, les Administrateurs prennent, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

La démission de Monsieur Raymond le Lourec, conseiller fiscal, de son mandat d’Administrateur de la société est

acceptée. 

Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat d’Administrateur. 

<i>Deuxième résolution 

Monsieur Marco Cecconi, administrateur de sociétés, demeurant 60/2-128 Volokalamskaia Shasse, Moscou, Républi-

que de Russie, est nommé, par cooptation, Administrateur en remplacement de l’Administrateur démissionnaire. 

Le nouvel Administrateur ainsi nommé, déclare accepter son mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2005. 

Le conseil d’administration de la société est dès lors composé de la manière suivante, et ce jusqu’à l’issue de l’assem-

blée générale ordinaire qui se tiendra en 2005: 

- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg, 
- Monsieur Marco Cecconi, administrateur de société, demeurant à Moscou (République de Russie), 
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
D’un commun accord, les Administrateurs décident que cette nomination sera entérinée lors de la prochaine assem-

blée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2005. 

<i>Troisième résolution 

D’un commun accord, les Administrateurs de la société nomment Monsieur Marco Cecconi, prénommé, Président

du Conseil d’Administration de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005. 

D’un commun accord, les Administrateurs décident que cette nomination sera entérinée lors de la prochaine assem-

blée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06183. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004866.3/3083/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.425. 

In the year two thousand and four, on the twenty-first day of the month of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Com-

pany»), a société à responsabilité limitée incorporated by deed of notary Joseph Elvinger as a société à responsabilité
limitée on 30th September 2004 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

The articles of association have been modified for the last time by a notarial deed of the undersigned notary on 11th

November 2004 not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations. 

The meeting was presided by Maître Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as secretary Maître Maryline Esteves, maître en droit, residing in Luxembourg and scrutineer

Maître François Felten, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which is

signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list
will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities. 

As it appears from said attendance list, all 58,073 shares currently in issue in the Company are represented at the

present general meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items
of the agenda. 

2. That the agenda of the meeting is as follows:
(A) Increase of the issued share capital of the Company by an amount of EUR 109,125 from EUR 1,451,825 to

1,560,950 Euro by the issue of 4,365 new shares with a nominal value of twenty five euro (EUR 25) each and a total

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

Signature.

18158

premium of EUR 982,125 against the contribution in cash of EUR 1,091,250, the subscription to the new shares by
FASHION ONE MANAGEMENT BETEILIGUNGS GmbH &amp; Co KG and payment of the total subscription price by way
of contribution in cash, allocation of EUR 109,125 to the share capital account, allocation of EUR 10,912.5 to the stat-
utory reserve account and allocation of the balance of EUR 971,212.5 to the share premium account which shall be
freely distributable and which can without limitation be used for the repurchase of shares of the Company, consequential
amendment of article 6 first paragraph of the articles of association of the Company (as provided for in agenda item 2) 

(B) Amendment and Restatement of the articles of incorporation substantially in the form as set out in the proxies

(and taking into account the resolution under (A) above). 

(C) Confirmation of the mandates of the existing board members and qualification of Mr Peter Gangsted as «A Di-

rector». 

After deliberation the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital from one million four hundred and fifty one thousand eight

hundred and twenty five euro (EUR 1,451,825) to one million five hundred and sixty thousand nine hundred and fifty
euro (1,560,950) Euro by the issue of 4,365 new shares with a nominal value of twenty five euro (EUR 25) each and a
total premium of EUR 982,125 against the contribution in cash of EUR 1,091,250. 

The newly issued shares have been subscribed to and fully paid by FASHION ONE MANAGEMENT BETEILIGUNGS

GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership, with registered office at c/o Pöllath + Partner, Fünf Höfe, Kardinal-Faulhaber-
Str. 10 in 80333 Munich, registered with the commercial register of the local court of Munich under number HRA 84446,
here represented by Maître Toinon Hoss, prenamed,

by virtue of a proxy hereto attached.
Out of the one million ninety one thousand two hundred and fifty euro (EUR 1,091,250) received by the Company,

an amount of one hundred and nine thousand one hundred twenty five euro (EUR 109,125) is allocated to the share
capital account, an amount of ten thousand nine hundred and twelve point five euro (EUR 10,912.5) is allocated to the
statutory reserve account and the balance of nine hundred and seventy one thousand two hundred and twelve point
five euro (EUR 971,212.5) is allocated the share premium account. The meeting resolved that the share premium be
freely distributable and can also without limitation be used to repurchase shares of the Company.

Proof of the above contribution in cash to the Company was given to the undersigned notary.
Consequently to the above the meeting resolved to amend article 6 first paragraph of the articles of association of

the Company as set out under a resolution 2 hereafter:

<i>Second resolution

The meeting thereafter unanimously resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company as

set out hereafter (taking into account the first resolution). 

Art. 1. Definitions. A Director Means the Director(s) designated as «A Directors» by the General Meeting 
«Affiliates» Means any legal entity or partnership which either directly or indirectly controls or is either directly or

indirectly controlled by an Investor Shareholder within the meaning of Sec. 15 et seq German Stock Corporation Act

«Approved Transferees» Means each of the funds advised, from time to time, by Cinven Limited or an affiliate of

Cinven Limited in the meaning of Sec. 15 et seq German Stock Corporation Act and the general partners of such funds
as well as each of the funds, advised, from time to time, by APAX PARTNERS EUROPE MANAGERS Ltd. or an affiliate
thereof in the meaning of Sec. 15 et seq German Stock Corporation Act and the general partners of such funds.

«Articles or Articles of Incorporation» Means the articles of association of the Company from time to time
«Auditors» Means either one of KPMG, PWC, E&amp;Y or DELOITTE or any internationally reputable investment bank
«Bad Leaver» Means a Departing Employee who leaves the Company or any Group Member due to (x) voluntary

resignation or termination by the Departing Employee for a reason other than for cause within eight years from the
Commencement Date; (y) a dismissal or termination by the Company or any Group Member for cause (wichtiger Gr-
und) or (z) expiry of his then existing employment or service agreement within eight years of the Commencement Date
without replacement by a new or renewal of the then existing employment or service agreement, provided that the
Departing Employee has been offered reasonably in advance the renewal or the extension of the then existing employ-
ment or service agreement at terms and conditions (but for the term thereof) which are at least as good as the ones in
the then existing employment or service agreement in all material respects.

If a Departing Employee leaves the Company or a company of the Group due to voluntary resignation or termination

by the Departing Employee for a reason other than for cause following the fifth anniversary of the Commencement
Date, the Company and the Departing Employee shall enter into good faith negotiations, to determine whether the De-
parting Employee is deemed to be a Good Leaver rather than a Bad Leaver. 

«Board or Board of Directors» Means the board of directors of the Company appointed pursuant to the provisions

of the Articles 

«Business Day» Means a day other than a Saturday or a Sunday on which banks are open for usual business in Lux-

embourg-City 

«Cessation Date» Means the date upon which a Person becomes a Departing Employee 
«Cinven Limited» Means Cinven Limited, a limited liability company incorporated under the laws of England with reg-

istered office at Pinner’s Hall. 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH and registered in England and Wales under
number 2192937 

«Commencement Date» Means 12 November 2004
«Company law» Means the law of 10th August 1915 on commercial companies 

18159

«Connected Transfers» Means (i) any transfer of Shares which, but for the date of such transfer, otherwise form part

of any Triggering Transfer and (ii) any transfer of Shares separately agreed upon, but economically connected to the
Triggering Transfer 

«Cost» Means in respect of a Share in the capital of the Company, the aggregate amount paid up in respect of the

nominal value thereof and any share premium thereon at the time of issue of such Share less capital duty paid thereon
by the Company 

«Departing Employee» Means any individual who is an employee, executive or a managing or other director of one

or more Group Members, who is served notice of termination in relation to his employment or service agreement or
who ceases to be employed by or to be a managing director of the relevant Group Member and who does not begin or
continue to otherwise provide services to any Group member, provided that he or she shall be deemed to become a
Departing Employee on such date on which he or she discontinues his or her activities for the Group, whether upon
request of the Group or otherwise, in particular due to release (Freistellung) from duties; or (ii) vice-versa; provided in
both (i) and (ii) that such individual holds Shares, whether directly or through a partnership interest in Manager Part-
nership 

«Departing Employee’s Group» Means (i) a Departing Employee, (ii) the Manager Partnership, (iii) the legal entity,

partnership or trusteeship under or through which the Departing Employee and/or a third party holds Shares in the
Company, either directly or through the Manager Partnership, (iv) any other Person, who holds Shares directly or in-
directly as a legal successor of any of the afore-mentioned 

«ERISA Shareholder» Means Third Cinven Fund US (N

°

 1) Limited Partnership, Third Cinven Fund US (N

°

 2) Limited

Partnership, Third Cinven Fund US (N

°

 3) Limited Partnership, Third Cinven Fund US (N

°

 4) Limited Partnership and

Third Cinven Fund US (N

°

 5) Limited Partnership 

«General Meeting» Means the general meeting of Shareholders resolving at the majority requirements provided for

in the Articles 

«Good Good Leaver» Means a Departing Employee who leaves the Company or any Group Member (x) due to re-

tirement at mandatory retirement age, (y) due to death or (z) due to permanent disability. 

«Good Leaver» Means a Departing Employee who is neither a Good Good Leaver nor a Bad Leaver 
«Group» Means the Company, any company or undertaking that is directly or indirectly controlled by the Company

or controls (directly or indirectly) the Company or is under common control of the Company from time to time and
«Group Member» shall have the corresponding meaning

«Investor Group Member» Means any Person which at the relevant time is under the direct or indirect management

of a Person which manages, advises or administers (whether or not in the form of a general partner) private equity funds,
or any Person so designated as such by an Investor Group Member 

«Investor Shareholder» Means any of FASHION ONE HOLDING, S.à r.l., (R.C.S. 101.878) and FASHION ONE PAR-

TICIPATIONS, S.à r.l., (R.C.S. 103.912) and any transferee of Shares from any Investor Shareholder pursuant to Article
9.1 which is also an Investor Group Member 

«Manager Partnership» Means FASHION ONE MANAGEMENT BETEILIGUNGS GmbH &amp; Co. KG, a limited part-

nership (Kommanditgesellschaft) registered with the commercial register of the local court in Munich under HR A
84446

«Manager Partnership Agreement» Means the limited partnership agreement (Kommanditgesellschaftsvertrag) con-

stituting the Manager Partnership, as amended from time to time

«Market Value» Means in relation to Shares the value thereof as determined in accordance with Article 10 
«Person» Means any individual or any legal entity of any nature whatsoever
«Pro Rata Portion» Means (i) such number of Shares of the Other Holder which is the sum of the Shares which the

Other Holder could have Transferred if he had been entitled to sell the same percentage of Shares which the Investor
Shareholders (as a group) transferred since the Commencement Date, and including the Transfer which triggers the Tag
Along or the Come Along, as the case may be, to the extent any such Transfers which are not a Sale otherwise consti-
tute a Sale but for the threshold of 50%, (ii) minus such number of Shares already Transferred.

«Register of Shareholders» Means the register of Shareholders held by the Company in which are inscribed in par-

ticular the Shareholders and their shareholding in the Company 

«Sale» Means (a) the Transfer (whether through a single transaction or a series of transactions) of Shares in the Com-

pany which would result in the Investor Shareholders (and/or any one or more of its Affiliates, counted as a group)
owning directly or indirectly Shares conferring less than 50 per cent of the voting rights in the Company Provided that
there shall be no Sale as a result of (a) any Transfer pursuant to Article 9.1 and/or to an Affiliate or (b) any form of
capital reorganisation or scheme of arrangement or the like under Luxembourg law or (c) any Transfer of Shares in the
12 months following the Commencement Date within an equity syndication duly recorded as such in the Transfer doc-
ument delivered to the Company

«Shareholders» Means the holders of Shares of the Company 
«Shares» Means all the shares of the Company (parts sociales) 
«Transfer of Shares» Means any transfer of one or more Shares or any direct, indirect or fiduciary right or interest

therein in any manner whatsoever including by way of a sale, disposal, transfer, pledge, encumbrance, charge or other-
wise; and to Transfer, Transferring or Transferred, Transferable shall be construed accordingly

 Art. 2. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name FASHION ONE

LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company») formed by the current Shareholder(s) and all Persons who will become Share-
holders thereafter. The Company will be governed by these Articles and the relevant legislation. 

Art. 3. Purpose and Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever,

in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any

18160

other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company
may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, preferred equity

certificates, debentures or any other kind of debt instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest of any kind or which forms or will form part of the
group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any
operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose. 

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company does not come to an end by

the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any Shareholder.

Art. 5. Registered office .The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary General Meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the Board should determine that extraordinary political, economic or social developments have oc-

curred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Board.

Art. 6. Share capital 
6.1 The issued share capital of the Company is set at 1,560,950 Euro divided into 62,438 Shares, each with a nominal

value of twenty-five Euro (EUR 25). 

6.2 The capital of the Company may be increased or reduced and Shares may be issued or cancelled by a resolution

of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles. 

6.3 The Company may purchase and hold (directly or indirectly) its own Shares upon the authorisation of the General

Meeting resolving pursuant to Article 15.4(i). 

Art. 7. Transfer of Shares
7.1 Except as provided for by mandatory provisions of law, any Transfer restrictions set out herein may be waived

by a majority of Shareholders representing at least 75% of the share capital of the Company.

7.2 Any Transfer of Shares shall always be subject to, and will be effective and recognised by the Company only if

realised in compliance with the provisions set out in these Articles of Incorporation. Any recognition and/or inscription
of a Transfer of Shares will be subject to compliance with the provisions set out in the present Articles of Incorporation. 

7.3 Except for Transfers among Shareholders pursuant to Article 9.1 and Transfers to the Approved Transferees, any

Transfer of Shares shall be subject to the approval of Shareholders representing at least 75% (three-quarters) of the
share capital of the Company. 

7.4 In the event a shareholder or like agreement (if any) exists at such time between all or part of the Shareholders

and the Company, any Transfer of Shares may, in addition as otherwise set out in the present Articles of Incorporation,
be made only subject to the Transferee in each case becoming a party to such agreement, unless the General Meeting
of Shareholders resolves otherwise. 

Art. 8. Tag Along and Come Along
8.1 Subject to Article 7 and save as provided in Article 9.1 and save as set out hereafter, if the effect of any Transfer

of any Shares would, if made, result in there being a Sale (the «Triggering Transfer»), the Transfer shall not be made
unless either:

(i) the proposed transferee has unconditionally offered to purchase or cause a third party to purchase a Pro Rata

Portion of the other issued Shares of the Company held by Shareholders other than any Shareholder who is the pro-
posed transferor or who is an Affiliate of the proposed transferor or the proposed transferee of the Shares proposed
to be the subject of the Transfer (the «Other Holders») on the same terms and conditions as those of the Triggering
Transfer (save as provided below in this Article 8.1 and in Article 8.8), and/or

(ii) the transferor or, if more than one transferor, either one of them alone or jointly, unconditionally offer(s) to pur-

chase a Pro Rata Portion of the issued Shares held by the Other Holders on the same terms and conditions as those of
the Triggering Transfer (save as provided below in this Article 8.1 and in Article 8.8), provided that the sale of such
Shares by the transferor in the Triggering Transfer or later shall not entitle the Other Holders to a Tag Along Offer.

Provided always that (x) in the event of a combination of (i) and (ii), the Pro Rata Portion shall be calculated on the

basis of the aggregate number of Shares offered to be Transferred thereunder, and (y) the aggregate purchase price to
be paid to the Other Holder for the Pro Rata Portion shall always be the sum of the purchase prices the Other Holder
would have been entitled to had he sold Shares pro rata in all Transfers referred to in the definition of the Pro Rata
Portion prior to and including the Sale, and (z) no offer pursuant to (i) and (ii) above (the «Tag Along Offer») shall be
required in the event of the exercise of the Call pursuant to Article 8.5. 

18161

8.2 Article 8.1 shall apply mutatis mutandis to any Transfer of Shares by the Investor Shareholders after a Sale to the

extent such Transfers constitute a Sale but for the threshold of 50%. 

8.3 Any Tag Along Offer shall be made by a notice (the «Tag Notice») sent by the relevant offeror to each of the

Other Holders to its address set out in the Register of Shareholders and the Company. The Tag Notice shall set out
the terms and conditions of the Tag Along Offer. Any Tag Along Offer shall remain open for acceptance for not less
than 10 Business Days from the date of dispatch of the Tag Along Notice (the «Acceptance Period»). 

8.4 Each Other Holder wishing to accept the Tag Along Offer shall notify the offeror in writing of their acceptance

with a copy to the Company. The acceptance shall include the information on whether the Other Holder accepts the
Tag Along Offer with respect to the entire portion of Shares as offered or whether it accepts only a part thereof and,
in the case that it accepts only a part, which part. Other Holders not having so accepted the Tag Along Offer by the
end of the Acceptance Period have refused the Tag Along Offer. The Transfer of the relevant Shares to the offeror
against the consideration therefor shall occur within one (1) Business Day of the offeror requesting the Transfer. In any
event, the offeror may request that the relevant Shares are Transferred simultaneously with those Shares Transferred
upon the Triggering Transfer.

8.5 Upon satisfaction of the procedure set out in Article 8.1 to 8.4 the Triggering Transfer respectively the Transfer

may occur (it being understood that the Triggering Transfer or the Transfer referred to in Article 8.2 and the Transfers
pursuant to the acceptances by Other Holders of the Tag Along Offer may occur at the same time and, if to the pro-
posed transferee, in the same document). 

8.6 In the event of or prior to a Triggering Transfer, the Transferring Shareholder (or, if there is more than one Trans-

ferring Shareholder, any of them) (the «Calling Shareholder») hereby has the right to require all the other Shareholders
(the «Called Shareholders») to Transfer up to all the Shares held by them and shall be entitled to determine whether
the Transfer shall be either to the Calling Shareholder and/or to the proposed transferee, in either case upon the same
terms and conditions as the Triggering Transfer (save as set out below in this Article 8.6 and in Article 8.8) (the «Call»),
provided that (i) the aggregate purchase price shall always be such as if the Called Shareholders had exercised their Tag-
Along Right upon the Triggering Transfer and Connected Transfers with respect to the same number of Shares trans-
ferred upon the Call, and (ii) the sale of such Shares by the Calling Shareholder in the Triggering Transfer or later shall
not entitle the Other Holders to a Tag Along Offer. In the event that the Transferring Shareholder does not require
the Called Shareholders to Transfer all the Shares held by them, but only a portion thereof, the Transferring Shareholder
shall treat each Called Shareholder equal on a pro rata basis. For the avoidance of doubt the Calling Shareholder shall
have a call option (which it may transfer to the proposed transferee of the Triggering Transfer) with respect to any such
Shares. 

8.7 The Call is exercised by sending a written notice (the «Come Along Notice») to each Called Shareholder to its

address set out in the Register of Shareholders and the Company. The Come Along Notice shall set out the terms and
conditions of the Call accompanied by copies of all documents required to be executed by the Called Shareholders for
the Transfer of Shares under the Call. The Transfer of the Shares upon the exercise of the Call shall occur within 5
Business Days from the date of receipt of the Come Along Notice (or such later date as may be indicated in the Come
Along Notice) and in such form as specified in the Come Along Notice. 

8.8 In addition to the terms and conditions equally applying in a Triggering Transfer to all selling Shareholders, the

proposed transferor may reasonably request that Other Holders who are individuals or partnerships agree to an escrow
not uncustomary in such transactions. 

8.9 If a Called Shareholder defaults in Transferring its Shares pursuant to the exercise of the Call under Article 8.6

(the «Defaulting Shareholder»), the Board of the Company (or its delegatee for that purpose), shall hereby be duly and
irrevocably appointed as agent of the Defaulting Shareholder with full power to execute, complete and deliver in the
name and on behalf of the Defaulting Shareholder all documents necessary to give effect to the Transfer of the Shares
held by the Defaulting Shareholder to the relevant transferee under the Call on behalf of the Defaulting Shareholder
and to take such further steps as may be required or useful to accomplish the above. The Board is expressly authorised
to receive and give a good discharge at the sole risk of the Defaulting Shareholder for any consideration received on
behalf of the Defaulting Shareholder and may duly record the Transfer in the Register of Shareholders and as may be
otherwise required. The Company shall forward the consideration (without interest and less any sums owed by the
Defaulting Shareholder to the Company) to the bank account indicated by the Defaulting Shareholder. In the event the
Defaulting Shareholder does not indicate a bank account to which the consideration shall be transferred, the Company
may either deposit such amount on an account opened for such purpose or send a cheque for such amount to the last
address of such Defaulting Shareholder appearing in the Register of Shareholders or known to the Company, each time
at the sole risk and costs of the Defaulting Shareholder. Upon transfer or deposit of the consideration or the posting
of a cheque as aforesaid, neither the Defaulting Shareholder nor any Person interested in the Defaulting Shareholder’s
transferred Shares pursuant to the exercise of the Call shall have any further interest in such Defaulting Shareholder’s
Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof or of the consideration. By
acquiring Shares in any way in the Company each Shareholder expressly confirms and accepts the present provisions.

8.10 Whenever Shares of Other Holders are Transferred in accordance with this article 8, such Other Holders are

entitled to request, and under Article 8.6 the Company is entitled to request, that a pro rata portion of any shareholder
loans (if any) granted to the Company by such Other Holders from time to time shall, at the sole discretion of the Com-
pany, either be fully repaid (including accrued interest thereon) or be Transferred to the proposed transferee at face
value (including accrued interest thereon) it being understood that such pro rata portion of any such shareholder loans
(if any) shall correspond to the pro rata portion of the Shares of Other Holders which are Transferred in accordance
with this Article 8. Article 8.9 shall apply mutatis mutandis. 

18162

Art. 9. Special Transfers
9.1 Permitted Transfers
Any Transfer of Shares set out hereunder shall be a «Permitted Transfer» and not be subject to the provisions of

Article 8 (Tag Along and Come Along).

9.1.1 Any Investor Shareholder may Transfer any Shares to any Investor Shareholder as well as to any Investor Group

Member.

9.1.2 Any Investor Shareholder may Transfer within one year from the Commencement Date any Shares within an

equity syndication duly recorded as such in the Transfer document delivered to the Company.

9.1.3 Any Transfer of Shares to any of the Approved Transferees. 
9.1.4 Any Transfer of Shares by any of the Approved Transferees to any of the partners in any of the Approved Trans-

ferees or any person with a direct or indirect interest in the assets of the Approved Transferees. 

9.1.5 Any Transfer by any of the Investor Shareholders to any directors, including non-executive directors, executives

or employees of any Group Member or to the Manager Partnership on behalf of any one of the aforementioned.

9.1.6 Any Transfer from Manager Partnership to any Investor Shareholder and vice-versa. 
9.1.7 Any Transfer under Article 10, except for a transfer under 10.2.3 if not otherwise permitted under this Article

9, and any Transfer by any of the Persons or entities referred to under article 10.2.2 to a manager, director, executive
or employee of a Group Member.

9.2 Certain Transfers by or Affecting Manager Partnership
If, other than with the approval pursuant to Article 7.3, (i) the Manager Partnership is dissolved, for whatever reason,

or (ii) Shares are Transferred by the Manager Partnership to any third party (including the partners of the Manager Part-
nership), save for a permitted Tag Along or Come Along pursuant to Article 8 or a Transfer pursuant to Article 10, or
(iii) a partnership interest in the Manager Partnership is Transferred other than as permitted under the Manager Part-
nership Agreement, the Company shall have a pre-emptive right (x) in case of (i) above on all the Shares held by Manager
Partnership, (y) in case of (ii) above on such Shares Transferred and (z) in case of (iii) above on such Shares allocable to
the partnership interest Transferred without approval, and hereby is always entitled to acquire all or the allocable
Shares, as the case may be, held by the Manager Partnership or such Person to which they have been Transferred by
the Manager Partnership at a price which is equal to the price provided in Article 10.3.1 for a Bad Leaver. In any event
the Company hereby has a call option with respect to such Shares at the conditions set forth hereabove.

 Art. 10. Departing Employee Transfers
10.1 If a Person becomes or is a Departing Employee, the Departing Employee Group shall, unless otherwise agreed

by the Board, be deemed to have given on the Cessation Date a transfer notice at the amount determined under Article
10.3 below in respect of all of the Shares such Departing Employee’s Group holds in relation to the Departing Employee.
In any event, the Company hereby has a call option on such Shares at the conditions set forth hereafter. 

10.2 Subject to Article 10.3. below, following the Cessation Date, the Company shall be entitled within a period of

three months to either accept the transfer notice itself and/or have it accepted, in either case, by written notice to the
Manager Partnership and at the price referred to in Article 10.3.:

10.2.1. by a Person or Persons, if any, replacing (directly or indirectly) the Departing Employee as manager, employee,

executive or director of the Company (or of a Group Member);

10.2.2. by a trust, scheme or entity (including an Investor Shareholder) for the benefit of a replacement manager or

employee or other director, executive, employee or manager of any Group Member; or

10.2.3. otherwise as determined by the Board. 
10.3 The amount at which any Shares shall be offered under this Article 10 shall be determined as follows: 
10.3.1. The price at which the Shares shall be offered for Transfer under this Article 10 shall be determined by ref-

erence to the reason why the Departing Employee becomes a Departing Employee as set out in the table below:  

10.3.2. In determining the Market Value of the Shares Transferred hereunder the Company may propose to the De-

parting Employee a price which if accepted by the Departing Employee shall be deemed to be the Market Value. In the
absence of such agreement the Market Value shall be determined in accordance with Article 10.3.3 or, if a determination
of the Market Value pursuant to Article 10.3.3 took place within the 6 months prior to the Cessation Date the Company

Cessation 
Date:

On or prior to the sec-
ond anniversary of the
Commencement Date

After second and prior
to or on the third anni-
versary of the Com-
mencement Date

After third and prior to
or on the fourth anni-
versary of the Com-
mencement Date

Any time after the
fourth anniversary of
the Commencement
Date

Good Good 
Leaver

Cost

50% Cost and 50% of
the higher of Cost and
Market Value on the
Cessation Date

25% Cost and 75% of
the higher of Cost and
Market Value on the
Cessation Date

100% of the higher of
Cost and Market Value
on the Cessation Date

Good Leaver

The lower of Cost and
Market Value on the
Cessation Date

50% of the lower of
Cost and Market Value
on the Cessation Date
plus 50% of the Market
Value on the Cessation
Date 

25% of the lower of
Cost and Market Value
on the Cessation Date
plus 75% of the Market
Value on the Cessation
Date

100% of the Market
Value on the Cessation
Date

Bad Leaver

The lower of Cost and
Market Value on the
Cessation Date

The lower of Cost and
Market Value on the
Cessation Date

The lower of Cost and
Market Value on the
Cessation Date

The lower of Cost and
Market Value on the
Cessation Date

18163

may determine that the Market Value of the Shares Transferred hereunder shall be based upon the price per share im-
plied in the Market Value so last determined.

10.3.3. Subject to Article 10.3.2., the Market Value of the Shares which are the subject of the Transfer Notice (the

«Transferred Shares») shall be the market value of the Transferred Shares as of the Cessation Date as determined by
the Auditors acting as experts and not arbitrators and whose determination shall be final and binding on the parties
concerned. In arriving at the Market Value of the Transferred Shares, the Auditors shall be instructed to determine the
market value of the Company applying any generally accepted method on the valuation of enterprises or businesses as
at the Cessation Date (the «Company Value»); and allocate such Company Value to all Shares pro rata (but deducting
any outstanding contributions (if any) into the nominal capital or premium). When calculating the Company Value, in
particular, but not exclusively, any net debt, including long term and other indebtedness, and shareholder loans (if any),
and cash shall be taken into account. In arriving at the Market Value of the Shares, the Auditors shall also take into con-
sideration to the extent they deem appropriate, which appropriateness shall be reasoned in reasonable detail in writing,
the fact that the Company is privately held and that there is no liquid market for the Shares and an amount, if any, rep-
resenting a premium for control, provided, however, that these factors shall in aggregate not result in a deduction of
more than 20%.

10.3.4. The costs and expenses of the Auditors shall be borne by the Departing Employee’s Group if the Departing

Employee is a Bad Leaver, and shall be deducted from the amount to be paid for the sold Shares.

10.4 If the price for Shares calculated in accordance with Article 10.3 exceeds Cost, the Company is entitled to re-

quest that the balance shall not be paid out, but be converted into a shareholder loan bearing an interest rate equal to
3 months LIBOR plus 100 basis points, such loan due and payable under the same conditions as apply to shareholder
loans under these Articles or an agreement amongst the Shareholders, if any. Article 10.5 shall not be affected thereby.
Any price per Share up to Cost shall be due and payable within two months following the acceptance of the Transfer
Notice in accordance with Article 10.2 above. 

10.5 Whenever the Company accepts the offer in accordance with Article 10.2, the Company shall fully repay any

shareholder loan (if any) which may have been granted to it from time to time by the Departing Employee’s Group on
behalf of the Departing Employee plus any accrued interest thereon, but excluding any shareholder loans which may
arise under Article 10.4.

10.6 If the Departing Employee is a Good Leaver or a Good Good Leaver, the Departing Employee’s Group has the

right to request from the Company (the «Purchase Request») the purchase of all, but not less than all Shares such De-
parting Employee’s Group holds in relation to such Departing Employee (the «Put Shares»). The Purchase Request must
be made in writing within a period of four months from the Cessation Date. If the Company is in receipt of the Purchase
Request within the afore-mentioned period, it is obliged to enter into or have either one or more of the parties listed
in 10.2.1 through 10.2.3 enter into a sale and purchase agreement on the Put Shares at a price per Share as follows: 

If the Departing Employee is a Good Good Leaver, the price per Share shall be as determined in the table under

Article 10.3.1 above. If the Departing Employee is a Good Leaver, the price per Share shall always be Cost.

 Art. 10.3.3, Article 10.4 and Article 10.5 shall apply mutatis mutandis. 
10.7 The Company may set-off any claim on payment the Company has against a Departing Employee against any

payment it owes to such Departing Employee’s Group under this Article 10.

10.8 Article 8.9 shall apply mutatis mutandis to any Transfers under Article 10. 

Art. 11. Board of Managers 
11.1 The Company is managed by a board of directors (the «Board of Directors») appointed as a collegial body by

the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The members of the Board
of Directors (each a «Director» or a «Board Member») need not be Shareholders. The Board of Directors shall be
composed of the number of members determined by decision of the General Meeting of Shareholders at a majority of
at least 75 % (three-quarters) of the total number of Shares then in issue and duly recorded in the minutes of such Meet-
ing and elected pursuant to the provisions of this Article 11. 

11.2 The Board Members are appointed and removed from office by decision of the General Meeting of Shareholders

at a majority of at least 75% (three-quarters) of the total number of Shares then in issue, which determines their powers
and the term of their mandates. If no term is indicated, the Directors are appointed for an undetermined period. The
Directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time
by the General Meeting at the majority set out in the preceding sentence.

11.3 The General Meeting of Shareholders shall always designate at least one Board Member as an «A Director».
11.4 In the event one or more indirect shareholders are ERISA Shareholders, each Shareholder who is a subsidiary

of such ERISA Shareholder shall have the right (but not the obligation) to propose for election by the General Meeting
of Shareholders to the Board of Directors candidates for the election of a Board Member (each an ERISA Board Mem-
ber) and the Board shall always be composed to include one of such ERISA Board Members. Such Shareholders shall
further have the right to request the removal by decision of the General Meeting of Shareholders of the Board Member
elected from such candidates. 

11.5 The ERISA Shareholder(s) may waive in part or in full (for such period of time as it determines) its right to pro-

pose candidates for Board elections as provided for herein. In the event such Shareholder(s) decide to terminate such
waiver, the Company shall within one (1) month proceed to the election of Board Members as appropriate.

Art. 12 Board Proceedings
12.1 The Board of Directors may elect a chairman among its members. 
12.2 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or

represented at a meeting (such majority to include all A Directors).

18164

12.3 Meetings of the Board of Directors shall be called by the chairman of the Board of Directors or any A Director

with at least five (5) Business Days prior notice, unless corporate affairs require a shorter notice period or for urgency
(down to 24 hours), unless all Board Members are present or represented or such convening period has been waived
by those Board members not present or represented at the relevant meeting. The convening notice may be waived by
the unanimous consent given in writing or by fax, cable, telegram, or email of all Directors. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of
the Board of Directors. 

12.4 Meetings of the Board of Directors may be held physically or, in all circumstances, by way of conference call (or

similar means of communication which permit the participants to communicate with each other). The Board of Direc-
tors may further in all circumstances take decisions by way of unanimous written resolutions. Resolutions in writing
approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions passed at a Board of Directors’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by mail, courier, electronic mail or telefax.

12.5 Any Board Member may participate in any meeting of the Board of Directors by conference-call or by other

similar means of communication allowing all Board Members taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any Director may act
at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, or telegram another Board Member as his proxy.
A Board member may represent more than one of his colleagues. 

12.6 Decisions of the Board of Directors shall be taken by the votes of the majority of the Board Members present

or represented at the relevant meeting provided that such majority must always include all A Directors. 

12.7 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the Board or an A

Director. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman of the Board or an A Director. 

Art. 13. Board Powers, Binding Signatures
13.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to

authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers
not expressly reserved by the law or by the Articles of Incorporation to the General Meeting shall be within the com-
petence of the Board of Directors. Vis-à-vis third parties the Board of Director has the most extensive powers to act
on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company not reserved by law or the Articles of Incorporation to the General Meeting or as may be otherwise provided
herein. 

13.2 The Company will be bound by the joint signature of any two Board Members, to the extent such joint signature

includes all A Directors of the Company (in the case of more than two A Directors the binding signature shall be the
joint signature of all A Directors), or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory
power shall have been delegated by the Board of Directors.

13.3 The Board may implement committees, designate the committee members, who may, but need not be Board

Members, determine the purpose of the committee, the rules applicable thereto, and delegate any of its powers to such
committees. 

 Art. 14. Board Indemnification
14.1 The Directors are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the performance of their duties.

14.2 Subject to the exceptions and limitations listed in Article 14.3. below, every person who is, or has been, a Di-

rector or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against
liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or pro-
ceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer
and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words «claim», «action», «suit» or «pro-
ceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or
threatened and the words «liability» and «expenses» shall include without limitation attorneys’ fees, costs, judgements,
amounts paid in settlement and other liabilities.

14.3 No indemnification shall be provided to any Director or officer:
14.3.1. Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross neg-

ligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

14.3.2. With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and

not in the interest of the Company; or

14.3.3. In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or

by the Board of Directors.

14.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any

Director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director
or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained
herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be
entitled by contract or otherwise under law.

Reasonable expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or

proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof
upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately deter-
mined that he is not entitled to indemnification under this Article. 

18165

Art. 15 Shareholder Decisions
15.1 Shareholders’ decisions are taken by the General Meeting of Shareholders. However, the holding of a meeting

is not compulsory as long as the number of Shareholders is less than twenty-five and in such case Shareholders’ resolu-
tions may be validly passed in writing. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company or any valid
written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. (General Meet-
ings and written resolutions shall be equivalent and any reference to a General Meeting herein, save as otherwise pro-
vided by law, shall include a reference to a written resolution)

15.2 Each Shareholder may take part in General Meetings or written resolutions. Each Shareholder has a number of

votes equal to the number of Shares he owns and may validly act at any meeting of Shareholders through a special proxy. 

15.3 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail or courier service to Shareholders to

their address appearing in the Register of Shareholders held by the Company at least 5 Business Days prior to the date
of the Meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a Meeting the Meeting may be held without
prior notice. In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their
addresses inscribed in the Register of Shareholders held by the Company at least 5 Business Days before the proposed
effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as set out
herein for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein).
Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice. 

15.4 (i) Except as otherwise provided herein, decisions of the General Meeting shall be validly adopted if approved

by Shareholders representing the majority of the total number of Shares then in issue. (ii) However, decisions concern-
ing the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing at
least three quarters (i.e. 75%) of the total number of Shares then in issue and (iii) decisions to change the nationality of
the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the Shares in issue. 

15.5 In case and for as long as the Company has more than 25 Shareholders, an annual General Meeting shall be held

on 30th June at 11:00 a.m. of each year. If such day is not a Business Day, the Meeting shall be held on the immediately
following Business Day. 

15.6 Each Shareholder hereby waives his respective rights to contest, whether in court or otherwise, shareholders

resolutions, except for the claim that such shareholders resolutions have not been passed with the respective majority
as required under these Articles. 

Art. 16 Dividends
16.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. 

16.2 The Shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the

Board of Directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried for-
ward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be
established by law, provided that any distribution may only be made pursuant to the provisions set out hereafter under
Article 16.5.

16.3 The balance may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of Shareholders pro-

vided however always that any distribution may only be made pursuant to the provisions set out hereafter under Article
16.5. The Shareholders may also decide that the balance be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.

16.4 To the extent available the share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a

General Meeting of Shareholders provided however that any distribution may only be made pursuant to provisions set
out hereafter under Article 16.5. The General Meeting of Shareholders may decide to allocate any amount out of the
share premium account to the legal reserve account.

16.5 Distribution allocation: In the case of a distribution under any of Articles 16.1 to 16.4 above, such amount shall

always be allocated (the «Distribution») to the Shareholders holding Shares pro rata according to their total sharehold-
ing in the Shares of the Company. 

Art. 17 Dissolution, Liquidation 
17.1 The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

17.2 Upon closure of the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company will be allocated to the

shareholders in the manner set out in Article 17.3. (it being understood that any prepayment of liquidation surplus dur-
ing the liquidation process shall follow the same allocation provisions). 

17.3 Surplus allocation: In the case of a distribution of liquidation surplus under Article 17.2 above, such amount (the

«Surplus») shall be allocated to Shareholders in accordance with Article 16.5. 

Art. 18 Accounting Year. The accounting year of the Company begins on 1st January of each year and ends on

31st December of the same year. The first accounting year starts on the date of incorporation of the Company and ends
on 31st December 2004. 

Art. 19 Annual Accounts, auditor. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up

by the Board of Directors.

The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 Shareholders be subject to the supervi-

sion of a statutory auditor (or to the extent the thresholds set by law are reached, an independent auditor). In such
case the statutory auditor (or independent auditor) shall be elected by the General Meeting of Shareholders. Such au-
ditor in office may be removed at any time by the General Meeting of Shareholders with or without cause. 

18166

Art. 20 Sole Shareholder. If, and as long as one Shareholder holds all the shares of the Company, the Company

shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the Company law, in this case, articles 200-1 and
200-2, among others, of the same law are applicable. 

Art. 21 Arbitration. To the extent permitted by law: 
21.1. All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with these Articles of Association in-

cluding any question regarding its existence, validity or termination («Disputes») shall be settled by an amicable effort
on the part of the Shareholders. An attempt to arrive at a settlement shall be deemed to have failed as soon as one of
the Shareholders so notifies the other Shareholders in writing.

21.2. If such an attempt fails, all Disputes shall be finally decided by an arbitration tribunal comprising three arbitrators,

in accordance with the 1998 Arbitration Rules (Schiedsgerichtsordnung) of the German Institution of Arbitration (Deut-
sche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V., DIS) without recourse to the ordinary courts. The place for arbitration
proceedings shall be Frankfurt/Main, Germany. Unless the parties otherwise agree, the procedural law of this place shall
apply where the Arbitration Rules of the German Institution of Arbitration are silent.

21.3. The Manager Partnership on one hand and the other Shareholders on the other hand shall nominate one (1)

arbitrator each to be confirmed by the German Institution for Arbitration under the applicable rules. Both arbitrators
shall agree on the third arbitrator within 30 days. If the two arbitrators fail to agree on the third arbitrator within the
above time-limit, he shall be appointed by the German Institution for Arbitration.

21.4. If there are two or more defendants, any nomination of an arbitrator by or on behalf of such defendants must

be jointly agreed between them. If such defendants fail to agree on such joint nomination within the time-limit fixed by
the German Institution for Arbitration, the proceedings against each of them must be separated.

21.5. The language to be used in the arbitration proceeding shall be English.
21.6. The arbitration court shall also decide on the liability for costs including the reimbursement of reasonable at-

torney fees.

21.7. Nothing contained in this Article 21 shall be construed to limit or preclude any action in any court of competent

jurisdiction for injunctive or other provisional relief to compel any other person to comply with its obligations under
these Articles.

<i>Third resolution

In light of the amended and restated articles of incorporation, the meeting resolved to confirm the mandates of the

existing board members and to qualify Mr Peter Gangsted as «A Director», so that the Board of Managers is composed
of:

- Mr Peter Gangsted, A Director
- Mr Guy Davison,
- Mr Christian Dosch, 
- Mrs Pascale Nutz, and
- Mr Frank-Matthias Przygodda
There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated a sixteen thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausend und vier, am einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft FASHION ONE LUXEM-

BOURG, S.à r.l. (die «Gesellschaft») eine société à responsabilité limitée gegründet als société à responsabilité limitée
gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph Elvinger am 30. September 2004, welche noch nicht im Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde. 

Die Satzung wurde zum letzten Mal durch eine Urkunde des unterzeichnenden Notar am 11. November 2004 geän-

dert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Maître Toinon Hoss, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Schriftführer Maître Maryline Esteves, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg und zum

Stimmenzähler Maître François Felten, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
1. Die vertretenen Gesellschafter sowie die Zahl der Gesellschaftsanteile ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste die

von den Bevollmächtigten, den Vorsitzenden, den Schriftführer und den Stimmenzähler und den unterzeichneten Notar
unterzeichnet wurde. Die erwähnte Liste wird mit der gegenwärtigen Urkunde bei den Behörden registriert werden.

Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich dass alle 58,073 Geschäftsanteile in der Gesellschaft vertreten sind in die-

ser Versammlung so dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tages-
ordnung beraten kann.

18167

2. Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt: 
(A) Erhöhung des Gesellschaftskapital von eine Million vierhundert und einundfünfzig tausend achthundert fünfund-

zwanzig euro auf eine Million fünfhundert sechzigtausend neunhundert fünfzig euro durch die Emission von viertausend
dreihundert fünfundsechzig (4.365) neue Anteile mit je einem Nennwert von fünfundzwanzig euro (25 EUR) und ein
totaler Emissionsagio von 982.125 EUR gegen den Beitrag in Bargeld von 1.091.250 EUR, Zeichnung der neuen Anteile
durch FASHION ONE MANAGEMENT BETEILIGUNGS GmbH &amp; Co KG und Bezahlung des ganzen Zeichnungspreises
durch einen Beitrag in Bargeld, Zuweisung von 109.125 EUR auf das Kapitalkonto der Gesellschaft, Zuweisung von
10.912.5 EUR auf das Konto der gesetzlichen Reserve und Zuweisung von dem (971.212,5 EUR) auf Emissionsagiokonto
der Gesellschaft, Emissionsagio welcher frei verfügbar ist und welcher ohne Einschränkung zum Rückkauf von Anteilen
der Gesellschaft gebraucht werden kann, folgend Änderung des ersten Abschnittes von Artikel 6 der Satzung der Ge-
sellschaft (so wie es unter Punkt 2 der Tagesordnung vorgesehen ist)

B) Änderung und Neuverfassung der Satzung der Gesellschaft wesentlich in der Form die in den Vollmächten vorge-

sehen wurde (und den oberen Beschluß unter (A) in Betracht bezogen).

(C) Bestätigung der Mandate der bestehenden Geschäftsführer und Ernennung von Herr Peter Gangsted als «Ge-

schäftsführer A».

Nach Beratung, fasst die Versammlung sodann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschloss das Gesellschaftskapital von einer Million vierhundert und einundfünfzig tausend acht-

hundert fünfundzwanzig euro (1.451.825 EUR) auf eine Million fünfhundert sechzigtausend neunhundert fünfzig euro
(1.560.950 EUR) durch die Emission von 4.365 neue Anteile mit je einem Nennwert von fünfundzwanzig euro (25 EUR)
und ein totaler Emissionsagio von 982.125 EUR gegen den Beitrag in Bargeld von 1.091.250 EUR. 

Die neuen Anteile die ausgegeben wurden, wurden gezeichnet und bezahlt von FASHION ONE MANAGEMENT BE-

TEILIGUNGS GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft mit Amtssitz in c/o Pöllath + Partner, Fünf Höfe, Kardinal-
Faulhaber -Str. 10 in 80333 München, eingetragen im Handelsregister des örtlichen Gerichts München unter Nummer
HRA 84446, hier vertreten durch Maître Toinon Hoss, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht welche dieser Urkunde
beigebogen bleibt.

Aus den eine Million einundneunzig tausend zweihundert fünfzig euro (1.091.250 EUR) die die Gesellschaft bekom-

men hat wird eine Summe von einhundert neuntausend einhundert fünfundzwanzig euro (109.125 EUR) auf das Kapital-
konto der Gesellschaft zugewiesen, eine Summe von zehntausend neunhundert zwölf Komma fünf euro (10.912,5 EUR)
auf das Konto der gesetzlichen Reserve und der Überschuss von neunhundert einundsiebzig tausend zweihundert zwölf
Komma fünf euro (971.212,5 EUR) wird auf das Emissionsagiokonto zugewiesen. Die Versammlung beschloss, dass das
Emissionsagio frei verfügbar ist und, dass er auch ohne Einschränkung zum Rückkauf von Anteilen der Gesellschaft ge-
braucht werden kann.

Der Beweis des oben erwähnten Beitrags in Bargeld an die Gesellschaft wurde dem unterzeichnenden Notar gegeben.
Folgend beschloss die Versammlung den ersten Absatz des Artikels 6 der Satzung der Gesellschaft wie folgt (gemäß

des nachstehendes zweiter Beschlusses) zu ändern:

Art. 1. Definitionen.
«A-Geschäftsführer» Der/die Geschäftsführer, welche von der Generalversammlung zum «A-Geschäftsführer» er-

nannt worden sind

«Anlegender Anteilinhaber» Jede FASHION ONE HOLDING, S.à r.l. (R.C.S. 101.878) und FASHION ONE PARTI-

CIPATIONS S.à r.l. (R.C.S. 103.912) und jeder Erwerber von Anteilen von einem Anlegenden Anteilinhaber gemäß Ar-
tikel 9.1, welcher auch ein Mitglied der Investorengruppe ist

«Anteile» Alle Anteile der Gesellschaft (parts sociales)
«Anteilinhaber» Die Halter von Anteilen an der Gesellschaft
«Anteilinhaberregister» Das von der Gesellschaft gehaltene Anteilinhaberregister, in dem insbesondere die Anteilin-

haber und deren Anteile an der Gesellschaft eingetragen sind 

«Tätigkeitsbeginn» 12. November 2004
«Schlechter Ex-Mitarbeiter» Ein Ex-Mitarbeiter, welcher die Gesellschaft oder ein Mitglied der Gesellschaftsgruppe

aufgrund (x) einer freiwilligen Kündigung oder Beendigung aus einem anderen als einem wichtigen Grund innerhalb von
acht Jahren nach Tätigkeitsbeginn verlässt; (y) eine Kündigung oder Beendigung seitens der Gesellschaft oder eines Mit-
glieds der Gruppe aus wichtigem Grund oder (z) Ablauf seines zu dem Zeitpunkt bestehenden Anstellungs- oder Dienst-
leistungsvertrages innerhalb von acht Jahren nach Tätigkeitsbeginn ohne Ersatz durch einen neuen Vertrag oder die
Erneuerung des zu dem Zeitpunkt bestehenden Anstellungs- oder Dienstleistungsvertrages, sofern dem Ex-Mitarbeiter
im Voraus angemessenerweise die Erneuerung oder die Verlängerung des zu dem Zeitpunkt bestehenden Anstellungs-
oder Dienstleistungsvertrages zu den Bedingungen (aber für denselben Zeitraum), welche in jeglicher materieller Sicht
mindestens genau so gut sind wie diejenigen des zu dem Zeitpunkt bestehenden Anstellungs- oder Dienstleistungsver-
trages. 

Falls ein Ex-Mitarbeiter die Gesellschaft oder eine Gruppengesellschaft aufgrund freiwilliger Kündigung oder Beendi-

gung aus einem anderen als einem wichtigen Grund nach dem fünften Jahrestag nach Tätigkeitsbeginn verlässt, so treten
die Gesellschaft und der Ex-Mitarbeiter in Gutglaubensverhand-lungen ein, um festzulegen, ob der Ex-Mitarbeiter eher
als Guter Ex-Mitarbeiter als Schlechter Ex-Mitarbeiter behandelt wird. 

«ERISA-Anteilinhaber» Third Cinven Fund US (N

°

 1) Kommanditgesellschaft, Third Cinven Fund US (N

°

 2) Komman-

ditgesellschaft, Third Cinven Fund US (N

°

 3) Kommanditgesellschaft, Third Cinven Fund US (N

°

 4) Kommanditgesell-

schaft und Third Cinven Fund US (N

°

 5) Kommanditgesellschaft

18168

«Ex-Mitarbeiter» (i) jedes Individuum, welches ein Mitarbeiter, ein Geschäftsführer oder ein geschäftsführender Ge-

schäfts-führer einer oder mehrerer Mitglieder der Gesellschaftsgruppe ist, welcher bereits ein Kündigungsschreiben im
Zusammenhang mit seinem Anstellungs- oder Dienstleistungsvertrag erhalten hat oder welcher aufhört, Geschäftsfüh-
rer des betreffenden Mitglieds der Gesellschaftsgruppe oder sonstwie angestellt zu sein und welcher nicht sonstwie da-
mit anfängt, einem Mitglied der Gesellschaftsgruppe weitere Dienstleistungen zu erbringen, sofern er oder sie zu diesem
Datum ein Ex-Mitarbeiter werden soll, an welchem er oder sie seine/ihre Aktivitäten für die Gruppe entweder auf Ver-
langen der Gruppe oder sonstwie, insbesondere infolge Freistellung, beendet; oder (ii) umgekehrt; sofern dieses Indivi-
duum in beiden Fällen (i) und (ii) Anteile, entweder mittelbar oder durch einen Gesellschaftsanteil an der
Kommanditgesellschaft, hält.

«Gruppe des Ex-Mitarbeiters» (i) ein Ex-Mitarbeiter, (ii) die Kommanditgesellschaft, (iii) die Rechtseinheit, Personen-

gesellschaft oder Treuhänderschaft, unter der oder durch die der Ex-Mitarbeiter und/oder eine dritte Partei Anteile an
der Gesellschaft entweder unmittelbar oder durch die Kommanditgesellschaft hält, (iv) jede andere Person, welche un-
mittelbar oder mittelbar als Rechtsnachfolger einer der Vorbezeichneten Anteile hält

«Genehmigte Erwerber» Jeder der von Zeit zu Zeit von Cinven Limited oder einem verbundenen Unternehmen im

Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes beratenden Fonds und deren Komplementäre sowie jeder der von Zeit
zu Zeit von APAX PARTNERS EUROPE MANAGERS Ltd. oder einem verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes beratenden Fonds und deren Komplementäre 

«Generalversammlung» Die mit der in der Satzung vorgesehenen erforderlichen Mehrheit beschließende General-

versammlung

«Geschäftsführung oder Geschäftsführungsausschuss» Der gemäß den Bestimmungen der Satzung bestellte Ge-

schäftsführungsausschuss 

«Geschäftstag» Ein Tag, der nicht ein Samstag oder ein Sonntag ist, an dem die Banken in Luxemburg-Stadt für die

üblichen Geschäfte geöffnet sind

«Gesellschaftsgruppe» Die Gesellschaft, jede Gesellschaft oder jedes Unternehmen, welche mittelbar oder unmittel-

bar von der Gesellschaft kontrolliert werden oder die Gesellschaft (mittelbar oder unmittelbar) kontrolliert oder von
Zeit zu Zeit der gemeinsamen Kontrolle der Gesellschaft unterliegen. «Mitglied der Gesellschaftsgruppe» hat entspre-
chende Bedeutung

«Sehr Guter Ex-Mitarbeiter» Ein Ex-Mitarbeiter, welcher die Gesellschaft oder ein Mitglied der Gesellschaftsgruppe

(x) aufgrund Altersrente infolge des Renteneintrittsalters, (y) im Todesfall oder (z) aufgrund ständiger Arbeitsunfähig-
keit, verlässt. 

«Guter Ex-Mitarbeiter» Ein Ex-Mitarbeiter, welcher weder ein Sehr Guter Ex-Mitarbeiter noch ein Schlechter Ex-

Mitarbeiter ist

«Handelsgesellschaftengesetz» Das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
«Mitglied der Investorengruppe» Jede Person, welche zur entsprechenden Zeit unter der unmittelbaren oder mittel-

baren Verwaltung einer Person, welche Private Equity Fonds verwaltet oder berät (sei es auch in der Form eines Kom-
plementärs), steht, oder jede von einem Mitglied der Investorengruppe dazu ernannte Person 

«Kosten» Der hinsichtlich des Nominalwerts einbezahlte Gesamtbetrag im Zusammenhang mit einem Anteil am Ka-

pital der Gesellschaft und jede diesbezügliche Anteilsprämie zum Zeitpunkt der Ausgabe eines solchen Anteils abzüglich
der darauf von der Gesellschaft bezahlten Pauschalabgabe

«Tätigkeitsende» Das Datum, an dem eine Person (im Sinne dieses Artikels 1) zum Ex-Mitarbeiter wird
«Kommanditgesellschaft» FASHION ONE MANAGEMENT BETEILIGUNGS GmbH &amp; Co. KG, eine im Handelsregi-

ster des örtlichen Gerichts in München unter HR A 84446 eingetragene Kommanditgesellschaft 

«Kommanditgesellschaftsvertrag» Der die Kommanditgesellschaft gründende Kommanditgesellschaftsvertrag, in sei-

ner jeweils geltenden Fassung

«Marktwert» Der gemäß Artikel 10 festgelegte Wert eines Anteils
«Cinven Limited» Cinven Limited, eine nach englischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit

Gesellschaftssitz in Pinner’s Hall. 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, und welche in England und Wales unter
der Nummer 2192937 eingetragen ist 

«Person» Jedes Individuum oder jede rechtliche Einheit jedweder Natur
«Pro-Rata-Teil» (i) die Anzahl von Anteilen des Anderen Halters, die die Summe der Anteile, die der Andere Halter

hätte übertragen können, wenn er berechtigt gewesen wäre, dieselbe von den Anlegenden Anteilinhabern (als Gruppe)
seit Tätigkeitsbeginn übertragene Prozentzahl von Anteilen zu verkaufen, einschließlich der die Tag Along oder die
Come Along auslösende Übertragung, je nachdem, sofern jede dieser Übertragungen, welche nicht einen Verkauf (wie
weiter unten definiert) darstellen, sondern sonstwie einen Verkauf (wie unten definiert) bis zur 50%-Grenze darstellen
(ii) minus der Anzahl der bereits übertragenen Anteile

«Satzung» Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in seiner jeweils geltenden Fassung
«Übertragung von Anteilen» Jede Übertragung eines oder mehrerer Anteile oder jedes mittelbare, unmittelbare oder

treuhänderische Recht oder Interesse daran, in welcher Art auch immer, einschließlich mittels Verkauf, Veräußerung,
Übertragung, Verpfändung, Hypothek, Belastung oder sonstwie; Übertragen, Übertragend oder Übertragbar haben ent-
sprechende Bedeutung

«Verbundene Übertragungen» (i) jede Anteilsübertragung, welche (im Hinblick auf das Datum dieser Übertragung)

sonstwie Teil einer Auslösenden Übertragung ist und (ii) jede Anteilsübertragung, welche gesondert vereinbart worden
ist aber im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Auslösenden Übertragung steht 

«Verbundene Unternehmen» Jede rechtliche Einheit oder Personengesellschaft, welche entweder mittelbar oder un-

mittelbar einen Anlegenden Anteilinhaber kontrolliert oder von diesem entweder mittelbar oder unmittelbar kontrol-
liert wird, gemäß §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes

18169

«Verkauf» (a) Die Anteilsübertragung in der Gesellschaft (entweder durch eine einzige Transaktion oder durch eine

Reihe von Transaktionen), die dazu führt, dass die Anlegenden Anteilinhaber (und/oder jedes oder mehrere Verbundene
Unternehmen, die als Gruppe zählen) mittelbar oder unmittelbar Anteile im Eigentum halten, die weniger als 50 Prozent
der ausübbaren Stimmrechte gewähren, Sofern diese keinen Verkauf infolge (a) einer Übertragung gemäß Artikel 9.1
und/oder an ein Verbundenes Unternehmen oder (b) jeglicher Art von Kapitalreorganisation oder ähnliches unter lu-
xemburgischem Recht oder (c) jeglicher Anteilsübertragung innerhalb eines Anteilsvertriebs-Runde, das als solches in
den an die Gesellschaft ausgehändigten Übertragungsdokumenten niedergeschrieben ist, innerhalb von 12 Monaten nach
Tätigkeitsbeginn, darstellen

«Wirtschafts-/Buchprüfer» Entweder KPMG, PWC, E&amp;Y oder DELOITTE oder jede international angesehene Invest-

mentbank

Art. 2. Firma. Es besteht zwischen den gegenwärtigen Anteilinhabern und all denjenigen Personen, welche zu einem

späteren Zeitpunkt Anteilinhaber werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit der Bezeichnung FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l. (die «Gesellschaft»). Die Gesellschaft unterliegt der vor-
liegenden Satzung und den entsprechenden Gesetzen. 

Art. 3. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen,

in welcher Form auch immer, in Luxemburg und an ausländischen Gesellschaften oder anderen Geschäftseinheiten, der
Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in welcher Form auch immer sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder
sonstwie von Wertpapieren, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldtiteln und anderen Wertpapieren jeglicher Art,
und das Eigentum, die Entwicklung und die Verwaltung des Portfolios der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann darüber
hinaus Beteiligungen an Personengesellschaften halten und ihre Geschäfte durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland
durchführen. 

Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen und Privatplazierungen für die Ausgabe von Anleihen, be-

vorzugten Anteilszertifikaten, Schuldverschreibungen oder sonstigen verbrieften Schuldtiteln tätigen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft (durch Kredite, Zuschüsse, Garantien, Sicherheiten oder sonstwie) anderen

Gesellschaften und Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung jeglicher Art hält oder Teil der Gesell-
schaftsgruppe, zu der die Gesellschaft gehört, sind oder sein werden, Unterstützung gewähren, jegliche Kontrollen und
Aufsichtsmaßnahmen vornehmen und jegliche Geschäfte tätigen, welche sie für die Erfüllung und Entwicklung ihres Ge-
genstands als nützlich erachtet. 

Letztendlich kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, technischen und finanziellen oder anderen Geschäfte, welche

unmittelbar oder mittelbar mit allen Bereichen in Verbindung stehen, tätigen, um die Erfüllung ihres Gegenstands zu er-
reichen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet. Die Lebensdauer der Gesellschaft endet

nicht durch Tod, Aussetzung der Grundrechte, Bankrott oder Insolvenz eines Anteilinhabers.

Art. 5. Sitz der Gesellschaft
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann an einen anderen

Ort im Großherzogtum Luxemburg durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber, die
in der für die Änderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beschließt, verlegt werden.

Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch Entscheidung der Geschäftsführung innerhalb der Kommune verlegt

werden. 

Die Gesellschaft kann Büros und Filialen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.
Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen, welche nach

Ansicht der Geschäftsführung die gewöhnliche Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur
Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegt werden; diese vorläufige Maßnahme hat jedoch kei-
nerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes wei-
terhin luxemburgisch bleibt. Solche vorübergehende Maßnahmen werden von der Geschäftsführung beschlossen und
jeder davon betroffenen Partei mitgeteilt.

Art. 6. Stammkapital
6.1 Das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.560.950 Euro, das in 62.438 Anteile aufgeteilt ist. Die

Anteile haben jeweils einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

6.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Anteilinhaber, der in der für die Änderung dieser

Satzung vorgesehenen Art und Weise gefasst worden ist, erhöht oder herabgesetzt und Anteile ausgegeben oder an-
nulliert werden.

6.3 Die Gesellschaft kann mit Genehmigung der Generalversammlung, welche gemäß Artikel 15.4(i) hierüber be-

schließt, ihre eigenen Anteile erwerben und halten (mittelbar oder unmittelbar).

Art. 7. Übertragung von Geschäftsanteilen
7.1 Auf jede hierin festgelegte Übertragungsbeschränkung kann durch eine Mehrheit der Anteilinhaber, welche min-

destens 75% des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentiert, verzichtet werden, es sei denn, solche Übertragungsbe-
schränkungen sind ausdrücklich gesetzlich vorgesehen.

7.2 Jede Anteilsübertragung wird stets von der Gesellschaft anerkannt und tritt nur dann in Kraft, wenn sie im Ein-

klang mit den in dieser Satzung festgelegten Bestimmungen vorgenommen wurde. Jegliche Anerkennung und/oder Ein-
tragung einer Anteilsübertragung wird gemäß den in der vorliegenden Satzung festgelegten Bestimmungen erfolgen. 

18170

7.3 Jede Anteilsübertragung wird von den Anteilinhabern, welche mindestens 75% (drei Viertel) des Stammkapitals

der Gesellschaft repräsentieren, genehmigt werden, es sei denn, es handelt sich um eine Übertragung zwischen den An-
teilinhabern gemäß Artikel 9.1 und um eine Übertragung an die Genehmigten Erwerber. 

7.4 Falls ein Anteilinhaber- oder ein ähnlicher Vertrag (falls vorhanden) zu einem solchen Zeitpunkt zwischen allen

Anteilinhabern oder Teilen der Anteilinhaber und der Gesellschaft besteht, kann jede Anteilsübertragung, zusätzlich zu
dem, was in der vorliegenden Satzung festgelegt wurde, nur an einen Erwerber erfolgen, welcher Partei eines solchen
Vertrages wird, es sei denn die Generalversammlung fasst einen abweichenden Beschluss. 

Art. 8. Tag Along und Come Along
8.1 Falls die Auswirkung einer gemäß Artikel 7, abgesehen von Artikel 9.1 und der nachfolgenden Bestimmung, vor-

genommenen Anteilsübertragung, wenn vorgenommen, einem Verkauf (wie im Artikel 1 definiert) gleich kommt («Aus-
lösende Übertragung»), so wird die Übertragung nicht durchgeführt, es sei denn:

(i) der vorgeschlagene Erwerber hat bedingungslos angeboten oder eine dritte Partei dazu gebracht, einen Pro-Rata-

Teil der anderen ausgegebenen Anteile der Gesellschaft, welche von den anderen Anteilinhabern als dem vorgeschlage-
nen übertragenden Anteilinhaber, oder von einem verbundenen Unternehmen des übertragenden Anteilinhabers oder
des vorgeschlagenen Erwerbers der Anteile, welche Gegenstand der Übertragung sind, gehalten werden (die «Anderen
Halter»), zu denselben Bedingungen wie für die Auslösende Übertragung vorgesehen (abgesehen von den nachstehen-
den Bestimmungen dieses Artikels 8.1 und des Artikels 8.8) zu erwerben und/oder

(ii) der übertragende Anteilinhaber oder, falls es mehrere davon gibt, entweder einer allein oder gemeinsam, bietet/

bieten bedingungslos an, einen Pro-Rata-Teil der ausgegebenen Anteile, welche von den Anderen Haltern unter den glei-
chen Bedingungen wie diejenigen gehalten werden, die für die Auslösende Übertragung vorgesehen sind (abgesehen von
den nachstehenden Bestimmungen dieses Artikels 8.1 und des Artikels 8.8), zu erwerben, sofern der Verkauf solcher
Anteile durch den Übertragenden Anteilinhaber, die Anderen Anteilinhaber im Rahmen der Auslösenden Übertragung
oder später, nicht zu einem Tag Along Angebot berechtigt.

Es wird stets vorausgesetzt, dass (x) im Falle einer Kombination von (i) und (ii), der Pro-Rata-Teil auf der Basis der

Gesamtzahl der zur Übertragung angebotenen Anteile zu berechnen ist und (y) der an den Anderen Halter für den Pro-
Rata-Teil insgesamt zu zahlende Kaufpreis stets die Summe der Kaufpreise darstellt, die der Andere Halter zu haben
berechtigt wäre, wenn er Anteile anteilsmäßig (pro rata) bei allen in der Definition des «Pro-Rata-Teils» erwähnten
Übertragungen vor dem und einschließlich des Verkaufs (im Sinne von Artikel 1) verkauft hätte und (z) ein gemäß (i)
und (ii) erfolgtes Angebot (das «Tag Along Angebot») im Falle der Ausübung der Anfrage gemäß Artikel 8.5 nicht erfor-
derlich ist. 

8.2 Artikel 8.1 ist auf jede von den Anlegenden Anteilinhabern nach einem Verkauf (im Sinne von Artikel 1) vorge-

nommene Anteilsübertragung entsprechend anwendbar (im Sinne von Artikel 1), soweit solche Übertragungen bis zur
50%-Grenze einen Verkauf (mutatis mutandis) darstellen. 

8.3 Jedes Tag Along Angebot erfolgt durch eine Mitteilung (die «Tag Mitteilung»), welche von dem entsprechenden

Anbieter an jeden Anderen Halter an seine im Anteilinhaberregister und der Gesellschaft angegebene Adresse versen-
det wird. Die Tag Mitteilung soll die Bedingungen des Tag Along Angebots enthalten. Jedes Tag Along Angebot bleibt
mindestens zehn Geschäftstage verbindlich, angefangen mit dem Datum der Veröffentlichung der Tag Along Mitteilung
(die «Annahmeperiode»).

8.4 Jeder Andere Halter, welcher das Tag Along Angebot anzunehmen wünscht, hat den Anbieter schriftlich über die

Annahme in Kenntnis zu setzen. Eine Kopie dieses Schriftstücks erfolgt an die Gesellschaft. Die Annahme muss die In-
formation enthalten, ob der Andere Halter das Tag Along Angebot hinsichtlich der gesamten angebotenen Anteile oder
nur Teile davon annimmt. Für den Fall, dass der Andere Halter nur einen Teil der angebotenen Anteile annimmt, ist
anzugeben, welcher Teil angenommen wird. Die Anderen Halter, welche das Tag Along Angebot bis zum Ablauf der
Annahmeperiode nicht angenommen haben, werden so behandelt, als hätten sie das Tag Along Angebot verweigert. Die
Übertragung der entsprechenden Anteile an den Anbieter gegen Zahlung des entsprechenden Betrages erfolgt innerhalb
eines (1) Geschäftstages des Anbieters, welcher die Übertragung verlangt. Der Anbieter kann in jedem Falle verlangen,
dass die betreffenden Anteile gleichzeitig mit denjenigen Anteilen, welche im Rahmen der Auslösenden Übertragung
Übertragen worden sind, Übertragen werden.

8.5 Nach Erfüllung des in den Artikeln 8.1 bis 8.4 festgelegten Verfahrens kann die Auslösende Übertragung bzw. die

Übertragung vollzogen werden (wenn man unterstellt, dass die Auslösende Übertragung oder die Übertragung gemäß
Artikel 8.2 und die Übertragung gemäß der Annahme des Tag Along Angebots durch die Anderen Halter zur gleichen
Zeit und, falls an den vorgeschlagenen Erwerbern, im gleichen Dokument vollzogen wird). 

8.6 Im Falle der oder vor der Auslösenden Übertragung hat der Übertragende Anteilinhaber (oder, falls es mehrere

Übertragende Anteilinhaber gibt, jeder von ihnen) (der «Anfragende Anteilinhaber») hierdurch das Recht, von allen an-
deren Anteilinhabern (die «Angefragten Anteilinhaber») zu verlangen, bis zu sämtliche von ihnen gehaltenen Anteile zu
Übertragen; ferner ist er (falls es mehrere sind, jeder von ihnen) berechtigt, festzulegen, ob die Übertragung entweder
auf den Anfragenden Anteilinhaber und/oder auf den vorgeschlagenen Erwerber erfolgt. In beiden Fällen erfolgt die
Übertragung unter denselben Bedingungen wie bei der Auslösenden Übertragung (abgesehen von den nachstehenden
Bestimmungen dieses Artikels 8.6 und des Artikels 8.8) (die «Anfrage»), sofern (i) der gesamte Kaufpreis stets demje-
nigen entspricht, als hätten die Angefragten Anteilinhaber ihr Tag Along Recht im Rahmen der Auslösenden Übertragung
und der Verbundenen Übertragungen hinsichtlich der gleichen Anzahl der im Rahmen der Anfrage übertragenen Anteile,
ausgeübt, und (ii) der Verkauf solcher Anteile durch den Anfragenden Anteilinhaber im Rahmen der Auslösenden Über-
tragung oder später, die Anderen Halter nicht zu einem Tag Along Angebot berechtigt. Für den Fall, dass der Übertra-
gende Anteilinhaber von den Angefragten Anteilinhabern nicht verlangt, dass sie alle von ihnen gehaltenen Anteile,
sondern nur einen Teil davon, Übertragen, so wird der Übertragende Anteilinhaber jeden Angefragten Anteilinhaber im
Pro-Rata-Verhältnis gleich behandeln. Um jeden Zweifel auszuräumen, wird der Anfragende Anteilinhaber eine Kaufop-

18171

tion (welche auf die vorgeschlagenen Erwerber der Auslösenden Übertragung übertragen werden kann) hinsichtlich die-
ser Anteile haben. 

8.7 Die Anfrage erfolgt durch die Versendung einer schriftlichen Mitteilung (die «Come Along Mitteilung») an jeden

Angefragten Anteilinhaber an seine im Anteilinhaberregister und der Gesellschaft mitgeteilten Adresse. Die Come Along
Mitteilung beinhaltet die Bedingungen der Anfrage nebst Kopien aller notwendigen Dokumente, welche von den Ange-
fragten Anteilinhabern für die Übertragung der Anteile innerhalb der Anfrage benötigt werden. Die Übertragung der
Anteile nach Ausübung der Anfrage erfolgt innerhalb von 5 Geschäftstagen, angefangen mit dem Datum des Erhalts der
Come Along Mitteilung (oder zu einem späteren Datum, wie gegebenenfalls in der Come Along Mitteilung angegeben)
und in der in der Come Along Mitteilung angegebenen Form. 

8.8 Zusätzlich zu den auf alle verkaufenden Anteilinhaber im Rahmen einer Auslösenden Übertragung ebenfalls an-

wendbaren Bedingungen kann der vorgeschlagene Übertragende berechtigterweise verlangen, dass Andere Anteilinha-
ber, welche Einzelpersonen oder Personengesellschaften sind, sich mit einer bei solchen Transaktionen nicht unüblichen
Hinterlegung einverstanden erklären.

8.9 Falls ein Angefragter Anteilinhaber seiner Verpflichtung, seine Anteile gemäß der ausgeübten Anfrage gemäß Ar-

tikel 8.6 zu übertragen, nicht nachkommt (der «Säumige Anteilinhaber»), so wird die Geschäftsführung der Gesellschaft
(oder ihr für diesen Zweck bestimmter Delegierter) ordnungsgemäß und unwiderruflich als Vertreter des Säumigen An-
teilinhabers bestellt, um alle notwendigen Dokumente auszufüllen, zu liefern und auszuüben, um für und im Namen des
Säumigen Anteilinhabers die vom Säumigen Anteilinhaber gehaltenen Anteile auf den betreffenden Erwerber im Rahmen
der Anfrage rechtmäßig zu übertragen und jegliche weiteren Maßnahmen zu ergreifen die notwendig oder dienlich sind,
um das Obengenannte auszuführen. Die Geschäftsführung wird ausdrücklich bevollmächtigt, auf das alleinige Risiko des
Säumigen Anteilinhabers für jegliche im Namen des Säumigen Anteilinhabers erhaltenen Beträge Entlastung zu erhalten
und zu erteilen und die Übertragung im Anteilinhaberregister und sonstwo, wo es notwendig ist, einzutragen. Die Ge-
sellschaft wird den Betrag (ohne Zinsen und abzüglich irgendwelcher Summen, welche der Säumige Anteilinhaber der
Gesellschaft schuldet) auf das vom Säumigen Anteilinhaber angegebene Bankkonto weiterleiten. Für den Fall, dass der
Säumige Anteilinhaber kein Bankkonto angibt, auf welches der Betrag überwiesen werden soll, so kann die Gesellschaft
den Betrag auf ein zu diesem Zweck eröffnetes Konto hinterlegen oder einen Scheck in Höhe dieser Summe an die zu-
letzt im Anteilinhaberregister angegebene oder der Gesellschaft bekannte Adresse des Säumigen Anteilinhabers zusen-
den, jeweils auf das alleinige Risiko und Kosten des Säumigen Anteilinhabers. Nach Überweisung oder Hinterlegung des
Betrages oder der Zusendung eines Schecks, wie oben beschrieben, wird weder der Säumige Anteilinhaber noch eine
andere Person (im Sinne von Artikel 1), welche ein Interesse an den gemäß der Ausübung der Anfrage übertragenen
Anteilen oder Teilen der Anteile des Säumigen Anteilinhabers hat, einen weiteren Anspruch darauf oder einen Anspruch
gegen die Gesellschaft oder gegen ihr diesbezügliches Vermögen oder hinsichtlich des Betrages haben. Durch Erwerb,
in welcher Art auch immer, von Anteilen der Gesellschaft bestätigt und akzeptiert ausdrücklich jeder Anteilinhaber die
vorliegenden Bestimmungen.

8.10 Sobald Anteile Anderer Anteilinhaber gemäß dieses Artikels 8 Übertragen werden, sind diese Anderen Anteil-

inhaber berechtigt, und gemäß Absatz 8.6 ist die Gesellschaft berechtigt, zu verlangen, dass ein Pro-Rata-Teil jeglicher
von der Gesellschaft an diesen Anderen Anteilinhabern von Zeit zu Zeit gewährten Anteilinhaber-Darlehen (falls vor-
handen), nach Ermessen der Gesellschaft entweder vollständig zurückgezahlt (einschließlich der darauf anfallenden Zin-
sen) oder auf die vorgeschlagenen Erwerber zum Nennwert (einschließlich der darauf anfallenden Zinsen) Übertragen
werden. Dabei ist davon auszugehen, dass der Pro-Rata-Teil jeder dieser Anteilinhaber-Darlehen (falls gegeben) dem
gemäß diesem Artikel 8 übertragenen Pro-Rata-Teil der Anteile der Anderen Halter entspricht. Artikel 8.9 findet ent-
sprechend Anwendung (mutatis mutandis).

Art. 9. Besondere Übertragungen
9.1 Erlaubte Übertragungen
Jede hierunter festgelegte Übertragung von Anteilen ist eine «Erlaubte Übertragung» und untersteht nicht den im

Artikel 8 (Tag Along und Come Along) festgelegten Bestimmungen.

9.1.1 Jeder Anlegende Anteilinhaber kann Anteile sowohl an jeden anderen Anlegenden Anteilinhaber als auch an ein

Mitglied der Investorengruppe Übertragen.

9.1.2 Jeder Anlegende Anteilinhaber kann innerhalb eines Jahres nach Tätigkeitsbeginn jeden Anteil im Rahmen einer

Anteilsvertriebs-Runde, welche als solche in den an die Gesellschaft ausgehändigten Übertragungsdokumenten festge-
halten wurde, übertragen.

9.1.3 Jede Übertragung von Anteilen an jeden der Genehmigten Erwerber. 
9.1.4 Jede Übertragung von Anteilen durch jeden der Genehmigten Erwerber an jeden Partner eines jeden Geneh-

migten Erwerbers oder an jede Person, welche ein mittelbares oder unmittelbares Interesse am Vermögen der Geneh-
migten Erwerber hat. 

9.1.5 Jede Übertragung durch jeden Anlegenden Anteilinhaber an jeden Direktor, einschließlich nicht geschäftsfüh-

render Direktoren, Geschäftsführer oder Mitarbeiter eines Mitglieds der Gesellschaftsgruppe oder an die Kommandit-
gesellschaft im Namen jeder der obengenannten Personen.

9.1.6 Jede Übertragung von der Kommanditgesellschaft an jeden Anlegenden Anteilinhaber und umgekehrt. 
9.1.7 Jede gemäß Artikel 10 erfolgte Übertragung, mit Ausnahme einer Übertragung gemäß 10.2.3, falls nicht ander-

weitig in diesem Artikel 9 erlaubt, und jede Übertragung, durch die unter Artikel 10.2.2 genannten Personen (im Sinne
von Artikel 1) oder Einheiten an einen Manager, Direktor, Geschäftsführer oder Mitarbeiter eines Mitglieds der Gesell-
schaftsgruppe.

9.2 Gewisse Übertragungen durch oder betreffend die Kommanditgesellschaft 
Falls (i) sich die Kommanditgesellschaft, anderswie als mit Genehmigung gemäß Artikel 7.3, aus welchen Gründen

auch immer auflöst, oder (ii) Anteile von der Kommanditgesellschaft an eine dritte Partei (einschließlich der Gesellschaf-

18172

ter der Kommanditgesellschaft), abgesehen von einer erlaubten Tag Along oder Come Along gemäß Artikel 8 oder einer
Übertragung gemäß Artikel 10, übertragen werden, oder (iii) ein Kommanditanteil an der Kommanditgesellschaft anders
als im Kommanditgesellschaftsvertrag erlaubt, Übertragen wird, so hat die Gesellschaft ein Vorkaufsrecht (x) im Falle
von (i) auf alle von der Kommanditgesellschaft gehaltenen Anteile (y) im Falle von (ii) auf solche Übertragenen Anteile
und (z) im Falle von (iii) auf solche Anteile, die der Kommanditgesellschaft-Beteiligung zuzuordnen sind und ohne Ge-
nehmigung Übertragen worden sind. Die Gesellschaft ist hierdurch stets berechtigt, alle von der Kommanditgesellschaft
oder der Person (im Sinne von Artikel 1), an welche die Anteile durch die Kommanditgesellschaft Übertragen wurden,
gehaltenen oder ihr zuzuordnenden Anteile, je nachdem, zu einem Preis zu erwerben, der dem in Artikel 10.3.1 für einen
Schlechten Ex-Mitarbeiter vorgesehenen Preis entspricht. Die Gesellschaft hat in jedem Fall hierdurch eine Kaufoption
zu den hier oben festgelegten Bedingungen hinsichtlich solcher Anteile. 

Art. 10. Übertragungen des Ex-Mitarbeiters
10.1 Falls eine Person (im Sinne von Artikel 1) ein Ex-Mitarbeiter ist oder sein wird, wird angenommen, dass die

Gruppe des Ex-Mitarbeiters am Tätigkeitsende eine Übertragungsmitteilung über den im untenstehenden Artikel 10.3
festgelegten Betrag hinsichtlich sämtlicher Anteile, die die Gruppe von Ex-Mitarbeitern im Zusammenhang mit dem Ex-
Mitarbeiter hält, sofern die Geschäftsführung nichts anderes vereinbart hat. In jedem Falle hat die Gesellschaft hierdurch
eine Kaufoption auf solche Anteile gemäß den nachfolgend festgelegten Bedingungen. 

10.2 Gemäß untenstehendem Artikel 10.3. ist die Gesellschaft nach Tätigkeitsende während 3 Monaten berechtigt,

die Übertragungsmitteilung, jeweils durch schriftliche Mitteilung an die Kommanditgesellschaft und zum im Artikel 10.3
erwähnten Preis, entweder selbst zu akzeptieren und/oder akzeptieren zu lassen:

10.2.1. durch eine Person oder Personen, die (mittelbar oder unmittelbar) den Ex-Mitarbeiter als Manager, Mitarbei-

ter, Leitender Angestellter oder Direktor der Gesellschaft (oder eines Mitglieds der Gesellschaftsgruppe) ersetzen;

10.2.2. durch eine Holding, ein Unternehmen oder eine Einheit (einschließlich eines Anlegenden Anteilinhabers) zu

Gunsten eines Ersatzmanagers oder Mitarbeiters oder eines anderen Direktors, Leitenden Angestellten, Mitarbeiters
oder Managers eines Mitglieds der Gesellschaftsgruppe; oder

10.2.3. anderweitig, wie von der Geschäftsführung bestimmt. 
10.3 Der Betrag, zu welchem jeder Anteil gemäß diesem Artikel 10 angeboten wird, wird wie folgt bestimmt: 
10.3.1. Der Preis der für die Übertragung gemäß dieses Artikels 10 anzubietenden Anteile wird unter Angabe des

Grundes, warum der Ex-Mitarbeiter ein Ex-Mitarbeiter wird, erfolgen, wie in nachstehender Tabelle dargelegt: 

10.3.2. Um den Marktwert der hierunter übertragenen Anteile zu bestimmen, kann die Gesellschaft dem Ex-Mitar-

beiter einen Preis vorschlagen, der, wenn er vom Ex-Mitarbeiter akzeptiert wird, als Marktwert gilt. Mangels einer sol-
chen Vereinbarung wird der Marktwert im Einklang mit Artikel 10.3.3 festgelegt oder, falls eine Festlegung des
Marktwerts gemäß Artikel 10.3.3 innerhalb der 6 Monate vor dem Tätigkeitsende stattgefunden hat, so kann die Gesell-
schaft festlegen, dass der Marktwert der hierunter übertragenen Anteile auf dem Anteilspreis basiert, der in dem zuletzt
festgelegten Marktwert enthalten ist.

10.3.3. Gemäß Artikel 10.3.2. ist der Marktwert der Anteile, die Gegenstand der Übertragungsmitteilung sind (die

«Übertragenen Anteile»), derselbe Marktwert der Übertragenen Anteile am Tätigkeitsende, wie von dem als Experten
und nicht als Schlichter agierenden Wirtschaftsprüfer festgelegt. Dessen Festlegung ist endgültig und für die betreffenden
Parteien verbindlich. Nach Feststellung des Marktwerts der Übertragenen Anteile wird der Wirtschaftsprüfer angewie-
sen, den Marktwert der Gesellschaft festzustellen, indem der Wirtschaftsprüfer jede allgemein akzeptierte Bewertungs-
methode von Gesellschaften oder Geschäften am Tätigkeitsende anwendet (der «Gesellschaftswert»). Der

Tätigkeitsende:

Am oder vor dem 2.
Jahrestag des Tätig-
keitsbeginns

Nach dem 2. Jahrestag
aber vor dem oder am
3. Jahrestag des Tätig-
keitsbeginns

Nach dem 3. Jahrestag
aber vor dem oder am
4. Jahrestag des Tätig-
keitsbeginns

Jederzeit nach dem 4.
Jahrestag des Tätig-
keitsbeginns

Sehr Guter Ex-

Mitarbeiter

Kosten (wie im Artikel
1 definiert)

50% Kosten (wie im Ar-
tikel 1 definiert) und
50% des höheren Be-
trages zwischen den
Kosten (wie in Artikel 1
definiert) und dem
Marktwert am Tätig-
keitsende

25% Kosten (wie im Ar-
tikel 1 definiert) und
75% des höheren Be-
trages zwischen den
Kosten (wie in Artikel 1
definiert) und dem
Marktwert am Tätig-
keitsende

100% des höheren Be-
trages zwischen den
Kosten (wie in Artikel 1
definiert) und dem
Marktwert am Tätig-
keitsende

Guter Ex-Mitar-

beiter

Der niedrigere Betrag
zwischen den Kosten
(wie im Artikel 1 defi-
niert) und dem Markt-
wert am Tätigkeitsende

50% des niedrigeren
Betrages zwischen den
Kosten (wie im Artikel
1 definiert) und dem
Marktwert am Tätig-
keitsende plus 50% des
Marktwerts am Tätig-
keitsende

25% des niedrigeren
Betrages zwischen den
Kosten (wie im Artikel
1 definiert) und dem
Marktwert am Tätig-
keitsende plus 75% des
Marktwerts am Tätig-
keitsende

100% des Marktwerts
am Tätigkeitsende

Schlechter Ex-

Mitarbeiter

Der niedrigere Betrag
zwischen den Kosten
(wie im Artikel 1 defi-
niert) und dem Markt-
wert am Tätigkeitsende

Der niedrigere Betrag
zwischen den Kosten
(wie im Artikel 1 defi-
niert) und dem Markt-
wert am Tätigkeitsende

Der niedrigere Betrag
zwischen den Kosten
(wie im Artikel 1 defi-
niert) und dem Markt-
wert am Tätigkeitsende

Der niedrigere Betrag
zwischen den Kosten
(wie im Artikel 1 defi-
niert) und dem Markt-
wert am Tätigkeitsende

18173

Wirtschaftsprüfer wird ferner diesen Gesellschaftswert allen Anteilen anteilsmäßig (Pro-Rata) zuordnen (jedoch unter
Abzug jeglicher ausstehenden Beiträge (falls vorhanden) zum Nennkapital oder für die Prämien). Bei der Bewertung des
Gesellschaftswerts werden insbesondere, aber nicht ausschließlich, alle Schulden, einschließlich langfristiger und anderer
Schulden und Anteilinhaber-Darlehen (falls vorhanden) und Barbestände berücksichtigt. Nach Feststellung des Markt-
werts der Anteile hat der Wirtschaftsprüfer, soweit er es als angemessen erachtet und die Angemessenheit ausreichend
detailliert schriftlich begründet, die Tatsachen, dass die Gesellschaft privat gehalten wird und kein liquider Markt für die
Anteile vorhanden ist sowie den eine Kontrollprämie darstellenden Betrag (falls vorhanden) zu berücksichtigen, sofern
diese Faktoren insgesamt zu einem Abzug von nicht mehr als 20% führen. 

10.3.4. Die Kosten und Ausgaben für den Wirtschaftsprüfer werden von der Gesellschaftsgruppe des Ex-Mitarbeiters

getragen, sofern der Ex-Mitarbeiter ein Schlechter Ex-Mitarbeiter ist. Ferner sind diese Kosten vom für die verkauften
Anteile zu zahlenden Betrag abzuziehen.

10.4 Falls der im Einklang mit Artikel 10.3 kalkulierte Anteilspreis die in Artikel 1 definierten Kosten übersteigt, so

ist die Gesellschaft berechtigt, zu verlangen, dass der Überschuss nicht ausgezahlt wird, sondern in ein Anteilinhaber-
Darlehen mit einem Zinssatz, der 3 Monats-Libor plus 100 Basis Punkten entspricht, umgewandelt wird, wobei ein sol-
ches Darlehen unter den gleichen Bedingungen wie denjenigen, die auf Anteilinhaber-Darlehen gemäß dieser Satzung
oder Vereinbarungen zwischen den Anteilinhabern, falls vorhanden, anwendbar sind, fällig und zahlbar wird. Artikel 10.5
ist hiervon nicht berührt. Jeder Anteilspreis bis zur Höhe der Kosten (wie im Artikel 1 definiert) ist innerhalb von 2
Monaten nach Annahme der Übertragungsmitteilung gemäß obenstehendem Artikel 10.2 fällig und zahlbar. 

10.5 Sobald die Gesellschaft das Angebot gemäß Artikel 10.2 annimmt, wird sie jegliches Anteilinhaber-Darlehen (falls

vorhanden) vollständig abzahlen, welches ihr von Zeit zu Zeit durch die Gesellschaftsgruppe des Ex-Mitarbeiters im Na-
men des Ex-Mitarbeiters gewährt wurde, nebst hierzu anfallenden Zinsen, jedoch mit Ausnahme jeglicher Anteilinhaber-
Darlehen, welche gemäß Artikel 10.4 entstehen können.

10.6 Falls der Ex-Mitarbeiter ein Guter Ex-Mitarbeiter oder ein Sehr Guter Ex-Mitarbeiter ist, so hat die Gesell-

schaftsgruppe des Ex-Mitarbeiters das Recht, den Erwerb sämtlicher aber nicht weniger als sämtliche Anteile dieser Ge-
sellschaftsgruppe dieses Ex-Mitarbeiters, die sie im Zusammenhang mit dem Ex-Mitarbeiter hält (die «Verkaufsanteile»),
zu verlangen (die «Erwerbsanfrage»). Die Erwerbsanfrage muss innerhalb eines Zeitraums von 4 Monaten nach Tätig-
keitsende schriftlich erfolgen. Falls die Gesellschaft die Erwerbsanfrage innerhalb des obengenannten Zeitraums erhält,
ist sie verpflichtet, entweder selbst einen Verkaufs-/Kaufvertrag über die Verkaufsanteile abzuschließen oder eine oder
mehrere in Artikel 10.2.1 bis Artikel 10.2.3 aufgeführten Parteien dazu zu bringen, einen solchen Vertrag abzuschließen.
Der Anteilspreis der Verkaufsanteile wird wie folgt sein:

Falls der Ex-Mitarbeiter ein Sehr Guter Ex-Mitarbeiter ist, wird der Anteilspreis wie in der obenstehenden Tabelle

unter Artikel 10.3.1 festgelegt. Falls der Ex-Mitarbeiter ein Guter Ex-Mitarbeiter ist, wird der Anteilspreis stets den Ko-
sten entsprechen. 

Artikel 10.3.3, Artikel 10.4 und Artikel 10.5 sind entsprechend anwendbar (mutatis mutandis). 
10.7 Die Gesellschaft kann jeden Zahlungsanspruch, den die Gesellschaft gegen den Ex-Mitarbeiter hat, mit einer Zah-

lung, die die Gesellschaft der Gesellschaftsgruppe des Ex-Mitarbeiters gemäß diesem Artikel 10 schuldet, verrechnen.

10.8 Artikel 8.9 ist auf jede gemäß Artikel 10 erfolgte Übertragung entsprechend anwendbar (mutatis mutandis).

Art. 11 Geschäftsführung
11.1 Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführungsausschuss (die «Geschäftsführung») verwaltet, welcher als

kollegiales Gremium von der Generalversammlung der Anteilinhaber im Einklang mit den nachfolgenden Bestimmungen
gewählt wird. Die Mitglieder der Geschäftsführung (jeweils für sich ein «Geschäftsführer» oder ein «Mitglied der Ge-
schäftsführung») müssen nicht Anteilinhaber sein. Die Geschäftsführung setzt sich aus der Anzahl der Mitglieder zusam-
men, welche durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber durch eine Mehrheit von mindestens 75%
(drei Viertel) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Gesamtzahl der Anteile gefasst und im Protokoll der Generalver-
sammlung niedergeschrieben wird. Die Mitglieder werden gemäß den Bestimmungen des Artikels 11 gewählt. 

11.2 Die Mitglieder der Geschäftsführung werden durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber, wel-

cher von einer Mehrheit von mindestens 75% (Dreiviertel-Mehrheit) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Gesamtzahl
der Anteile gefasst werden muss, bestellt und abberufen. Die Generalversammlung bestimmt auch die Befugnisse und
die Dauer der Mandate der Mitglieder. Wenn keine Dauer angegeben ist, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte
Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Wiederwahl mit oder ohne Grund
(ad nutum) jederzeit von der Generalversammlung durch die im vorangegangenen Satz angegebene Mehrheit widerrufen
werden.

11.3 Die Generalversammlung der Anteilinhaber wird jederzeit mindestens ein Mitglied der Geschäftsführung zum

«A-Geschäftsführer» ernennen.

11.4 Für den Fall, dass es sich bei einem oder mehreren unmittelbaren Anteilinhabern um ERISA-Anteilinhaber han-

delt, wird jeder Anteilinhaber, welcher eine Tochtergesellschaft eines solchen ERISA-Anteilinhabers ist, das Recht haben
(jedoch nicht die Verpflichtung), der Geschäftsführung Kandidaten für die Wahl eines Mitglieds der Geschäftsführung
zwecks Wahl durch die Generalversammlung der Anteilinhaber (jeder für sich ein ERISA- Geschäftsführer) vorzuschla-
gen. Die Geschäftsführung wird stets so zusammengesetzt sein, dass ein solcher ERISA-Geschäftsführer der Geschäfts-
führung angehört. Diese Anteilinhaber werden ferner das Recht haben, die Abberufung des aus diesen Kandidaten
gewählten Mitglieds der Geschäftsführung durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber zu verlangen. 

11.5 Der/Die ERISA-Anteilinhaber kann/können teilweise oder ganz (für den von ihm festgelegten Zeitraum) auf sein/

ihr Recht, einen Kandidaten für die hierin vorgesehene Wahl der Geschäftsführung vorzuschlagen, verzichten. Für den
Fall, dass der/die Anteilinhaber bestimmt/bestimmen, einen solchen Verzicht zu beenden, wird die Gesellschaft innerhalb
eines (1) Monats mit der Wahl der Mitglieder der Geschäftsführung beginnen.

18174

Art. 12. Verfahrensweise der Geschäftsführung
12.1 Die Geschäftsführung kann aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählen. 
12.2 Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beschließen oder handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Ge-

schäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten sind (eine solche Mehrheit schließt alle A-Geschäftsführer ein). 

12.3 Sitzungen der Geschäftsführung werden per Einberufung durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsaus-

schusses oder jeden der A-Geschäftsführer mindestens fünf (5) Geschäftstage im Voraus einberufen, es sei denn, Un-
ternehmensgeschäfte verlangen eine kürzere Einberufungsfrist oder es handelt sich um einen Notfall (dann kann jeweils
die Frist auf 24 Stunden verkürzt werden), es sei denn, alle Mitglieder der Geschäftsführung sind anwesend oder ver-
treten oder auf eine solche Einberufungsfrist wurde durch die bei der betreffenden Sitzung nicht anwesenden oder ver-
tretenen Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet. Auf das Einberufungsschreiben kann mittels Zustimmung aller
Geschäftsführer schriftlich oder per Fax, Fernschreiben, Telegramm oder E-Mail verzichtet werden. Individuelle Sitzun-
gen, welche an Ort und Zeitpunkt abgehalten werden, wie in einem von der Geschäftsführung per Beschluss gefassten
Terminplan vorgeschrieben, bedürfen keines gesonderten Einberufungsschreibens. 

12.4 Sitzungen der Geschäftsführung können in Anwesenheit oder in allen Fällen per Telefonkonferenz (oder ähnliche

Kommunikationsmittel, welche den Teilnehmern erlaubt, miteinander zu kommunizieren) gehalten werden. Die Ge-
schäftsführung kann ferner in allen Fällen einstimmige schriftliche Beschlüsse treffen. Schriftliche Beschlüsse, die von allen
Geschäftsführern genehmigt und unterschrieben sind, haben die gleiche Wirkung wie die in einer Sitzung der Geschäfts-
führung gefassten Beschlüsse. In solchen Fällen werden die Beschlüsse ausdrücklich gefasst und in einem Rundschreiben
niedergeschrieben, welches per Post, Kurier, E-Mail oder Telefax weitergeleitet wird.

12.5 Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an allen Sitzungen der Geschäftsführung per Telefonkonferenz oder

durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, um den Mitgliedern der Geschäftsführung zu erlauben, in der Sitzung
einander zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel steht der Teilnahme in Person an einer solchen
Sitzung gleich. Jeder Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung der Geschäftsführung durch schriftliche Ernennung oder Er-
nennung per Telefax, Fernschreiben oder Telegramm eines anderen Mitglieds der Geschäftsführung als sein Bevollmäch-
tigter handeln. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehr als einen seiner Kollegen vertreten. 

12.6 Beschlüsse der Geschäftsführung werden durch Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden oder

vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung gefasst, sofern eine solche Mehrheit stets alle A-Geschäftsführer ein-
schließt. 

12.7 Das Protokoll einer Sitzung der Geschäftsführung wird vom Vorsitzenden oder einem A-Geschäftsführer unter-

zeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die für juristische Verfahren oder anderweitig erstellt werden, wer-
den vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder einem A-Geschäftsführer unterzeichnet. 

Art. 13 Befugnisse der Geschäftsführung, Zeichnungsberechtigungen
13.1 Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft zu ver-

walten und alle innerhalb des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft fallenden Verfügungs- und Verwaltungshand-
lungen zu erlauben und/oder selbst vorzunehmen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich von Gesetzes wegen oder
durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung die weitestgehenden Befugnisse, in allen Fällen im Namen der Gesellschaft
zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte hinsichtlich der Gesellschaft, die nicht von Gesetzes wegen oder durch
diese Satzung der Generalversammlung oder sonstwie hierin bestimmt, vorbehalten sind, vorzunehmen, zu erlauben und
zu genehmigen. 

13.2 Die Gesellschaft wird durch die Unterschriften zweier Mitglieder der Geschäftsführung, sofern diese Unter-

schriften alle A-Geschäftsführer der Gesellschaft einschließen (im Falle von mehr als zwei A-Geschäftsführern gilt die
verpflichtende Unterschrift als gemeinsame Unterschrift aller A-Geschäftsführer), oder durch die alleinige oder gemein-
same Unterschrift einer oder mehrerer Personen, denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch die Geschäftsführung
übertragen wurde, wirksam verpflichtet.

13.3 Die Geschäftsführung kann Komitees einführen, Mitglieder des Komitees ernennen, welche nicht Mitglieder der

Geschäftsführung sein müssen, den Zweck des Komitees und die darauf anwendbaren Regeln bestimmen und jede ihrer
Befugnisse an ein solches Komitee übertragen. 

Art. 14 Die Schadloshaltung der Geschäftsführung
14.1 Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Schulden der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft

sind sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben verantwortlich.

14.2 Vorbehaltlich der im untenstehenden Artikel 14.3 aufgelisteten Ausnahmen und Beschränkungen wird jede Per-

son, die ein Geschäftsführer oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, durch die Gesellschaft im vom
Gesetz weitestgehenden erlaubten Maße von der Haftung und von allen ordnungsgemäß entstandenen Ausgaben oder
von ihm im Zusammenhang mit einem Anspruch, Handlung, Klage oder Verfahren, in welchem er als Partei oder ander-
weitig aufgrund seiner Eigenschaft als Geschäftsführer oder ehemaliger Geschäftsführer oder leitender Angestellter be-
teiligt ist, und von den durch ihn bei der diesbezüglichen Umsetzung entstandenen oder von ihm bezahlten Beträgen,
schadlos gehalten. Die Begriffe «Anspruch», «Handlung», «Klage» oder «Verfahren» finden auf alle gegenwärtigen oder
drohenden Ansprüche, Handlungen, Klagen oder Verfahren (zivilrechtlicher, strafrechtlicher oder sonstiger Art, ein-
schließlich Berufungen) Anwendung und die Begriffe «Haftung» und «Ausgaben» schließen ohne Einschränkung Rechts-
beratungsgebühren, Kosten, Urteile, für Vergleiche bezahlte Beträge und andere Haftungen ein. 

14.3 Eine Schadloshaltung wird für jeden Geschäftsführer oder leitenden Angestellten in den folgenden Fällen nicht

erfolgen:

14.3.1. Haftung der Gesellschaft oder ihrer Anteilinhaber infolge vorsätzlichen Fehlverhaltens, Bösgläubigkeit, grober

Fahrlässigkeit oder Rücksichtslosigkeit bei Erfüllung der im Rahmen seines Bereichs anfallenden Aufgaben;

18175

14.3.2. Hinsichtlich jeder Rechtssache, bei der er letztendlich verurteilt wurde, bösgläubig und gegen die Interessen

der Gesellschaft gehandelt zu haben; oder

14.3.3. Im Falle eines Vergleichs, es sei denn, der Vergleich wurde von einem Gericht der zuständigen Gerichtsbarkeit

oder von der Geschäftsführung genehmigt.

14.4 Das hierin vorgesehene Recht zur Schadloshaltung ist abtrennbar. Alle anderen Rechte, zu denen jeder Ge-

schäftsführer oder leitende Angestellte gegenwärtig oder zu einem späteren Zeitpunkt berechtigt ist, werden hiervon
nicht berührt. Dieses Recht besteht auch für die Personen weiter, welche nicht mehr Geschäftsführer oder leitende
Angestellte sind, und gilt ferner auch zugunsten von Erben, Testamentsvollstreckern und Vermögensverwaltern einer
solchen Person. Die hierin enthaltene Bestimmung wird keine Rechte auf Schadloshaltung, zu denen das Gesellschafts-
personal, einschließlich der Geschäftsführer und leitenden Angestellten durch Vertrag oder sonstwie per Gesetz be-
rechtigt sind, berühren.

Berechtigte Ausgaben, die in Verbindung mit der Vorbereitung und Vorstellung der Verteidigung eines Anspruchs,

Handlung, Klage oder Verfahren der in diesem Artikel beschriebenen Art stehen, werden von der Gesellschaft vor der
diesbezüglichen Zurverfügungstellung aber nach Erhalt der Übernahmeverpflichtung des Geschäftsführers oder in sei-
nem Namen oder im Namen des leitenden Angestellten, einen solchen Betrag zurückzuzahlen, geleistet, sofern endgültig
feststeht, dass er gemäß diesem Artikel nicht zur Schadloshaltung berechtigt ist.

Art. 15. Beschlüsse der Anteilinhaber
15.1 Beschlüsse der Anteilinhaber werden von der Generalversammlung der Anteilinhaber gefasst. Jedoch ist das Hal-

ten einer solchen Versammlung nicht bindend, solange die Anzahl der Anteilinhaber weniger als 25 beträgt. In diesem
Falle können die Beschlüsse der Anteilinhaber schriftlich gefasst werden. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung
der Anteilinhaber der Gesellschaft oder jeder ordnungsgemäße schriftliche Beschluss (je nachdem) steht für das gesamte
Gremium der Anteilinhaber der Gesellschaft. (Generalversammlungen und schriftliche Beschlüsse sind gleichwertig und
jeglicher Verweis hierin auf eine Generalversammlung, vorbehalten einer gegenteiligen gesetzlichen Bestimmung, be-
inhaltet einen Verweis auf einen schriftlichen Beschluss).

15.2 Jeder Anteilinhaber kann an Generalversammlungen oder schriftlichen Beschlüssen teilnehmen. Jeder Anteilin-

haber hat eine Anzahl von Stimmen, die der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile entspricht. Er kann durch eine be-
sondere Vollmacht an jeder Versammlung der Anteilinhaber ordnungsgemäß handeln. 

15.3 Versammlungen werden durch Einberufungsschreiben, welches per Einschreibebrief oder Kurierservice minde-

stens fünf Geschäftstage vor dem Datum der Versammlung an die im von der Gesellschaft gehaltenen Anteilinhaberre-
gister angegebenen Adressen der Anteilinhaber versandt wird, einberufen. Falls das gesamte Stammkapital der
Gesellschaft bei einer Versammlung vertreten ist, so kann die Versammlung ohne vorherige Mitteilung gehalten werden.
Im Falle schriftlicher Beschlüsse wird der Wortlaut solcher Beschlüsse an die im von der Gesellschaft gehaltenen An-
teilinhaberregister eingetragenen Adressen mindestens fünf Geschäftstage vor dem vorgeschlagenen Datum des Inkraft-
tretens der Beschlüsse versandt. Die Beschlüsse werden nach Genehmigung der hierin für gemeinsame Entscheidungen
festgelegten Mehrheit in Kraft treten (oder nach Erfüllung der Mehrheitserfordernisse, zum hierin bestimmten Datum).
Einstimmige schriftliche Beschlüsse können jederzeit ohne vorherige Mitteilung gefasst werden. 

15.4 (i) Sofern nicht hierin anderswie vereinbart, werden Beschlüsse der Generalversammlung ordnungsgemäß ange-

nommen, wenn sie von Anteilinhabern, welche die Mehrheit der Anzahl der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile
vertreten, genehmigt werden. (ii) Beschlüsse, welche jedoch die Änderung der Satzung betreffen, werden von (x) einer
Mehrheit der Anteilinhaber, (y) welche mindestens drei Viertel (d.h. 75%) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile
repräsentieren, gefasst, und (iii) Beschlüsse, die die Änderung der Nationalität der Gesellschaft betreffen, werden von
den Anteilinhabern, welche 100% der ausgegebenen Anteile repräsentieren, gefasst. 

15.5 Für den Fall, dass, und solange die Gesellschaft mehr als 25 Anteilinhaber hat, wird eine jährliche Generalver-

sammlung am 30. Juni um 11.00 Uhr eines jeden Jahres gehalten. Ist dieser Tag kein Geschäftstag, so wird die Versamm-
lung am darauffolgenden Geschäftstag gehalten. 

15.6 Jeder Anteilinhaber verzichtet hierdurch auf seine entsprechenden Rechte, Anteilinhaberbeschlüsse anzufechten,

es sei denn, es handelt sich um den Anspruch, dass solche Beschlüsse nicht mit der entsprechenden in dieser Satzung
geforderten Mehrheit gefasst worden sind. 

Art. 16. Ausschüttungen
16.1 Aus dem Nettogewinn werden fünf Prozent (5%) auf ein gesetzliches Rücklagenkonto überwiesen. Dieser Abzug

stellt dann keine Verpflichtung mehr dar, sobald diese gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des ausgegebenen
Stammkapitals der Gesellschaft beträgt. 

16.2 Die Anteilinhaber können beschließen, auf Basis der von der Geschäftsführung vorbereiteten Kontenauszüge,

welche aufzeigen, dass für die Auszahlung ausreichend Vermögen vorhanden ist, Zwischendividenden auszuzahlen. Dabei
wird davon ausgegangen, dass der auszuzahlende Betrag die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres realisierten Ge-
winne, erhöht durch die übertragenen Gewinne und auszahlbaren Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verlu-
ste und den per Gesetz vorgeschriebenen Rücklagen zuzuteilenden Summen, nicht überschreitet, sofern eine
Auszahlung nur gemäß den nachfolgend unter Artikel 16.5 festgelegten Bestimmungen erfolgt.

16.3 Der Betrag kann an die Anteilinhaber nach Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber ausgezahlt wer-

den, sofern jedoch jede Auszahlung stets nur gemäß den nachfolgenden unter Artikel 16.5 festgelegten Bestimmungen
vorgenommen wird. Die Anteilinhaber können ebenfalls beschließen, dass die Ausschüttung entweder übertragen oder
auf ein außerordentliches Rücklagenkonto überwiesen wird.

18176

16.4 Soweit vorhanden, kann das Anteilsprämienkonto nach Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber an

diese ausgezahlt werden, sofern jedoch jede Auszahlung nur gemäß den nachfolgend unter Artikel 16.5 festgelegten Be-
stimmungen vorgenommen wird. Die Generalversammlung der Anteilinhaber kann bestimmen, jeden Betrag aus dem
Anteilsprämienkonto auf das gesetzliche Rücklagenkonto zu übertragen.

16.5 Zuteilungsmodus: Im Falle einer Auszahlung gemäß einem der obengenannten Artikel 16.1 bis 16.4 wird ein sol-

cher Betrag stets dem Anteilinhaber zugeteilt (die «Auszahlung»), welcher Anteile pro Rata im Verhältnis zu dessen ge-
samten Anteilseigentum an Anteilen der Gesellschaft hält.

Art. 17. Auflösung, Liquidation 
17.1 Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, welche

von der Generalversammlung der Anteilinhaber, die die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren festlegt, bestellt
werden.

17.2 Nach Beendigung der Liquidation der Gesellschaft wird das überschüssige Vermögen der Gesellschaft den An-

teilinhabern in der im Artikel 17.3 festgelegten Art und Weise zugeteilt (dabei wird davon ausgegangen, dass jegliche
Vorzahlung des Liquidationsüberschusses während des Liquidationsverfahrens denselben Zuteilungsbestimmungen
folgt). 

17.3 Zuteilung des Überschusses: Im Falle der Auszahlung des gemäß obenstehenden Artikel 17.2 Liquidationsüber-

schusses, wird dieser Betrag (der «Überschuss») den Anteilinhabern im Einklang mit Artikel 16.5 zugeteilt.

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am

31. Dezember desselben Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungsdatum der Gesellschaft und endet am
31. Dezember 2004. 

Art. 19. Jahresberichte, Wirtschaftsprüfer. Die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr zum Ende des Geschäfts-

jahres den Jahresbericht. 

Die Geschäfte der Gesellschaft werden, sofern die Gesellschaft mehr als 25 Anteilinhaber zählt, Gegenstand der Auf-

sicht eines Buchprüfers (oder sofern die per Gesetz festgelegten Bedingungen erfüllt sind, eines Wirtschaftsprüfers) sein.
In einem solchen Falle wird der Buchprüfer (oder der Wirtschaftsprüfer) von der Generalversammlung der Anteilinha-
ber gewählt. Ein bestellter Prüfer kann jederzeit durch Angabe eines Grundes oder grundlos durch die Generalversamm-
lung der Anteilinhaber abberufen werden.

Art. 20. Einziger Anteilinhaber. Falls und solange ein einziger Anteilinhaber alle Anteile der Gesellschaft hält,

wird die Gesellschaft als eine Ein-Mann-Gesellschaft gemäß Artikel 179 (2) des Handelsgesellschaftengesetzes existieren.
In diesem Falle sind, unter anderem, die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes anwendbar.

Art. 21. Schiedsverfahren. Soweit vom Gesetz gestattet:
21.1 Alle aus oder in Verbindung mit dieser Satzung, einschließlich jeder Fragestellung hinsichtlich ihres Bestehens,

ihrer Gültigkeit oder Beendigung, entstehenden Streitigkeiten, Widersprüche oder Differenzen («Streitigkeiten») wer-
den seitens der Anteilinhaber freundschaftlich beigelegt. Der Versuch einer Beilegung gilt dann als gescheitert, sobald
einer der Anteilinhaber die anderen Anteilinhaber darüber schriftlich informiert. 

21.2 Falls ein solcher Versuch scheitert, werden alle Streitigkeiten von einem mit drei Schiedsrichtern besetzen

Schiedsgericht gemäß der Schiedsgerichtsordnung von 1998 der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.
(«DIS»), ohne Regressmöglichkeit bei den ordentlichen Gerichten, endgültig entschieden. Ort des Schiedsverfahrens ist
Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland. Soweit die Parteien nichts anderes vereinbaren, werden Lücken der
Schiedsgerichtsordnung der DIS durch das lokale Prozessrecht geschlossen. 

21.3 Die Kommanditgesellschaft einerseits und die anderen Anteilinhaber andererseits werden ein (1) jeweils von der

DIS gemäß den anwendbaren Gesetzen bestätigten Schiedsrichter ernennen. Beide Schiedsrichter einigen sich innerhalb
von 30 Tagen auf den dritten Schiedsrichter. Falls die beiden Schiedsrichter sich innerhalb dieses Zeitraums auf den drit-
ten Schiedsrichter nicht einigen können, so wird dieser von der DIS bestellt. 

21.4 Falls es zwei oder mehrere Beklagte gibt, wird jede Bestellung eines Schiedsrichters durch diese oder im Namen

dieser Beklagten untereinander vereinbart. Falls sich diese Beklagten innerhalb des von der DIS vorgegebenen Zeitraums
nicht auf eine gemeinsame Ernennung einigen können, so werden die Verfahren gegen jeden von ihnen abgetrennt. 

21.5 Die im Schiedsverfahren anwendbare Sprache ist Englisch. 
21.6 Das Schiedsgericht wird auch über die Kosten, einschließlich der Rückerstattung angemessener Rechtsanwalts-

honorare, entscheiden. 

21.7 Nichts in diesem Artikel 21 ist dahingehend aufzufassen, eine Antragstellung für eine einstweilige Verfügung oder

eine Unterlassungsverfügung zu beschränken oder auszuschließen, um jede andere Person dadurch zu zwingen, ihren
Verpflichtungen gemäß dieser Satzung nachzukommen.

<i>Zweiter Beschluss

In Betracht der ergänzte und neu formulierte Satzung der Gesellschaft die Versammlung beschloss die Mandate der

bestehenden Geschäftsführer zu bestätigen und Herr Peter Gangsted als «Geschäftsführer A» zu ernennen.

18177

sodass die Geschäftsführung wie folgt zusammengesetzt ist: 
- Herr Peter Gangsted, Geschäftsführer A
- Herr Guy Davison,
- Herr Christian Dosch, 
- Frau Pascale Nutz, und
- Herr Frank-Matthias Przygodda
Kein anderer Punkt war auf Tagesordnung sodass die Sitzung geschlossen wurde.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten und Gebühren aus jeweiligen Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Ka-

pitalerhöhung erwachsen sind, auf ungefähr sechzehn tausend Euro zu schätzen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maß-
gebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie anfangs erwähnt.
Und nach Vorlesung dieser Urkunde an die Komparenten, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unter-

schrieben.

Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2004, vol. 429, fol. 100, case 4. – Reçu 10.912,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt. 

(005738.3/242/1268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.425. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005741.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

ALBI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 52.094. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004944.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Mersch, den 12. Januar 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 janvier 2005.

H. Hellinckx.

Signature.

18178

TELLURIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 85.719. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2004 

Les actionnaires, réunis, au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, le 20 décembre 2004, ont décidé, à

l’unanimité de prendre les résolutions suivantes: 

La démission des administrateurs: 
- Monsieur Walter Brugnoni, employé privé, demeurant à F-54680 Errouville, 27, rue des Acacias, 
- Monsieur Mauro Tacchi, employé privé, demeurant à F-57390 Russange, 18, rue Anatole France, 
- Monsieur Alain Bales, employé privé, demeurant à L-3713 Rumelange, 20, rue J.-P. Bausch, 
- Monsieur Jean-Noël Ferry, employé privé, demeurant à L-4423 Soleuvre, 6, rue des Erables. 
est acceptée. 
Pleine et entière décharge leur est donnée pour l’exercice de leurs mandats. 
Sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale Annuelle de 2007: 

- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt, 

- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, 
- Monsieur Georges Gredt, comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt. 
Les nouveaux administrateurs déclarent accepter leurs mandats. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004881.3/3083/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

LIBELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.201. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du mercredi 4 février 2004, que l’assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante: 

<i>Cinquième résolution 

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

30 juillet 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer, pour un terme
de 1 (un) an, les Administrateurs suivants: 

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration; 

- Monsieur Mirko la Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur; 

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur. 

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2003. 

L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., en qualité

de Commissaire et décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société MEVEA S.à r.l., 6-12, place d’Armes L-
1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire. 

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005102.3/043/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Le Conseil d’Administration 
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateurs 

18179

CGD LUXEMBURGO, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.254. 

DISSOLUTION

<i>Extrait 

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 29

décembre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 janvier 2005, volume 891, folio 16, case 3, que la société ano-
nyme «CGD LUXEMBURGO», ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 62.254, constituée suivant acte du notaire soussi-
gné, en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 80 du 6 février 1998, dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois, suivant décision des actionnaires prise en assemblée générale annuelle, tenue en date du 21 mars
2001, un extrait de ladite assemblée a été publié au Mémorial C numéro 252 du 14 février 2002, au capital social de
soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), divisé en trente mille (30.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR) par action, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire
unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme «CGD LUXEMBURGO», prédésignée. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 janvier 2005.

(004900.4/239/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

CSN EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.478. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of December
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg

There Appeared:

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, a listed public company incorporated and governed by the laws of Brazil,

with registered office at Rua São José, n

°

. 20, sala 1602, Rio de Janeiro, RJ, registered with the Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica of the República Federativa do Brasil under number 33.042730/0001-04 listed on the São Paulo and New
York Stock Exchange, under the quote sign SID

here represented by Mrs. Cornelia Mettlen, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, 

by virtue of a proxy under private seal given in São Paulo, Brazil, on December 29, 2004
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing person, represented as stated hereabove, requested the notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of a Company incorporated and existing under the laws of the Cayman

Islands under the name CSN EXPORT CO. (the «Company»), in process of de-registration, with registered office at c/
o Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

II. The authorised capital of the company is fixed at two million United States Dollars (USD 2,000,000) divided into

two million (2,000,000) shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each. 

III. The issued share capital of the Company is currently fixed at one million five hundred ninety-seven thousand six

hundred ninety United States Dollars (USD 1,597,690.-) represented by one million five hundred ninety-seven thousand
six hundred ninety (1,597,690) shares of one United States Dollars (USD 1.-) each, entirely paid-in.

IV. The resolutions of the shareholder of the Company taken on December 23, 2004, which resolved, among others, 
a. to transfer the registered seat and the administrative and actual effective management seat of the Company by way

of continuation and without any dissolution from Grand Cayman in the Cayman Islands to Münsbach, Grand Duchy of
Luxembourg; 

b. to set the date of effectiveness of the said transfer from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg

as at December 29, 2004;

are fully ratified. The minutes of said resolutions of the sole shareholder after signature ne varietur by the proxyhold-

er of the appearing person and the notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxy, to be
filed at the same time with the registration authorities. 

V. The registered office and the administrative and actual effective management seat of the Company is hereby trans-

ferred by way of continuation and without any dissolution from George Town (Grand Cayman, Cayman Islands) to
Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with effect on December 29, 2004, and the simultaneous transformation of
CSN EXPORT Co. into a company of Luxembourg nationality. 

VI. The Company will be submitted to Luxembourg laws as a legal entity situated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Pour extrait conforme
J.-J. Wagner 
<i>Notaire

18180

VII. The Company adopts the form of a «société à responsabilité limitée».
VIII. The Company shall continue to operate under the Name CSN EXPORT, S.à r.l.
IX. The address of the registered office is fixed at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Lux-

embourg.

X. The officers of the Company, being the president, the treasurer and the secretary of the Company resigned from

their office with effect as at December 29, 2004. 

XI. The appearing person, in quality as the sole shareholder of the Company, is the person responsible to enact all

administrations matters pertaining to the change of domicile of the Company from the Cayman Islands to Luxembourg. 

XII. The authorized share capital fixed at two million United States Dollars (USD 2,000,000) divided into two million

(2,000,000) shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each is hereby revoked. 

XIII. The Sole Shareholder resolved to increase the Company’s share capital by ten United States Dollars (USD 10)

in order to raise it from its present amount of one million five hundred ninety-seven thousand six hundred ninety United
States Dollars (USD 1,597,690.-) to one million five hundred ninety-seven thousand seven hundred United States Dol-
lars (USD 1,597,700.-) by the creation of ten shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each. 

<i>Subscription - Payment

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL, prenamed, duly represented by its proxyholder, declares to subscribe

to the ten (10) new shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each and to pay them up fully
by incorporation of an amount of ten United States Dollars (USD 10.-) of the Earnings of the year of the Company into
the capital.

XIV. The Sole Shareholder resolves to convert the one million five hundred ninety-seven thousand seven hundred

(1,597,700) shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each into thirty-one thousand nine hun-
dred and fifty four (31,954) shares of nominal par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, per a conversion
rate of fifty (50) shares of nominal par value of one United States Dollars (USD 1.-) each into one new share of nominal
par value of fifty United States Dollars (USD 50.-), so that the subscribed share capital remains fixed at one million five
hundred ninety-seven thousand seven hundred United States Dollars (USD 1,597,700.-) represented by thirty-one thou-
sand nine hundred and fifty four (31,954) shares of nominal par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each,
entirely paid in.

XV. All the assets and all the liabilities of the Company previously of Cayman nationality, without limitation, remain

the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own all the assets and continues to be
obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously of Cayman nationality.

XVI. The sole shareholder resolves to approve the report established on December 29, 2004, by the independent

auditor, ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, having its registered office in
Luxembourg in charge with the valuation of the company, which concludes as follows:

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets

and liabilities of the Company, which corresponds at least to the shareholders’ equity of the Company (’000) USD
29,605 and hence its subscribed share capital of (’000) USD 1,598 and its profits for the year of (’000) USD 28,007.

Said report, after having been signed ne varietur by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

XVII. The Company proceeds with a total restatement of its Articles of Association in order to bring them in con-

formity with Luxembourg laws, which shall henceforth be worded as follows:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The object of the Company consists of: 
- granting loans or borrowing in any form with or without security and raising funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convertible or not, the
use of financial derivatives or otherwise;

- holding participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage, as well

as develop these participations; 

- acquiring any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner

participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any
company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or enterprise);

- purchasing and selling of steel and related products, and consequently entering enter into any types of agreements

for the purchase and sale of steel and related products; 

- generating receivables for these products and selling such receivables to any related or unrelated companies for a

consideration in either cash or nature, and consequently entering enter into any types of agreements for generating and
selling these receivables;

The company may moreover carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the

public. 

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it

may deem useful in the accomplishment and development of it purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name CSN EXPORT, S.à r.l. 

18181

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schüttrange)
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at one million five hundred ninety-seven thousand seven hundred United States

Dollars (USD 1,597,700.-) represented by thirty-one thousand nine hundred and fifty four (31,954) shares of nominal
par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, entirely paid in. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

The managers need not to be shareholders. The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the sole

shareholder of the Company.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature

of two managers, with necessarily the signature of one category A and one category B manager. 

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the board of manager can validly deliberate in the presence of at least a majority of

category A managers and one category B manager. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the
majority of the managers present or represented at the meeting, with necessarily a simple majority in each category of
managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers to be held in Luxembourg by telephone

or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting.

Art. 13. The manager or the board of managers assumes, by reason of his/its position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by him/it in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular res-

olutions, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolutions.

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year.

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the manager or the board

of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

18182

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends under

the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers showing that sufficient retained profits

are available for distribution. If desired, these interim accounts may be reviewed by an independent professional;

- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

XVIII. The current Directors of the Company remain in place as Category A managers of the company. 
XIX. The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as Category B manager of the Company, with

immediate effect and for unlimited duration:

- Mr Dominique Ransquin, company manager, born on September 4, 1951 in Namur (Belgium), residing at 25, route

de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

- Mr Romain Thillens, company manager, born on October 30, 1952 in Wiltz (Grand Duchy of Luxembourg), residing

at 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg.

XX. The Sole Shareholder therefore acknowledges that the board of managers of the company is composed as fol-

lows:

Category A managers
- Mr Vasco Augusto Pinto Da Fonseca Dias Junior, Business person, born on December 25, 1956 in Vassouras, State

of Rio de Janeiro, Brazil, with professional address at Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

andar, Torre I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900

- Mr Otavio De Garcia Lazcano, Business person, born on June 9, 1969 in Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro,

Brazil with professional address at Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

 andar, Torre I,

Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900

- Mr Marcos Marinho Lutz, Business person, born on December 30, 1969 in São Paulo, State of São Paulo, Brazil, with

professional address at Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

 andar, Torre I, Itaim Bibi, São

Paulo, SP, Brazil 04543-900

- Mr Lauro Henrique Campos Rezende, Business person, born on July 15, 1962 in Rio de Janeiro, State of Rio de

Janeiro, Brazil, with professional address at Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

 andar,

Toore I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900I

- Mr Nelson Geraldo Silva Da Cunha, Business person, born on August 31, 1950 in Rio de Janeiro, State of Rio de

Janeiro, Brazil, with professional address at Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

 andar,

Torre I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brazil 04543-900I

Category B managers
- Mr Dominique Ransquin, company manager, born on September 4, 1951 in Namur (Belgium), residing at 25, route

de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

- Mr Romain Thillens, company manager, born on October 30, 1952 in Wiltz (Grand Duchy of Luxembourg), residing

at 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Estimate of equity value of the Company

For registration purposes, the amount of USD 1,597,690.- United States dollars is estimated being the equivalent of

EUR 1,175,000 Euros

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at 14,000 Euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

18183

A Comparu:

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, une société cotée en bourse constituée et régie par les lois du Brésil,

avec siège social à Rua São José, n. 20, sala 1602, Rio de Janeiro, RJ, inscrite au Cadastre National des Personnes Morales
de la République Fédérale du Brésil sous le numéro 33.042730/0001-04 cotée en bourse de São Paulo et de New York
Stock sous le signe SID

ici représentée par Cornelia Mettlen, employée, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, en vertu d’une procuration donnée sous seing privée à São Paulo, Brésil, le 29 décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée d’une société constituée et existante selon le droit des Iles Cayman sous la

dénomination de CSN EXPORT CO. (la «Société»), en procédure de désinscription, avec siège social au c/o Walkers
SPV Limited, PO Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman.

II. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux millions de Dollars Américains (USD 2.000.000) divisé en deux

millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1.-) chacune. 

III. Le capital social libéré de la Société est actuellement fixé à un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent

quatre-vingt-dix Dollars Américains (USD 1.597.690,-) représenté par un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille
six cent quatre-vingt-dix (1.597.690) actions d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) chacune. 

IV. Les résolutions de l’associée de la société prises le 23 décembre 2004, qui décident, entre autres, 
a. de transférer le siège social et le siège de direction effective de la société par voie de continuation et sans dissolu-

tion de Grand Cayman, Iles Caymans, à Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg;

b. de fixer la date d’effet dudit transfert des Iles Caymans au Grand-Duché de Luxembourg au 29 décembre 2004;
sont entièrement ratifiées. Une copie du procès-verbal desdites résolutions de l’actionnaire unique, après avoir été

signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour
être enregistrée avec elles.

V. Le siège social et le siège de direction effective de la Société sont transférés par voie de continuation et sans dis-

solution de George Town (Grand Cayman, Iles Cayman) à Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 29
décembre 2004, avec transformation simultanée de CSN EXPORT Co. en une société de nationalité luxembourgeoise.

VI. La Société est soumise au droit luxembourgeois comme toute personne morale située au Grand-duché de Luxem-

bourg. 

VII. La Société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée.
VIII. La Société continuera dorénavant à exister sous la dénomination sociale CSN EXPORT, S.à r.l.
IX. L’adresse du siège social de la société est fixée au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de

Luxembourg.

X. Les agents de la Société, étant le président, le trésorier et le secrétaire de la Société ont démissionnés de leurs

fonctions avec effet au 29 décembre 2004. 

XI. La comparante, en qualité de seule associée de la Société, est la personne responsable pour le règlement de toutes

les formalités administratives relatives au changement de domicile de la Société des Iles Cayman au Luxembourg.

XII. Le capital autorisé fixé à deux millions de Dollars Américains (USD 2.000.000) divisé en deux millions (2.000.000)

d’actions d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) chacune est par la présente annulé. 

XIII. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de dix Dollars Américains (USD

10,-) pour le porter de son montant actuel de un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix
Dollars Américains (USD 1.597.690,-) à un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent Dollars Américains
(USD 1.597.700,-) par la création de dix nouvelles par sociales dune valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1)
chacune. 

<i>Souscription - Libération

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL, préqualifiée, représentée par son mandataire, déclare souscrire aux dix

(10) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1,-) chacune et de les payer intégra-
lement par l’allocation d’un montant de dix Dollars Américains (USD 10,-) des profits de l’année de la société au capital. 

XIV. L’associée unique décide de convertir les un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent (1.597,700)

parts sociales de un Dollar Américain (USD 1,-) chacune en trente et un mille neuf cent cinquante quatre (31,954) parts
sociales d’une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune, suivant un taux de conversion de
cinquante parts sociales d’une valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1,-) chacune en une nouvelle part sociale
d’une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,-), de telle sorte que le capital souscrit reste fixé à un
million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent Dollars Américains (USD 1.597.700,-) représenté par trente et
un mille neuf cent cinquante quatre (31,954) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD
50,-) chacune, entièrement libérées.

XV. Tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité des Iles Cayman restent sans limitation et

dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continuera à être propriétaire de tous les actifs
et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment de nationalité des Iles Cayman.

XVI. L’assemblée générale décide d’approuver le rapport émis le 29 décembre 2004 par ERNST &amp; YOUNG TAX

ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg en charge de l’évaluation
de la Société, lequel conclut comme suit:

18184

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets

and liabilities of the Company, which corresponds at least to the shareholders’ equity of the Company (’000) USD
29,605 and hence its subscribed share capital of (’000) USD 1,598 and its profits for the year of (’000) USD 28,007.

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent

acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

XVII. La Société procède à une refonte complète de ses statuts pour les mettre en conformité avec le droit luxem-

bourgeois, lesquels auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts »), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet de
- prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émettre des titres, des obligations, des

billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser des instruments financiers dérivés
ou autres;

- prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations;

- acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière,

participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur fournir toute
assistance (que la Société ait ou n’ait pas de participation dans telle société ou entreprise);

- acheter et vendre de l’acier et tous produits dérivés, et par conséquent conclure tout type de contrat pour l’achat

et la vente d’acier et produits dérivés; 

- émettre des créances pour ces produits et vendre ces créances à n’importe quelle société, liée ou non, en consi-

dération de liquidités ou de biens en nature, et par conséquent conclure tout type de contrats pour l’émission et la vente
de ces créances.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination CSN EXPORT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schüttrange).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent Dollars Américains (USD

1.597.700,-) représenté par trente et un mille neuf cent cinquante quatre (31,954) parts sociales d’une valeur nominale
de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. 

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont nommés et révocables ad nutum par l’associé uni-

que de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société est valablement engagée vis à vis des tiers par la signature de son gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée vis à vis des tiers par les signatures conjointes de

deux gérants, avec obligatoirement la signature d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

18185

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés avec obligatoirement une majorité dans chaque catégorie de gérants. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil à tenir au Luxembourg par conference

call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

Art. 13. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être adoptées par

voie de résolutions circulaires, le texte desquelles devra être envoyé à tous les associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par télégramme, télex, téléfax ou e-mail. Les associés émettront leur vote par la signature du
procès-verbal des résolutions circulaires. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou le conseil

de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement de dividen-

des intérimaires sous les conditions suivantes:

- Les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou par le conseil de gérance, montrant que des bénéfices repor-

tés suffisants sont disponibles pour distribution. Si désiré, ces comptes intérimaires peuvent être revus par un profes-
sionnel indépendant;

- Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne

sont pas menacés. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
XVIII. Les gérants actuels de la société restent en place en qualité de gérants de catégorie A de la Société. 
XIX. L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de catégorie B de la société,

avec effet immédiate et pour une durée illimitée: 

- Mr Dominique Ransquin, administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), résidant au 25,

route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

- Mr Romain Thillens, administrateur de sociétés, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg),

résidant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

XX. L’associé unique reconnaît donc que le conseil de gérance le la société est composé comme suit:

Gérants de catégorie A
- M. Vasco Augusto Pinto Da Fonseca Dias Junior, home d’affaire, né le 25 décembre 1956 à Vassouras, état de Rio

de Janeiro, Brésil, avec adresse professionnelle au Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

andar, Torre I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-900;

- M. Otavio De Garcia Lazcano, homme d’affaire, né le 9 juin 1969 à Rio de Janeiro, état de Rio de Janeiro, Brésil,

avec adresse professionnelle au Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

 andar, Torre I, Itaim

Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-900;

- M. Marcos Marinho Lutz, home d’affaire, né le 30 décembre 1969 à São Paulo, état de São Paulo, Brésil, avec adresse

professionnelle au Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

 andar, Torre I, Itaim Bibi, São Pau-

lo, SP, Brésil 04543-900;

18186

- M. Lauro Henrique Campos Rezende, home d’affaire, né le 15 juillet 1962 à Rio de Janeiro, état de Rio de Janeiro,

Brésil, avec adresse professionnelle au Condominio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

 andar, Toore

I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-900I;

- M. Nelson Geraldo Silva Da Cunha, homme d’affaire, né le 31 août 1950 à Rio de Janeiro, état de Rio de Janeiro,

Brésil, avec adresse professionnelle au Condomínio Edificio São Luiz, av. Juscelino Kubistcheck, 1830/ 13

°

 andar, Torre

I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-900I;

Gérants de catégorie B
- Mr Dominique Ransquin, administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), résidant au 25,

route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mr Romain Thillens, administrateur de sociétés, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg),

résidant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Estimation de la valeur nette de la société

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de 1.597.690 Dollars Américains est estimé être l’équivalent de

1.174.100 Euros.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ quatorze mille Euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 146S, fol. 75, case 12. – Reçu 11.740,81 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006289.3/211/442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

MAAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.783. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 19

mars 2004 que: 

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes: 

- Monsieur Christian Jacquemoud, avocat, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève. 
- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal

L-2249 Luxembourg. 

- Madame Catherine Schorderet, employée privée, élisant domicile au 2, rue Bellot, CH-1206 Genève. 
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005. 
Son mandat étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante: 
LUX AUDIT REVISION S.à r.l., ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005. 
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 19 mars 2004 que: 

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le

19 mars 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège so-
cial, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué». 

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,-
EUR) ou la contre valeur en devise) et sous la réserve de la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant quin-
ze mille euros (15.000,- EUR), ainsi que tous les actes relevant de l’achat, la vente de et l’hypothèque de biens ainsi que
toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005015.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

J. Elvinger.

Pour inscription 
Signature

18187

AMELL INTERNATIONAL LUX. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.870. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00145. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004989.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

FRUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.077. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03636, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005131.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

GEODESIA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.320. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue extraordinairement le 30 décembre 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009: 

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, Président du conseil d’administration; 

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg; 

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg. 

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009: 

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02515. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005095.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire 
Signatures

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

18188

BALLARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.997. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes révoqué Franck Mc Carroll demeurant à Du-

blin, Irlande. La société LUXOR AUDIT S.à r.l. dont le siège est situé au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été
nommée nouveau commissaire aux comptes pour une période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004993.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.748. 

<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 23 décembre 2004

 Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Gerhard Biasi de ses fonctions d’Administrateur avec

effet au 1

er

 janvier 2005.

 Il accepte la cooptation de Monsieur Paul Dart en remplacement de celui-ci comme administrateur jusqu’à ratification

lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.  

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005190.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

BAIXAS FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.841. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

Signature.

Signature 
<i>Un mandataire 

18189

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00143. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004996.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

TELEMATICA BEDRIJVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 62.724. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes révoqué Franck Mc Carroll demeurant à Du-

blin, Irlande. La société LUXOR AUDIT S.à r.l. dont le siège est situé au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été
nommée nouveau commissaire aux comptes pour une période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00142. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004998.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

TRIO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.089. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005003.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

18190

THE NAVIGATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.796. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes révoqué Franck Mc Carroll demeurant à Du-

blin, Irlande. La société LUXOR AUDIT S.à r.l. dont le siège est situé au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été
nommée nouveau commissaire aux comptes pour une période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005000.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

GUSTAV 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.085. 

L’adresse de Monsieur Eric Assimakopoulos est dorénavant fixée au 5485 Ashton Lake Drive, Sarasota Florida 34231,

United States of America.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005335.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

AMIKABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 53.575. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes révoqué Franck Mc Carroll demeurant à Du-

blin, Irlande. La société LUXOR AUDIT S.à r.l. dont le siège est situé au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été
nommée nouveau commissaire aux comptes pour une période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

Signature.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

18191

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005026.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

VERDIAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 64.738. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005006.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

BEECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 50.885. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes révoqué Franck Mc Carroll demeurant à Du-

blin, Irlande. La société LUXOR AUDIT S.à r.l. dont le siège est situé au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été
nommée nouveau commissaire aux comptes pour une période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005029.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

Signature.

 

Signature.

18192

VINCAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 85.189. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005018.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

WEMAES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 81.432. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat. 

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-

Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00137. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005021.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Farmipart S.A.

Alexandre Loc., S.à r.l.

Mille-Services Luxembourg, S.à r.l.

Wawelux Logistics S.A.

Corsica Paradise S.A.

Scania Luxembourg S.A.

Les Thermes du Beauregard S.A.

Leruth Réalisations S.A.

Moog Hydrolux

Almeezan Luxembourg, S.à r.l.

Expandos S.A.

Key Plastics Europe, S.à r.l.

Blumenthal, S.à r.l.

Rain Man S.A.

St. George’s School, S.à r.l.

Cornel, S.à r.l.

Bergon S.A.Holding

Bergon S.A.Holding

Gadd Capital Management Ltd (Luxembourg Branch)

Société Financière Industrielle S.A.

Fashion One Luxembourg, S.à r.l.

Fashion One Luxembourg, S.à r.l.

Albi Finance S.A.

Telluris S.A.

Libelle S.A.

CGD Luxemburgo

CSN Export, S.à r.l.

Maat S.A.

Amell International Lux. S.A.

Frust Holding S.A.

Geodesia

Ballard Holding S.A.

HVB Alternative Program Index

Baixas Finance Holding S.A.

Telematica Bedrijven S.A.

Trio Invest S.A.

The Navigation Company S.A.

Gustav 1, S.à r.l.

Amikaba S.A.

Verdiam Holding S.A.

Beech International S.A.

Vincal Invest S.A.

Wemaes Investments S.A.