This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
10849
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 227
14 mars 2005
S O M M A I R E
21 Tech. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10884
Gesmat S.A., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10894
Albrida S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10885
GKV Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10882
Autoétoile, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10890
Gottschol Alcuilux S.A., Eselborn . . . . . . . . . . . . . .
10886
Baltar Invest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
10880
Happy Relations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
10893
Belim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10884
Hostellerie de la Bonne Auberge S.A., Hobscheid
10895
Bohman Finance Holding S.A.H., Luxemburg . . . .
10883
I.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10889
CDC SP S.A., Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10889
Immocar, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .
10889
CEP II Top Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
10880
Indigo Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
CEREP Ivry Seine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
10850
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10879
CEREP Ivry Seine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
10851
Information Technology Masters International S.A.,
Chauffage-Sanitaire Kremer, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
10881
Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10886
Cindra Finance S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
10882
Information Technology Masters Technologies S.A.,
Copagest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10850
Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10887
Cord A.G., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10890
Jyvass International S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . .
10883
Coyote Café Lëtzebuerg, S.à r.l., Luxembourg. . . .
10883
Kitty Bell’s, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .
10890
Delta Corp Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . .
10879
Laguardia Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10891
Empé Immo S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10893
Loginvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10884
Empé Immo S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10893
Lux Forêts, S.à r.l., Beringen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10893
Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
10888
M & M Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
10886
EurotaxGlass’s Acquisition S.A., Luxembourg . . . .
10853
Maison Wies, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10894
Exploitation Forestière Breser, S.à r.l., Burg-
Ostergaard’s Bike Shop, S.à r.l., Mersch . . . . . . . .
10892
linster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10892
Pase Private Equity Holdings S.A., Luxembourg. .
10891
Exploitation Forestière Breser, S.à r.l., Burg-
Quadram, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10891
linster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10894
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures),
Fademo, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10893
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10889
Figestor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10891
Rothesay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10890
Fleurs Vera-Vesnalux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . .
10892
Sangiafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10894
Foudre Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10852
Securicor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
10885
Gastrom Pommerlach S.A., Pommerloch. . . . . . . .
10895
Securicor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
10885
Gastrom Pommerlach S.A., Pommerloch. . . . . . . .
10896
Telenet Solutions Luxembourg S.A., Luxembourg
10889
GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l., Lu-
Telenet Solutions Luxembourg S.A., Luxembourg
10890
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10887
Textilcord Steinfort S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . .
10891
GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l., Lu-
United Agro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10882
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10887
Velan Holding S.A., Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10888
GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l., Lu-
Velan Holding S.A., Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10896
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10887
Vertime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10881
GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l., Lu-
Vinifera International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10892
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10887
Vinifera International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10892
10850
COPAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.687.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre
1990 publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 205 du 7 mai 1991;
—
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de COPAGEST S.A. en date du 10 juin 2004 que Messieurs Jean Faber,
Didier Kirsch et Lionel Capiaux ont démissionné de leur fonction d’administrateur avec effet immédiat et que:
- Monsieur Marcel Nickmans, administrateur de sociétés, demeurant à B-Lasne,
- Monsieur Bernard Sargis, administrateur de sociétés, demeurant à F-Bourges,
- Monsieur Jean-Marc Dubois, administrateur de sociétés, demeurant à F-Bourges,
- Monsieur Dominique Jacquet, administrateur de sociétés, demeurant à F-Bourges,
- Monsieur Patrice Vander Stappen, administrateur de sociétés, demeurant à B-Bruxelles,
- Monsieur Paul van Damme, administrateur de sociétés, demeurant à B-Oostduinkerke,
ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour
une période de trois ans. Monsieur Nickmans assumera également la tâche de Président du Conseil.
Luxembourg, le 3 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(102401.3/622/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
CEREP IVRY SEINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP INVESTMENT FOUR, S.à r.l.).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.534.
—
In the year two thousand and four, on the thirtieth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole unitholder of CEREP INVESTMENT FOUR, S.à r.l., a «société à
responsabilité limitée», having its registered office in L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, inscribed at the Trade
Register Office in Luxembourg at section B under number 102.534, incorporated by deed enacted on 6th July, 2004,
not yet published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole unitholder represented and the number of shares held by him, are shown on an attendance list. That list
as well as the proxy, signed by the appearing party and by the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 250 (two hundred and fifty) units of EUR 50.- (fifty euro) each, represent-
ing the whole unit capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the agenda of
which the sole unitholder has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1.- Change of the name of the Company into CEREP IVRY SEINE, S.à r.l., and related amendment of article four of
the Articles of Association in order to reflect such decision.
2.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole unitholder, the following resolution has been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to change the name of the Company from CEREP INVESTMENT FOUR, S.à r.l., to CEREP IVRY SEINE,
S.à r.l.
As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 4 of the Articles of Association to read
as follows:
«Art. 4. The Company will have the name CEREP IVRY SEINE, S.à r.l.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 30 octobre 2003 publié au Mémorial, Recueil C n° 1320 du 11 décembre 2003.
<i>Pour la société i>
<i>COPAGEST S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
10851
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing par-
ties and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le treize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la société à responsabilité limitée CEREP INVEST-
MENT FOUR, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 102.534, constituée suivant acte reçu le 6 juillet
2004, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est présidée par M. Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,
demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique ici représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de présen-
ce. Cette liste ainsi que la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de EUR 50,- (cinquante euros)
chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé unique a été préalablement informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de dénomination de la Société en CEREP IVRY SEINE, S.à r.l., et modification afférente de l’article 4
des statuts afin de transcrire cette décision.
2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé, la résolution suivante a été prise:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de changer la dénomination de la Société de CEREP INVESTMENT FOUR, S.à r.l. en CEREP IVRY SEINE,
S.à r.l.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article quatre des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a comme dénomination CEREP IVRY SEINE, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 22, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099906.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.
CEREP IVRY SEINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP INVESTMENT FOUR, S.à r.l.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.534.
—
Les statuts coordonnés de la société suite à l’acte du 13 octobre 2004 ont été déposés par le notaire Joseph Elvinger
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099907.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Luxembourg, le 5 novembre 2004.
J. Elvinger.
<i>Pour la Société
i>Signature
10852
FOUDRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 85.910.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation FOUDRE IN-
VESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 85.910, constituée suivant acte reçu en date du 28 décembre 2001,
publié au Mémorial C numéro 769 du 21 mai 2002.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 24 juin 2004, comprenant nomination
de Monsieur Francesco Abbruzzese, demeurant à Luxembourg, en tant que liquidateur; la société L’ALLIANCE REVI-
SION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Bischen Jacmohone, réviseur d’entrepri-
ses, a été nommée en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions représentant l’intégralité du capital
social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 an-
nées et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-
port du liquidateur et du commissaire-vérificateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-
taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui
concerne l’exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, vol. 145S, fol. 59, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099795.3/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Luxembourg, le 23 novembre 2004.
J. Elvinger.
10853
EurotaxGlass’s ACQUISITION S.A., Société Anonyme.
Share capital: EUR 31,000.-.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.125.
—
In the year two thousand and four, on the first day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
There appeared:
EUROTAX GLASS’S INVESTMENTS L.P., a company governed by the laws of the Cayman Islands, having its regis-
tered office at the offices of APPLEBY CORPORATE SERVICES (CAYMAN) Ltd., Clifton House, 75 Fort Street, George
Town, Grand Cayman Island;
duly represented by Yasmin Gabriel, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on 30 September 2004;
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting as the sole shareholder of EurotaxGlass’s ACQUISITION S.A., a société anonyme incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 102.125,
incorporated on 1 July 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations (the «Company»).
The appearing party acting in its said capacity and representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company from thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) up to an amount of EUR
2,714,068.75 through the issue of 2,146,455 shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
2. Approval and determination of an authorized capital
3. Full restatement of the articles of incorporation of the Company, without modification of its corporate purpose.
4. Resignation of the Directors of the Company. Discharge. Appointment of new Directors of the Company.
5. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The appearing party resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 31,000
up to an amount of EUR 2,714,068.75 through the issue of 2,146,455 new shares with a par value of EUR 1.25 each.
The issued shares have been subscribed and paid up as follows:
1) 1,783,731 shares have been subscribed by EUROTAX GLASS’S INVESTMENTS L.P., prenamed.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 18,085 shares in EUROTAX
GLASS’S HOLDING AG, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, having its registered office
at Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach (EUROTAX AG).
2) 2,869 shares have been subscribed by Mrs Sarah Beal, residing at 156 Watersplash Road, Shepperton/Middlesex,
TW17 0EW, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 29 shares in EUROTAX AG.
3) 2,885 shares have been subscribed by Mr William Carter, residing at 2 Charlbury Close The Warren, Bracknell/
Bershire, RG12 9YJ, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 29 shares in EUROTAX AG.
4) 2,862 shares have been subscribed by Mr Graham Elmer, residing at Mill House Newmarket Road, Great Ches-
terford/ Essex, CB10 1NS, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 29 shares in EUROTAX AG.
5) 2,862 shares have been subscribed by Mrs Susan Gibson, Woodcote Christmas Common, Watlington/Oxforshire,
OX49 5HL, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 29 shares in EUROTAX AG.
6) 2,862 shares have been subscribed by Mrs Jane Goodman, residing at Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes
Road, Weybridge/Surrey KT13 9TU, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 29 shares in EUROTAX AG.
7) 8,585 shares have been subscribed by Mr Glenn Harvey, residing at Larkrise Merrywood Lane Thakeham, Stor-
rington/West Sussex, RH20 3HD, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 86 shares in EUROTAX AG.
8) 8,585 shares have been subscribed by Mrs Hannah Oxborough, residing at Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes
Road, Weybridge/Surrey, KT13 9TU, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 86 shares in EUROTAX AG.
9) 2,862 shares have been subscribed by Mr David Littleford, residing at Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes
Road, Weybridge/Surrey KT13 9TU, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 29 shares in EUROTAX AG.
10) 2,862 shares have been subscribed by Christopher Parkinson, residing at Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes
Road, Weybridge/Surrey KT13 9TU, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 29 shares in EUROTAX AG.
10854
11) 25,754 shares have been subscribed by Mr Jean Thompson, residing at Lytonmore Ridgway, Pyrford/Surrey, GU22
8PN, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 258 shares in EUROTAX AG.
12) 2,862 shares have been subscribed by Mr David Wilde, residing at Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes Road,
Weybridge/Surrey KT13 9TU, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 29 shares in EUROTAX AG.
13) 2,707 shares have been subscribed by Mr Robert Williams, residing at Ty Mawr Llanfaelog, Anglesey/Gwynedd,
LL63 5TN, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 27 shares in EUROTAX AG.
14) 187,868 shares have been subscribed by Mr Helmuth H. Lederer, residing at Lindenstrasse, CH-48832 Wollerau,
Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 1,879 shares in EUROTAX AG.
15) 3,125 shares have been subscribed by Mr Peter Affolter, residing at Studienbühlstrasse, CH-518832 Wollerau,
Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 31 shares in EUROTAX AG.
16) 551 shares have been subscribed by Mr Hans Peter Anner, residing at St. Martinstrasse, CH-586430 Schwyz, Swit-
zerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 6 shares in EUROTAX AG.
17) 919 shares have been subscribed by Mr Manfred Botsch, residing at Rossdorferstraße 2, D-60385 Frankfurt,
Maintal, Germany.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 9 shares in EUROTAX AG.
18) 1,654 shares have been subscribed by Mr Germano Cameira, residing at Eurotax Portuguesa Lda, Edifio Ferra-
giaIR. do Ferragial No. 5, P-1200 Lisboa, Portugal.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 17 shares in EUROTAX AG.
19) 251 shares have been subscribed by Mr Osman Dirilgen, residing at Weingartenstrasse, Ch-88708 Männedorf,
Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 3 shares in EUROTAX AG.
20) 74 shares have been subscribed by Mr Hubert Jung, residing at Im Waldwinkel 14, D-52385 Nideggen-Rath, Ger-
many.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 1 share in EUROTAX AG.
21) 919 shares have been subscribed by Mr Gabor Kertesz, residing at Szuglo Utca130, H-1141 Budapest, Hungary.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 9 shares in EUROTAX AG.
22) 74 shares have been subscribed by Mr Janusz Korniewicz, residing at Pasaz ursynowski 3 n.33, PL-02736 War-
zawa, Poland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 1 share in EUROTAX AG.
23) 257 shares have been subscribed by Mr René Knorr, residing at Lufenwies Süd, CH-98852 Altendorf, Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 3 shares in EUROTAX AG.
24) 1,123 shares have been subscribed by Mrs Irene Kühne, residing at Sonnenriedstrasse 2B, CH-8855 Wangen,
Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 11 shares in EUROTAX AG.
25) 2,243 shares have been subscribed by Mr Sylvio Lips, residing at Stahmelner Straße 137, D-04159 Lüzschena-Stah-
meln, Germany.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 22 shares in EUROTAX AG.
26) 919 shares have been subscribed by Mr Hans-Joachim Minder, residing at Via Cantonale 29, CH-6613 Porto Ron-
co, Switzerland
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 9 shares in EUROTAX AG.
27) 1,123 shares have been subscribed by Mrs Renate Okermüller, residing at Nussdorfer Straße 4/24, A-1090 Wien,
Austria.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 11 shares in EUROTAX AG.
28) 3,125 shares have been subscribed by Mr Erich Pomassl, residing at Sechschimmelgasse 4/29, A-1090 Wien, Aus-
tria.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 31 shares in EUROTAX AG.
29) 461 shares have been subscribed by Mr Ernst Riedmüller, residing at Holzknechtstraße 64, A-1100 Wien, Austria.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 5 shares in EUROTAX AG.
30) 1,056 shares have been subscribed by Mr Rudolf Roth, residing at Mosenstrasse, CH-88854 Galgen, Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 11 shares in EUROTAX AG.
31) 1,875 shares have been subscribed by Mr Heinz Schildgen, Seidenstrasse 24A, CH-8853 Lachen, Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 19 shares in EUROTAX AG.
32) 74 shares have been subscribed by Mr Stephan Spohn, residing at Frankfurterstr. 79, D-35440 Linden, Germany.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 1 share in EUROTAX AG.
33) 571 shares have been subscribed by Mr Walter Steinhauser, residing at Stammersdorferstraße 143/1/15, A-1210
Wien, Austria.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 6 shares in EUROTAX AG.
34) 3,813 shares have been subscribed by Mr Kurt Stocker, Bitzihofstrasse, CH-648854 Siebnen, Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 38 shares in EUROTAX AG.
10855
35) 956 shares have been subscribed by Mrs Bea Van Hauwaert, residing at Seidenstrasse 24A, CH-8853 Lachen, Swit-
zerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 10 shares in EUROTAX AG.
36) 919 shares have been subscribed by Mr Marcel Weiss, residing at Alsterstrasse 19, CH-94123 Allschwil, Switzer-
land.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 9 shares in EUROTAX AG.
37) 4,191 shares have been subscribed by Mr Stefano Zanni, residing at Stampfenbrunnenstrasse 24, CH-8048 Zürich.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 42 shares in EUROTAX AG.
38) 2,243 shares have been subscribed by Mr Werner Lederer, residing at Lerchenbergstrasse 92, CH-8703 Erlen-
bach, Switzerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 22 shares in EUROTAX AG.
39) 588 shares have been subscribed by Mr Nicolas Leutwiler, residing at Dorfstrasse 34, CH-8835 Feusisberg, Swit-
zerland.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 6 shares in EUROTAX AG.
40) 51,733 shares have been subscribed by Mr Malcolm Robin Oliphant, residing at 45 Alwyn Avenue, London W4
4PA, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 517 shares in EUROTAX AG.
41) 21,462 shares have been subscribed by Mr Gregory Anthony Smith, residing at 12, Levignen Close Church,
Crookham/Hampshire, GU13 OTW, England.
The shares so subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of 215 shares in EUROTAX AG.
The total contribution of EUR 3,464,720.55 by the subscribers will be allocated as follows:
- EUR 2,683,068.75 to the share capital;
- EUR 781,651.80 to the issue premium.
The general meeting acknowledges that in accordance with article 26-1 and 262 of the Luxembourg law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, a report of the independent auditor PricewaterhouseCoopers, réviseurs
d’entreprises on the value of the aforementioned contribution of 21,718 shares in EUROTAX AG to the Company has
been established on 1 October 2004, a copy of which is attached to the present deed.
The conclusion of the report of PricewaterhouseCoopers is the following: «Based on the work performed as de-
scribed in section III of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the
contribution in kind is not at least equal to the number and the par value of the shares to be issued, plus the share
premium.»
The proof of the existence and of the value of the total contribution have been produced to the undersigned notary.
The appearing party hereby gives power to Mr Pierre Beissel, maître en droit, Mr Sébastien Binard, licencié en droit
or to Ms. Yasmin Gabriel, maître en droit, all residing in Luxembourg, each acting individually, to duly amend the register
of registered shares of the Company in order to reflect the aforementioned capital increase.
After the above mentioned capital increase (First resolution), the new shareholders of the Company enter the meet-
ing and participate in the vote relating to item 2 to 4 of the agenda, and thus take part in the following resolutions.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors to issue 275,518,096 new shares,
with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, representing an aggregate amount of EUR 344,397,620
hence creating an authorised capital (including the issued share capital) of EUR 347,111,688.75.
This authorisation is limited to a period of five years from the date of the present authorisation pursuant to which
the directors will be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such
persons and on such terms as they shall see fit.
The directors are specifically authorized to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a
preferential right to subscribe to the Shares issued exclusively in relation to the conversion of CPECs issued on or
around 30 September, for a maximum of 275,518,096 Shares, as explained in a report made by the board of directors
in accordance with the provisions of article 32-3(5) of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial compa-
nies, and presented to the meeting.
<i>Third resolutioni>
Further to the foregoing resolutions, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of in-
corporation of the Company, without modifying the corporate purpose, so as to read as follows:
ARTICLES OF INCORPORATION
<i>Preliminay Section: Definitionsi>
«Affiliate» means, with respect to any Person, any Person (a «control person«) who, directly or indirectly, controls,
is controlled by or is under common control with that Person. For purposes of this definition, «control» when used
with respect to any Person means the power to direct the management and policies of such Person, directly or indi-
rectly, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
«Article» means, if not otherwise specified, an article of these Articles of Incorporation.
«Asking Price» shall have the meaning as set forth in Article 11.
«Beneficial Holder» means the Person beneficially entitled to shares held by a nominee or bare trustee on his behalf.
«Business Plan» shall have the meaning as set forth in Article 41.
«CEO» shall have the meaning as set forth in Article 34.
«Company» shall have he meaning as set forth in Article 1.
10856
«Company Law» shall mean the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as -amended.
«Co-Seller» shall have the meaning as set forth in Article 17.
«CPECs» means Convertible Preferred Equity Certificates with a nominal value of EUR 1.25 each issued by the Com-
pany.
«Encumbrance» means a mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction, third party right or interest, other en-
cumbrance or security interest of any kind;
«Excess Shares» shall have the meaning as set forth in Article 15.
«Family Trust» means, as regards any individual person or deceased individual, a trust (whether arising under a set-
tlement, declaration of trust or other instrument by whomsoever made or under a testamentary disposition or on an
intestacy) under which no immediate beneficial interest in any of the Shares in question is for the time being vested in
any person other than the individual and Privileged Relations of the individual and by virtue of which no voting or other
rights attaching thereto are or may become liable to be exercisable by or as directed by or subject to the consent of
any person other than the individual and Privileged Relations of the individual or the trustee as trustees of such trust.
«Fair Market Value» shall have the meaning as set forth in Article 17.
«First Closing Date» shall have the meaning as set forth in Article 15.
«Fully-Diluted Shares» means, at any time, the then outstanding Shares plus (without duplication) all Shares issuable,
whether at such time or upon the passage of time or the occurrence of future events, upon the exercise, conversion,
or exchange of all then outstanding Share Equivalents.
«Glass’s Cayman» means EUROTAX GLASS’S INVESTMENTS L.P., a member of the HMC GROUP, and any direct
or indirect transferee of Glass’s Cayman who shall become a party to any shareholders’ agreement to be entered into
by the Company and its Shareholders on terms that such person shall be treated as Glass’s Cayman.
«Glass’s Cayman Designee» shall have the meaning as set forth in Article 22.
«Group» shall have the meaning as set forth in Article 26.
«HMC Group» means HMTF and its Affiliates and respective officers, directors, and employees (and members of its
families and trusts for the primary benefit of such family members).
«HMTF» means HICKS, MUSE, TATE & FURST INCORPORATED, a Texas corporation.
«Lederer» means Helmuth Lederer.
«Lederer Designee» shall have the meaning as set forth in Article 22.
«Mission» means: To develop value adding information sources of the highest quality by gathering automotive trans-
action oriented information and refining and interpreting this data. As result of this process, to develop applications to
enhance decisions and workflow for the benefit of clients, beginning at manufacturer’s level, through distribution and
related services to all other interested parties. The clear objective of the Company is to deliver its products and services
profitably, online and in real-time where at all possible.
«Offer Period» shall have the meaning as set forth in Article 16.
«Offer Notice» shall have the meaning as set forth in Article 16.
«Participation Offer» shall have the meaning as set forth in Article 18.
«Person» means any individual, corporation, partnership, limited liability company, joint venture, association, joint-
stock company, trust, unincorporated organization or government or other agency or political subdivision thereof.
«Privileged Relation» means, as regards any individual Shareholder or deceased or former individual Shareholder, the
spouse or the widower or widow of the individual and all the lineal descendants of the individual under the age of 18
years and for such purposes a stepchild or adopted child or illegitimate child of any person shall be deemed to be lineal
descendant of such person, or a company which is an Affiliate of such an individual holder.
«Relevant Shares» means (so far as the same remain for the time being held by any Privileged Relation or the trustees
of any Family Trust or by any Transferee Company or by any nominee or bare trustee) the Shares originally acquired
by such Privileged Relation or trustees or Transferee Company or nominee or bare trustee and any additional Shares
issued to such Privileged Relation or trustees or Transferee Company or nominee or bare trustee, whether acquired
by way of capitalisation, sub-division or consolidation, or in exercise of any right or option granted or arising by virtue
of the holding of the Relevant Shares or any of them or the membership thereby conferred, or otherwise.
«Sale Notice» shall have the meaning set forth in Article 11.
«Required Majority» shall have the meaning as set forth in Article 22.
«Sale Shares» shall have the meaning set forth in Article 11.
«Selling Holder» shall have the meaning set forth in Article 15.
«Share» means a share in the share capital of the Company issued from time to time and «Shares» shall be construed
accordingly.
«Share Equivalents» mean, without duplication with any other Shares or Share Equivalents, any rights, warrants, op-
tions, convertible securities or indebtedness, exchangeable securities or indebtedness, or other rights, exercisable for
or convertible or exchangeable into Shares, whether at the time of issuance or upon the passage of time or the occur-
rence of some future event, it is understood that CPECs are Share Equivalents.
«Shareholder» means a holder of Shares.
«Second Closing Date» shall have the meaning as set forth in Article 15.
«Significant Tag Sale» shall have the meaning as set forth in Article 18.
«Significant Drag Sale» shall have the meaning as set forth in Article 17.
«Subsidiary» of any Person means (a) a corporation a majority of whose outstanding shares of capital stock or other
equity interests with voting power, under ordinary circumstances, to elect directors, is at the time, directly or indirectly,
owned by such Person, by one or more subsidiaries of such Person or by such Person and one or more subsidiaries of
such Person, and (b) any other Person (other than a corporation) in which such Person, a subsidiary of such Person or
10857
such Person and one or more subsidiaries of such Person, directly or indirectly, at the date of determination thereof,
has (x) at least a majority ownership interest or (y) the power to elect or direct the election of the directors or other
governing body of such Person.
«Transfer» means any disposition of any Share or CPEC, or any interest therein.
«Transferee Company» means a Person for the time being holding Shares in consequence, directly or indirectly, of a
transfer or series of transfers of Shares between Affiliates;
«Transferor Company» means a Person (other than a Transferee Company) which has transferred or proposes to
transfer Shares to an Affiliate (and in the case of a series of transfers the relevant Transferor Company for the purposes
of determining whether any Person shall be or shall have ceased to be an Affiliate shall be the first transferor in such
series).
«Transferor Shareholder» shall have the meaning set forth in Article 11.
«Vision» means: «To become the leading European online automotive information and solutions company by provid-
ing current, past and future value added data in relation to vehicle lifetime and costing for the Company’s professional
clients and consumers.»
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is established among the current owner(s) of the Shares created hereafter and all those who may be-
come Shareholders in future, a société anonyme (the «Company«) which shall be governed by the Company Law, as
well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio including but not limited to the establishment of branches and subsidiaries.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment
of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of EurotaxGlass’s ACQUISITION S.A.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its Shareholders. Within the
same city, the registered office may be transferred through simple resolution of the director or the board of directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company’s Share capital is set at 2,714,068.75 represented by 2,171,255 Shares with a par value of one
euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.
Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. The Company will recognize only
one holder per Share. The joint coowners shall appoint a single representative who shall represent them towards the
Company.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by a resolution of the Shareholders adopted in the manner
required for amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 8. The authorized capital (including the issued share capital) is set at EUR 347,111,688.75 divided into
277,689,351 Shares with a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.
The authorised capital exclusively serves the following purpose:
The conversion of CPECs issued on or around 30 September 2004, for a maximum of 275,518,096 Shares.
Consequently, the board of directors is authorised and empowered to
- increase the Share capital once or in successive phases by issuing new shares
- fix the place and date of the issue or successive issues, the issue price, including all premiums, the terms and con-
ditions for the subscription and paying-up of new Shares, and
- remove or restrict the preferential subscription right of the Shareholders when issuing new Shares; but only in order
to serve the purposes as stated here above.
Such authorization is valid for a period of five years commencing the date of the publication of these Articles of In-
corporation and it can be renewed by decision of the general meeting concerning the Shares of the authorised capital
that, at such date, have not been issued by the board of directors. Following each capital increase, duly recorded pur-
suant to the applicable laws, the first paragraph of this article shall be amended accordingly; said amendment shall be
recorded in a notarial deed at the request of the board of directors or by any person empowered by the latter for the
purpose thereof.
Art. 9. The Shares of the Company are in registered form. A register of registered Shares will be kept at the regis-
tered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. This register will contain all the information
required by article 40 of the Company Law. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said
register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors.
Art. 10. The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own Shares.
10858
Art. 11. The Shares are freely transferable between the Shareholders.
Any Transfer of Shares is only possible by transferring simultaneously Shares and CPECs in the same proportion as
defined by any exchange offer which may have been made by the Company prior to the date of this notarial deed with
the consent of HMC GROUP to all shareholders of EUROTAX GLASS’S HOLDING AG, an Aktiengesellschaft incor-
porated in Switzerland whose registered office is at 11A, Wolleraustrasse, CH-8807 Freienbach, Switzerland. This pro-
vision does not apply to any transfers of CPECs in connection with a redemption or repurchase of CPECs by the
Company.
Any Transfer of Shares by a Shareholder signatory to any shareholders’ agreement which may be entered into by the
Company and its Shareholders (the «Transferor Shareholder») to any person not signatory to such shareholders’ agree-
ment will be subject to the approval of the board of directors. Prior to any Transfer, the Transferor Shareholder shall
serve notice on the board of directors (the «Sale Notice») stating the number of Shares to be transferred (the «Sale
Shares») and the asking price for each Share (the «Asking Price»). Within seven days of receiving the Sale Notice, the
board of directors shall decide on the approval of such Transfer. The approval may be declined without giving any rea-
sons but only, if the board of directors offers to the Transferor Shareholder to acquire the Transfer Shares for the Ask-
ing Price for the account of the Company, for the account of one or several other Shareholders or for the account of
a third party, on the same terms as provided in Article 15. This paragraph 3 shall not apply to a transfer made in accord-
ance with Articles 17 and 18.
Art. 12. The transfer of Shares held in escrow pursuant to any escrow agreement which may be entered into by the
Company will be subject to the conditions of such escrow agreement.
Art. 13. Any Shares of the Company may at any time be transferred by a Shareholder where it is demonstrated to
the reasonable satisfaction of the board of directors that the transferee has agreed to become bound by the terms of
any shareholders’ agreement which may be entered into by the Company and its Shareholders and that the transfer is
made:
(a) by any individual Shareholder (not being in relation to the Shares concerned a holder thereof as a trustee of any
Family Trust or a nominee) to a Privileged Relation of such Shareholder; or
(b) by any such individual Shareholder to trustees to be held upon a Family Trust related to such individual Share-
holder; or
(c) by any Shareholder other than an individual (not being in relation to the Shares concerned a holder thereof as a
trustee of any Family Trust or a nominee) to an Affiliate of the Transferor Company; or
(d) by any Person entitled to Shares in consequence of the death of an individual Shareholder to any Person to whom
such individual Shareholder, if not dead, would be permitted hereunder to transfer the same; or
(e) by any Beneficial Holder to a Person as the nominee of, or bare trustee for, that Beneficial Holder and by any such
nominee or bare trustee to such Beneficial Holder or to another nominee or bare trustee for such Beneficial Holder; or
(f) by the trustees of a Company employee Share scheme to any beneficiary of such scheme.
Where Shares are held by trustees of a Family Trust, the trustees and their successors in office may (subject to the
provisions of Article 14) transfer all or any of the Relevant Shares as follows:
(a) to the trustees for the time being of the Family Trust concerned on any change of trustees;
(b) to the trustees for the time being of any other trust being a Family Trust in relation to the same individual Share-
holder or deceased or former Shareholder;
(c) to the relevant member or former Shareholder who made the original transfer permitted pursuant to Article 13
or any Privileged Relation of such relevant Shareholder or deceased or former Shareholder; and
(d) to any beneficiary of a Family Trust.
Art. 14. If following any transfer of Relevant Shares permitted pursuant to Article 13,
(a) any Person to whom Company’s Shares are transferred as a Privileged Relation ceases to be a Privileged Relation
of the relevant member or former or deceased Shareholder;
(b) any of the Relevant Shares come to be held otherwise than upon a Family Trust related to the relevant Share-
holder or former or deceased Shareholder;
(c) a Transferee Company ceases to be an Affiliate of the Transferor Company; or
(d) any Person to whom Shares- are transferred as a nominee or bare trustee ceases to hold any of the Relevant
Shares absolutely on behalf of the relevant Beneficial Holder,
in each case other than as permitted by or in accordance with the provisions of any shareholders agreement which
may be entered into by the Company and its Shareholders,
it shall be the duty of the relevant Shareholder and the former holder of the Relevant Shares to notify the Company
in writing that such event has occurred. Within three months of service of such notice or the date on which the Com-
pany otherwise becomes aware that such event has occurred (unless the Relevant Shares are transferred within six
weeks of the occurrence of such event to the relevant Shareholder or former Shareholder or to any Person to whom
a transfer of Shares by such relevant Shareholder or former Shareholder would be permitted pursuant to Article 13),
any such transfer being deemed to be authorised under the foregoing provisions of Article 13 the other Shareholders
shall have an option to acquire the Relevant Shares on the same terms as if the trustees of the former Family Trust, the
former Privileged Relation, the Transferee Company or the former nominee or bare trustee (as the case may be) had
given a Sale Notice (as defined in Article 15) in respect of the Relevant Shares pursuant to Article 15, with the Asking
Price (as defined in Article 15) being a fair market value, determined by agreement of Glass’s Cayman and Lederer or,
in default of agreement, by an independent auditor.
Art. 15. Articles 11 paragraph 3, Articles 15, 16, 17 and 18 shall not apply to a transfer permitted by Articles 13 and
14.
10859
The non-Glass’s Cayman Shareholders (a «Selling Holder») wishing to transfer Shares to a third party other than pur-
suant to Article 13 and 14, shall serve the Sale Notice on the Company stating the number of Sale Shares to be trans-
ferred and the Asking price for each Share.
The Selling Holder may state in the Sale Notice that it is only willing to transfer all the Sale Shares, in which case no
Sale Shares can be sold unless all Sale Shares are sold in accordance with this Article 15. The Sale Notice shall make the
Company the Selling Holder’s agent for the sale of the Sale Shares on the following terms, which the Company shall
notify by an invitation to the other Shareholders within seven days of receiving the Sale Notice:
(a) the price for each Sale Share shall be the Asking Price;
(b) the Sale Shares are to be sold free from all Encumbrances together with all rights attaching. to them;
(c) each of the Shareholders other than the Selling Holder is entitled to buy the Sale Shares, in the event of compe-
tition in proportions reflecting, as nearly as possible, such Shareholder’s aggregate existing holdings of Shares (but a
Shareholder may offer to buy fewer Sale Shares than his proportional entitlement);
(d) a Shareholder may offer to buy any number of Shares that are not accepted by the other Shareholders («Excess
Shares»); and
(e) 60 days after the Company’s dispatch of the terms for the sale of the Sale Shares (the «First Closing Date»):
(i) the Sale Notice shall become irrevocable;
(ii) a Shareholder who has not responded to the invitation in writing shall be deemed not to wish to purchase any
Sale Shares; and
(iii) each offer made by a Shareholder to acquire Sale Shares shall become irrevocable.
If by the First Closing Date the Company receives offers for less Shards (excluding offers for Excess Shares) than the
number of Sale Shares, each Shareholder who offered to buy Excess Shares shall be entitled, but not bound, to buy a
number of Excess Shares reflecting, as nearly as possible, the number of Excess Shares such Shareholder offered to buy
as a proportion of the total number of Excess Shares for which offers were received. If by the First Closing Date the
Company receives offers for less Shares (including offers for Excess Shares) than the number of Sale Shares and the
Selling Holder has stated in the Sale Notice that it is only willing to transfer all the Sale Shares, a number of Sale. Shares
equal to the shortfall shall be re-offered to those Shareholders who had offered to purchase Sale Shares and they shall
be entitled to offer to purchase the shortfall in any proportions they may agree.
Within fourteen days after the Closing Date (the «Second Closing Date»), the Company shall notify the Selling Holder
and the Shareholders who offered to buy Sale Shares of the result of the offer and, if any Sale Shares are to be sold to
Shareholders:
(a) the Company shall notify the Selling Holder of the names and addresses of the Shareholders who are to buy Sale
Shares and the number to be bought by each;
(b) the Company shall notify each Shareholder of the number of Sale Shares it is to buy; and
(c) the Company’s notices shall state a place and time, between 7 and 14 days later, on which the sale and purchase
of the Sale Shares is to be completed.
If by the Second Closing Date the Company has not received offers for all of the Sale Shares, the Selling Holder may
within the next two months transfer the Sale Shares for which offers were not received or, if the Sale Notice stated
that the Selling Holder was only willing to transfer all its Sale Shares, all the Sale Shares, to any person not being any of
the persons named in Schedule 1 at not less than the Asking Price per Share, with any other terms not being more
favorable to the purchaser than those in the Sale Notice.
Art. 16. Glass’s Cayman may at any time serve a notice on the other Shareholders indicating its preparedness to sell
some or all of the Shares (the «Sale Shares») held by it. If any of the other Shareholders wishes to purchase any or all
of the Sale Shares it shall have 28 days (the «Offer Period») within which to make a binding.offer to purchase some or
all of those Sale Shares (an «Offer Notice») which shall specify the price at which it is willing to purchase the Sale Shares
and any other relevant terms. If an offer to acquire the Sale Shares is made by more than one Shareholder and is ac-
cepted, then the Sale Shares shall be sold pro rata according to the number of Sale Shares each such Shareholder has
offered to acquire. If such offer is accepted, the Shareholder making such offer shall be irrevocably bound to purchase
such Sale Shares and shall (subject to applicable governmental or regulatory requirements) have four weeks within which
to complete the purchase of the Sale Shares it offered to buy and Glass’s Cayman shall be bound to transfer the Sale
Shares on completion. If such offer is accepted but the Shareholders making the Offer fail to complete the purchase
within the specified period (or if no offer is made for any of the Sale Shares during the Offer Period), GLASS’S CAYMAN
shall be free to sell the Sale Shares to any Person at any price within 12 months after the end of the Offer Period (subject
always to Articles 17 and 18). If (i) such offer is not accepted or (ii) an offer is made but such Offer is not made in.respect
of all of the Sale Shares within the Offer Period, Glass’s Cayman may at any time within 12 months after the end of the
Offer Period without being subject to the restrictions of Article 11 paragraph 3, sell some or all of the Sale Shares to
any Person provided that such sale is not on terms that are any more favourable to the purchaser than those contained
in the Offer Notice and is at a price not less than one per cent more than the lowest price offered by any such Share-
holder and, having agreed to sell the Sale.Shares to any such Person shall have a further one month (subject to applicable
governmental or regulatory requirements) in which to complete such sale. The non-transferring Shareholders shall not
take any action which may prejudice the sale to such third party but, subject thereto, nothing in this Article 16 shall
prevent any of them from making another offer within such 12 month period to acquire the Sale Shares.
Art. 17. In connection with any sale or transfer by Glass’s Cayman of Shares representing (i) more than fifty per cent
(50%) of the Shares owned by it at this date and (ii) at least 25% of all the Shares then outstanding (a «Significant Drag
Sale»), Glass’s Cayman shall have the right to require each non-selling Shareholder (each, a «Co-Seller») to transfer a
portion of its Shares which represents the same percentage of the Fully-Diluted Shares held by such Co-Seller as the
Shares being disposed of by Glass’s Cayman represent the Fully-Diluted Shares held by Glass’s Cayman. (For example,
10860
if Glass’s Cayman is selling fifty per cent (50%) of its Fully-Diluted Shares position, each Co-Seller shall be required to
sell fifty per cent (50%) of its Fully- Diluted Shares position.) All Shares transferred by Shareholders pursuant to this
Article 17 must be sold on an arm’s length basis and at not less than fair market value supported (if required by other
Shareholders) by a fairness opinion from an independent investment banker of international repute («Fair Market Val-
ue») and shall be sold at the same price and otherwise treated identically with the Shares of the same kind being sold
by Glass’s Cayman in all respects; provided, that the Co-Seller shall not be required to make any representations or
warranties in connection with such transfer other than representations and warranties as to (i) such Co-Seller’s own-
ership of his or its Shares to be transferred free and clear of all liens, claims and encumbrances, (ii) such Co-Seller’s
power and authority to effect such transfer, and (iii) such matters pertaining to compliance with securities laws as the
transferee may reasonably require except that the transferee may not require that each transferring Co-Seller be an
Accredited Investor and provided also that the Co-Seller shall not be obliged to accept securities as consideration unless
there is a buyer willing to purchase such securities at the Fair Market Value or there is a readily accessible and liquid
market for such securities.
Glass’s Cayman shall give each Co-Seller at least thirty (30) days’ prior written notice of any Significant Drag Sale as
to which Glass’s Cayman intends to exercise its rights under this Article 17. If Glass’s Cayman elects to exercise its
rights under this Article 17, the Co-Sellers shall take such actions as may be reasonably required and otherwise coop-
erate in good faith with Glass’s Cayman in connection with consummating the Significant Drag Sale (including, without
limitation, the voting of any Shares to approve such Significant Drag Sale). At the closing of such Significant Drag Sale,
each Co-Seller shall duly transfer and deliver all Shares to be sold by such Co-Seller, to the purchaser against payment
of the appropriate purchase price.
Art. 18. In the event that Glass’s Cayman desires to effect a sale of Shares which, when aggregated with all previous
sales of Shares made by Glass’s Cayman would result in Glass’s Cayman having disposed of more than twenty-five per
cent (25%) of the sum of (X) all Shares held by Glass’s Cayman as at the date of any shareholders agreement to be
entered into by the Company and its shareholders and (Y) any further Shares hereafter purchased or subscribed by
Glass’s Cayman (a «Significant Tag Sale»), and it does not elect to exercise its rights (if any) under Article 17 hereof,
then at least thirty (30) days prior to the closing of such Significant Tag Sale, Glass’s Cayman shall make an offer (the
«Participation Offer») to each Co-Seller to include in the proposed Significant Tag Sale a portion of its Shares which
represents the same percentage of such Co-Seller’s Fully-Diluted Shares as the Shares being sold by Glass’s Cayman
represent of its Fully-Diluted Shares; provided that, if the consideration to be received by Glass’s Cayman includes any
securities, only Co-Sellers who have certified to the reasonable satisfaction of Glass’s Cayman that they are Accredited
Investors shall be entitled to participate in such transfer, unless the transferee consents otherwise.
The Participation Offer shall describe the terms and conditions of the proposed Significant Tag Sale and shall be con-
ditioned upon (i) the consummation of the transactions contemplated in the Participation Offer with the transferee
named therein, and (ii) each Co-Seller’s execution and delivery of all agreements and other documents as Glass’s Cay-
man is required to execute and deliver in connection with such Significant Tag Sale (provided that the Co-Seller shall
not be required to make any representations or warranties in connection with such sale or transfer other than repre-
sentations and warranties as to (A) such Co-Seller’s ownership of his or its Shares to be sold or transferred free and
clear of all liens, claims, and encumbrances, (B) such Co-Seller’s power and authority to effect such transfer and (C)
such matters pertaining to compliance with securities laws as the transferee may reasonably require). If any Co-Seller
shall accept the Participation Offer, Glass’s Cayman shall reduce, to the extent necessary, the number of Shares it oth-
erwise would have sold in the proposed transfer so as to permit those Co-Sellers who have accepted the Participation
Offer to sell the number of Shares that they are entitled to sell under this Article 18, and Glass’s Cayman and such Co-
Sellers shall transfer the number of Shares specified in the Participation Offer to the proposed transferee in accordance
with the terms of such transfer as set forth in the Participation Offer.
In no event shall any exchange, reclassification, or other conversion of Shares into any cash, securities, or other prop-
erty pursuant to a merger or consolidation of the Company or any Subsidiary with, or any sale or transfer by the Com-
pany or any Subsidiary of all or substantially all its assets to, any Person constitute a Significant Drag Sale or a Significant
Tag Sale of Shares by Glass’s Cayman for purposes of Article 17 or Article 18. In addition, Articles 17 and 18 hereof
shall not apply to any transfer, sale, or disposition of Shares solely by Glass’s Cayman to one of its Affiliates.
Art. 19. When Shares are presented to the Company with a request to register the transfer of such Shares, the
Company shall register the transfer as requested if the transfer has been made in compliance with the provisions of
these Articles of Incorporation.
Art. 20. The bankruptcy or insolvency of one of the Shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 21. Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
1. Board of Directors
Art. 22. The Company is managed by a board of directors composed of seven members who need not to be Share-
holders.
The directors are appointed by a general meeting of Shareholders which determines the term of their office and their
remuneration. The term of their office shall run until the next annual meeting.
They may be dismissed freely at any time and without specific cause.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of Shareholders, by observing the applicable legal provisions.
10861
Five (5) directors shall be appointed from among the candidates nominated by Glass’s Cayman (the «Glass’s Cayman
Designees»). One director shall be appointed from among the candidates presented by Lederer (the «Lederer Design-
ee»). One director shall be appointed by unanimous resolution from among the candidates presented by the Glass’s
Cayman Designees and the Lederer Designee. Such Director shall not be employed by or have any interest in any of
the Shareholders or any of the respective Affiliates.
The board of directors shall appoint the Lederer Designee as chairman of the board for a tenure of one year. It may
also appoint a secretary who does not necessarily have to be a member of the board, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the Shareholders.
If Holders holding not less than 83.8% of the Shares (a «Required Majority») object to the appointment of any Lederer
Designee as a director and chairman they shall give notice to Lederer specifying the reasons for their objection. Lederer
and the objecting Shareholders shall then enter into consultations for a period of not more than two weeks to see if
the objections they have to the Lederer Designee as chairman can be overcome. If the objections of the objecting Share-
holders cannot be overcome following such consultation, Lederer may elect either to have the Lederer Designee initially
nominated by him appointed as a director only or nominate another Lederer Designee to be appointed as a director
and chairman. A Required Majority may object to any such replacement Lederer Designee being appointed as chairman
but must specify their objections and must exercise their objection rights in good faith and not as a means of frustrating
Lederer’s right to appoint the Lederer Designee as both director and chairman. A Required Majority may also by notice
to the Company remove the Lederer Designee as chairman but not as a director. At least two weeks prior to serving
any such notice on the Company the Required Majority serving such notice must have notified Lederer of the reasons
why they wish to remove the Lederer Designee as chairman and have consulted with him with a view to establishing
whether their objections to the Lederer Designee as chairman can be overcome.
Art. 23. The right of Glass’s Cayman and Lederer to nominate such number of directors as is specified in Article 22
shall terminate upon the first to occur of (i) the termination or expiration of any shareholder agreement which may be
entered into between the Company and Glass’s Cayman and Lederer, (ii) such time as Lederer or Glass’s Cayman elects
in writing to terminate their rights under Article 22 (iii) for Glass’s Cayman only, such time as Glass’s Cayman ceases
to own at least 60% of the Shares owned by it at the date of any shareholders’ agreement which may be entered into
by the Company and its Shareholders (at which time Glass’s Cayman shall be entitled to nominate the number of direc-
tors specified below), (iv) for Lederer only, such time as Lederer ceases to own at least 50% of the Shares owned by
him at the date of any shareholders’ agreement which may be entered into by the Company and its Shareholders or (v)
for Lederer only, such time as the Shares owned by Lederer represent less than 2% of all the Shares then outstanding.
Whilst Glass’s Cayman owns at least 45% of the Shares owned by it at the date of any shareholders’ agreement which
may be entered into by the Company and its Shareholders, it shall be entitled to nominate four directors. Whilst Glass’s
Cayman owns at least 30% of the Shares owned by it at the date of any shareholders’ agreement which may be entered
into by the Company and its Shareholders, it shall be entitled to nominate three directors. Whilst Glass’s Cayman owns
at least 15% of the Shares owned by it at the date of any shareholders’ agreement which may be entered into by the
Company and its Shareholders, it shall be entitled to, nominate two directors. Whilst Glass’s Cayman owns less than
15% of the Shares owned by it at the date of any shareholders’ agreement which may be entered into by the Company
and its Shareholders, it shall be entitled to nominate one director.
Art. 24. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the
notice of meeting.
The chairman shall preside at all meeting of Shareholders and of the board of directors, but in his absence, the Share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
The board of directors shall convene a meeting as often as the business and affairs of the Company require and when-
ever it is requested by one of its members, but at least at quarterly intervals.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty (20) days at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of directors.
Any director may request a meeting of the board of directors to be held by issuing at least twenty (20) days prior
written notice specifying the agenda, date, time and place of the meeting.
The notice requirements above may be waived if all directors are either present or represented at the meeting, or if
the absent directors agree in writing to waive the notice requirement.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 25. The meetings of the board of directors shall be minuted. Such minutes shall in particular contain the decla-
rations by any member with the request to be minuted as well as all the resolutions.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-
chairman, or by two directors. Copies or excerpts. of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.
10862
Art. 26. In dealings with third parties, the board of directors has the most extensive powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object. The board of
directors shall in particular be in charge of the ultimate direction, supervision and control of the Management. It shall
give directives with regard to the business policies as necessary and shall be informed about the business on a regular
basis. The board of directors shall conduct the business in accordance with the Vision and Mission statements.
The board of directors shall, among others, have the following non-transferable and inalienable duties:
1. the ultimate management of the Company, including determination of the Company’s vision and the strategy of the
Company and each of its subsidiaries from time to time (the «Group»), and the giving of the necessary directives;
2. the establishment of the organization of the Company;
3. the structuring of the accounting system and of the financial control as well as the financial planning to the extent
necessary to manage the Company;
4. the appointment and removal of the persons responsible for the management and the representation of the Com-
pany, as provided for in these articles of incorporation;
5. the ultimate supervision of the persons responsible for the management, in view of compliance with the law and
these Articles of Incorporation and any directives enacted hereunder;
6. the preparation of business report as well as the preparation of the general meeting of Shareholders, and the im-
plementations of its resolutions;
7. the notification of the judge in case of insolvency.
Furthermore, the board of directors shall have the following duties:
1. approval of business plan both for the Company and for the Group, including approval of midterm strategies and
financial, investment and cash flow planning;
2. approval of any winding-up, dissolution or liquidation for whatsoever reason and in whatsoever form, including,
without limitation, a merger, of any member of the Group or the filing by any such member of a petition relating to
bankruptcy, insolvency, receivership, reorganization or any other similar matter;
3. approval of any change of the location of the administrative headquarters of the Group;
4. approval of the entering by any member of the Group of any material contract or arrangement in conflict with the
objectives set out in the Vision and Mission Statement;
5. the disposal or series of disposals by the Company or any of its subsidiaries that constitute, alone or together, the
disposal of all or substantially all of the business of the Group;
6. any transaction between any member of the Group, on the one hand and any Shareholder or any Affiliate of such
Shareholder, on the other hand, which, is not on arms-lengths terms;
7. approval of transfer of Shares if required by the Articles of Incorporation. Otherwise, the management of any of
the Group companies remains fully with its management, except where the law and these Articles of Incorporation or
any directives enacted hereunder provide differently.
Art. 27. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or
represented at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
With respect to the following resolutions, whether carried out by the Company or any member of the Group, but
to the extent of the legal competence of the board of directors of the Company, both the Glass’s Cayman Designees
and the Lederer Designee of the board of directors of the Company must consent for the resolution to validly pass:
a) Proposals to the general meeting of Shareholders regarding the alteration of these articles of incorporation;
b) proposals to the general meeting of Shareholders regarding the alteration of the Company’s Share capital or the
rights attaching to the Shares;
c) any winding up, dissolution or liquidation, for whatsoever reason and in whatsoever form, including, without limi-
tation, a merger, of any member of the Group or the filing by any such member of a petition relating to bankruptcy,
insolvency, receivership, reorganization or any other similar matter;
d) any change of the location of the administrative headquarters of the Group;
e) the entering by any member of the Group of any material contract or arrangement in conflict with the objectives
set in the Vision and Mission Statement;
f) any disposal or series of disposals by the Company or any of its subsidiaries that constitute, alone or together, the
disposal of all or substantially all of the business of the Group;
g) any transaction between any member of the Group, on the one hand and any Shareholder or any affiliate of such
Shareholder, on the other hand, which is not on arms-length terms.
h) any repurchase or redemption of the CPECs where such repurchase or redemption involves the value of the
CPECs exceeding their nominal value plus accrued yield.
Art. 28. The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writ-
ing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 29. Each member of the board of directors is entitled to request and receive information regarding all matters
relating to the Company at any reasonable time.
The management is required to provide information requested by a member of the board of directors without delay.
Art. 30. The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors or the signature
of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
The board of directors may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
10863
Art. 31. The death or resignation of a director, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 32. The directors do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
2. The Chairman
Art. 33. The chairman of the board of directors shall supervise the management. Further, the chairman of the board
of directors shall
- represent the Company to the industry (including «big 5» manufacturers), community, shareholders and local gov-
ernments;
- take primary responsibility for communications with the board of directors;
- communicate board reactions, input, and decisions back to relevant people in the organization;
- prepare acquisitions and divestments of business, alliances etc. for approval by the board of directors
3. Management
Art. 34. The management shall consist of the chief executive officer (the «CEO» or «administrateur-délégué») and
the management team.
Art. 35. The CEO is appointed by the board of directors.
Art. 36. The CEO has all the powers and duties that are not explicitly reserved to the board of directors or the
chairman by these Articles of Incorporation or the Company Law.
In particular, he has the following powers and duties:
- the preparation and implementation of the resolutions passed by the board of directors that fall within its field of
activity;
- the organization, management and control of the day-to-day business of the Company;
- proposals to the board of directors for the appointment of members of management and for the approval of trans-
actions as listed in article 26 of these articles of incorporation;
- the organization of the management and the preparation, calling and presiding of the meetings of the management;
- the assurance of a timely and organized flow of information between the management and the board of directors.
Art. 37. The CEO shall report to the chairman and shall regularly;inform the chairman of the board of directors on
the current course of business and all major business matters of the Company and the Group. Extraordinary matters
shall be reported to the chairman without delay.
Art. 38. The management team is appointed by the board of directors.
Art. 39. The management team attends to the day-to-day business under supervision of the CEO.
Art. 40. All details of management organization shall be determined in organizational rules of management to be
approved by the board of directors.
Subject to Articles 26 et seqq., the management of the Company is entrusted to its management.
Subject to Articles 26 et seqq., the management of any of the Group companies is entrusted to its management. Such
management shall be appointed by the board of directors of such Group company.
4. Business Plan
Art. 41. A five year business plan of the Company and the Group shall be submitted to the board of directors on or
before 31 October each year (the «Business Plan»). Such Business Plan shall be reviewed and approved by the board of
directors and include detailed monthly budgets for the first year of such Business Plan. In the event that the board of
directors does not approve by 31 December the new five-year business plan that is to take effect on 1st January of the
following year, then the plan for the last year that is included in the most recently approved Business Plan shall be
deemed to be the approved plan for the additional year in the new business plan while for the other years, the previous
plan will be continued.
5. Board of Directors - Miscellaneous
Art. 42. The Company will pay all reasonable out-of-pocket expenses incurred by its independent directors in con-
nection with their participation in meetings of the board of directors of the Company and, if any, committees thereof,
as well as in meetings of the board of directors of the subsidiaries of the Company and, if any, committees thereof.
Art. 43. Members of the board of directors and of the management shall abstain from exercising their voting rights
in matters involving their personal interests or the interests of individuals or entities related to them.
Art. 44. The members of the board of directors and of the management shall keep confidential all information and
documents obtained in connection with the exercise of their function for the Company. Upon termination of their func-
tion, they shall return to the Company all documents obtained in connection therewith.
D. Supervision of the Company
Art. 45. The general meeting of Shareholders appoints one or more auditors. The auditors shall have the duties and
powers provided for in section IV of the Company Law, as well as any other applicable provisions of the Company Law.
If the Company exceeds the thresholds set by article 215 of the Company Law, the general meeting shall replace the
statutory auditor by one or more independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d’en-
treprises, and set the duration of their mandate.
10864
E. General meetings
Art. 46. The annual general meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on
June 30 at 2.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business
day.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 47. Each Shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of Shares which he
owns. Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents Shares. Shareholders may be represented
at general meetings of Shareholders by special proxy, the validity of which shall be appreciated by the board of directors.
Art. 48. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed
by a simple majority of those present or represented. If all of the Shareholders are present or represented at a meeting
of Shareholders, and if they state that they have taken notice of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice or publication.
Art. 49. All general meeting of Shareholders resolving upon amendments to the articles of incorporation require the
presence or representation of Shareholders representing fifty per cent of the Share capital at least. Such decisions will
be adopted by an affirmative vote of the Shareholders representing two thirds of the share capital present or represent-
ed, whereby at least the affirmative vote of Glass’s Cayman and Lederer are required. The following decisions in partic-
ular are subject to the above mentioned majority requirements:
1. the amendment of the Company’s corporate purpose;
2. limitations to the transferability of Shares;
3. the alteration of the Company’s share capital (including any increase, allotment, buy-in or redemption hereof), or
the rights attaching to the Shares;
4. the limitation or suppression of the preferred subscription rights of the existing Shareholders;
5. the transfer of the Company’s registered office;
6. the dissolution or liquidation of the Company, for whatsoever reason and in whatsoever form, including, without
limitation, a merger.
In case it is contemplated to increase the majority requirements set out in paragraph 1 of this Article, such decision
will have to be adopted by an affirmative vote taken at the new majority requirements which are to be adopted.
Art. 50. The board of directors shall convene all general meetings of Shareholders in case the addresses of all Share-
holders are known to the Company by registered mail only and otherwise in addition to the mailing by publication in
the Mémorial C. The convening notice shall specify the place, date and time of the general meeting as well as its agenda
and shall in case of the annual general meeting be mailed together with a copy of the Company’s annual accounts at least
twenty days prior to such date. Business report and auditor’s report will be open for inspection by Shareholders at the
Company’s registered office at least twenty days prior to the date of the general meeting.
Art. 51. The minutes of each collective decision or general meeting of Shareholders shall be held at the Company’s
registered office. The minutes shall indicate the number and class of the Shares present or represented, as well as the
resolutions, votes, requests and responses and the declarations of the Shareholders.
The minutes shall be signed by the chairman, secretary and scrutineer of the meeting.
The Shareholders shall have access to such minutes.
F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 52. The Company’s year commences on the 1st of January of each year and ends on the 31st of December of
the same year.
Art. 53. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the directors prepare an inventory includ-
ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the above inventory.
and balance sheet at the Company’s registered office. The annual accounts shall be approved within six months of the
end of the financial year.
Art. 54. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the Share capital. The balance may be freely used by the Shareholders.
The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and
conditions provided for by law.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 55. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be Shareholders, and which are appointed by the general meeting of Shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the Shareholders proportionally to the Shares
held by them.
Art. 56. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the
Company Law.
10865
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to accept the resignation of all of the directors of the Company.
The meeting resolves to grant full discharge to the resigning directors for their mandate during the financial year 2004
until the day of the present meeting.
The meeting resolves to appoint with immediate effect the following persons as new directors of the Company:
- Mr Nicolas Leutwiler, Verwaltungsratspräsident, born on 2 November 1960 in Reinach, Switzerland, with profes-
sional address at Quellen AG, Lindenstrasse 11, CH-8832 Wollerau, Switzerland;
- Mr John R. Muse, Verwaltungsratsmitglied, born in Worth, United States, on 24 February 1951, with professional
address at Hicks, Muse, Tate and Furst Limited, 21, Grosvenor Place, London SW1X7HF, Untied Kingdom;
- Mr Stephan Lobmeyr, Verwaltungsratsmitglied, born on 29 July 1966 in Klagenfurth, Austria, with professional ad-
dress at Hicks. Muse, Tate & Furst Limited, 21 Grosvenor Place, London SW1X7HF, United Kingdom;
- Mr Lyndon Lea, Verwaltungsratsmitglied, born on 13 January 1969 in Morecambe, United Kingdom, with profes-
sional address at Hicks, Muse, Tate and Furst Limited, 21, Grosvenor Place, London SW1X7HF, United Kingdom;
- Dr. Hans Michel Piech, born on 10 January 1942 in Wien, Austria, with professional address at Spiegelgasse 2/24,
1010 Wien, Austria;
- Dr. Gerhard Zeidler, born on 12 May 1936 in Breslau, Germany, with professional address at Haus Dekra, Hand-
werkstraße 15, D-70565 Stuttgart;
- Mr Philippe von Stauffenberg, born on 17 May 1964 in Neuilly-sur-Seine, France, with professional address at
Stauffenberg Capital Partners LLP Solidus Private Equity, Thames Whard Studio 2nd Floor, Block 1 Rainville Road, Lon-
don W6 9HA.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translating. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,
civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundvier, den ersten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar M
e
Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg)
Sind erschienen:
EUROTAX GLASS’S INVESTMENTS L.P., eine Gesellschaft nach Recht der Cayman Inseln, mit Sitz in den Geschäfts-
räumen von Appleby Corporate Services (Cayman) Ltd., Clifton House, 75 Fort Street, George Town, Insel von Grand
Cayman;
vertreten durch Yasmin Gabriel, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht; aus-
gestellt am 30. September 2004;
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
Solche erschienene Partei, handelnd als alleiniger Aktionär von EurotaxGlass’s ACQUISITION S.A., eine société an-
onyme gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, ein-
getragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 102.125, gegründet am 1. Juli 2004
gemäß einer Urkunde des unterzeichneten Notars, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations
publiziert wurde (die «Gesellschaft»).
Die erschienene Partei, handelnd in ihrer angegebenen Eigenschaft, und das gesamte Aktienkapital vertretend, hat fol-
gende Beschlüsse getroffen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) auf EUR 2.714.068,75
durch Ausgabe von 2.146.455 Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) pro
Aktie.
2. Bewilligung und Bestimmung des autorisierten Aktienkapitals.
3. Vollständige Neuformulierung der Satzungen der Gesellschaft, ohne Abänderung des Gesellschaftszweckes.
4. Rücktritt der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft. Entlastung. Ernennung neuer Mitglieder
des Verwaltungsrates der Gesellschaft.
5. Verschiedenes.
<i>Erster Beschlussi>
Die erschienene Partei beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Wert von einund-
dreißigtausend Euro (EUR 31.000) anzuheben auf EUR 2.714.068,75 durch Ausgabe von 2.146.455 neuen Aktien mit ei-
nem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) pro Aktie.
Die ausgegebenen Aktien wurden gezeichnet und gezahlt wie folgt:
1) 1.783.731 Aktien wurden gezeichnet von vorgenannter EUROTAX GLASS’S INVESTMENTS L.P.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 18.085 Aktien der EUROTAX
GLASS’S HOLDINGS AG eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach Schweizer Recht, mit Sitz in Wolleraustrasse
11a, CH-8807 Freienbach (EUROTAX AG).
10866
2) 2.869 Aktien wurden gezeichnet von Mrs Sarah Beal, wohnhaft in 156 Watersplash Road, Shepperton/Middlesex,
TW17 0EW, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 29 Aktien der EUROTAX AG.
3) 2.885 Aktien wurden gezeichnet von Mr William Carter, wohnhaft in 2 Charlbury Close The Warren, Bracknell/
Bershire, RG12 9YJ, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 29 Aktien der EUROTAX AG.
4) 2.862 Aktien wurden gezeichnet von Mr Graham Elmer, wohnhaft in Mill House Newmarket Road, Great Che-
sterford/ Essex, CB10 1NS, England
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 29 Aktien der EUROTAX AG.
5) 2.862 Aktien wurden gezeichnet von Mrs Susan Gibson, wohnhaft in Woodcote Christinas Common, Watlington/
Oxforshire, OX49 5HL, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 29 Aktien der EUROTAX AG.
6) 2.862 Aktien wurden gezeichnet von Mrs Jane Goodman, wohnhaft in Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes
Road, Weybridge/Surrey KT 13 9TU, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 29 Aktien der EUROTAX AG.
7) 8.585 Aktien wurden gezeichnet von Mr Glenn Harvey, wohnhaft in Larkrise Merrywood Lane Thakeham, Stor-
rington/West Sussex, RH20 3HD, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 86 Aktien der EUROTAX AG.
8) 8.585 Aktien wurden gezeichnet von Mrs Hannah Oxborough, wohnhaft in Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes
Road, Weybridge/Surrey, KT13 9TU, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 86 Aktien der EUROTAX AG.
9) 2.862 Aktien wurden gezeichnet von Mr David Littleford, wohnhaft in Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes
Road, Weybridge/Surrey KT 13 9TU, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 29 Aktien der EUROTAX AG.
10) 2.862 Aktien wurden gezeichnet von Christopher Parkinson, wohnhaft in Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes
Road, Weybridge/Surrey KT13 9TU, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 29 Aktien der EUROTAX AG.
11) 25.754 Aktien wurden gezeichnet von Mr Jean Thompson, wohnhaft in Lytonmore Ridgway, Pyrford/Surrey,
GU22 8PN, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 258 Aktien der EUROTAX AG.
12) 2.862 Aktien wurden gezeichnet von Mr David Wilde, wohnhaft in Glass’s Guide Service Limited, 1 Princes Road,
Weybridge/Surrey KT13 9TU, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 29 Aktien der EUROTAX AG.
13) 2.707 Aktien wurden gezeichnet von Mr Robert Williams, wohnhaft in Ty Mawr Llanfaelog, Anglesey/Gwynedd,
LL63 5TN, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 27 Aktien der EUROTAX AG.
14) 187.868 Aktien wurden gezeichnet von Mr Helmuth H. Lederer, wohnhaft in Lindenstrasse, CH-48832 Wollerau,
Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 1.879 Aktien der EUROTAX
AG.
15) 3.125 Aktien wurden gezeichnet von Mr Peter Affolter, wohnhaft in Studienbühlstrasse, CH-518832 Wollerau,
Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 31 Aktien der EUROTAX AG.
16) 551 Aktien wurden gezeichnet von Mr Hans Peter Anner, wohnhaft in St. Martinstrasse, CH-586430 Schwyz,
Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 6 Aktien der EUROTAX AG.
17) 919 Aktien wurden gezeichnet von Mr Manfred Botsch, wohnhaft in Rossdorferstraße 2, D-60385 Frankfurt,
Maintal, Deutschland.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 9 Aktien der EUROTAX AG.
18) 1.654 Aktien wurden gezeichnet von Mr Germano Cameira, wohnhaft in Eurotax Portuguesa Lda, Edifio Ferragi-
aIR. do Ferragial No. 5, P-1200 Lisboa, Portugal.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 17 Aktien der EUROTAX AG.
19) 251 Aktien wurden gezeichnet von Mr Osman Dirilgen, wohnhaft in Weingartenstrasse, Ch-88708 Männedorf,
Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 3 Aktien der EUROTAX AG.
20) 74 Aktien wurden gezeichnet von Mr Hubert Jung, wohnhaft in hn Waldwinkel 14, D-52385 Nideggen-Rath,
Deutschland.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 1 Aktie der EUROTAX AG.
21) 919 Aktien wurden gezeichnet von Mr Gabor Kertesz, wohnhaft in Szuglo Utcal30, H-1141 Budapest, Ungarn.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 9 Aktien der EUROTAX AG.
22) 74 Aktien wurden gezeichnet von Mr Janusz Korniewicz, wohnhaft in Pasaz ursynowski 3 n.33, PL-02736 Warza-
wa, Polen.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 1 Aktie der EUROTAX AG.
23) 257 Aktien wurden gezeichnet von Mr René Knorr, wohnhaft in Lufenwies Süd, CH-98852 Altendorf, Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 3 Aktien der EUROTAX AG.
10867
24) 1.123 Aktien wurden gezeichnet von Mrs Irene Kühne, wohnhaft in Sonnenriedstrasse 2B, CH-8855 Wangen,
Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 11 Aktien der EUROTAX AG.
25) 2.243 Aktien wurden gezeichnet von Mr Sylvio Lips, wohnhaft in Stahmelner Straße 137, D-04159 Lüzschena-
Stahmeln, Deutschland.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 22 Aktien der EUROTAX AG.
26) 919 Aktien wurden gezeichnet von Mr Hans-Joachim Minder, wohnhaft in Via Cantonale 29, CH-6613 Porto Ron-
co, Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 9 Aktien der Eurotax AG.
27) 1.123 Aktien wurden gezeichnet von Mrs Renate Okermüller, wohnhaft in Nussdorfer Straße 4/24, A-1090 Wien,
Österreich.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 11 Aktien der EUROTAX AG.
28) 3.125 Aktien wurden gezeichnet von Mr Erich Pomassl, wohnhaft in Sechschimmelgasse 4/29, A-1090 Wien,
Österreich.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 31 Aktien der EUROTAX AG.
29) 461 Aktien wurden gezeichnet von Mr Ernst Riedmüller, wohnhaft in Holzknechtstraße 64, A-1100 Wien, Öster-
reich.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 5 Aktien der EUROTAX AG.
30) 1.056 Aktien wurden gezeichnet von Mr Rudolf Roth, wohnhaft in Mosenstrasse, CH-88854 Galgen, Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 11 Aktien der EUROTAX AG.
31) 1.875 Aktien wurden gezeichnet von Mr Heinz Schildgen, wohnhaft in Seidenstrasse 24A, CH-8853 Lachen,
Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 19 Aktien der EUROTAX AG.
32) 74 Aktien wurden gezeichnet von Mr Stephan Spohn, wohnhaft in Frankfurterstr. 79, D-35440 Linden.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 1 Aktie der EUROTAX AG.
33) 571 Aktien wurden gezeichnet von Mr Walter Steinhauser, wohnhaft in Stammersdorferstraße 143/1/15, A-1210
Wien, Österreich.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 6 Aktien der EUROTAX AG.
34) 3.813 Aktien wurden gezeichnet von Mr Kurt Stocker, wohnhaft in Bitzihofstrasse, CH-648854 Siebnen, Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 38 Aktien der EUROTAX AG.
35) 956 Aktien wurden gezeichnet von Mrs Bea Van Hauwaert, wohnhaft in Seidenstrasse 24A, CH-8853 Lachen,
Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 10 Aktien der EUROTAX AG.
36) 919 Aktien wurden gezeichnet von Mr Marcel Weiss, wohnhaft in Alsterstrasse 19, CH-94123 Allschwil, Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 9 Aktien der EUROTAX AG.
37) 4.191 Aktien wurden gezeichnet von Mr Stefano Zanni, wohnhaft in Stampfenbrunnenstrasse 24, CH-8048 Zü-
rich, Schweiz
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 42 Aktien der EUROTAX AG.
38) 2.243 Aktien wurden gezeichnet von Mr Werner Lederer, wohnhaft in Lerchenbergstrasse 92, CH-8703 Erlen-
bach, Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 22 Aktien der EUROTAX AG.
39) 588 Aktien wurden gezeichnet von Mr Nicolas Leutwiler, wohnhaft in Dorfstrasse 34, CH-8835 Feusisberg,
Schweiz.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 6 Aktien der EUROTAX AG.
40) 51.733 Aktien wurden gezeichnet von Mr Malcolm Robin Oliphant, wohnhaft in 45 Alwyn Avenue, London W4
4PA, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 517 Aktien der EUROTAX AG.
41) 21.462 Aktien wurden gezeichnet von Mr Gregory Anthony Smith, wohnhaft in 12, Levignen Close Church,
Crookham/Hampshire, GU13 OTW, England.
Die so gezeichneten Aktien wurden eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 215 Aktien der EUROTAX AG.
Der gesamte Beitrag von EUR 3.464.720,55 durch die Zeichner wird wie folgt zugeteilt:
- EUR 2.683.068,75 dem Aktienkapital,
- EUR 781.651,80 der Emissionsprämie.
Die Hauptversammlung der Aktionäre erkennt an, dass gemäß Artikel 26-1 und 26-2 des Gesetzes vom zehnten Au-
gust neunzehnhundertfünfzehn, über Handelsgesellschaften, neue Fassung, am 1. Oktober 2004 ein Bericht des unab-
hängigen Rechnungsprüfers PricewaterhouseCoopers, réviseurs d’entreprises bezüglich dem obengenannten Beitrag
von 21.718 Aktien der EUROTAX AG zugunsten der Gesellschaft erstellt wurde, wobei eine Kopie dieses Berichtes
der gegenwärtigen Urkunde beigefügt ist.
Die Schlussfolgerung des Berichtes von PricewaterhouseCoopers lautet wie folgt: «Based on the work performed as
described in section III of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the
contribution in kind is not at least equal to the number and the par value of the shares to be issued, plus the share
premium.»
Der Beweis der Existenz und des Wertes des gesamten Beitrages wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
Die erscheinende Partei bevollmächtigt hiermit M
e
Pierre Beissel, maître en droit, Mr Sébastien Binard, licencié en
droit, oder M
e
Yasmin Gabriel, maître en droit, allesamt wohnhaft in Luxemburg, individuell handlungsfähig, das Register
der Namensaktien der Gesellschaft gebührend abzuändern, um die oben genannte Kapitalerhöhung wiederzuspiegeln.
10868
Nach der oben genannten Kapitalerhöhung (Erster Beschluss), treten die neuen Aktionäre der Gesellschaft der Ver-
sammlung bei und nehmen an der Abstimmung bezüglich der Punkte 2 bis 4 der Tagesordnung teil, und nehmen dem-
gemäß an folgenden Beschlüssen teil.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, 275.518.096 neue Aktien aus-
zugeben, mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) pro Aktie, welche einen Gesamt-
betrag von 344.397.620 Euro darstellen, und genehmigt folglich ein autorisiertes Aktienkapital (einschließlich des
ausgegebenen Aktienkapitals) von 347.111.688,75 Euro.
Diese Ermächtigung gilt für fünf Jahre, ab dem Datum der gegenwärtigen Ermächtigung, gemäß welcher die Mitglieder
des Verwaltungsrates hierbei ermächtigt sind und sein werden, Aktien auszugeben und Optionen zum Zeichnen von
Aktien auszugeben, zugunsten solcher Personen und zu solchen Bedingungen wie sie es als angemessen erachten wer-
den.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind insbesondere ermächtigt, so zu verfahren, ohne den Altaktionären ein be-
vorzugtes Zeichnungsrecht einräumen zu müssen, dies ausschließlich im Falle einer Ausgabe von Aktien infolge einer
Umwandlung von CPECs, welche ungefähr am 30. September 2004 ausgegeben wurden, für einen Maximalbetrag von
275.518.096 Aktien wie in einem Bericht des Verwaltungsrates erklärt gemäß den Bestimmungen in Artikel 32-3(5) des
Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn, über Handelsgesellschaften, neue Fassung, und der Versamm-
lung vorgelegt.
<i>Dritter Beschlussi>
Als Folge der vorhergehenden Beschlüsse, beschließt die Hauptversammlung der Aktionäre, die Satzungen der Ge-
sellschaft vollständig neu zu formulieren, ohne den Gesellschaftszweck abzuändern. Die Satzung wird somit wie folgt
lauten:
SATZUNG
<i>Einleitung: Definitioneni>
«Angegliedertes Unternehmen» bedeutet, bezüglich jeglicher Rechtsperson, jede Rechtsperson die, mittelbar oder
unmittelbar, eine solche Rechtsperson kontrolliert, von ihr kontrolliert wird oder mit ihr unter einer gemeinsamen Kon-
trolle steht. Für den Bedarf der gegenwärtigen Definition, bedeutet Kontrolle, falls bezüglich einer Rechtsperson ge-
braucht, das Vermögen, die Geschäftsführung und Organisation einer solchen Rechtsperson, mittelbar oder unmittelbar,
zu bestimmen, sei es durch das Halten von Stimmrecht gewährenden Anteilen, durch vertragliche Ermächtigung oder
durch andere Mittel.
«Artikel» steht, falls nicht näher beschrieben, für einen Artikel dieser Satzung.
«Verkaufspreis» hat die in Artikel 11 festgelegte Bedeutung.
«Nießbrauchsberechtigter» bezeichnet die Person, die zu ihrem Vorteil Anspruch hat auf Aktien, die von einer be-
nannten Person oder einem Treuhänder in ihrem Namen gehalten werden.
«Business Plan» hat die in Artikel 41 festgelegte Bedeutung.
«CEO» hat die in Artikel 34 festgelegte Bedeutung.
«Gesellschaft» hat die in Artikel 1 festgelegte Bedeutung.
«Gesetz» steht für das Gesetz des 10 August 1915, über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
«Mitverkäufer» hat die in Artikel 17 festgelegte Bedeutung.
«CPECs» bedeutet von der Gesellschaft ausgegebene «Convertible Preferred Equity Certificates» mit einem Nenn-
wert von EUR 1,25 pro CPEC.
«Belastung» bedeutet Hypothek, Lasten, Pfand, Zurückbehaltungsrecht, Optionen, Einschränkungen, Rechte Dritter
oder ihre Interessen, sowie alle anderen Belastungen oder Sicherungsrechte jeder Art;
«überschüssige Anteile» hat die in Artikel 15 festgelegte Bedeutung.
«Family Trust» bezeichnet, jede einzelne Person oder Verstorbenen betreffend, ein Treuhandvermögen (gleichgültig
ob sich aus einem Vergleich, einer Treuhanderklärung oder einem anderen Rechtsgeschäft ergebend, durch wen auch
immer durchgeführt, oder durch letztwillige Verfügung oder Tod ohne Hinterlassung eines Testaments entstehend) im
Rahmen dessen kein direktes Nießbrauchsrecht bezüglich jeglicher besagter Aktien besteht, in dieser Zeitspanne, auf
das andere Personen als jene einzelne Person und die bevorrechtigte Verwandtschaft Anspruch haben, und kraft wessen
keine hierzu gewährten Stimm- oder andere Rechte, deren Ausübung durch oder wie festgelegt von oder unter Vor-
aussetzung der Zustimmung von jeglichen anderen Personen als der einzelnen Person oder der bevorrechtigte Ver-
wandtschaft der einzelnen Person oder des Treuhänders als Treuhänder eines solchen Treuhandvermögens
obligatorisch ist oder werden kann.
«Fairer Marktwert» hat die in Artikel 17 festgelegte Bedeutung.
«Erstes abschließendes Datum» hat die in Artikel 15 festgelegte Bedeutung haben.
«Gesamter Aktienbestand» bedeutet, zu jedem Zeitpunkt, die dann ausgegebenen Aktien sowie (Duplikate ausge-
schlossen) alle auszugebenden Aktien, sei es zu dem Zeitpunkt, oder nach Ablauf einer Zeitspanne, oder dem Eintreten
zukünftiger Ereignisse, nach Ausübung, Umwandlung oder Eintausch von allen an dem Zeitpunkt ausstehenden aktien-
ähnliche Wertpapiere.
«Glass’s Cayman» steht für EUROTAX GLASS’S INVESTMENTS L.P., Mitglied der HMC Gruppe, und jeden unmit-
telbaren oder mittelbaren Übernehmer von Glass’s Cayman, der Teil eines Aktionärsbindungsvertrages wird, welcher
zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären geschlossen wird, zu Bedingungen die einer solchen Person weiterhin
erlauben, wie Glass’s Cayman behandelt zu werden.
«Glass’s Cayman Vertreter» hat die in Artikel 22 festgelegte Bedeutung.
10869
«Gruppe» hat die in Artikel 26 festgelegte Bedeutung.
«HMC Gruppe» bezeichnet HTMF und ihre Tochtergesellschaften, die jeweiligen Angestellten, Leiter und das Perso-
nal (sowie ihre Familienmitglieder und Treuhandfonds für die Hauptbegünstigung solcher Familienmitglieder).
«HTMF» bedeutet Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated, eine texanische Aktiengesellschaft.
«Lederer» bedeutet Helmuth Lederer.
«Lederers Ernannter» hat die in Artikel 22 festgelegte Bedeutung.
«Mission» bedeutet: Wertsteigernde Informationsquellen der höchsten Qualität entwickeln, durch Erfassen von In-
formationen bezüglich Geschäftsabläufe in der Automobilindustrie und das Präzisieren sowie Auslegen solcher Daten.
Aus diesem Vorgang resultiert die Entwicklung von Anwendungssystemen zur Verbesserung des Entscheidungs- und Ar-
beitsablaufes/Auftragsdurchlaufes zum Vorteil der Kunden, bereits auf herstellerischer Ebene, anhand Vertriebes und
zugehöriger Dienstleistungen zugunsten jeglicher interessierter Dritter. Das erklärte Ziel der Gesellschaft besteht im
gewinnbringenden Ausliefern ihrer Produkte und Ausführen ihrer Dienstleistungen, online und in Echtzeit, falls möglich.
«Angebotsfrist» hat die in Artikel 16 festgelegte Bedeutung.
«Angebotsbescheid» hat die in Artikel 16 festgelegte Bedeutung.
«Beteiligungsangebot» hat die in Artikel 18 festgelegte Bedeutung.
«Rechtsperson» bedeutet jede individuelle, gesellschaftliche, partnerschaftliche, oder beschränkt haftbare Gesell-
schaft, Interessengemeinschaft, jeder Interessenverband, jede Aktiengesellschaft, treuhänderische, nicht als AG einge-
tragene Gesellschaft oder Regierung oder andere Kommissionen oder öffentlich-rechtliche Unterteilungen hiervon.
«bevorrechtigte Verwandtschaft» schließt, jeden einzelnen, verstorbenen oder ehemaligen Aktionär betreffend, den
Ehepartner, den Witwer oder die Witwe der einzelnen Person und seine ganze gradlinige Nachkommenschaft unter 18
ein. Zu diesem Zweck wird ein Stiefkind oder adoptiertes, respektiv uneheliches Kind als gradliniger Nachkomme einer
solchen Person angesehen. Einbezogen sind auch angegliederte Unternehmen eines solchen einzelnen Aktionärs.
«Vorzugsaktien» sind (so weit diese in Besitz der privilegierten Verwandtschaft, des Übernehmers eines Family
Trusts, der übernehmenden Gesellschaft, einer beliebigen benannten Person oder eines bloßen Treuhänders bleiben)
die Aktien, die ursprünglich von einer bevorrechtigten Verwandtschaft, von Treuhändern, von einer übernehmenden
Gesellschaft, einer benannten Person oder einem bloßem Treuhänder gezeichnet wurden, sowie zusätzliche Aktien die
an eine bevorrechtigte Verwandtschaft, Treuhänder, eine übernehmende Gesellschaft, eine benannte Person oder einen
bloßen Treuhänder ausgegeben wurden, ob sie durch Kapitalisierung, Unterteilung, Fusion oder auf Grund der Aus-
übung, jeglichen gewährten Rechts oder einer gewährten Möglichkeit beziehungsweise sich ergebend auf Grund der Hal-
tung der Vorzugsaktien, oder einiger dieser, oder durch die hierdurch verliehene Mitgliedschaft, angeeignet wurden,
oder auf sämtlichen anderen Wegen.
«Verkaufsbescheid» hat die in Artikel 11 festgelegte Bedeutung.
«Erforderliche Mehrheit» hat die in Artikel 22 festgelegte Bedeutung.
«Verkaufsaktien» hat die in Artikel 11 festgelegte Bedeutung.
«Verkaufender Inhaber» hat die in Artikel 15 festgelegte Bedeutung.
«Aktie» steht für eine Aktie des Aktienkapitals der Gesellschaft, von Zeit zu Zeit ausgegeben und «Aktien» ist dem-
entsprechend auszulegen.
«Aktienähnliche Wertpapiere» steht für Duplikate anderer Aktien oder aktienähnlicher Wertpapiere, ausgenommen
jegliche Rechte, Warrants, Optionen, eintauschbare Wertpapiere, Wechselanleihen, oder andere Rechten, die ausüb-
bar, umwandelbar oder eintauschbar sind in Aktien, sei es zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe, oder nach Ablauf einer Zeit-
spanne, oder dem Eintreten eines zukünftigen Ereignisses, hierbei wird angenommen, dass CPECs aktienähnliche
Wertpapiere sind.
«Aktionär» bezeichnet den Halter von Aktien.
«Zweites Abschlussdatum» hat die in Artikel 15 festgelegte Bedeutung.
«Significant Tag Sale» hat die in Artikel 18 festgelegte Bedeutung.
«Significant Drag Sale» hat die in Artikel 17 festgelegte Bedeutung.
«Tochtergesellschaft» einer jeglichen Rechtsperson bedeutet (a) eine Gesellschaft, wessen unter üblichen Bedingun-
gen Stimmrecht zur Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates gewährende ausstehende Aktien oder Interessen am Ei-
genkapital, an dem Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar, gehalten werden von einer solchen Rechtsperson, von einer
oder mehreren Tochtergesellschaften einer solchen Person oder von einer solchen Rechtsperson und einer oder meh-
reren Tochtergesellschaften einer solchen Rechtsperson, und (b) jegliche andere Rechtsperson (die nicht Aktiengesell-
schaft ist) in der eine solche Rechtsperson, eine Tochtergesellschaft einer solchen Rechtsperson oder eine solche
Rechtsperson und eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften, unmittelbar oder mittelbar, an dem Zeitpunkt, we-
nigstens (x) ein mehrheitliches Eigentumsinteresse oder (y) über die Befähigung verfügt, die Mitglieder des Verwaltungs-
rates oder andere leitende Organe einer solchen Person zu wählen oder wahlbestimmenden Einfluss auszuüben.
«Übertragung» steht für die Veräußerung jeglicher Aktien oder CPECs, respektive jegliche Beteiligung daran.
«übernehmende Gesellschaft» bezeichnet eine Rechtsperson die zu dem Zeitpunkt Aktien besitzt, als mittelbare oder
unmittelbare Folge einer Übertragung oder einer Reihe von Übertragungen, von Aktien zwischen angeschlossenen Un-
ternehmen;
«übertragende Gesellschaft» bezeichnet eine Rechtsperson (keine übernehmende Gesellschaft) welche bereits Akti-
en übertragen hat oder übertragen wird an andere angeschlossene Unternehmen (im Falle einer Reihe von Übertragun-
gen soll die maßgebliche übertragende Gesellschaft, mit dem Ziel zu bestimmen welche Person noch ein angegliedertes
Unternehmen ist, respektive nicht mehr, die Erst-Übertragende sein.)
«übertragender Aktionär» hat die in Artikel 11 festgelegte Bedeutung.
«Vision» bedeutet: «Der Wunsch, die führende europäische Gesellschaft zu werden im Anbieten von automobiltech-
nischen Online-Lösungen und Informationen, durch Angebot von aktuellen, vergangenen und zukünftigen wertsteigern-
10870
den Daten bezüglich der Lebensdauer- und Kostenermittlung, für professionelle Kunden und Auftraggeber der
Gesellschaft.»
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und allen zukünftigen Aktionären, eine
Aktiengesellschaft gegründet, welche sowohl vom Gesellschaftsrecht als auch von den folgenden Satzungen der Gesell-
schaft geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art in luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften, sowie jegliche Form sonstiger Investitionen; der Erwerb von Wertpapieren, durch Ankauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie die Übertragung beliebiger Wertpapiere durch Verkauf und Tausch; als auch die sonstige
Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung des Wertpapierbestandes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Filialen und
Tochtergesellschaften.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, oder welche
der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere
Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Vollen-
dung ihres Zweckes dienen.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Zeitspanne.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Firma EurotaxGlass’s ACQUISITION S.A.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Aktionäre an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Verwaltungsrates verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland
eröffnen.
B. Aktienkapital - Aktien
Art. 6. Das Aktienkapital beträgt EUR 2.714.068,75 dargestellt durch 2.171.255 Aktien mit einem Nennwert von je
einem Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie.
Jede Aktie gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Die gemeinsamen Miteigentümer müssen einen einzel-
nen Vertreter ernennen, welcher beide Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 7. Das Aktienkapital kann jederzeit durch Beschlüsse der Aktionäre verändert werden, welche nach der für eine
Abänderung der Satzung vorgeschriebenen Art, angenommen werden.
Art. 8. Das autorisierte Aktienkapital beträgt EUR 347.111.688,75, aufgeteilt in 277.689.351 Aktien mit einem Nenn-
wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie.
Das autorisierte Aktienkapital erfüllt ausschließlich folgenden Zweck:
Für einen Maximalbetrag von 275.518.096 Aktien dient es der Umwandlung von CPECs welche ungefähr am 27. Sep-
tember 2004 ausgegeben wurden.
Folglich ist der Verwaltungsrat berechtigt und ermächtigt,
- das Aktienkapital einmal oder schrittweise durch die Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen
- Ort und Datum der Ausgabe oder der fortlaufenden Ausgaben zu bestimmen, sowie den Ausgabepreis, einschließ-
lich aller Prämien, die Bedingungen und Voraussetzungen für die Zeichnung und Zahlung neuer Aktien, und
- Vorzugsbezugsrechte der Aktionäre zu annullieren oder einzuschränken bei der Ausgabe von neuen Aktien; aber
nur um die oben angegebenen Zwecke zu erfüllen.
Eine solche Ermächtigung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Datum der Veröffentlichung dieser Satzung und
kann durch Beschluss der Hauptversammlung über die Aktien des autorisierten Kapitals, zu diesem Zeitpunkt noch nicht
vom Verwaltungsrat ausgegeben wurden, erneuert werden. Nach Erhöhung des Kapitals, und ordnungsgemäß den an-
wendbaren Gesetzen zufolge aufgezeichnet, wird der erste Absatz dieses Artikels dementsprechend geändert; die ge-
nannte Abänderung wird in einer notariellen Urkunde auf Antrag des Verwaltungsrats oder jedes durch diesen
bevollmächtigten Verwaltungsratsmitgliedes festgehalten.
Art. 9. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Ein Register der Namensaktien wird am Sitz gehalten, und zur Einsehung aller Aktionäre bereitgehalten. Dieses Re-
gister wird alle, von Artikel 40 vorgeschriebenen Informationen zum Gesellschaftsrecht enthalten. Der Besitz der Na-
mensaktien wird durch Eintragung in dieses besagte Register etabliert. Die Bescheinigungen dieser Einträge werden von
zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates ausgegeben und unterschrieben.
Art. 10. Die Gesellschaft kann, nach den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen und im vorgeschriebenen Umfang,
seine eigenen Aktien zurücknehmen.
Art. 11. Die Aktien sind zwischen Aktionären frei übertragbar. Jede Form der Aktienübertragung ist nur möglich,
wenn eine gleichzeitige Übertragung der Aktien und CPECs stattfindet, im gleichen Verhältnis, wie festgelegt durch ein
beliebiges Austauschangebot, welches die Gesellschaft vor dem Datum der notariellen Urkunde getätigt hat, unter Zu-
stimmung von HMC Group an alle Gesellschaftern von EUROTAX GLASS’S HOLDING AG, eine in der Schweiz inkor-
porierte Aktiengesellschaft, mit Sitz in 11A, Wollerausstrasse, CH-8807 Freienbach, Schweiz, befindet.
Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Übertragungen von CPECs im Zusammenhang mit einer Rückzahlung oder
einem Rückkauf dieser Anleihen durch die Gesellschaft.
10871
Jede Übertragung von Aktien durch einen Aktionär, der einen Aktionärbindungsvertrag, welcher durch Gesellschaft
und Aktionäre abgeschlossen werden kann, unterschrieben hat, an einen anderen Aktionär, der nicht durch einen sol-
chen Aktionärbindungsvertrag gebunden ist, benötigt die Zustimmung des Verwaltungsrates. Der Abtretende Aktionär
muss vor jeglicher Übertragung den Verwaltungsrat durch Notiz in Kenntnis setzen, («Verkaufsbescheid») welche Notiz
sowohl die Anzahl der zu übertragenden Aktien, als auch den Verkaufspreis pro Aktie beinhaltet. Innerhalb sieben Tage
nach Empfang des Verkaufsbescheids, entscheidet der Verwaltungsrat über seine Bewilligung der Übertragung. Die Be-
willigung kann ohne Nennung von Gründen abgelehnt werden, unter der Bedingung, dem verkaufenden Aktionär wird
angeboten, die zu verkaufenden Aktien zum Verkaufspreis zu erstehen, im Namen der Gesellschaft, eines oder mehrerer
Aktionäre oder im Namen eines Dritten zu denselben Bedingungen wie in Artikel 15 vorgesehen. Dieser Paragraph 3
soll keine Anwendung finden auf eine Übertragung gemäß Artikel 17 und 18.
Art. 12. Die Übertragung von Aktien, welche von einem Treuhänder gehalten werden, gemäß jeglichen von der Ge-
sellschaft abschließbaren Treuhandvertrages, ist den Bedingungen eines solchen Treuhandvertrages unterworfen.
Art. 13. Jede Aktie der Gesellschaft kann zu jeder Zeit von einem Aktionär übertragen werden, wenn der Überneh-
mer sich zu ausreichender Zufriedenheit des Verwaltungsrates bereit erklärt, jegliche Bedingungen eines Aktionärbin-
dungsvertrages anzunehmen, welche die Gesellschaft und ihre Aktionäre vorsieht, und die Übertragung. durch folgende
Personen geschieht:
(a) durch jeden einzelnen Aktionär (der die besagten Aktien weder als Treuhänder noch als designierte Person des
Family Trusts hält) an eine bevorrechtigte Verwandtschaft eines solchen Aktionärs; oder
(b) durch beliebige einzelne Aktionäre an Treuhänder, welche gemäß dem mit dem Aktionär zusammenhängenden
Treuhandvertrag (Family Trust) verwaltet werden, oder
(c) durch jeden, nicht individuellen Aktionär (der die besagten Aktien weder als Treuhänder noch als designierte Per-
son des Family Trusts hält) an ein der Aktien übertragenden Gesellschaft angegliedertes Unternehmen; oder
(d) durch jede Person, der Aktien auf Grund des Todes eines einzelnen Aktionärs zustehen, an jede Rechtsperson
der dieser Aktionär zu seinen Lebzeiten dieselbe Übergabe zugestanden hätte;
(e) durch jeden Nießbrauchsaktieninhaber an eine benannte Person oder einen einfachen Treuhänder für diesen
Nießbrauchsaktieninhaber sowie, durch jegliche benannte Person oder einen einfachen Treuhänder an einen so genann-
ten Nießbrauchsaktieninhaber, oder etwa an eine andere benannte Person oder einen einfachen Treuhänder für einen
Nießbrauchsaktieninhaber; oder
(f) durch die Treuhänder eines Belegschaftsaktienplans an jeden Begünstigten eines solchen Plans.
Wenn die Aktien Treuhändern eines Family Trusts gehören, können die Treuhänder und ihre Nachfolger im Amt alle
oder keine der entsprechenden Aktien nach folgenden Möglichkeiten übertragen:
(a) an die vorläufigen, beteiligten Treuhänder des Family Trusts betroffen von jedem Wechsel der Treuhänder;
(b) an die vorläufigen Treuhänder jedes anderen Trusts, vorausgesetzt es handelt sich um einen Family Trust in Be-
ziehung zu demselben einzelnen Aktionär, beziehungsweise dem verstorbenen oder ehemaligen Aktionär;
(c) an das maßgebliche Mitglied oder den ehemaligen Aktionär, welcher die ursprüngliche Übergabe getätigt hat ge-
mäß Artikel 13, oder an jede bevorrechtigte Verwandtschaft eines derart maßgeblichen Aktionärs, beziehungsweise ei-
nes verstorbenen oder ehemaligen Aktionärs; und
(d) an jeden Begünstigten des Family Trust.
Art. 14. Wenn nach Übertragung von sachbezogenen Aktien gemäß Artikel 13, entweder
(a) jede Person, an welche als bevorrechtigte Verwandtschaft Aktien der Gesellschaft übertragen werden, als bevor-
rechtigte Verwandtschaft des maßgeblichen Mitglieds beziehungsweise des ehemaligen oder verstorbenen Aktionärs
wegfällt; oder
(b) jede der sachbezogenen Aktien anderweitig verwaltet wird als im Rahmen eines Family Trusts mit Bezug zum maß-
geblichen, ehemaligen oder verstorbenen Aktionär;
(c) die übernehmende Gesellschaft aufhört, ein angeschlossenes Unternehmen der übertragenden Gesellschaft zu
sein; oder
(d) jede Person, an welche als benannte Person oder als bloßer Treuhänder Aktien übertragen werden, aufhört, sach-
bezogene Anteile uneingeschränkt im Interesse des nutznießenden Inhabers zu halten,
und es sich um einen Fall handelt, der nicht von den Vorschriften des Aktionärbindungsvertrages, die von der Gesell-
schaft und ihren Aktionären gegebenenfalls geschlossen werden, genehmigt ist oder der nicht mit ihnen übereinstimmt,
wird es zur Aufgabe des maßgeblichen Aktionärs und des ehemaligen Inhabers der sachbezogenen Anteile, die Ge-
sellschaft schriftlich über das Auftreten eines solchen Ereignisses in Kenntnis zu setzen. Innerhalb von drei (3) Monaten
der Zustellung einer solchen Bescheides, oder ab dem Datum, an dem die Gesellschaft anderweit das Auftreten eines
solchen Ereignisses gewahr wird (es sei denn die Übertragung der sachbezogenen Aktien erfolgt innerhalb von sechs (6)
Wochen, ab dem Auftreten eines solchen Ereignisses, an den maßgeblichen Aktionär oder ehemaligen Aktionär, bezie-
hungsweise an jede andere Rechtsperson, an welche eine solche Aktienübergabe durch einen solch maßgeblichen oder
ehemaligen Aktionär gemäß Artikel 13 gestattet ist), soll jede Übergabe dieser Art als genehmigt gelten gemäß Vorschrif-
ten des Artikels 13; die anderen Aktionäre sollen die Möglichkeit haben, die sachbezogenen Aktien zu erwerben unter
denselben Voraussetzungen wie die Treuhänder eines Family Trusts, die vorher bevorrechtigte Verwandtschaft, die Er-
werbergesellschaft oder die erstere benannte Person, beziehungsweise der bloße Treuhänder (wie es der Fall sein kann)
der einen «Verkaufsbescheid» (wie definiert in Artikel 15) bezüglich der sachbezogenen Aktien gemäß Artikel 15, bietet,
zu einem «Verkaufspreis» (wie definiert in Artikel 15), der einen angemessenen Marktwert darstellt und durch Einigung
von Glass’s Cayman und Lederer bestimmt wird, oder, mangels Einigung, von einem unabhängigen Rechnungsprüfer fest-
gelegt wird.
10872
Art. 15. Artikel 11 Paragraph 3, sowie Artikel 15, 16, 17 und 18 finden keine Anwendung bezüglich einer durch Ar-
tikel 13 und 14 erlaubten Übertragung. Die nicht Glass’s Cayman zugehörigen Aktionäre (ein «Verkaufender Inhaber»),
welche gewillt sind, Aktien an andere Dritte als in Artikel 13 und 14 aufgeführte, sollen der Gesellschaft den Verkaufs-
bescheid liefern, welcher die Anzahl der zu übernehmenden Verkaufsanteile sowie den Verkaufspreis zu beinhalten hat.
Der verkaufende Inhaber kann in der Verkaufsmitteilung angeben, dass er nur bereit ist, sämtliche Verkaufsaktien zu
übertragen, wobei in diesem Falle keine Verkaufsaktien verkauft werden können, außer sämtliche Verkaufsaktien wer-
den in Übereinstimmung mit Artikel 15 verkauft. Die Verkaufsmitteilung macht die Gesellschaft zum Vertreter des Ver-
kaufenden Inhabers für den Verkauf der Verkaufsaktien unter folgenden Bedingungen, die die Gesellschaft bekannt geben
wird mittels Aufforderung der anderen Aktionäre innerhalb von sieben Tagen ab Empfang der Verkaufsmitteilung:
(a) der Preis jeder Verkaufsaktie soll der Verkaufspreis sein;
(b) die Verkaufsaktien müssen lastenfrei und gemeinsam mit den ihnen angehörigen Rechten verkauft werden;
(c) jeder Aktionär, mit Ausnahme des verkaufenden Inhabers, hat das Recht, Verkaufsanteile zu erstehen, im Falle
eines Wettbewerbs, welcher durch Anteile reflektiert wird, die so genau wie möglich die Gesamtheit des vorhandenen
Aktienbesitzes der Aktionäre darstellen (allerdings kann ein Aktionär anbieten, weniger Verkaufsanteile zu kaufen als es
ihm sein anteilsmäßiger Anspruch ermöglicht); und
(d) ein Aktionär kann auch gewillt sein, eine unbestimmte Anzahl Aktien zu kaufen, welche nicht von den restlichen
Aktionären gutgeheißen wird («überschüssige Anteile»); und
(e) 60 Tage nach Festsetzung der Bedingungen eines Verkaufs von Verkaufsaktien (das «Erste Abschluss Datum»):
(i) wird die Verkaufsmitteilung unwiderruflich;
(ii) ein Aktionär, welcher die Aufforderung nicht schriftlich beantwortet, gilt darauf hin nicht mehr als potenzieller
Käufer, der Verkaufsanteile; und
(iii) wird jedes Angebot eines Aktionärs, Verkaufsaktien zu erstehen, unwiderruflich.
Wenn bis zum ersten Abschlussdatum die Gesellschaft Angebote für weniger Aktien bekommt (mit Ausnahme von
Angeboten für überschüssige Aktien) als die Anzahl der Verkaufsaktien beträgt, ist jeder Aktionär, der angeboten hat
überschüssige Aktien zu kaufen, berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, eine Anzahl an überschüssigen Aktien zu kaufen,
welche so genau wie möglich die Anzahl der überschüssigen Aktien widerspiegelt, die der Aktionär zu kaufen angeboten
hat, als Anteil des Gesamtangebots an überschüssigen Aktien, für die Angebote eingegangen sind. Wenn die Gesellschaft
bis zum ersten Abschlussdatum Angebote für weniger Aktien feststellt, (einschließlich der Angebote für überschüssige
Aktien) als die Anzahl der Verkaufsaktien beträgt, und der verkaufende Inhaber im Verkaufsbescheid angegeben hat, dass
er nur bereit ist, sämtliche Verkaufsaktien zu übertragen, wird eine der Fehlmenge entsprechende Anzahl an Verkaufs-
aktien neu angeboten, an die Aktionäre, welche sich vorher bereiterklärt hatten, Verkaufsaktien zu erlangen; diesen Ak-
tionären ist das; Recht vorbehalten ihr Angebot für den Ankauf der Fehlmenge zu machen.
Innerhalb von vierzehn Tagen nach Abschlussdatum (das «Zweite Abschluss Datum») sollte die Gesellschaft den ver-
kaufenden Inhabern und den Aktionären, welche sich für den Kauf von Verkaufsaktien bereit erklärt haben, Auskunft
über das Resultat des Angebots geben und ihnen mitteilen; und sollten beliebige Verkaufsaktien zum Verkauf stehen,
(a) unterrichtet die Gesellschaft den verkaufenden Inhaber über die Namen und Adressen der Aktionäre, welche im
Begriff sind, Verkaufsaktien zu erwerben, und teilt ihm die von jedem gekaufte Anzahl an Verkaufsaktien mit;
(b) teilt die Gesellschaft jedem Aktionär mit, welche Anzahl an Verkaufsaktien zum Verkauf steht; und
(c) die Bekanntmachung der Gesellschaft setzt Ort und Zeit, zwischen 7 und 14 Tagen nach Vollendung der An -und
Verkäufe von Verkaufsaktien.
Wenn die Gesellschaft zum zweiten Abschlussdatum noch nicht alle Angebote für alle Verkaufsaktien erhalten hat,
besteht die Möglichkeit, dass der verkaufende Inhaber innerhalb der folgenden 2 Monate die zu übertragenden Aktien,
für welche kein Angebot vorliegt, überträgt; oder, für den Fall dass der Verkaufsbescheid besagt, dass der verkaufende
Inhaber nur gewillt ist, seine gesamten Verkaufsanteile zu übertragen, dann werden sämtliche Verkaufsaktien an alle Per-
sonen übertragen, mit Ausnahme von den in Plan 1 erwähnten Personen, für nicht weniger als den Verkaufspreis pro
Aktie, unter der Voraussetzung, dass keine anderen Zahlungsbedingungen für den Käufer vorteilhafter erscheinen als
die im Verkaufsbescheid.
Art. 16. Glass’s Cayman kann zu jeder Zeit den anderen Aktionären ihre Bereitschaft erklären, einige oder sämtliche
Aktien (die «Verkaufsaktien») die sie besitzt, zu verkaufen.
Wenn einer der übrigen Aktionäre den Wunsch äußert, einige oder sämtliche Verkaufsaktien zu erwerben, stehen
ihm 28 Tage zur Verfügung (die «Angebotsfrist») innerhalb derer er gebeten ist, ein verbindliches Kaufangebot über ei-
nige oder sämtliche Verkaufsaktien zu machen («Angebotsbescheid») und welches den Preis beinhalten sollte, zu dem
er bereit ist, die Verkaufsaktien zu erstehen, sowie alle weiteren wichtigen Bedingungen. Sofern ein Kaufangebot der
Verkaufsaktien von mehreren Aktionären vorliegt und anerkannt wird, werden die Verkaufsaktien pro rata verkauft,
gemäß der Anzahl an Verkaufsanteilen, die jeder dieser Aktionäre zu erwerben gewünscht hat. Falls ein solches Angebot
angenommen wird, ist der anbietende Aktionär alsbald unwiderruflich zum Kauf der Verkaufsanteile verpflichtet und hat
(gemäß anwendbarer amtlich-behördlicher Vorschriften) eine Frist von 4 Wochen, um den von ihm angebotenen Er-
werb an Verkaufsaktien zu vervollständigen. Glass’s Cayman ist ihrerseits zur Übertragung der Verkaufsanteile verpflich-
tet, sobald die vorhergehenden Kriterien erfüllt sind.
Wenn ein derartiges Angebot angenommen wird, die anbietenden Aktionäre ihrer Pflicht der Kaufvollendung inner-
halb der erwähnten Frist aber nicht gerecht werden (oder wenn kein Angebot für die Verkaufsaktien innerhalb der «An-
gebotsfrist» existiert), kann Glass’s Cayman die Verkaufsaktien an jede beliebige Person und zu jedem beliebigen Preis
innerhalb der 12 Monate nach Ende der Angebotsfrist verkaufen (immer den Bedingungen der Artikel 17 und 18 unter-
liegend).
Wenn (i) ein solches Angebot abgelehnt wird oder (ii) ein Angebot gemacht wurde, das nicht den Verkaufsanteilen
innerhalb der Angebotsfrist entspricht, ist Glass’s Cayman berechtigt, zu jeder Zeit innerhalb der 12 Monate nach Ende
10873
der Angebotsfrist, ohne den Beschränkungen des Artikels 11 Paragraph 3 zu unterliegen, einige oder sämtliche Verkaufs-
aktien an eine beliebige Person zu verkaufen, vorausgesetzt, die Verkaufsbestimmungen sind für den Käufer nicht vor-
teilhafter als die des Kaufangebotes und der Preis des Verkaufs mindestens ein Prozent höher als der niedrigste, von
einem Aktionär gebotene, Preis. Auf Grund der Einwilligung, die Verkaufsaktien an eine beliebige Person zu verkaufen,
hat die Gesellschaft einen weiteren Monat Zeit, einen solchen Verkauf zu vollenden (gemäß anwendbarer amtlich-be-
hördlicher Vorschriften).
Die Aktionäre, welche nicht zu übertragen gewillt sind, führen keine Handlungen durch, die in irgendeiner Form einen
solchen Verkauf an Dritte beeinträchtigen könnten, und in Einklang hiermit, hindert Artikel 16 die Aktionäre nicht daran,
innerhalb solch einer 12 Monats-Spanne Verkaufsaktien zu erstehen.
Art. 17. In Zusammenhang mit einem Aktienverkauf oder einer Aktienübertragung durch Glass’s Cayman, (i) die
mehr als fünfzig Prozent (50%) des Aktienbestandes, der zu diesem Datum Eigentum der Gesellschaft ist (ii), und min-
destens fünfundzwanzig Prozent (25%) aller gegenwärtig ausstehenden Aktien ausmacht («Signifcant Drag Sale», «Mit-
verkaufspflichten»); hat Glass’s Cayman das Recht, von jedem nicht übertragenden Aktionär (jeder ein
«Mitverkäufer»)die Übertragung einer bestimmten Menge Aktien zu verlangen, welche denselben Prozentsatz des Ge-
samten Aktienbestandes beträgt, verwaltet von einem. solchen Mitverkäufer; genau wie die von Glass’s Cayman verwal-
teten Aktien, die den Gesamten Aktienbestand von Glass’s Cayman darstellen. (Zum Beispiel, wenn Glass’s Cayman den
Verkauf von 50% des Gesamten Aktienbestandes anstrebt, soll ist jeder Mitverkäufer veranlasst, 50% des Gesamten Ak-
tienbestandes zu verkaufen).
Sämtliche von den Aktionären gemäß Artikel 17 übertragene Aktien müssen zu entsprechenden Marktbedingungen
und nicht billiger als zum Marktwert verkauft werden, aufgrund (wenn von anderen Aktionären verlangt) einer zuver-
lässigen Stellungnahme eines unabhängigen Investmentbänkers von internationaler Bedeutung («fairer Marktwert») und
müssen sowohl zum gleichen Preis verkauft werden, als auch identisch behandelt werden wie die Aktien, welche Glass’s
Cayman ohnehin verkauft; vorausgesetzt, die Mitverkäufer haben es nicht nötig, bezüglich der Übertragung jegliche Ver-
tretungen oder Zusicherungen einzugehen, außer die Vertretungen und Zusicherungen hinsichtlich (i) eines solchen Mit-
verkäufereigentums von Wertpapieren, welche frei von jeglichen Rückbehaltungsrechten, Ansprüchen und Lasten
übertragen werden sollen, sowie (ii) die Befugnis und Ermächtigung des Mitverkäufers, eine derartige Übertragung
durchzuführen, und (iii) jene Angelegenheiten die sich auf die Einhaltung der Wertpapiergesetze beziehen, welche der
Erwerber berechtigterweise verlangen kann, außer der Erwerber erwartet nicht, dass jeder übertragende Mitverkäufer,
ein beglaubigter Investor ist, und vorausgesetzt, dass der Mitverkäufer, auch nicht gezwungen ist, Wertpapiere als Ge-
genwert anzunehmen, es sei denn, es existiert ein Käufer, welcher gewillt ist, solche Wertpapiere zum fairen Marktpreis
zu erstehen oder es besteht ein leicht zugänglicher und flüssiger Markt für solche Wertpapiere.
Glass’s Cayman informiert mindestens 30 Tage vorher, per schriftlicher Ankündigung, jeden Mitverkäufer über jeden
Significant Drag Sale, auf Grund dessen Glass’s Cayman beabsichtigt ihre Rechte, gemäß Artikel 17, auszuüben. Wenn
Glass’s Cayman sich entscheidet, ihre Rechte gemäß Artikel 17 auszuüben, sollten die Mitverkäufer, wie vernünftiger-
weise zu erwarten, diese Aktien übernehmen und andererseits bei der Ausführung des Significant Drag Sale in gutem
Glauben mit Glass’s Cayman zusammenwirken (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Ausübung des Stimmrechts
im Sinne des Significant Drag Sale). Zum Abschluss eines solchen Gegenkraftverkaufs, sollte jeder Mitverkäufer ord-
nungsgemäß die von ihm zu verkaufenden Wertpapiere an den Käufer, gegen Zahlung des entsprechenden Erwerbswer-
tes, übertragen und liefern.
Art. 18. Falls Glass’s Cayman wünscht, einen Wertpapierverkauf durchzuführen, welcher zusammen mit vorherge-
henden, von Glass’s Cayman getätigten, Wertpapierverkäufen, nach sich ziehen würde, dass Glass’s Cayman über mehr
als fünfundzwanzig Prozent (25%) der Gesamtsumme von (X) sämtlicher sich zum Zeitpunkt jeden Aktionärsbindungs-
vertrages zwischen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre im Besitz von Glass’s Cayman befindlichen Anteile, und (Y) alle
weiteren von Glass’s Cayman erstandenen und gezeichneten Wertpapiere verfügt («Significant Tag Sale» «Mitverkaufs-
rechte»); und Glass’s Cayman nicht ihre Rechte gemäß vorangehendem Artikel 17 (falls einschlägig) nicht ausübt, muss
sie jedem Mitverkäufer ein Beteiligungsangebot machen, mindestens 30 Tage vor Abschluss eines solchen, einen Teil
ihrer Aktien in den vorgeschlagenen Significant Tag Sale einzuschließen, welche den selben Prozentsatz ausmachen wie
der Anteil der Mitverkäufer am Gesamten Aktienbestand sowie die von Glass’s Cayman verkauften Wertpapiere ihren
Anteil am vollständig verwässerten Aktienbestand darstellen; vorausgesetzt und für den Fall, dass die von Glass’s Cay-
man zu erhaltene Gegenleistung Wertpapiere beinhaltet, können ausschließlich Mitverkäufer, welche zur angemessenen
Zufriedenheit von Glass’s Cayman bescheinigen, dass sie zugelassene Investoren sind, eine solche Übertragung vollst-
rekken, es sei denn, der Unternehmer erklärt sich mit etwas anderem einverstanden.
Das Beteiligungsangebot beschreibt die Bedingungen und Bestimmungen des vorgeschlagenen «Significant Tag Sale»,
und ist bedingt durch (i) den Vollzug der im Beteiligungsangebot vorgesehenen Übertragung an den im Beteiligungsan-
gebot bestimmten Erwerber, sowie durch (ii) die Unterzeichnung und Zustellung jeglicher Vereinbarungen und auch an-
derer Dokumente, die Glass’s Cayman zu unterzeichnen und zuzustellen hat im Zusammenhang mit einem solchen
Significant Tag Sale (vorausgesetzt der Mitverkäufer ist nicht verpflichtet, Vertretungen und Garantien einzugehen in Be-
zug auf einen derartigen Verkauf oder eine solche Übertragung, mit Ausnahme der Vertretungen und Garantien, welche
(A) das Mitverkäufereigentum betreffen, wobei die Aktien verkauft oder übergeben werden, frei von allen Rückbehal-
tungsrechten, Ansprüchen und Lasten, oder (B) die Befugnis und Ermächtigung des Mitverkäufers, eine solche Übertra-
gung durchzuführen betreffen, und (C) mit Ausnahme der Angelegenheiten welche, die Einhaltung der
Wertpapierbestimmungen betreffen, wie sie der Erwerber vernünftigerweise verlangt).
Angenommen, der Mitverkäufer nimmt das Beteiligungsangebot an, reduziert Glass’s Cayman im nötigen Ausmaße,
die Anzahl der Aktien, welche sie sonst bei der vorgesehenen Übertragung verkauft hätte, um so den Mitverkäufern, die
das Beteiligungsangebot angenommen haben, zu ermöglichen, die Anzahl Wertpapiere zu verkaufen, zu der sie gemäß
Artikel 18 berechtigt sind. Außerdem übertragen Glass’s Cayman und die jeweiligen Mitverkäufer die Anzahl Aktien an
10874
den Erwerber, welche im Beteiligungsangebot festgelegt ist, gemäß den Bestimmungen einer solchen Übertragung, wie
es im Beteiligungsangebot dargelegt ist.
Auf keinen Fall kann ein Austausch, eine Umbuchung, oder eine andere Umwandlung der Aktien in Bargeld, Wertpa-
piere, oder sonstiges Vermögen, als Folge einer Fusion oder Gruppenbildung der Gesellschaft oder einer der Tochter-
gesellschaften, respektive jeglicher Verkauf oder Übertragung der Gesellschaft oder Tochtergesellschaft allen oder fast
allen Vermögens an jegliche Person, einen Significant Drag Sale oder Significant Tag Sale von Aktien durch Glass’s Cay-
man auf Grund von Artikel 17 und 18 darstellen.
Zusätzlich sollten die vorhergehenden Artikel 17 und 18 nicht angewendet werden in Bezug auf jegliche Übertragung,
jeglichen Verkauf oder Verfügung von Aktien, mit einziger Ausnahme einer Übertragung, eines Verkaufs oder einer Ver-
fügung zwischen Glass’s Cayman, und ihrer angeschlossenen Unternehmen.
Art. 19. Wenn der Gesellschaft Aktien vorgelegt werden, mit dem Gesuch, die Übertragung solcher Aktien einzu-
tragen, dann wird die Gesellschaft diese Übertragung wie verlangt und gemäß den Bestimmungen ihrer Satzung verzeich-
nen.
Art. 20. Die Insolvenz und die Zahlungsunfähigkeit eines Aktionärs bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.
Art. 21. Weder Gläubiger, noch Bevollmächtigte, haben das Recht, Vermögensgegenstände oder Dokumente der
Gesellschaft mit Siegeln zu versehen.
C. Geschäftsführung
1. Der Verwaltungsrat
Art. 22. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher sich aus sieben Mitgliedern zusammen-
setzt die keine Aktionäre sein müssen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche auch ihre
Mandatsdauer und ihr Einkommen festsetzt. Ein Mandat sollte bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung laufen.
Die Verwaltungsratsmitglieder können zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen entlassen werden.
Im Falle einer nicht besetzten Stelle im Verwaltungsrat auf Grund des Todes, des Rücktritts eines Verwaltungsrats-
mitgliedes oder anderer Ursachen wird diese Stelle, gemäß der gültigen rechtlichen Bestimmungen, provisorisch bis zum
nächsten Aktionärstreffen besetzt.
Fünf (5) Mitglieder des Verwaltungsrates werden aus den Reihen der von Glass’s Cayman ausgewählten Kandidaten
ernannt (die «Class’s Cayman Kandidaten»). Ein Verwaltungsratsmitglied wird aus der Mitte der von Lederer vorgestell-
ten Kandidaten ernannt (der «Lederer Kandidat»). Ein (1) Verwaltungsratsmitglied wird durch einstimmigen Beschluss
aus der Mitte, der von den Glass’s Cayman Kandidaten und dem Lederer Kandidaten, vorgestellten Kandidaten auser-
wählt. Ein solches Verwaltungsratsmitglied darf weder von einem der Aktionäre beschäftigt sein, noch soll es jegliches
Interesse haben an den Aktionären oder einem jeweiligen angegliederten Unternehmen.
Der Verwaltungsrat wird den Lederer Kandidaten zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wählen, für die Dauer ei-
nes Jahres. Er kann auch einen Sekretär ernennen, welcher nicht unbedingt Mitglied des Verwaltungsrates sein muss.
Der Sekretär ist für die Protokollführung der Verwaltungsratssitzungen und der Aktionäre verantwortlich.
Wenn Aktieninhaber, welche mindestens 83,8% der Aktien (die «Erforderliche Mehrheit») halten, gegen die Ernen-
nung eines Lederer Kandidaten als Verwaltungsratsmitglied und Sekretär Einspruch erheben, müssen sie Lederer unter
Angabe der Einspruchsgründe hierüber informieren. In einem solchen Falle werden Lederer und die Einspruch erheben-
den Aktieninhaber in Verhandlungen treten. Diese dürfen nicht länger als zwei Wochen dauern und sollen dazu dienen,
eine Lösung zur Beseitigung der Einspruchsgründe zu finden. Sollte dies nicht möglich sein, ist Lederer berechtigt, ent-
weder den betreffenden Lederer Kandidaten nur als Verwaltungsratsmitglied, oder einen anderen Lederer Kandidaten
als Mitglied und gleichzeitig Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestellen zu lassen. Die Erforderliche Mehrheit kann ge-
gen die Ernennung eines solchen Ersatz - Lederer Kandidaten als Sekretär Einspruch erheben, aber nur unter Angabe
von Gründen. Die Erforderliche Mehrheit muss in gutem Glauben handeln, und nicht um Lederer’s Recht zu unterbin-
den, um einen Lederer Kandidaten als Verwaltungsratmitglied und als Verwaltungsratvorsitzenden bestellen zu lassen.
Die erforderliche Mehrheit kann auch durch Mitteilung an die Gesellschaft den Lederer Kandidaten von seiner Stellung
als Sekretär, jedoch nicht als Verwaltungsratsmitglied, absetzen. Mindestens zwei Wochen vor Mitteilung an die Gesell-
schaft muss die Erforderliche Mehrheit Lederer von den Gründen der gewünschten Absetzung unterrichten und in Ver-
handlungen mit demselben treten, um eine gemeinsame Lösung zur Beseitigung der bestehenden Einwände zu finden.
Art. 23. Das Recht von Glass’s Cayman und Lederer, die entsprechende Zahl von Verwaltungsratmitgliedern nach
Artikel 22 zu benennen, endet jeweils (i) zum Zeitpunkt der Auflösung jedes Aktionärbindungsvertrages der zwischen
der Gesellschaft und Glass’s Cayman und Lederer geschlossen werden kann, (ii) nach schriftlicher Erklärung von Lederer
oder Glass’s Cayman über die Beendigung ihrer Rechte nach Artikel 22, oder (iii) nur für Glass’s Cayman, wenn letztere
weniger als 60% ihrer zu .diesem Zeitpunkt gehaltenen Aktien hält (in welchem Falle Glass’s Cayman die unten angege-
bene Zahl von Verwaltungsratsmitgliedern benennen darf), (iv) für Lederer, wenn die von Lederer gehaltenen Aktien
weniger als 50% der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Aktien der Gesellschaft darstellen, oder (v) für Lederer, wenn
die von Lederer gehaltenen Aktien weniger als 2% aller, Aktien zu diesem Zeitpunkt darstellen.
Wenn Glass’s Cayman mindestens 45% der Aktien hält zu diesem Zeitpunkt, hat sie das Recht, vier Verwaltungsrat-
mitglieder zu benennen. Wenn Glass’s Cayman mindestens 30% der Aktien hält, hat sie das Recht, drei Verwaltungsrat-
mitglieder zu benennen. Wenn Glass’s Cayman mindestens 15% der Aktien hält, hat sie das Recht, zwei
Verwaltungsratmitglieder zu benennen. Wenn Glass’s Cayman weniger als 15% der Aktien hält, hat sie das Recht, ein
Verwaltungsratmitglied zu benennen.
10875
Art. 24. Der Verwaltungsrat wird entweder durch den Sekretär oder zwei seiner Mitglieder einberufen, und ver-
sammelt sich an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Orte.
Der Sekretär präsidiert jede Versammlung der Aktionäre und des Verwaltungsrats, doch in seiner Abwesenheit kön-
nen die Aktionäre oder der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratmitglied als Sekretär aussuchen und ernennen
und dies pro tempore und durch eine Abstimmung von der Mehrheit der in jeder derartigen Versammlung Anwesenden.
Der Verwaltungsrat wird, so oft wie die Geschäfte und Affären der Gesellschaft dies benötigen, eine Sitzung einbe-
rufen und wenn dies von einem seiner Mitglieder verlangt wird, und dies mindestens in einem Abstand von drei Monaten.
Die schriftliche Ankündigung jeder Versammlung des Verwaltungsrates muss den Mitgliedern mindestens zwanzig
(20) Stunden vor dem geplanten Datum der Versammlung gegeben werden, außer im Falle einer Notlage. In diesem Fall
werden die Eigenschaft und die Beweggründe des Notfalls in der Ankündigung erwähnt.
Diese Ankündigung kann ausgelassen werden im Falle einer Zustimmung jedes Mitglieds per Schreiben, per Tele-
gramm, per Telex, per Fax oder sonstiger Kommunikationsmittel. Ein gesondertes Einberufungsschreiben wird nicht
verlangt für eine Verwaltungsratssitzung, deren Zeitpunkt und Ort durch vorhergehenden Beschluss festgelegt und vom
Verwaltungsrat bestimmt wurde.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann eine Verwaltungsratssitzung beantragen mittels einer schriftlichen Bekanntma-
chung, zwanzig Tage vorher, welche Tagesordnung, Datum, Dauer und Ort der Sitzung bestimmt.
Auf vorangehende Einberufungsbedingungen kann verzichtet werden, wenn entweder sämtliche Verwaltungsratsmit-
glieder in der Sitzung anwesend oder vertreten sind, oder wenn die abwesenden Verwaltungsratsmitglieder schriftlich
zustimmen, dass auf die Einberufungsbedingungen verzichtet werden kann. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann anhand
von Telegramm, Telex oder Fax ein anderes Verwaltungsmitglied zu seinem Bevollmächtigten ernennen und durch ihn
in der Sitzung handeln.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung per Telefonkonferenz oder sonstiger Kommuni-
kationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt die Teilnehmer hören sich gegenseitig. Eine solche Teilnahme an der Sitzung
entspricht einer Teilnahme in Person an einer derartigen Sitzung.
Art. 25. Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden protokollier. Diese Protokolle enthalten speziell alle Bekannt-
machungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, für welche ausdrücklich Protokollierung verlangt wird, sowie alle weiteren
Bekanntmachungen.
Die Protokolle einer jeden Sitzung des Verwaltungsrates werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden, oder im Falle
seiner Abwesenheit, von Vizeverwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge solcher Protokolle werden nach rechtlichem Verfahren oder anders erstellt und werden vom
Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 26. Dritten gegenüber ist der Verwaltungsrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft
zu handeln, und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen. Der Ver-
waltungsrat leitet die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsführung. Er bestimmt im Rahmen des Notwendigen die Richt-
linien seiner Geschäftspolitik und wird jederzeit über den Stand der Geschäfte informiert. Der Verwaltungsrat führt die
Geschäft in Übereinstimmung mit den «Vision und Statements» in Anlage 1.
Der Vorstand hat folgende nicht übertragbare und unveräußerliche Pflichten:
1. Die Oberleitung der Gesellschaft, auch hinsichtlich der «Vision» der Gesellschaft und der Strategie der Gruppe,
und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation der Gesellschaft;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle, sowie die Finanzplanung, insoweit dies zur Füh-
rung der Gesellschaft erforderlich ist;
4. die Bestimmung und Entlassung der Personen die für die Geschäftsleitung und Vertretung der Gesellschaft verant-
wortlich sind, wie in den Artikeln der Satzung vorgesehen;
5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung der Gesellschaft betrauten Personen, insbesondere im Hinblick
auf die Befolgung der vorliegenden Statuten, der erteilten Weisung, sowie des Gesetzes vom 10. August 1915;
6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der ordentlichen Generalversammlung, und die Aus-
führung ihrer Beschlüsse;
7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
Der Vorstand hat außerdem folgende Pflichten:
1. Die Bewilligung des «business plan» der Gesellschaft und der Gruppe, einschließlich mittelfristiger Strategien und
Finanzierungs-, Investitions,- und «cash flow»-Pläne;
2. die Bewilligung der Auflösung oder Liquidation einer Gesellschaft der Gruppe, aus welchen Gründen und in wel-
cher Form auch immer, einschließlich, ohne Einschränkung, einer Fusion, oder der Einreichung durch eine solche Ge-
sellschaft eines Antrages auf Insolvenz, auf Vermögensverwaltung, Umstrukturierung oder eines ähnlichen Antrages;
3. die Bewilligung jedweden Wechsels des Verwaltungssitzes der Gruppe;
4. die Bewilligung des Eintritts einer Gesellschaft der Gruppe in einen Vertrag oder ein Übereinkommen materieller
Art, welche gegen die in Anlage 1 festgelegten Zielsetzungen verstoßen;
5. die Veräußerung oder Folge von Veräußerungen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften die, allein
oder zusammen, die Veräußerung des ganzen, oder im Wesentlichen des ganzen Geschäftes der Gruppe darstellt;
6. jegliche Abwicklung zwischen Mitgliedern der Gruppe, einerseits und einem Aktionär oder einem dem Aktionär
anverwandten Gesellschaft andererseits, welche nicht nach den üblichen Marktbedingungen erfolgt;
7. die Bewilligung oder Übertragung von Aktien, falls von der Satzung der Gesellschaft verlangt.
10876
Art. 27. Der Verwaltungsrat ist nur dann beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder
des Verwaltungsrates in der Sitzung des Verwaltungsrates anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Folgende, im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse des Verwaltungsrates verabschiedete Beschlüsse, sei es dass sie
durch die Gesellschaft oder durch eine andere der Gesellschaftsgruppe zugehörige Gesellschaft durchgeführt werden,
müssen durch ein von Glass’s Cayman und ein von Lederer vorgeschlagenes Mitglied des Verwaltungsrats bewilligt wer-
den, damit sie Gültigkeit erlangen können:
a) Vorschläge an die Hauptversammlung bezüglich der Abänderung der gegenwärtigen Satzung,
b) Vorschläge an die Hauptversammlung über Umänderungen des Aktienkapitals der Gesellschaft oder der Aktio-
närsrechte;
c) die Auflösung und Liquidation einer der Gesellschaftsgruppe zugehörigen Gesellschaft, aus welchen Gründen und
in welcher Form auch immer, einschließlich, ohne Einschränkung, einer Fusion, oder jede Einreichung einer solchen Ge-
sellschaft eines Antrages auf Insolvenz, Geschäftsführung unter Aufsicht, Umgestaltung oder ähnliche Verfahren;
d) die Verlegung des Verwaltungssitzes der Gesellschaftsgruppe;
e) der Abschluss durch eine der Gesellschaftsgruppe zugehörigen Gesellschaft eines Vertrages oder Arrangements,
welche in Konflikt treten könnten mit den in den «Vision and Statements» aufgeführten Zielsetzungen;
f) die Veräußerung, bzw. Reihe von Veräußerungen durch die Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften,
welche einzeln oder zusammen der Veräußerung der gesamten oder im Wesentlichen der gesamten Geschäftstätigkeit
der Gesellschaftsgruppe gleichkommt;
g) die Geschäftsabwicklung zwischen einerseits einer der Gesellschaftsgruppe zugehörigen Gesellschaft und anderer-
seits einem Aktionär oder ein dem Aktionär angegliederten Unternehmen, welche nicht zu üblichen Marktbedingungen
erfolgt;
h) der Rückkauf oder die Rücknahme der CPECs, wobei ein solcher Rückkauf oder eine solche Rücknahme über ei-
nen Wert geschieht, der den nominalen Wert der CPECs einschließlich der angefallenen Rendite übersteigt.
Art. 28. Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels schriftlicher, durch
Kabel, Telegramm, Telex, Telefax. oder andere entsprechenden Kommunikationsmittel belegte Unterlagen gefasst wer-
den, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der angegeben Unterlagen bildet das
Protokoll, welches als Nachweis der Beschlussfassung gilt.
Art. 29. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist befugt, Informationen bezüglich sämtlicher die Gesellschaft betref-
fenden Angelegenheiten zu fordern und in angemessenem Zeitraum zu erhalten.
Die Geschäftsführung ist dazu angehalten, jedem Mitglied des Verwaltungsrates die von ihm geforderten Informatio-
nen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
Art. 30. Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mitglieder des Ver-
waltungsrats, oder durch die einzelne Unterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person
verpflichtet.
Der Verwaltungsrat kann Handlungsvollmachten privatschriftlich erteilen. Sondervollmachten können nur aufgrund
notarieller Urkunde erteilt werden.
Art. 31. Weder der Tod, noch der Rücktritt eines Mitgliedes des Verwaltungsrates können, aus welchem Grund
auch immer, die Auflösung der Gesellschaft bewirken.
Art. 32. Die Mitglieder des Verwaltungsrates übernehmen aufgrund ihres Mandates keine persönliche Haftung be-
züglich der durch sie im Namen der Gesellschaft regulär abgeschlossenen Rechtsgeschäfte. Als Bevollmächtigte haften
sie lediglich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates.
2. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats
Art. 33. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats überwacht die Geschäftsführung. Der Vorsitzende des Verwaltungs-
rats muss des weiteren:
- die Gesellschaft in der Industrie vertreten (einschließlich der «big 5» Hersteller), wie auch im Gemeinwesen, bei
den Aktionären und bei den Lokalbehörden;
- die Hauptverantwortung übernehmen bezüglich des Informationsaustausches mit dem Verwaltungsrat
- die Benachrichtigung wichtiger Personen in der Organisation über Beschlüsse Reaktionen und Beiträge des Verwal-
tungsrates;
- Vorschläge über den Erwerb, beziehungsweise die Veräußerung von Geschäften, Zusammenschlüsse usw., auszuar-
beiten, um sie dem Verwaltungsrat zur Zustimmung zu unterbreiten.
3. Das Management
Art. 34. Das Management setzt sich aus dem Hauptgeschäftsführer (der «CEO» oder administrateur-délégué) und
den übrigen Mitgliedern des Managements zusammen.
Art. 35. Der CEO wird vom Verwaltungsrat ernannt.
Art. 36. Der CEO hat sämtliche Befugnisse und unterliegt sämtlichen Pflichten, welche nicht durch diese Satzung
oder das Gesetz dem Verwaltungsrat oder dem Verwaltungsratsvorsitzenden ausdrücklich vorbehalten sind.
Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Pflichten:
- die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Verwaltungsrates, welche in sein Zuständigkeitsgebiet fallen;
- die Gestaltung, Ausführung und Kontrolle der laufenden Geschäfte der Gesellschaft;
10877
- das Unterbreiten von Vorschlägen an den Verwaltungsrat bezüglich der Ernennung von Mitgliedern des Manage-
ments und der Abschluss von Rechtsgeschäften gemäß Artikel 26.
- die Gestaltung der Geschäftsführung und die Vorbereitung, die Einberufung und der Vorsitz der Sitzungen des Ma-
nagements;
- das Sichern eines regelmäßigen und organisierten Informationsflusses zwischen Management und Verwaltungsrat
Art. 37. Der CEO berichtet dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates und informiert ihn bezüglich des aktuellen Stan-
des der Geschäfte und aller wichtigen geschäftlichen Angelegenheiten betreffend der Gesellschaft und der Gesellschafts-
gruppe. Außergewöhnliche Angelegenheiten sind unverzüglich dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu berichten.
Art. 38. Das Management wird vom Verwaltungsrat ernannt.
Art. 39. Das Management leitet die laufende Geschäftsführung unter Aufsicht des CEO’s.
Art. 40. Einzelheiten der Organisation der Geschäftsführung wird durch Management-Organisationsregeln be-
stimmt, welche durch den Verwaltungsrat festgelegt werden.
Vorbehaltlich Artikel 26 ff. ist die Geschäftsführung der Gesellschaft ihrem Management anvertraut
Vorbehaltlich Artikel 26 ff. ist die Geschäftsführung einer jeden Gesellschaft der Gesellschaftsgruppe ihrem jeweiligen
Management anvertraut. Die Geschäftsführung einer jeden Gesellschaft der Gesellschaftsgruppe wird vom Verwaltungs-
rat der jeweiligen Gesellschaft der Gesellschaftsgruppe ernannt.
3. Business Plan
Art. 41. Ein Fünfjahres-Business Plan bezüglich der Gesellschaft und der Gesellschaftsgruppe wird dem Verwaltungs-
rat alljährlich am 31. Oktober vorgelegt (der «Business Plan»). Ein solcher Business Plan wird vom Verwaltungsrat über-
prüft und bestätigt, und beinhaltet detaillierte monatliche Finanzpläne für das erste Jahr eines solchen Business Plans. Für
den Fall, dass der Verwaltungsrat den für die nächsten fünf Jahre geltenden Business Plan am 31. Dezember nicht bestä-
tigt hat, welcher am 1. Januar des folgenden Jahres in Kraft treten soll, wird der für das letzte Jahr vorgesehene Plan,
welcher im zuletzt bestätigten Business Plan enthalten ist, als bestätigt erachtet für das zusätzliche Jahr im neuen Business
Plan, während für die übrigen Jahre der vorhergehende Business Plan in Kraft bleibt.
4.Verwaltungsrat - Verschiedenes
Art. 42. Die Gesellschaft zahlt sämtliche, durch ihre unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrates in vernünftigen
Maßen getätigten Ausgaben in Zusammenhang mit ihrer Teilname an den Sitzungen des Verwaltungsrates. Gleiches gilt
für die Teilnahme an Ausschüssen des Verwaltungsrates, falls solche stattfinden sollten, wie auch für die Teilnahme Sit-
zungen des Verwaltungsrates von Tochtergesellschaften der Gesellschaft, sowie für die Teilnahme an Ausschüssen letz-
terer.
Art. 43. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und das Management unterlassen es, ihr Stimmrecht in Bereichen aus-
zuüben, welche ihre persönlichen Interessen, sowie mit ihnen verwandte Personen oder Einheiten betreffen.
Art. 44. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und das Management behandeln sämtliche Informationen und Doku-
mente, die sie im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Mandates erhalten, streng vertraulich.
Nach Niederlegung ihres Mandates erstatten sie der Gesellschaft alle in Zusammenhang des Mandates erhaltenen Do-
kumente zurück.
D. Aufsicht
Art. 45. Die Gesellschafterversammlung ernennt einen oder mehrere Rechnungsprüfer. Die Rechnungsprüfer ver-
fügen über die in Sektion IV des Gesetzes enthaltenen Rechte und Pflichten, wie auch jene, welche in jeglichen anderen
Bestimmungen des Gesetzes enthalten sind.
Falls die Gesellschaft den in Artikel 215 des Gesetzes festgelegenen Schwellenwert übersteigt, ersetzt die Gesellschaft
den statutarischen Rechnungsprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Rechnungsprüfer, welche unter den Mit-
gliedern des Institut des réviseurs d’entreprises auserwählt werden, und legt die Dauer ihres Mandates fest.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 46. Die jährliche Hauptversammlung findet an einem im Einberufungsschreiben bestimmten Ort in Luxemburg
jeweils um 14.00 Uhr am 30. Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg
fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungs-
schreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.
Art. 47. Jeder Aktionär ist ermächtigt, an der Beschlussfassung in Hauptversammlungen der Gesellschaft teilzuneh-
men, unabhängig von der Menge der von ihm gehaltenen Anteile. Jeder Aktionär verfügt über so viele Stimmen, wie er
Anteile hält oder vertritt. Jeder Aktionär ist ermächtigt, sich per Sondervollmacht in Hauptversammlungen vertreten zu
lassen. Der Verwaltungsrat beurteilt die Gültigkeit einer solchen Sondervollmacht.
Art. 48. Außer gesetzlich anderweitig verordnet, werden Beschlüsse der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit
der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen. Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder
vertreten, und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.
Art. 49. Hauptversammlungen, welche Beschlüsse über Satzungsänderungen betreffen, benötigen die Teilnahme
oder Vertretung von mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertretenden Aktieninhabern. Die somit gefassten
Beschlüsse benötigen die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, wobei
zumindest Glass’s Cayman und Lederer zustimmen müssen. Nachfolgend aufgeführte Beschlüsse unterliegen insbeson-
dere den hier erwähnten Mehrheitsanforderungen:
10878
1. die Abänderung des Gesellschaftszwecks;
2. die Einschränkung der Übertragbarkeit der Aktien;
3. die Abänderung des Aktienkapitals der Gesellschaft (einschließlich seiner Erhöhung, Zuteilung, seines Rückkauf
oder seiner Herabsetzung), oder der Aktionärsrechte;
4. die Einschränkung oder Tilgung der bevorzugten Bezugsrechte der Altaktionäre;
5. die Verlegung des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft;
6. die Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft.
Falls eine Anhebung der in Paragraph 1 festgelegten Mehrheitsanforderungen beschlossen werden soll, so muss jener
Beschluss zu den durch denselben Beschluss angestrebten Mehrheitsanforderungen getroffen werden.
Art. 50. Sind der Gesellschaft alle Adressen der Aktionäre bekannt, beruft der Verwaltungsrat die Hauptversamm-
lung ausschließlich per Einschreiben ein, andernfalls ergänzt eine Bekanntmachung im Mémorial C den Postversand. Das
Einberufungsschreiben beinhaltet Ort, Datum und Zeit der Hauptversammlung, sowie die Tagesordnung, und wird im
Falle der jährlichen Hauptversammlung zusammen mit einer Kopie der Jahresbilanz der Gesellschaft versendet, und dies
mindestens 20 Tage vor besagter Hauptversammlung. Geschäftsbericht und Bericht der Rechnungsprüfer stehen den
Aktionären zur Einsicht am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft zu Verfügung, und dies mindestens zwanzig Tage
vor der Hauptversammlung.
Art. 51. Das Protokoll eines jeden Beschlusses oder jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird am eingetragenen
Firmensitz der Gesellschaft geführt. Das Protokoll führt Zahl und Art der anwesenden oder vertretenen Aktien an, so-
wie die Beschlüsse, Abstimmungen, Anträge und Antworten und die Erklärungen der Gesellschafter. Das Protokoll wird
vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, vom Sekretär und vom Stimmenzähler der Versammlung unterschrieben.
Die Aktionäre haben Zugang zu diesem Protokoll.
E. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinnausschüttungen
Art. 52. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 53. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen, und die Verwaltungsratsmitglieder
stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Aktionär ist ermächtigt, am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft Inventar und Jahresbilanz einzusehen. Der Jahres-
abschluss wird innerhalb der sechs auf das Ende des Geschäftsjahrs folgenden Monate bestätigt.
Art. 54. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des rest-
lichen Betrages des Nettogewinnes. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdi-
videnden ausschütten.
F. Auflösung der Gesellschaft - Liquidation
Art. 55. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrerer Liquidatoren, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung
ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest. Die Liquidatoren haben alle erforderlichen Be-
fugnisse zur Veräußerung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Überschuss wird unter den Aktionären im
Verhältnis zu dem von ihnen vertretenen Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 56. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, dem Rücktritt aller Mitglieder des Verwaltungsrates zuzustimmen.
Die Versammlung beschließt, den zurücktretenden Mitgliedern des Verwaltungsrates vollständige Entlastung zu ertei-
len bezüglich ihres Mandates während des Finanzjahres 2004, bis zum Tage der gegenwärtigen Versammlung.
Die Versammlung beschließt, folgende Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu ernen-
nen, mit sofortiger Wirkung:
- Herr Nicolas Leutwiler, Verwaltungsratspräsident, geboren am 2. November 1960 in Reinach, Schweiz, mit beruf-
licher Adresse in Quellen AG, Lindenstrasse 11, CH-8832 Wollerau, Schweiz;
- Herr John R. Muse, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 24. Februar 1951 in Worth, Vereinigte Staaten, mit beruf-
licher Adresse in Hicks, Muse, Tate & Furst Limited, 21, Grosvenor Place, London SW1X7HF, Vereinigtes Königreich
- Herr Stephan Lobmeyr, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 29. Juli 1966 in Klagenfurth, Österreich, mit berufli-
cher Adresse in Hicks. Muse, Tate & Furst Limited, 21 Grosvenor Place, London SW1X7HF, Vereinigtes Königreich;
- Herr Lyndon Lea, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 13. Januar 1969 in Morecambe, Vereinigtes Königreich, mit
beruflicher Adresse in Hicks, Muse, Tate & Furst Limited, 21, Grosvenor Place, London SW1X7HF, Vereinigtes König-
reich;
- Dr. Hans Michel Piech, geboren am 10. Januar 1942 in Wien, Österreich, mit beruflicher Adresse in Spiegelgasse 2/
24, 1010 Wien, Österreich;
- Dr. Gerhard Zeidler, geboren am 12. Mai 1936 in Breslau, Deutschland, mit beruflicher Adresse in Haus Dekra,
Handwerkstraße 15, D-70565 Stuttgart, Deutschland;
- Herr Philippe von Stauffenberg, geboren am 17. Mai 1964 in Neuilly-sur-Seine, Frankreich, mit beruflicher Adresse
in Stauffenberg Capital Partners LLP Solidus Private Equity, Thames Whard Studio 2’ Floor, Block 1 Rainville Road, Lon-
don W6 9HA, Vereinigtes Königreich;
Da keine weiteren Angelegenheiten anstehen, ist die Versammlung geschlossen.
10879
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-
teien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, erwähnt am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, welche alle dem Notar mit Vor- und Nachnamen sowie Zi-
vilstand und Wohnsitz bekannt sind, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Y. Gabriel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 9, case 25. – Reçu 34.647,21 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100644.3/211/1671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
INDIGO INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.025.000.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 101.752.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique en date du 6 décembre 2004i>
Il résulte d’une décision de l’Associé Unique de la société en date du 6 décembre 2004 les points suivants:
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Guy Harles de son poste de gérant, et ce avec effet immé-
diat;
- décision a été prise d’accorder pleine et entière décharge au gérant sortant pour la période de son mandat;
- décision a été prise d’accepter la nomination pour une durée indéterminée de Monsieur Alain Peigneux, né à Huy
(Belgique) le 27 février 1968, avec adresse professionnelle aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en tant
que nouveau gérant de la société, et ce avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03694. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100771.3/1005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
DELTA CORP CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 102.800.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 7 décembre 2004 au siège de la
société les actionnaires décident de fixer les pouvoirs de signature de la façon suivante:
Dans le cadre de la gestion journalière des affaires et de la représentation de la société, la société sera engagée soit
par la signature individuelle de l’administrateur-délégué de la société sur qui repose l’autorisation de commerce, soit
avec sa cosignature obligatoire.
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 7 décembre 2004i>
Conformément à l’assemblée générale des actionnaires de ce jour, le Conseil d’Administration entend préciser le
pouvoir de signature de M. David Waroquier de la façon suivante:
Dans le cadre de la gestion journalière des affaires et de la représentation de la société, la société sera engagée soit
par la signature individuelle de M. David Waroquier, administrateur délégué de la société sur qui repose l’autorisation
de commerce, soit avec sa cosignature obligatoire.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des sociétés et associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03063. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101052.3/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Luxemburg, den 27. Oktober 2004.
J. Elvinger.
MERCURIA SERVICES, Société Anonyme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures
10880
CEP II TOP LUXCO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.018.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l’associé unique du 18 novembre 2004i>
Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société du 18 novembre 2004 que le nombre des membres du
conseil de gérance de la Société est porté à cinq (5) et que M. Guy Harles, maître en droit, né le 4 mai 1955 à Luxem-
bourg, demeurant au 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg, a été nommé comme nouveau membre du conseil de gérance
de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui viendra à statuer sur les comptes de l’exercice au 31 décembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03687. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100772.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
BALTAR INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 70.748.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2004i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Ouverture de la séance.
2. Constitution de l’Assemblée Générale.
3. Désignation du secrétaire.
4. Désignation du scrutateur.
5. Cession de 100 parts sociales de SOVEMAR LTD à PARTS INVEST S.A. avec siège social au 63-65, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg
6. Démission de Monsieur José Jumeaux en sa qualité de gérant et nomination de la société PROLUGEST S.A. en lieu
et place.
7. Transfert du siège social du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg vers le 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxem-
bourg
1. La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. José Jumeaux demeurant 36 A, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg.
2. L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l’intégralité du capital social, était régulièrement constituée pour
délibérer valablement, tel qu’elle est constituée, sur les différents points portés à l’ordre du jour. Que l’intégralité du
capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communique au préalable.
3. L’Assemblée choisissait comme secrétaire Mme Edith Milanesi demeurant à 15, rue Jules Vernes, F-57570 Catte-
nom (France)
4. L’Assemblée choisissait comme scrutateur Mme Astrid Cabanas demeurant à 253, route de Burange, L-3429 Du-
delange
5. La société SOVEMAR LTD déclarait son intention de vendre les 100 parts sociales de la société à PARTS INVEST
S.A., société ayant son siège au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
L’assemblée décidait à l’unanimité d’accepter ce transfert de parts sociales. La répartition des parts sociales est donc
dès maintenant comme suit:
6. L’assemblée décidait à l’unanimité la démission de Monsieur José Jumeaux en sa qualité de Gérant et nomination
de la société PROLUGEST S.A. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en lieu et place.
7. L’Assemblée décidait à l’unanimité de transférer le siège social du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg vers
le 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
8. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02168. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101033.3/850/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
<i>Pour CEP II TOP LUXCO, S.à r.l.
i>Signature
PARTS INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
10881
VERTIME S.A., Société Anonyme,
(anc. VERSACE S.A.).
Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 50.977.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale des associés de la société du 30 novembre 2004i>
En date du 30 novembre 2004, les associés de la Société ont décidé:
* d’accepter les démissions des personnes suivantes:
- Monsieur Guy Bernard, demeurant à 8, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Santo Versace, demeurant à 21, Via Dell’Annunciata, I-20121 Milan, Italie;
- Monsieur Emile Uyldert, demeurant à 42, Koningslaan, NL-1075 AX Amsterdam, Pays-Bas,
en tant qu’administrateurs de la Société avec effet au 1
er
décembre 2004;
* d’accepter la démission de Monsieur Guy Bernard, demeurant à 8, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant qu’administrateur délégué de la Société avec effet au 1
er
décembre 2004;
* de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur David Payne, né le 26 juillet 1971 au Tennessee, U.S.A., avec adresse professionnelle à 555 Christian Road,
P.O. Box 310, Middlebury, CT 06762-0310, U.S.A.;
- Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle
à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Markell Fluckiger, né le 22 septembre 1959 en Californie, U.S.A., avec adresse professionnelle à 555 Chris-
tian Road, P.O. Box 310, Middlebury, CT 06762-0310, U.S.A.,
en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet au 1
er
décembre 2004 jusqu’à l’assemblée générale or-
dinaire annuelle des associés de la Société devant se tenir en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02960. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100885.3/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
CHAUFFAGE-SANITAIRE KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
R. C. Luxembourg B 82.874.
—
DISSOLUTION
<i>Clôture de la liquidationi>
<i>Rapport du Liquidateuri>
Par la présente, je fais part de mon rapport sur l’exécution du mandat de liquidateur de CHAUFFAGE-SANITAIRE
KREMER, S.à r.l. (en liquidation) qui m’a été confié par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 juin 2001
par-devant le notaire M
e
Tom Metzler, cette même assemblée ayant décidé de la dissolution anticipée de la société.
Après avoir procédé à la réalisation de tous les actifs et au règlement de tous les passifs, les comptes de liquidation
se présentent comme suit:
<i>Liquidation i>
Les associés sont invités à mettre à la disposition de la société EUR 4.123,61 et EUR 693,40.
Les livres de la société sont conservé à L-6462 Echternach, 10, rue des Bons Malades.
<i>Conclusioni>
Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, je déclare la liquidation com-
me clôturée.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101056.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
VERTIME S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Compte courant associé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.123,61
Frais de liquidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2.530,50
Impôt à paver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2.286,51
Mali de liquidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
693,40
J.-P. Kremer
<i>Liquidateuri>
10882
UNITED AGRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.167.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 23 novembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 2004, volume 529, folio 94, case 12;
I.- Que la société anonyme UNITED AGRO S.A., établie et ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue
de la Liberté, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 61.167, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 octobre
1997, publié au Mémorial C numéro 29 du 14 janvier 1998.
II.- Que la société IIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY PTE. Ltd. s’est rendue propriétaire de la totalité
des actions de la société.
III.- Que la société IIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY PTE. Ltd., réunissant en ses mains la totalité
des actions de la société UNITED AGRO S.A. a décidé de la dissoudre.
IV.- Que par la présente, le comparant, ès qualités, décide de prononcer la dissolution anticipée de la société UNITED
AGRO S.A., avec effet immédiat.
V.- Que l’activité de la société a cessé; l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et il réglera tout le passif de la
société dissoute.
VI.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
VII.- Que décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes.
VIII.- Qu’il y a lieu de procéder à la destruction des titres au porteur.
IX.- Que les livres et documents de la société UNITED AGRO S.A. seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège
social de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 décembre 2004.
(101059.4/231/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
CINDRA FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.
H. R. Luxemburg B 70.763.
—
AUFLÖSUNG
<i>Auszugi>
Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 23. November
2004, einregistriert in Luxemburg A.C., am 1. Dezember 2004, Band 145S, Blatt 92, Fach 3, wurde die Aktiengesellschaft
CINDRA FINANCE S.A., mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, aufgelöst.
Die Liquidation ist erfolgt und die Dokumente und Schriftstücke der Gesellschaft werden während fünf Jahren am
ehemaligen Gesellschaftssitz aufbewahrt.
Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 9. Dezember 2004.
(101075.4/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
GKV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 53.085.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05904, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105839.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour extrait conforme
J. Seckler
Notaire
E. Schlesser
<i>Notari>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
10883
JYVASS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8310 Capellen, 66, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.309.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
23 novembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
décembre 2004, volume 145S, folio 92, case 1, que la société
anonyme JYVASS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-8310 Capellen, 66, route d’Arlon, a été dissoute, que sa
liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
(101076.4/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
BOHMAN FINANCE HOLDING S.A.H., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.
H. R. Luxemburg B 67.458.
—
AUFLÖSUNG
<i>Auszugi>
Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 23. November
2004, einregistriert in Luxemburg A.C., am 1. Dezember 2004, Band 145S, Blatt 92, Fach 2, wurde die Holdinggesell-
schaft BOHMAN FINANCE HOLDING S.A.H., mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, aufgelöst.
Die Liquidation ist erfolgt und die Dokumente und Schriftstücke der Gesellschaft werden während fünf Jahren am
ehemaligen Gesellschaftssitz aufbewahrt.
Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 9. Dezember 2004.
(101078.4/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
COYOTE CAFE LETZEBUERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.118.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2004 i>
L’an deux mille quatre, le 15 novembre, Monsieur Paul Meyer et son épouse Nicole Meyer née Meyer ont, en leur
qualité d’associés uniques représentant la totalité des parts sociales, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Monsieur Domenico Loconte, cuisinier, né le 29 mai 1973 à Luxembourg, demeurant à L-4556 Differdange, 9, rue du
Chemin de Fer, est nommé gérant technique pour le domaine de la restauration.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Paul Meyer, commerçant demeurant à L-3328 Crauthem, 21, rue de Weiler est confirmé dans ses mandats
de gérant administratif et de gérant technique pour le domaine du débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
<i>Troisième résolution i>
Dans la gestion journalière la société est valablement engagée par les signatures conjointes du gérant administratif et
des gérants techniques des domaines respectifs, auxquels un droit de cosignature est accordé dans leur domaine res-
pectif.
Luxembourg, le 15 novembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05020. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101079.3/551/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
E. Schlesser
<i>Notairei>
E. Schlesser
<i>Notari>
P. Meyer / N. Meyer-Meyer
<i>Associéi> / <i>Associéei>
10884
BELIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.909.
—
Suite à l’Assemblée Générale ordinaire du 16 avril 2004, les organes de la société se composent comme suit:
Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable demeurant à Luxembourg, commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02159. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101081.3/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
21 TECH. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.226.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2004i>
<i>Conseil d’Administrationi>
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de son mandat d’administrateur de M. John Mowinckel et a
décidé de nommer M. Roger Neil Smith, Administrateur de Sociétés, demeurant à GB-London NW11 6HE comme nou-
vel administrateur pour terminer le mandat de son prédécesseur. Suite à cette décision le Conseil d’Administration en
fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2007 est composé comme suit:
- Zandona Carlos E., administrateur de sociétés, demeurant à Buenos Aires, catégorie A
- Rezzonico Mauro, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6968 Sonvico, catégorie A
- Lorenzin Renato, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (CH), catégorie A
- Smith Roger Neil, administrateur de sociétés, demeurant à GB-London NW11 6HE, catégorie B
- Spijkerman Theo, administrateur de sociétés, demeurant à NL-1901 LM Castricum, catégorie B
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03593. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101100.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
LOGINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 11.502.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 2004i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004:
<i>Conseil d’administrationi>
Commissaire aux comptes
HRT REVISION, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07540. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105411.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
MM.
Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
Signatures
10885
SECURICOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 8, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 10.427.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2004i>
- Monsieur Carlo Weisen, directeur de sociétés, demeurant à Bergem, est nommé administrateur-délégué responsa-
ble de la gestion journalière de la société. Il pourra engager la société en toute circonstance par sa seule signature.
- Monsieur Guy Wagner démissionne de son poste d’administrateur-délégué. Cependant, il continue à assurer la pré-
sidence au conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(101083.3/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
SECURICOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 8, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 10.427.
—
Suite aux différents changements intervenus, le conseil d’administration de la société se compose par:
- Monsieur Guy Wagner, demeurant à Fentange, administrateur et président
- Monsieur Colonel Fernand Brosius, demeurant à Hesperange, administrateur
- Monsieur Carlo Weisen, demeurant à Bergem, administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2004, réf. LSO-AX00374. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(101085.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
ALBRIDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.865.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2004i>
<i>Conseil d’Administration:i>
L’Assemblée a accepté la démission de Mme Carine Reuter-Bonert et de M. Jean-Hugues Antoine comme adminis-
trateurs de ALBRIDA S.A. et leur donne décharge.
L’Assemblée a décidé de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Rezzonico Mauro, Dirigeant, demeurant à CH-6968 Sonvico
- Renard Alain, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-8321 Olm
- Santino Jo, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-4432 Ans
Le mandat des administrateurs expire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2010.
Suite à ces décisions le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2010 est com-
posé comme suit:
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Rezzonico Mauro, Dirigeant, demeurant à CH-6968 Sonvico
- Renard Alain, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-8321 Olm
- Santino Jo, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-4432 Ans
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03592. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101103.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateuri>
10886
GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R. C. Luxembourg B 92.809.
—
1. La société civile KPMG AUDIT avec siège à Luxembourg a été désignée réviseur externe et chargée du contrôle
des comptes de l’exercice 2004.
2. Le mandat d’administrateur de Mme Josette Pierret-Elvinger a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
qui se tiendra en l’année 2010.
3. Le conseil d’administration se compose comme suit:
- M. Karl-Josef Gottschol, Dipl. Kfm., D-Hagen, président et administrateur-délégué (jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005)
- M. Ralph Gottschol, administrateur de sociétés, administrateur-délégué, L-Doennange (jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2009)
- Dr. Hans-Joachim Gottschol, Dr. Ing., D-Hagen, vice-président (jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra
en l’année 2006)
- Mme Josette Pierret-Elvinger, avocat-avoué, Luxembourg (jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en
l’année 2010)
- Mme Sabine Gottschol, pharmacienne, D-Güterfelde (jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année
2005)
- Mme Gabriele Gottschol-Baasner, administrateur de sociétés, D-Hagen (jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui
se tiendra en 2009)
Luxembourg, le 8 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02999. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101124.3/1261/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
M & M PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 82.954.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX07038, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105864.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
INFORMATION TECHNOLOGY MASTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 62.133.
—
<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique prises à Luxembourg en date du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2004i>
L’actionnaire unique de la Société a pris acte de la démission de monsieur John Cox prenant effet au 30 septembre
2004, ainsi que des démissions de messieurs Stephen Griffiths et Stephen Solcher prenant effet au 1
er
décembre 2004
et leur a accordé, à tous trois, décharge pleine et entière (quitus) pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’au jour de
leur démission. L’actionnaire unique de la société a nommé pour un terme de 6 ans messieurs George White Harring-
ton, Leonard Edwin Travis et Ruud van Overmeire prenant fonction au 1
er
décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03634. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101130.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GOTTSCHOL ALCUILUX S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Signature
Pour extrait
INFORMATION TECHNOLOGY MASTERS INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
10887
GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06413, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105863.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06418, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105842.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06423, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105840.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06428, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105838.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
INFORMATION TECHNOLOGY MASTERS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 64.136.
—
<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique prises à Luxembourg en date du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2004i>
L’actionnaire unique de la Société a pris acte de la démission de monsieur John Cox prenant effet au 30 septembre
2004, ainsi que des démissions de messieurs Stephen Griffiths et Stephen Solcher prenant effet au 1
er
décembre 2004
et leur a accordé, à tous trois, décharge pleine et entière (quitus) pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’au jour de
leur démission. L’actionnaire unique de la société a nommé pour un terme de 6 ans messieurs George White Harring-
ton, Leonard Edwin Travis et Ruud van Overmeire prenant fonction au 1
er
décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03636. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101134.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Signature.
Signature.
Signature
Signature.
Pour extrait
INFORMATION TECHNOLOGY MASTERS TECHNOLOGIES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
10888
VELAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8392 Nospelt, 18, rue d’Olm.
R. C. Luxembourg B 24.320.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04885, ont
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105923.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
EUROPLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 30.096.
—
L’an deux mille quatre, le huit novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Fernando Rocha De Almeida, maître-plâtrier, demeurant à Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin, agissant
comme seul associé et propriétaire des cent parts sociales (100) de la société à responsabilité limitée EUROPLATRE,
S.à r.l., avec siège social à L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 24 fé-
vrier 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 173 du 22 juin 1989;
dont les statuts ont été modifiés en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen,
en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 655 du 21 août 2001;
- modifiés en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil
C des Sociétés et Associations, numéro 1384 du 24 septembre 2002,
- modifiés en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial,
Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 1568 du 31 octobre 2002,
- modifiés en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil
C des Sociétés et Associations, numéro 690 du 1
er
juillet 2003,
- modifiés en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil
C des Sociétés et Associations, numéro 1029 du 4 octobre 2003,
- modifiés en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé en date du 26 septembre 2004, publié au Mémorial,
Recueil C des Sociétés et Associations de l’année 2004, page 17651.
Lequel s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique accepte la démission de Monsieur Rui Fonseca Alves Pindelo, plâtrier, demeurant à L-4251 Esch-sur-
Alzette, 27, rue du Moulin, de sa fonction de gérant unique de la prédite société et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à
ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme gérant unique de la prédite société, à compter de ce jour, pour une durée
indéterminée, Monsieur Fernando Rocha De Almeida, maître-plâtrier, demeurant à Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide que vis-à-vis des tiers la prédite société est engagée en toutes circonstances par la seule si-
gnature du gérant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais droits et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s’élèvent à quatre cents euros
(400,- Euros).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Rocha de Almeida, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2004, vol. 902, fol. 49, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(099883.3/203/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
décembre 2004.
A. Biel.
10889
I.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 2A, rue C. Hemmer.
R. C. Luxembourg B 71.415.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08217, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106019.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
IMMOCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf.
R. C. Luxembourg B 62.820.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08220, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106020.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.279.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07896, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105867.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
TELENET SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. CODENET S.A.).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 73.305.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX07009, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105855.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
CDC SP S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 58.931.
—
<i>Résolution du Conseil d’Administration du 19 mai 2004i>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Alain Prévot du Conseil d’Administration avec
effet au 31 mars 2004.
Le Conseil d’Administration décide de coopter Monsieur Arnaud Chambriard avec effet au 19 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08260. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105873.3/1122/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Luxembourg, le 27 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 décembre 2004.
Signature.
<i>Pour le Conseil de gérance
i>Certifié conforme
J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.
A. D’Alimonte
<i>Assistant Vice-Presidenti>
Luxembourg, le 22 décembre 2004.
Signature.
Certifié conforme et sincère
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures
10890
TELENET SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. CODENET S.A.).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 73.305.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX07008, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105857.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
ROTHESAY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 102.948.
—
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 21 décembre 2004.
(105859.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
CORD A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-8452 Steinfort, Schwarzenhof.
R. C. Luxembourg B 75.554.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05079, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105860.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
AUTOETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4985 Sanem, 10, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 40.236.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06705, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Soleuvre, le 28 décembre 2004.
(105883.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
KITTY BELL’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4601 Differdange, 5, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.914.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06707, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Soleuvre, le 28 décembre 2004.
(105884.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Luxembourg, le 22 décembre 2004.
Signature.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Wiltz, le 20 décembre 2004.
Signature.
<i>Pour AUTOETOILE, S.à r.l.
i>M. Limpach-Scheitler
<i>Comptable indépendanti>
<i>Pour KITTY BELL’S, S.à r.l.
i>M. Limpach-Scheitler
<i>Comptable indépendanti>
10891
TEXTILCORD STEINFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8452 Steinfort, Schwarzenhaff.
R. C. Luxembourg B 7.113.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05082, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105862.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
PASE PRIVATE EQUITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 82.129.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00760, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105881.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
LAGUARDIA CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 93.203.
—
Le bilan pour la période du 9 avril au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-
AX/07011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105885.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
QUADRAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.
R. C. Luxembourg B 47.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06708, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105886.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
FIGESTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 80.400.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2004i>
A l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2004 il a été procédé à:
- la démission du commissaire aux comptes: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
- la nomination d’un réviseur d’entreprise: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. ayant son siège social au 400, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07721. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105900.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Wiltz, le 20 décembre 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 22 décembre 2004.
Signature.
<i>Pour QUADRAM, S.à r.l.
i>M. Limpach-Scheitler
<i>Comptable indépendanti>
Pour extrait conforme
Signature
10892
VINIFERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2011 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.794.
Acte constitutif publié au Mémorial C n
°
540 du 22 décembre 1994
—
Le bilan au 30 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX07014, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105888.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
EXPLOITATION FORESTIERE BRESER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6161 Burglinster, 9, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 90.202.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06431, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bourglinster, le 28 décembre 2004.
(105889.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
VINIFERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2011 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.794.
Acte constitutif publie au memorial C n° 540 du 22 decembre 1994
—
Le bilan au 30 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX07016, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105890.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
FLEURS VERA-VESNALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 8, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 26.876.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06446, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105891.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
OSTERGAARD’S BIKE SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 41, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 80.705.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06444, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105893.4/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Luxembourg, le 22 décembre 2004.
Signature.
J.-C. Breser
<i>L’associé-représentant légali>
Luxembourg, le 22 décembre 2004.
Signature.
S. Djordjevic
<i>La gérantei>
J. Ostergaard
<i>Le géranti>
10893
FADEMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7765 Bissen, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 39.830.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06443, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105894.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
HAPPY RELATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 74.522.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06441, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105896.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
EMPE IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 83.215.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW/06439 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105897.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
EMPE IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 83.215.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW/06438 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105898.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
LUX FORETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7590 Beringen, 51, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 91.612.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06434, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105901.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
A. Mossong
<i>La gérantei>
J. Giacomantonio
<i>Le géranti>
M. Van Der Burg
<i>Le géranti>
M. Van Der Burg
<i>Le géranti>
M. Dos Anjos Mota Dinis
<i>Le géranti>
10894
MAISON WIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 40A, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 91.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06432, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2004.
(105902.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
EXPLOITATION FORESTIERE BRESER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6161 Burglinster, 9, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 90.202.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06425, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bourglinster, le 28 décembre 2004.
(105903.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
GESMAT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8469 Hobscheid, Maison 4.
R. C. Luxembourg B 35.505.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04881, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Arlon, le 28 décembre 2004.
(105909.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
SANGIAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.459.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 novembre 2004i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MAZARS, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105955.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
P. Binsfeld
<i>Le géranti>
J.-C. Breser
<i>L’associé-représentant légali>
<i>Pouri> <i>GESMAT S.A.
i>SUD FIDUCIAIRE SPRL
Signature
Mme
Fulvia Sangiacomo, juriste, demeurant à Brescia (Italie), président;
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
SANGIAFIN S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
10895
HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8469 Hobscheid, Maison 7.
R. C. Luxembourg B 55.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04882, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Arlon, le 28 décembre 2004.
(105910.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
GASTROM POMMERLACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 98.488.
—
L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GASTROM-POMMERLACH S.A. avec
siège social à Schmiede,
constituée suivant acte de scission de la société GASTROM S.A. dont le projet sous seing privé daté du 11 juillet 2003
a été publié au Mémorial C numéro 809 du 2 août 2003 et la scission définitive suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 17 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 264 du 5 mars 2004,
inscrite au Registre de Commerce de et à Diekirch sous le numéro B 98.488,
au capital social de soixante-deux mille cinq cent euros (EUR 62.500,-) représenté par cinquante actions (50) d’une
valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) chacune.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Ernest Schmitz, commerçant, demeurant à
Huldange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Winandy, employé privé, demeurant à Eschweiler/
Wiltz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Conny Wantz, employé privé, demeurant Boevange/Clervaux,
tous ici présents et cet acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire soussigné d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués
sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou leurs mandataires
et les membres du bureau, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou
représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour, conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social à L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne, et fixation de l’adresse postale à L-9964
Huldange, 2, rue de Stavelot - modification subséquente de l’article 2 des statuts.
2.- Fixation des pouvoirs de signature et modification subséquente de l’article 8 des statuts.
3.- Autorisation de la nomination d’un administrateur-délégué.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide transférer le siège social à l’adresse suivante:
L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne - Commune de Winseler.
L’adresse postale est fixée à:
L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts pour le mettre en conformité avec les résolutions prises.
«Art. 2. Le siège social est établi à L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne - Commune de Winseler.
L’adresse postale est fixée à L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
Le siège social et l’adresse postale peuvent être transférés dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg
par une décision du Conseil d’Administration.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer les pouvoirs de signature comme suit: La société se trouve engagée par la signature indi-
viduelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant,
conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’adminis-
trateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.
L’article 8 des statuts est par conséquent modifié pour lui donner la teneur suivante:
<i>Pouri> <i>HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE S.A.
i>SUD FIDUCIAIRE SPRL
Signature
10896
«Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes
Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de nommer Monsieur Michel Kune, cuisinier, demeurant à L-9964
Huldange, 3, op d’Schmëtt en tant qu’administrateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, en raison des présentes, sont à charge
de la société.
Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Schmitz, M. Winandy, C. Wantz, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 2 décembre 2004, vol. 404, fol. 100, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(904115.3/240/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.
GASTROM POMMERLACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 98.488.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(904117.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.
VELAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8392 Nospelt, 18, rue d’Olm.
R. C. Luxembourg B 24.320.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04996, ont
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105924.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Rambrouch, le 15 décembre 2004.
L. Grethen.
L. Grethen.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Copagest S.A.
CEREP Ivry Seine, S.à r.l.
CEREP Ivry Seine, S.à r.l.
Foudre Investments S.A.
EurotaxGlass’s Acquisition S.A.
Indigo Investments Luxembourg, S.à r.l.
Delta Corp Consulting S.A.
CEP II Top Luxco
Baltar Invest, S.à r.l.
Vertime S.A.
Chauffage-Sanitaire Kremer, S.à r.l.
United Agro S.A.
Cindra Finance S.A.
GKV Holding S.A.
Jyvass International S.A.
Bohman Finance Holding S.A.H.
Coyote Café Lëtzebuerg, S.à r.l.
Belim S.A.
21 Tech. S.A.
Loginvest S.A.
Securicor Luxembourg S.A.
Securicor Luxembourg S.A.
Albrida S.A.
Gottschol Alcuilux S.A.
M & M Participations, S.à r.l.
Information Technology Masters International S.A.
GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l.
GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l.
GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l.
GE Capital Luxembourg Financing III, S.à r.l.
Information Technology Masters Technologies S.A.
Velan Holding S.A.
Europlâtre, S.à r.l.
I.E. S.A.
Immocar, S.à r.l.
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures), S.à r.l.
Telenet Solutions Luxembourg S.A.
CDC SP S.A.
Telenet Solutions Luxembourg S.A.
Rothesay
Cord A.G.
Autoétoile, S.à r.l.
Kitty Bell’s, S.à r.l.
Textilcord Steinfort S.A.
Pase Private Equity Holdings S.A.
Laguardia Capital S.A.
Quadram, S.à r.l.
Figestor S.A.
Vinifera International S.A.
Exploitation Forestière Breser, S.à r.l.
Vinifera International S.A.
Fleurs Vera-Vesnalux, S.à r.l.
Ostergaard’s Bike Shop, S.à r.l.
Fademo, S.à r.l.
Happy Relations, S.à r.l.
Empé Immo S.A.
Empé Immo S.A.
Lux Forêts, S.à r.l.
Maison Wies, S.à r.l.
Exploitation Forestière Breser, S.à r.l.
Gesmat S.A.
Sangiafin S.A.
Hostellerie de la Bonne Auberge S.A.
Gastrom Pommerlach S.A.
Gastrom Pommerlach S.A.
Velan Holding S.A.