This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
97
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3
4 janvier 2005
S O M M A I R E
Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Minco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
139
Minco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
AD Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Misys Overseas Investments, S.à r.l., Luxem-
Alison Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
143
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Amalto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Misys Overseas Investments, S.à r.l., Luxem-
Andromédia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
114
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Axial Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
124
Private Life Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . .
127
Axial Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
124
Promedent Medical Supplies S.A., Esch-sur-Al-
AZ Express, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
113
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Canillac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
137
Promedent Medical Supplies S.A., Esch-sur-Al-
CIT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
123
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Citore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
Promedent Medical Supplies S.A., Esch-sur-Al-
Citore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Comgest Panda, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
144
Promedent Medical Supplies S.A., Esch-sur-Al-
Contere S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Croix Pattee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Promedent Medical Supplies S.A., Esch-sur-Al-
Csepel Luxembourg (No. 1), S.à r.l., Luxemburg . .
131
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Csepel Luxembourg (No. 1), S.à r.l., Luxemburg . .
131
Ratina Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
98
DHP Press S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Reval Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
122
Dinolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Reval Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
123
Dinolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Riviera Finance 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
124
European Robot, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
110
Serinha S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
Finacle Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
126
Serinha S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
Financière de Beaufort S.A., Luxembourg . . . . . . .
132
Sigval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
132
GE Fanuc Automation CNC Europe S.A., Echter-
Silawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Silawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
GE Fanuc Automation Europe S.A., Echternach . .
119
Siral S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
GE Fanuc Automation Solutions Europe S.A.,
Siral S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Sorokina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
138
IP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
132
Taboga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds,
Taboga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
Tool Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
131
Loffice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Viga Holdings (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
129
Log S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Viga Holdings (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
129
Lycoris Enterprises S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
126
Wam S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Lycoris Enterprises S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
126
Wam S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Mariz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
143
Watts Holdco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98
98
RATINA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 70.485.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 15 octobre 2004,
que les personnes suivantes ont été re-nommées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateurs de la société:
- Monsieur Neil Cracknell, né le 8 juillet 1961 au Royaume Uni (Huntingdon), demeurant au 10248 Whitetail Drive,
Oakdale CA, 95361, Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur James Clarke, né le 24 octobre 1949 aux Etats-Unis d’Amérique (Illinois), demeurant au 185, River Road,
Deerfield IL, 60015, Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Stephen J. Rolfs, born on May 26, 1964 aux Etats-Unis d’Amérique (Wisconsin), demeurant au 5346 N.
Whitefish Bay, WI 53217, Hollywood, Etats-Unis d’Amérique.
Il résulte également de ladite assemblée que la société AAD FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au 39, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été renommée avec effet
immédiat commissaire aux comptes de la société.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 15 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084657.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.
WATTS HOLDCO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.636.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the twenty-third day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
(1) BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV L.P., a Cayman Islands limited partnership, having its regis-
tered office at WALKERS SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-
lands and acting through its general partner, BLACKSTONE MANAGEMENT ASSOCIATES (CAYMAN) IV L.P., a
Cayman Islands limited partnership, represented by Mrs Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant
to a proxy;
(2) BLACKSTONE FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP (CAYMAN) IV-A L.P., a Cayman Islands limited partner-
ship, having its registered office at WALKERS SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands and acting through its general partner, BLACKSTONE MANAGEMENT ASSOCIATES (CAY-
MAN) IV L.P., a Cayman Islands limited partnership, represented by Mrs Toinon Hoss, prenamed, pursuant to a proxy;
(3) BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV-A L.P., a Cayman Islands limited partnership, having its reg-
istered office at WALKERS SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands and acting through its general partner, BLACKSTONE MANAGEMENT ASSOCIATES (CAYMAN) IV L.P., a
Cayman Islands limited partnership, represented by Mrs Toinon Hoss, prenamed, pursuant to a proxy;
(4) GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P, a Delaware limited partnership, having its registered office at THE CORPO-
RATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 and acting
through its general partner, GS ADVISORS 2000, L.L.C., a Delaware limited liability company, represented by Mrs
Toinon Hoss, prenamed, pursuant to a proxy;
(5) GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE, L.P., a exempt Cayman Islands limited partnership, having its regis-
tered office at MAPLES AND CALDER, P.O.B., 309, George town, Grand Cayman, Cayman Islands, and acting through
its general partner, GS ADVISORS 2000, L.L.C., a Delaware limited liability company, represented by Mrs Toinon Hoss,
prenamed, pursuant to a proxy;
(6) GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & Co. BETEILIGUNGS KG, a German limited partnership, at c/o P+P
PÖLLATH + PARTNER, Potsdamer Platz, Linkstraße 2, 10785 Berlin, and acting through its general partner, GOLD-
MAN, SACHS MANAGEMENT GP GmbH, a German limited liability company, represented by Mrs Toinon Hoss, pre-
named pursuant to a proxy;
(7) GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered of-
fice at THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Del-
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG Tax Advisory Services, S.à r.l.
Signature
99
aware 19801 and acting through its general partner, GS EMPLOYEE FUNDS 2000 GP, L.L.C., a Delaware limited liability
company, represented by Mrs Toinon Hoss, prenamed, pursuant to a proxy;
(8) GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND 2000, L.P., a Delaware limited partnership, having its regis-
tered office at THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilming-
ton, Delaware 19801 and acting through its general partner, GS EMPLOYEE FUNDS 2000 GP, L.L.C., a Delaware limited
liability company, represented by MrsToinon Hoss, prenamed, pursuant to a proxy;
(9) KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the
laws of Alberta, having its registered office at EESON WOOLSTENCROFT L.L.P., 500, 603 7th Avenue S.W., Calgary,
Alberta T2P 2T5, Canada, and acting through its general partner, KKR ASSOCIATES MILLENNIUM (OVERSEAS) LIM-
ITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the laws of Alberta, which is acting through its general part-
ner, KKR MILLENNIUM LIMITED, a Cayman Islands company, represented by Mrs Toinon Hoss, prenamed, pursuant
to a proxy;
(10) KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the laws
of Alberta, having its registered office at EESON WOOLSTENCROFT LLP, 500, 603 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta
T2P 2T5, Canada, and acting through its general partner, KKR 1996 OVERSEAS, LIMITED, a Cayman Islands company,
represented by Mrs Toinon Hoss, prenamed,pursuant to a proxy; and
(11) TPG-WATTS ADVISORS (CAYMAN) INC., a Cayman Islands Exempt Company, having its registered office at
M&C CORPORATE SERVICES Ltd., Ugland House, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, rep-
resented by Mrs Toinon Hoss, prenamed, pursuant to a proxy.
The said proxies, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties, acting in the above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up the
articles of incorporation of a joint stock company in the name of WATTS HOLDCO S.A. (société anonyme) which is
hereby established as follows:
Art. 1. - Name
Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter a Lux-
embourg société anonyme is hereby formed under the name of WATTS HOLDCO S.A.
Art. 2. - Duration
The duration of the Company is unlimited. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the extraor-
dinary general meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpora-
tion.
Art. 3. - Registered office
The Company shall have its registered office in Luxembourg-City in the Grand Duchy of Luxembourg.
The Board of Directors shall have the right to set up offices, administrative centers, agencies and subsidiaries wher-
ever it shall see fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the Board
of Directors and may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the
general meeting of Shareholders.
In the event that the Board of Directors determines that political, economic or social developments or events of
exceptional nature that are likely to affect normal working operations at the registered office or easy communications
with places abroad have occurred, threaten to occur or are imminent, the registered office may be declared provision-
ally transferred abroad, until such time as circumstances have completely returned to normal. Such declaration of the
registered office will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional transfer
abroad of the registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 4. - Object, Purpose
The object of the Company is the holding of participations and interest, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other businesses, enterprises or entities, the acquisition by purchase, subscription, transfer, con-
tribution or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange, contribution or otherwise of stock, bonds,
debentures, certificates, notes and other securities or instruments of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its busi-
ness through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds,
certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of security or instrument.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to com-
panies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has any financial or other interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry
out any operation which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform without limitation all commercial, technical and financial or other operations, con-
nected or related directly or indirectly with its purposes in all areas in order to facilitate the accomplishment of its pur-
poses.
Art. 5. - Capital of the Company
The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by twenty-four
thousand eight hundred (24,800) Shares with a nominal value of one point twenty-five euro (EUR 1.25) each.
100
The Company shall not issue fractional Shares. The Board of Directors shall be authorised at its discretion to provide
for the payment of cash or the issuance of script in lieu of any fraction of a share.
The Company may repurchase its own Shares in accordance with accordance with applicable law.
Art. 6. - Increase, Reduction of capital
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner
required for amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 7. - Shares of the Company
The Shares are in registered form only.
A register of Shareholders will be kept at the registered office of the Company where it will be available for inspection
by any Shareholder. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said register. A transfer of
registered Shares in accordance with the present Articles of Incorporation shall be carried out by means of a declaration
of transfer entered in the said register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised
representatives. The Company may accept and enter in the register a transfer on the basis of correspondence or other
documents recording the agreement between the transferor and the transferee.
The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the Share will be required to name one person as the owner of the Share vis-à-vis the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one person has been so
designated. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a
pledgor and a pledgee.
The Company may consider the person in whose name the registered Shares are registered in the register of Share-
holders as the full owner of such registered Shares. The Company shall be completely free from every responsibility in
dealing with such registered Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims
of such third parties in or upon such registered Shares to be non-existent, subject, however, to any right which such
third party might have to demand the registration or change in registration of registered Shares. In the event that a
holder of registered Shares does not provide an address to which all notices or announcements from the Company may
be sent, the Company may permit a note to this effect to be entered into the register of Shareholders and such holder’s
address will be deemed to be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered by
the Company from time to time, until a different address shall be provided to the Company by such holder. The holder
may, at any time, change his address as entered in the register of Shareholders by means of written notification to the
registrar.
Upon the request of a Shareholder, certificates recording the entry of such Shareholder in the register of Sharehold-
ers may be issued in such denominations as the Board of Directors shall prescribe. The certificates so issued shall be in
such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the Board of Direc-
tors. Such certificates shall be signed manually or by facsimile by two Directors of the Company or by a delegatee of
the Board of Directors.
Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indem-
nities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated certificates shall be delivered before new
share certificates are remitted.
Art. 8. - Voting rights
Each Share is entitled to one vote at general meeting of Shareholders, unless otherwise provided by law.
Art. 9. - Board of Directors
The Company shall be managed by a Board of Directors composed of no less than four (4) members who need not
be Shareholders of the Company (the «Directors»).
The Directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders by a simple majority vote of the shares
present or represented and voting for a period not exceeding 6 years. If no term is indicated in the relevant resolution,
the Directors then appointed are appointed for a period of six years; provided however always that any Director may
be removed with or without cause (ad nutum) by the general meeting of Shareholders by a simple majority vote of the
shares present or represented and voting at such general meeting of Shareholders. The Directors shall be eligible for
re-election.
In the case the vacancy in the office of a Director because of death, retirement, resignation, dismissal, removal or
otherwise, the remaining Directors may fill such vacancy by way of co-optation on a provisional basis.
Art. 10. - Chairman of the Board, day to day management
The Board of Directors may appoint a chairman among its members (the «Chairman»). The chairman of the Board
of Directors will generally preside over all meetings of the Board of Directors and of Shareholders. In the absence of
the chairman, either another Director or (but only in the event of Shareholder meetings, in the event that there are no
other Directors present) an ad hoc chairman elected by the relevant meeting shall chair the relevant Board of Directors’
meeting or the general Shareholders’ meeting. The chairman shall not have a casting vote.
The Board may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the power to represent
the Company in its day to day business, to individual Directors, committees or other officers or agents of the Company,
who need not be Shareholders. The Board will fix the conditions of appointment and dismissal as well as the remuner-
ation and powers of any person or persons so appointed. Any such delegation of daily management in favour of one or
more Directors requires the prior authorisation of the general meeting of Shareholders.
The Board may establish committees to or of the Board, appoint the members thereto (which may be Directors but
do not have to be) and determine the committees’ (if any) powers.
101
The Board of Directors may appoint a secretary of the Company, who need not be a member of the Board of Di-
rectors or a Shareholder, and determine his responsibilities, powers and authorities.
Art. 11. - Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, any Director (or by the secretary upon request by the
Chairman or any Director). Notice of any meeting shall be given by letter, telegram, telephone, facsimile transmission
or e-mail advice to each Director wherever practical 1 (one) business day before the meeting, except in the case of an
emergency or corporate urgency, in which event a twelve hours notice shall be sufficient, unless all Board members are
present or represented or such convening period has been waived by those Board members not present or represented
at the relevant meeting.
The convening notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or email of each Director and
is implicitly waived if all Board members are present or represented at a meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board
of Directors.
A meeting of the Board of Directors shall be duly quorated only if all of the Board members are present or repre-
sented.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing by letter or by telegram, or
facsimile transmission any other Director as his proxy. Any Director may represent more than one of his colleagues.
Any Director may also attend in all circumstances a Board meeting by telephone or by way of video conference. Such
attendance shall be equivalent to a physical attendance.
A meeting of the Board of Directors may be held in all circumstances by way of conference call or similar means of
communications. Such meeting shall be equivalent to a physical meeting.
Decisions of the Board of Directors shall be taken only by a unanimous vote of the Directors present or represented
at the meeting.
The Board of Directors may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by
circular means and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of the same res-
olution and may be evidenced by letters, cables or facsimile transmission.
Art. 12. - Minutes of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by all of the Directors.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
any one Director or by the secretary (if any).
Art. 13. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise
and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the Company. All pow-
ers not expressly reserved by the law or by the Articles of the Company to the general meeting of Shareholders shall
be within the competence of the Board of Directors.
Art. 14. - Binding signatures
The Company shall be bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole or joint signature(s) of any
person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors.
Art. 15. - Conflicts of interest
No contract or other transaction between the Company and any other corporation or entity shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in or is a director,
officer or employee of such other corporation or entity. Any Director or officer of the Company who serves as direc-
tor, officer or employee of any corporation or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not solely by reason of such affiliation with such other corporation or entity be prevented from consid-
ering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director of the Company shall have a personal interest in any transaction of the Company sub-
mitted to the vote of the Board of Directors, conflicting with the interest of the Company, such Director or officer shall
make known to the Board of Directors such personal conflicting interest and shall not deliberate or vote on such trans-
action. Any such transaction shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.
Art. 16. - Directors’ indemnification
Subject to the exceptions and limitations listed below:
(i) Every person who is, or has been, a Director or officer of the Company shall be indemnified by the Company to
the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in con-
nection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his
being or having been such Director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.
(ii) The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil,
criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words «liability» and «expenses» shall include with-
out limitation attorneys’ fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.
No indemnification shall be provided to any Director or officer:
(i) Against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
102
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the Board of Directors.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon re-
ceipt of any undertaking by or on behalf of the officer or Director, to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this Article 16.
Art. 17. - General Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company. General meetings of Shareholders are convened by the Board of Directors or by any Shareholder.
The annual general meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or
at such other place as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Wednesday of the month of
May in each year at 11.00 and for the first time in 2005. If such day is a legal holiday in the Grand Duchy of Luxembourg
the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Resolutions at a meeting of Shareholders will be passed only by the unanimous vote of all shares, save for the revo-
cation of board members which shall be passed by a simple majority vote of the shares represented at the relevant
meeting.
A Shareholder may be represented at a general meeting by a proxy who need not be a Shareholder.
If the entire issued share capital is represented at a general meeting of Shareholders, the proceedings of the general
meeting will be deemed valid even if no notice has been issued beforehand.
Art. 18. - Amendment of the Articles of Incorporation
The Articles of Incorporation may be amended from time to time by a resolution of the general meeting of Share-
holders to the quorum and voting requirements provided herein.
Art. 19. - Audit of the Company
The audit of the Company’s affairs will be carried out by a statutory auditor, unless otherwise provided by law. The
auditor shall be elected by the general meeting of Shareholders by the unanimous vote of all shares for a maximum pe-
riod of six years or until his successor is elected. The auditor shall be eligible for re-election.
Any auditor so elected may be removed with or without cause by the general meeting of Shareholders by the unan-
imous vote of all shares.
Art. 20. - Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the first January of each year and shall terminate on thirty-first
December of the same year (except for the year of incorporation which shall begin on the day of incorporation and
terminate on 31st December 2004).
Art. 21. - Allocation of results, Legal reserve
The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the an-
nual results of the Company will be disposed of.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company as stated in the Articles of Incorporation or as increased or reduced from time to time as pro-
vided for therein.
Art. 22. - Interim dividends
Interim dividends may be declared and paid by the Board of Directors subject to observing the terms and conditions
provided by law.
Art. 23. - Liquidation of the Company
In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever time, the liquidation will be per-
formed by liquidators or by the Board of Directors then in office who will be endowed with the powers provided by
articles 144 et seq. of the Luxembourg Company Law of 10th August, 1915.
Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of
Shares in the Company.
Art. 24. - Definitions
Art. 25. - Law of 10
th
August 1915
Except as otherwise provided herein the provisions of the Luxembourg Company Law of 10
th
August 1915, as
amended, will apply.
Articles or Articles of Incorporation:
Means the articles of incorporation of the Company from time to time.
Shareholder:
Means a holder of Shares of the Company.
Shares:
Means the shares of the Company with a nominal value of one point
twenty-five euro (EUR 1.25) each.
103
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing par-
ties have subscribed and paid up 25% of the total subscription price of the following shares:
Each of the Subscribers represented as aforesaid subscribed to the number of shares set out above against its name.
The shares have each been paid up for one quarter (25%) of their subscription price and nominal value of EUR 1.25 per
share.
Evidence of the payment of 25% of the total subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The members have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are named members of the Board of Directors of the Company for a period ending at the
general meeting approving the accounts of 2005 subject to the articles of incorporation of the Company:
3. The following person is appointed as statutory auditor of the Company for a term to end at the general meeting
resolving on the 2005 accounts:
EUROFID, S.à r.l., société à responsabilité limitée, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg and registered with the commercial register under the number B 92.176.
<i>Special provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2004.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
Subscribers
Number of shares
Aggregate subscription
price (EUR 1.25 per
share)
Payment
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS
(CAYMAN) IV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,798
7,247.50 EUR
1,811.875 EUR
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS
(CAYMAN) IV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
115.00 EUR
28.750 EUR
BLACKSTONE FAMILY INVESTMENT
PARTNERSHIP (CAYMAN) IV-A L.P. . . . . . . .
310
387.50 EUR
96.875 EUR
GS CAPITAL PARTNERS, 2000, L.P. . . . . .
3,527
4,408.75 EUR
1,102.188 EUR
GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFF-
SHORE, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,281
1,601.25 EUR
400.313 EUR
GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH &
Co. BETEILIGUNGS KG . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
183.75 EUR
45.938 EUR
GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE
FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,121
1,401.25 EUR
350.313 EUR
GOLDMAN SACHS DIRECT INVEST-
MENT FUND 2000, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
155.00 EUR
38.750 EUR
KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS),
LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,076
7,595.00 EUR
1,898.750 EUR
KKR PARTNERS (INTERNATIONAL),
LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
155.00 EUR
38.750 EUR
TPG-WATTS ADVISORS (CAYMAN) INC.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,200
7,750.00 EUR
1,937.500 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,800
31,000.00 EUR
7,750.000 EUR
Name
Address
Date of birth
Place of birth
Chinh Chu
c/o THE BLACKSTONE GROUP, 345, Park Av-
enue, 31st Floor, New York, NY 10154
October 7, 1966
Saigon, Vietnam
Adrian Jones
c/o GOLDMAN, SACHS & Co., 85, Broad
Street, New York, NY 10004
June 10, 1964
Roscommon, Ireland
Michael W. Michel-
son
c/o KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & Co.,
2800, Sand Hill Road, Suite 200, Menlo Park, CA
94025
April 10, 1951
Chester, Pennsylvania,
United States
Todd Sisitsky
c/o TEXAS PACIFIC GROUP, 345, California
Street, Suite 3300, San Francisco, CA 94104
October 5,
1971
Brooklyn, New York,
United States
104
The document having been read to the appearing person,known to the notary by her name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l’an deux mille quatre, le vingt-trois octobre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg),
Ont comparu:
(1) BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV L.P., un limited partnership du droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à WALKERS SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, et agissant par son general partner, BLACKSTONE MANAGEMENT ASSOCIATES (CAYMAN) IV L.P., un limi-
ted partnership du droit des Iles Cayman, représenté par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, résidant à Luxembourg agis-
sant par mandat (lequel mandat est déposé avec le présent document);
(2) BLACKSTONE FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP (CAYMAN) IV-A L.P., un limited partnership du droit des
Iles Cayman, ayant son siège social à WALKERS SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands, et agissant par son general partner, BLACKSTONE MANAGEMENT ASSOCIATES (CAY-
MAN) IV L.P., un limited partnership du droit des Iles Cayman, représenté par Madame Toinon Hoss, maître en droit,
résidant à Luxembourg, agissant par mandat;
(3) BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV-A L.P., un limited partnership du droit des Iles Cayman,
ayant son siège social à WALKERS SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, et agissant par son general partner, BLACKSTONE MANAGEMENT ASSOCIATES (CAYMAN) IV L.P.,
un limited partnership du droit des Iles Cayman, représenté par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par
mandat;
(4) GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P., un limited partnership du droit de l’Etat du Delaware, ayant son siège social
à THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware,
19801, et agissant par son general partner GS ADVISORS 2000 L.L.C., une limited liability company du droit de l’Etat
du Delaware, représentée par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par mandat;
(5) GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE, L.P., un limited partnership exempt du droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à MAPLES AND CALDER, P.O.B., 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, et agissant par
son general partner, GS ADVISORS 2000, L.L.C., une limited liability company du droit de l’Etat du Delaware, repré-
sentée par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par mandat;
(6) GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & Co. BETEILIGUNGS KG, un limited partnership de droit allemand, ayant
son siège social à c/o P+P PÖLLATH + PARTNER, Potsdamer Platz, Linkstrasse 2, 10785 Berlin et agissant par son ge-
neral partner, GOLDMAN SACHS MANAGEMENT GP GmbH, une limited liability company de droit allemand, repré-
sentée par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par mandat;
(7) GS CAPITAL PARTNERS 2002 EMPLOYEE FUND, L.P., un limited partnership du droit de l’Etat du Delaware,
ayant son siège social à THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, 19801, et agissant par son general partner, GS EMPLOYEE FUNDS 2000 GP, L.L.C., une limited
liability company du doit du Delaware, représentée par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par mandat;
(8) GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND 2000, L.P., un limited partnership du droit de l’Etat du De-
laware, ayant son siège social à THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware, 19801, et agissant par son general partner, GS EMPLOYEE FUNDS 2000 GP, L.L.C., une
limited liability company du droit de l’Etat du Delaware représentée par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant
par mandat;
(9) KKR MILLENIUM (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership du droit de Alberta, ayant son
siège social à EESON WOOLSTENCROFT, L.L.P., 500, 603 7th Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 2T5, Canada, et agis-
sant par son general partner, KKR ASSOCIATES MILLENIUM (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, un limited par-
tnership du droit de Alberta, qui agit par son general partner, KKR MILLENIUM LIMITED, une société des Iles Cayman,
représentée par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par mandat;
(10) KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership du droit de Calgary, Al-
berta, ayant son siège social à EESON WOOLSTENCROFT, L.L.P., 500, 603 7th Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 2T5,
Canada, et agissant par son general partner, KKR 1996 OVERSEAS LIMITED, une société des Iles Cayman, représentée
par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par mandat, et
(11) TPG-WATTS ADVISORS (CAYMAN) INC., une société exempte du droit des Iles Cayman, ayant son siège so-
cial à M&C CORPORATE SERVICES Ltd, Ugland House, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
représentée par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par mandat.
Les procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présen-
tes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société anonyme, dénommée WATTS HOLDCO S.A. (société anonyme), lesquels sont établis comme suit:
Art. 1
er
. - Nom
Il est constitué par la présente, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions, une
société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de WATTS HOLDCO S.A.
Art. 2. - Durée
La société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assem-
blée générale extraordinaire des Actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
105
Art. 3. - Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’Administration, des bureaux, centres administratifs, succursales ou
filiales partout où il l’estimera opportun, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration
et peut être transférée à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des Action-
naires.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec l’étranger se sont
produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 4. - Objet de la société
La Société a pour objet la prise de participations et d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou autres transactions, entreprises ou entités, l’acquisition par achat, souscription,
transfert, contributions ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange, apport ou de toute autre
manière d’actions, obligations, titres d’emprunt, bons de caisse, certificats de dépôts et d’autres valeurs et instruments,
ainsi que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des
parts dans des sociétés de personnes et exercer son objet à travers des succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder par placement public ou privé à l’émission
d’obligations, de certificats, de titres d’emprunt et de reconnaissances de dette de toute nature de même que tout autre
type de valeurs ou instruments.
D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance (par voie de prêts, d’avances, de garanties, de titres ou
par d’autres moyens) à toute société, entreprise, entités ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt finan-
cier quelconque ou autre intérêt, ou qui fait partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie, prendre toutes
mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et
le développement de son objet.
En général, la Société peut accomplir sans limitations toutes opérations commerciales, techniques, financières ou
autres opérations, directement ou indirectement liées à son activité, dans tous domaines dans le but de faciliter l’accom-
plissement de son activité.
Art. 5. - Capital de la société
Le capital émis par la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par vingt-quatre mille huit
cents (24.800) Actions ayant chacune une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).
La Société n’émettra pas de fractions d’actions. Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer discrétionnaire-
ment des paiements en espèces en lieu et place de fractions d’actions.
La Société pourra racheter ses propres actions en accord avec la loi applicable.
Art. 6. - Augmentation, réduction de capital
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des Actionnaires sta-
tuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification de statuts.
Art. 7. - Les actions de la société
Les actions sont uniquement des actions nominatives.
Un registre des actionnaires sera conservé au siège social de la Société où il sera disponible pour inspection par tout
Actionnaire. La propriété des Actions nominatives sera établie par inscription dans ce registre. Un transfert des Actions
nominatives conformément aux présents Statuts est effectué par déclaration de transfert inscrite dans ce registre, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. La Société peut accepter
et inscrire dans ce registre un transfert sur base de correspondance ou d’autres documents établissant l’accord entre
le cédant et le cessionnaire
La Société ne reconnaîtra qu’un détenteur par Action. Dans le cas où une Action est détenue par plus d’une personne,
les personnes revendiquant la propriété de l’Action seront tenus de nommer une personne comme étant le propriétaire
de l’Action . La Société a le droit de suspendre l’exercice de tout droit attaché à une telle Action jusqu’à ce qu’une telle
personne ait été ainsi désignée. La même règle s’appliquera en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire
ou entre un gageur et un créancier gagiste.
La Société pourra considérer la personne au nom de laquelle sont inscrites les Actions nominatives dans le registre
des Actionnaires comme étant le propriétaire unique de telles Actions nominatives. La Société sera complètement libre
de toute responsabilité vis-à-vis des tiers pour les opérations portant sur de telles Actions nominatives et sera en droit
de considérer comme inexistants tous droits, intérêts ou prétentions des tiers sur, ou en relation avec les Actions no-
minatives concernées, à l’exception cependant du droit des tiers de demander l’inscription ou le changement de l’ins-
cription dans le registre de tout droit que ce tiers peut avoir relatif à ces Actions nominatives. Dans le cas où le
détenteur d’une Action nominative ne procure pas une adresse à laquelle tous les avis et notices de la Société pourront
lui être envoyées, la Société peut permettre qu’une note soit inscrite à cet effet dans le registre des Actionnaires et que
l’adresse d’un tel Actionnaire soit considérée comme étant l’adresse du siége social de la Société ou toute autre adresse
pouvant être inscrite dans le registre de temps à autre, jusqu’à ce qu’une adresse différente ait été fournie à la Société
par cet Actionnaire. L’Actionnaire peut à tout moment modifier l’adresse inscrite sur le registre des Actionnaires par
le biais d’une notification écrite au teneur du registre.
106
A la demande d’un Actionnaire, des certificats attestant l’inscription d’un tel actionnaire dans le registre des Action-
naires, peuvent être émis dans les coupures déterminées par le Conseil d’Administration. Les certificats émis prendront
la forme et porteront les légendes et numéros d’identification tels que déterminés par le Conseil d’Administration. De
tels certificats doivent être signés de manière manuscrite ou par griffe par deux directeurs de la Société ou par un re-
présentant du Conseil d’Administration.
Les certificats perdus, volés ou endommagés seront remplacés par la Société sur présentation de preuves, garanties
et indemnités jugées satisfaisantes par la Société, sous réserve que des certificats endommagés soient remis avant que
ne soient délivrés des nouveaux certificats.
Art. 8. - Droit de vote
Chaque Action donne droit à un vote aux assemblées générales des Actionnaires, sauf disposition contraire de la loi.
Art. 9. - Conseil d’administration
La Société est dirigée par un Conseil d’Administration composé au minimum de quatre (4) membres qui n’ont pas
besoin d’avoir la qualité d’Actionnaire de la Société (les «Administrateurs»)
Les Administrateurs sont nommés, par l’assemblée générale des Actionnaires statuant à la majorité simple des actions
présentes ou représentées et votantes, pour une durée n’excédant pas six ans. Si aucune durée n’est indiquée dans la
résolution concernée, les Administrateurs nommés sont alors nommés pour une durée de six ans, étant entendu ce-
pendant qu’un Administrateur peut toujours être révoqué avec ou sans raison (ad nutum) par l’assemblée générale des
Actionnaires statuant à la majorité simple des Actions présentes ou représentées et votantes à cette assemblée générale
des Actionnaires. Les Administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’Administrateur pour cause de décès, départ en retraite, de démission, de révocation
ou tout autre cause, les Administrateurs restants peuvent provisoirement suppléer à cette vacance par cooptation.
Art. 10. - Président du Conseil d’administration, gestion au jour le jour
Le Conseil d’Administration peut nommer un président («le Président») parmi ses membres. Le Président du Conseil
d’Administration présidera généralement toutes les réunions du Conseil d’Administration et toutes les assemblées des
Actionnaires. En cas d’absence du Président, soit un autre administrateur soit (mais uniquement dans le cas d’assemblées
des Actionnaires, où il n’y a pas d’Administrateur présent) un Président ad hoc élu par l’assemblée concernée, devra
présider la réunion du Conseil d’Administration concerné ou l’assemblée générale des Actionnaires concernée. Le Pré-
sident n’a pas de voix prépondérante.
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que le pouvoir de représenter la
Société dans ses affaires courantes, à un ou plusieurs Administrateurs, à des comités ou autres membres, ou mandataires
de la Société, qui n’ont pas besoin d’être Actionnaires. Le Conseil d’Administration déterminera les conditions de no-
mination et de révocation ainsi que la rémunération et les pouvoirs de la ou des personnes ainsi nommés. Toute délé-
gation de la gestion courante en faveur de un ou plusieurs Administrateurs nécessite l’autorisation préalable de
l’assemblée générale des Actionnaires.
Le Conseil d’Administration peut créer des comités extérieurs ou dépendants du Conseil d’Administration, en dési-
gner les membres (qui peuvent être mais n’ont pas l’obligation d’être Administrateurs) et déterminer le pouvoir des
comités (le cas échéant).
Le Conseil d’Administration peut nommer un secrétaire de la Société qui n’a pas besoin d’être un membre du Conseil
d’Administration ou un actionnaire, et déterminer ses responsabilités, pouvoirs et compétences.
Art. 11. - Réunion du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit à la demande du Président ou de tout Administrateur (ou à la demande du
secrétaire agissant à la demande du Président ou d’un Administrateur). La convocation à une réunion pourra être faite
par lettre, télégramme, téléphone, fax ou e-mail à chaque Administrateur, si possible un (1) jour ouvrable avant la réu-
nion, sauf en cas d’urgence ou d’urgence sociétaire auquel cas une convocation donnée douze (12) heures avant la réu-
nion est suffisante, à moins que tous les membres du Conseil d’Administration ne soient présents ou représentés ou
que les membres du Conseil d’Administration non présents ou non représentés à cette réunion aient renoncé à un tel
délai de convocation.
Il peut être renoncé à une telle convocation par écrit, par fax ou télégramme ou e-mail par chaque Administrateur
et il y est implicitement renoncé si tous les membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés à la
réunion. Des convocations distinctes ne sont pas requises pour les réunions particulières qui se déroulent aux heures
et places déterminées dans un programme adopté préalablement par une résolution du Conseil d’Administration.
Une réunion du Conseil d’Administration dispose seulement du quorum nécessaire pour délibérer, si tous les mem-
bres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés.
Tout Administrateur peut agir lors d’une réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par lettre, par
télégramme ou par fax, tout autre Administrateur comme son mandataire. Tout Administrateur peut représenter plus
D’un de ses collègues. Tout Administrateur peut aussi assister en toute circonstances à un Conseil d’Administration par
téléphone ou par vidéoconférence. Cette manière d’assister à une réunion du Conseil d’Administration est considérée
comme équivalente à une présence physique.
Les décisions du Conseil d’Administration sont seulement adoptées à l’unanimité des votes des Administrateurs pré-
sents ou représentés à la réunion.
Le Conseil d’Administration peut également en toutes circonstances et à tout moment adopter à l’unanimité des dé-
cisions au moyen de résolutions circulaires écrites et signées par tous les membres du Conseil, une telle décision sera
aussi valable et effective que si elle avait été adoptées lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signa-
tures pourront apparaître sur un même document ou sur plusieurs copies d’une même résolution et pourront être
prouvées par lettres, télégramme ou par fax.
107
Art. 12. - Procès-verbaux du Conseil d’Administration
Le procès-verbal de toute réunion du Conseil d’Administration devra être signé par tous les Administrateurs.
Des copies ou extraits de ces procès-verbaux peuvent être produits en justice ou en d’autres circonstances devront
être signés par un des Administrateurs ou par le secrétaire (s’il y en a un).
Art. 13. - Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour
autoriser et/ou réaliser tous les actes de gestion, de disposition et d’administration dans le cadre de l’objet social. Tous
les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts de la Société à l’assemblée générale des Actionnaires
sont de la compétence du Conseil d’Administration.
Art. 14. - Signatures engageant la Société
La Société est engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la seule signature ou la signature
conjointe de toute personne ou des personne auxquelles ce pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d’Admi-
nistration.
Art. 15. - Conflits d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et tout autre société ou entité ne sont affectés ou annulés par
le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt dans une telle société en-
registrée ou personne morale, ou en est Administrateur, fondé de pouvoir ou employé. Tout Administrateur ou fondé
de pouvoir de la Société qui est Administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou entité avec laquelle
la Société conclue des contrats ou noue des relations d’affaires, ne saurait en raison de ce seul lien avec cette autre
société ou entité, être privé du droit de délibérer, et de voter sur ou d’intervenir dans une quelconque matière ayant
trait à de pareils contrats ou affaires.
Au cas où un Administrateur de la Société a un intérêt personnel dans une transaction de la Société soumise au vote
du Conseil d’Administration, qui est en conflit avec les intérêts de la Société, cet Administrateur ou fondé de pouvoir
doit faire connaître au Conseil d’Administration ce conflit d’intérêt et ne doit pas délibérer ou voter à propos de cette
transaction. Une telle transaction doit être rapportée à la prochaine assemblée générale des Actionnaires.
Art. 16. - Indemnisation des Administrateurs
Sous réserve des exceptions et limitations indiquées ci-dessous:
(i) Toute personne qui est ou a été Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société est indemnisée par la Société,
à concurrence du maximum permis par la loi, de toute responsabilité et dépenses raisonnablement encourues ou dé-
boursées par elle en rapport avec une quelconque demande, action, poursuite ou procédure à laquelle elle a été mêlée
ou autrement impliquée en sa qualité, présente ou passée, d’Administrateur, de fondé de pouvoir de la Société, de même
que de tous montants payés ou exposés à titre de transactions;
(ii) Les termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s’appliqueront à toutes les demandes, actions,
poursuites ou procédures (civiles, pénales et autres, y compris les instances d’appel) en cours ou pendantes; les termes
«responsabilités» et «dépenses» incluent sans restriction les honoraires d’avocats, les frais, les amendes, les montants
payés à titre d’arrangements et autres dettes,
Aucune indemnisation n’est consentie à un Administrateur ou fondé de pouvoir:
(i) Pour la mise en cause de sa responsabilité envers la Société ou ses Actionnaires découlant d’une infraction inten-
tionnelle, de mauvaise foi, de faute grave ou d’imprudence grossière dans l’accomplissement des devoirs découlant de
sa fonction;
(ii) Pour tout acte pour lequel il aura été finalement jugé qu’il a agi de mauvaise foi et non dans l’intérêt de la Société;
où
(iii) En cas de transaction, à moins que cet arrangement n’ait été approuvé par un tribunal compétent ou par le Conseil
d’Administration.
Le droit à indemnisation, tel que prévu par le présent article, est autonome et n’affecte pas les autres droits dont un
Administrateur ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsiste à l’égard d’une per-
sonne ayant cessée d’être Administrateur ou fondé de pouvoir et se transmet aux héritiers, exécuteurs testamentaires
et administrateurs de cette personne. Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit à indemnisation qui peut
être accordé par contrat ou autrement par la loi au personnel de la Société y compris aux Administrateurs et aux fondés
de pouvoir.
Les dépenses engagées en vue de la préparation et de la représentation d’une défense dans le cadre de toute deman-
de, action, poursuite ou procédure telles que décrites dans le présent article sont avancées par la Société avant la déci-
sion finale, contre l’engagement de l’Administrateur ou du fondé de pouvoir de rembourser le montant avancé s’il
apparaît en définitive qu’il n’avait pas droit à indemnisation en vertu du présent article 16.
Art. 17. - Assemblée Générale des Actionnaires
Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des Actionnaires de
la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, accomplir ou ratifier les actes concernant les opé-
rations de la Société. L’assemblée générale des Actionnaires est convoquée par le Conseil d’Administration ou par tout
Actionnaire.
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunira à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre
endroit précisé par la convocation à l’Assemblée, le premier mercredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures
et pour la première fois en 2005. Si ce jour est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, l’assemblée générale
annuelle des Actionnaires aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
108
Les résolutions de l’assemblée générale des Actionnaires sont seulement adoptées à l’unanimité de toutes les Actions,
à l’exception de la révocation des membres du Conseil d’Administration qui sera décidée par la majorité simple des
votes des Actionnaires présentes ou représentées lors de l’assemblée.
Un Actionnaire peut être représenté à une assemblée générale des Actionnaires par un mandataire qui n’a pas besoin
d’être un Actionnaire.
Si la totalité du capital émis est représenté à l’assemblée générale des Actionnaires, les délibérations de l’assemblée
générale des Actionnaires sont considérées comme valable même en l’absence de convocation préalable.
Art. 18. - Modification des statuts
Les Statuts peuvent être modifiés de temps à autre par une décision de l’assemblée générale des Actionnaires selon
les quorums et majorités prévus par les présents Statuts.
Art. 19. - L’audit de la Société
L’audit des affaires de la Société sera effectué par un commissaire aux comptes, sauf dispositions contraires prévues
par la loi.
Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale des Actionnaires à l’unanimité des Actions pour une
durée maximale de six (6) ans ou jusqu’à ce que son successeur ait été élu. Le commissaire aux comptes est rééligible.
Tout commissaire aux comptes ainsi élu peut être révoqué avec ou sans motifs par l’assemblée générale des Action-
naires à l’unanimité du vote des Actions.
Art. 20. - Exercice comptable
L’exercice comptable de la société commence le premier (1
er
) janvier de chaque année et prend fin le trente et un
(31) décembre de la même année (sauf pour l’année de la constitution, qui commencera le jour de la constitution et se
terminera le 31 décembre 2004).
Art. 21. - Répartition des bénéfices, allocation à la réserve légale
L’assemblée générale des Actionnaires, sur recommandation du Conseil d’Administration, déterminera l’affectation
du bénéfice annuel de la Société.
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par
la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
(10%) du capital souscrit de la Société, comme prévus dans les présents Statuts ou augmenté ou diminué de temps à
autre comme prévu dans les Statuts
Art. 22. - Acompte sur dividendes
La distribution d’acomptes sur dividendes peut être décidée et payée par le Conseil d’Administration, sous réserve
de l’observation des modalités et conditions prévues par la loi.
Art. 23. - Liquidation de la Société
En cas de dissolution de la Société pour quelque raison ou à quelque moment que ce soit, la liquidation sera réalisée
par des liquidateurs ou par le Conseil d’Administration en exercice, qui sera doté des pouvoirs prévus par les articles
144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales.
Une fois que l’ensemble des dettes, charges et frais de liquidation a été réglé, le solde éventuel sera payé aux Action-
naires de la Société.
Art. 24. - Définitions
Les Statuts: signifie les statuts de la Société en vigueur tel qu’ils sont modifiés de temps à autre.
Les Actionnaires: signifie les détenteurs d’Actions de la Société.
Les Actions: signifie les actions de la Société ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25)
chacune.
Art. 25. - Loi du 10 août 1915
Sauf dispositions contraires prévues par les présents Statuts, les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août
1915 sur les sociétés, telle que modifiée, seront applicables.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts de la Société ayant été rédigé par les présentes parties, les présentes parties ont souscrites et libérées
d’un quart (25%) les Actions suivantes:
Souscripteurs
Nombres
d’actions
Prix de souscription to-
tal (EUR 1,25 par Action)
Paiement
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN)
IV L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.798
7.247,50 EUR
1.811,875 EUR
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN)
IV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
115,00 EUR
28,750 EUR
BLACKSTONE FAMILY INVESTMENT PAR-
TNERSHIP (CAYMAN) IV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . .
310
387,50 EUR
96,875 EUR
GS CAPITAL PARTNERS, 2000, L.P. . . . . . . . . . .
3.527
4.408,75 EUR
1.102,188 EUR
GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE L.P. .
1.281
1.601,25 EUR
400,313 EUR
GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & Co. BE-
TEILIGUNGS KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
183,75 EUR
45,938 EUR
GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND,
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.121
1.401,25 EUR
350,313 EUR
109
Chacun des souscripteurs d’Actions, représenté tel que mentionné ci-dessus ont souscrit au nombre d’Actions men-
tionné ci-dessus. Les Actions ont été libérées à hauteur d’un quart (25%) de leur prix de souscription et valeur nominale
de EUR 1,25 par action.
La preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire soussigné.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les dépenses, coûts, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, résultant de la présente constitution
seront supportés par la Société sont estimés approximativement à deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les membres ont pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société pour une période pre-
nant fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux de 2005, conformément aux Statuts de la Société:
3. La personne suivante est nommée comme commissaire aux comptes de la Société pour une durée se terminant à
l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2005:
EUROFID, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et
enregistré sous le numéro B 92.176.
<i>Disposition spécialei>
Le premier exercice social commence à la date de constitution et se termine le 31 décembre 2004.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante
a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 octobre 2004, vol. 429, fol. 10, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087318.3/242/714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
LOFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.229.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06834, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087497.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT
FUND 2000, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
155,00 EUR
38,750 EUR
KKR MILLENIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED
PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.076
7.595,00 EUR
1.898,750 EUR
KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), LIMITED
PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
155,00 EUR
38,750 EUR
TPG-WATTS ADVISORS (CAYMAN) INC. . . . . .
6.200
7.750,00 EUR
1.937,500 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800
31.000,00 EUR
7.750,000 EUR
Nom
Adresse
Date de naissance Lieu de naissance
Chinh Chu
c/o THE BLACKSTONE GROUP, 345, Park Avenue,
31st Floor, New York, NY 10154
7 octobre 1966
Saigon, Vietnam
Adrian Jones
c/o GOLDMAN, SACHS & Co., 85, Broad Street,
New York, NY 10004
10 juin 1964
Roscommon, Ireland
Michael W.
Michelson
c/o KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & Co., 2800,
Sand Hill Road, Suite 200, Menlo Park, CA 94025
10 avril 1951
Chester,
Pennsylva-
nia, United States
Todd Sisitsky
c/o TEXAS PACIFIC GROUP, 345, California Street,
Suite 3300, San Francisco, CA 94104
5 octobre 1971
Brooklyn, New York,
United States
Mersch, le 27 octobre 2004.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Signatures.
110
EUROPEAN ROBOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 103.690.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le treize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Ludovic Roussel, indépendant, né à Obernai, (France), le 17 octobre 1974, demeurant à F-67700 Saver-
ne, 3, Passage Achille Demange, (France).
2.- Madame Nathalie Remy, contrôleur de gestion, née à Troyes, (France), le 19 octobre 1974, épouse de Monsieur
Ludovic Roussel, demeurant à F-67700 Saverne, 3, Passage Achille Demange, (France).
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Norbert Meisch, diplômé I.C.H.E.C., demeurant professionnelle-
ment à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme
suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de EUROPEAN ROBOT, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la conception de moyens de production robotique, d’ingénierie en
électronique et électrotechnique.
La société a en outre pour objet la conception et la mise en route de robots ainsi que l’assistance de production.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre
recommandée à ses co-associés.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
1.- Monsieur Ludovic Roussel, indépendant, demeurant à F-67700 Saverne, 3, Passage Achille Demange, (France),
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Nathalie Remy, contrôleur de gestion, demeurant à F-67700 Saverne, 3, Passage Achille Demange,
(France), cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
111
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.
La présente société est à considérer comme société à responsabilité limitée familiale, les associés étant époux.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Ludovic Roussel, indépendant, né à Obernai, (France), le 17 octobre 1974, demeurant à F-67700 Saverne,
3, Passage Achille Demange, (France).
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. Meisch, J. Seckler.
112
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2003, vol. 529, fol. 53, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(088325.3/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.
PROMEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4137 Esch-sur-Alzette, 35, rue de l’Hôpital.
R. C. Luxembourg B 35.863.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05974, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085883.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
PROMEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4137 Esch-sur-Alzette, 35, rue de l’Hôpital.
R. C. Luxembourg B 35.863.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05978, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085910.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
PROMEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4137 Esch-sur-Alzette, 35, rue de l’Hôpital.
R. C. Luxembourg B 35.863.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05981, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085917.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
PROMEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4137 Esch-sur-Alzette, 35, rue de l’Hôpital.
R. C. Luxembourg B 35.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05985, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085920.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
PROMEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4137 Esch-sur-Alzette, 35, rue de l’Hôpital.
R. C. Luxembourg B 35.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05987, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085924.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Junglinster, le 29 octobre 2003.
J. Seckler.
Signature
<i>Le Directeuri>
Signature
<i>Le Directeuri>
Signature
<i>Le Directeuri>
Signature
<i>Le Directeuri>
Signature
<i>Le Directeuri>
113
AZ EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 225, val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 103.694.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le six octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Abdelkrim Belaribi, chauffeur, demeurant à L-2121 Luxembourg, 225, val des Bons Malades.
2.- Madame Houria Belaribi-Akkouche, vendeuse, demeurant à L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le transport de voyageurs (taxi et ambulance), de marchandises nationales et inter-
nationales, la location de voitures ainsi que l’achat et la vente de voitures, l’import-export de voitures et le déménage-
ment.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de AZ EXPRESS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne
peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2004.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq euros
(745,- EUR).
1.- Monsieur Abdelkrim Belaribi, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2.- Madame Houria Belaribi-Akkouche, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
114
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Boubakeur Belaribi, chauffeur, demeurant à L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant.
2.- Le siège social est établi à L-2121 Luxembourg, 225, val des Bons Malades.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Belaribi, H. Akkouche, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2004, vol. 902, fol. 10, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(088340.3/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.
ANDROMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2737 Luxembourg, 16, rue Wurth Paquet.
R. C. Luxembourg B 100.102.
—
<i>Procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinairei>
Le 25 octobre 2004 a été tenue à 12 heures l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à respon-
sabilité limitée ANDROMEDIA, au capital de douze mille cinq cents EUR divisé en cent (100) parts sociales de cent
vingt-cinq (125) EUR chacune.
Société constituée suivant acte dressé le 8 avril 2004 par-devant maître Emile Schlesser, notaire alors de résidence à
Luxembourg, acte enregistré à Luxembourg le 9 avril 2004, vol. 20CS, fol.82, case 3 et déposé au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg le 19 avril 2004.
Les associés étant présents ou représentés et possédant ensemble l’intégralité des parts sociales, il n’y a pas lieu de
justifier de l’envoi des convocations et l’assemblée se reconnaît valablement réunie pour délibérer de son ordre du jour.
Sont présents ou représentés à la présente assemblée: les associés titulaires du nombre de parts qui suit: cent parts
sociales.
En conséquence, la présente assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les points portés
à son ordre du jour, qui est le suivant:
1
°
Transfert du siège social
2
°
Modification du domicile du gérant.
Tous les associés représentant le capital souscrit de douze mille cinq cents EUR divisé en cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq (125) EUR chacune étant présents ou représentés, la présente assemblée est valablement constituée
et a pouvoir pour délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui précède.
L’assemblée générale, après s’être considérée comme valablement constituée et convoquée, a délibéré et a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La décision du transfert du siège social de la société ANDROMEDIA est prise.
Le siège social sera désormais au 16, rue Wurth Paquet, L-2737 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le gérant sera à compter de ce jour domicilié professionnellement au 16, rue Wurth Paquet, L-2737 Luxembourg.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.00 heures.
Après lecture faite aux comparants, présents ou représentés, ils ont signé.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07205. – Reçu 91 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087478.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2004.
A. Biel.
115
CROIX PATTEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 95.416.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
Ont comparu:
1. - La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,
Wickhams Cay I, Road Town;
2. - La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,
Wickhams Cay I, Road Town;
ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de deux procurations
sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de CROIX PATTEE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 4. La société a pour objet la. prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
luxembourgeoises et étrangères, par l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres par l’acquisition de brevets
et licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
à son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d’émissions d’obliga-
tions qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.
En outre, la société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-
semblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, un
administrateur, désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi
souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.
116
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerres, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre empêché ou absent peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du
conseil et voter en ses lieu et place.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion du conseil est prépondérante.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-
sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.
Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,
confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-
dataire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux qui sont réservés expres-
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la
signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-
tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.
Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.
Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le troisième mercredi du mois de juin à 10.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le
premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-
mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales, Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents au représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-
taire, actionnaire ou non.
Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-
présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.
L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement
que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
117
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.
Art. 22. L’assemblce générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui
le remplace.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions
prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
un administrateur ou par un mandataire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-
dalités fixées par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne
seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Disposition générale
Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de juin à 10.00 heures
en 2004.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-
(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Ciovanni Vittore, Administrateur de Sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président
du Conseil d’Administration;
b) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
c) Monsieur Pierangelo Agazzini, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-Fentange, Administrateur.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur l’exercice 2005.
1.- PHILL ASSETS S.A.: trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- ULARIS FINANCE S.A.: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
118
5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journa-
lière de la société à un de ses membres.
6.- L’adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, vol. 140S, fol. 27, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053090.2/211/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.
CONTERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 93.880.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2004i>
La séance est ouverte à 18h sous la présidence de Monsieur Pierre Goffin qui désigne Madame Claudine Frutsaert
comme secrétaire.
L’Assemblée renonce à la désignation d’un scrutateur.
Le bureau ainsi formé, le Président constate qu’il résulte de la liste de présence, dûment signée et clôturée, que tous
les actionnaires sont dûment représentés en vertu de procurations, qui resteront annexées au présent procès-verbal.
Les actionnaires se reconnaissant avoir dûment été convoqués et avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué, il peut être fait abstraction des convocations.
L’Assemblée générale étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du réviseur pour l’exercice 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Répartition du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire réviseur.
5. Renouvellement du mandat des administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Commissaire réviseur.
7. Divers.
Le Président ouvre la discussion sur les points de l’ordre du jour et l’Assemblée prend les résolutions qui suivent:
<i>Première résolution (concerne les premier et second points de l’ordre du jour)i>
Après lecture, l’Assemblée approuve à l’unanimité des voix le rapport du Commissaire ainsi que le bilan et le compte
de pertes et profits de l’exercice 2003.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée approuve à l’unanimité des voix le report du résultat.
<i>Troisième résolutioni>
Par un vote spécial, l’Assemblée donne à l’unanimité décharge aux administrateurs et au commissaire réviseur.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée vote à l’unanimité le renouvellement du mandat des administrateurs en place à savoir, Monsieur Alfred
Bouckaert, Monsieur Gérard Fievet et Monsieur Pierre Goffin et ce jusqu’à l’Assemblée Générale qui approuvera les
comptes de 2004.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que commissaire jusqu’à l’assemblée
générale qui approuvera les comptes de 2004.
<i>Sixième résolutioni>
Aucun point divers n’est abordé.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, le Secrétaire donne lecture du procès-verbal.
La séance est levée à 18.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05697. – Reçu 91 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087623.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
Luxembourg, le 28 août 2003.
J. Elvinger.
Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétairei>
119
GE Fanuc Automation Europe S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 95.056.
GE Fanuc Automation CNC Europe S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 105.115.
GE Fanuc Automation Solutions Europe S.A., Scoiété Anonyme.
Registered office: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 105.114.
—
DEMERGER PROPOSAL
The Company was incorporated as a Luxembourg société anonyme on December 16, 1986 by a deed enacted by Me
Paul Frieders, notary residing in Luxembourg. The Company is a wholly owned subsidiary of GE Fanuc Automation Cor-
poration, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States 19801, being a joint
venture between General Electric Company, having its registered office at 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut,
United States 06431 and Fanuc Ltd, having its registered office at Yoshida Office of Kofu District Legal Affairs Bureau
3-9-13 Kamiyoshida, Fujiyoshida-shi, Yamanashi, Japan.
On December 16, 2004, the Company incorporated
(i) GE Fanuc CNC, a Luxembourg société anonyme, having its registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echter-
nach, in process of registration with the Trade and Companies Register, having a share capital of EUR 31,000, repre-
senting by 310 shares, of which 309 shares are held by the Company and 1 share is held by Fanuc Ltd; and
(ii) GE Fanuc Solutions, a Luxembourg société anonyme, having its registered office at Zone Industrielle, L-6468 Ech-
ternach, in process of registration with the Trade and Companies Register, having a share capital of EUR 31,000, rep-
resenting by 310 shares, of which 309 shares are held by the Company and 1 share is held by GE Fanuc Automation
Americas, Inc.
On December 23, 2004, the share capital of GE Fanuc CNC was increased by an amount of EUR 2,999,900, by way
of the issuance of 29,999 shares subscribed for by Fanuc Ltd, in consideration for a contribution in cash of EUR
19,856,000, of which an amount of EUR 2,999,900 has been allocated to the share capital account of GE Fanuc CNC,
and an amount of EUR 16,856,100 has been allocated to the share premium account of GE Fanuc CNC.
On December 23, 2004, the share capital of GE Fanuc Solutions was increased by an amount of EUR 900, by way of
the issuance of 9 shares subscribed for by GE Fanuc Automation Americas, Inc., in consideration for a contribution in
cash of EUR 741,000, of which an amount of EUR 900 has been allocated to the share capital account of GE Fanuc So-
lutions, and an amount of EUR 740,100 has been allocated to the share premium account of GE Fanuc Solutions.
I. Demerger and recipient companies
The board of directors of each of the Company, GE Fanuc CNC and GE Fanuc Solutions (GE Fanuc CNC and GE
Fanuc Solutions are hereinafter referred to as the Recipient Companies) has approved the demerger of the Company
whereby, following its dissolution without liquidation, the Company will transfer to GE Fanuc CNC and GE Fanuc So-
lutions (the Recipient Companies) all of its assets and liabilities, in accordance with articles 287 and following of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and this Demerger Proposal (the Demerger).
Pursuant to the Demerger, GE Fanuc CNC will continue the CNC business line of the Company and GE Fanuc So-
lutions will continue the Solutions business line of the Company. For purposes of the Demerger Proposal, CNC Business
shall mean the activities pertaining to computer numerical controls, cell controllers, related factory automation systems
and associated hardware and software products and services related thereto, excluding programmable logic controllers,
and Solutions Business shall mean the activities pertaining to programmable logic controllers, related factory automation
systems and associated hardware and software products and services related thereto excluding computer numeric con-
trollers and cell controllers.
II. General meeting of the shareholders of the Company and of the Recipient Companies
The board of directors of each of the Company and the Recipient Companies shall convene the shareholders of the
Company and the Recipient Companies respectively to an extraordinary general meeting of shareholders to be held
before a Luxembourg notary as soon as practicable after one month following the filing and publication of this Demerger
Proposal in accordance with article 9 of the Law, in order to approve the Demerger of the Company in accordance with
this Demerger Proposal (collectively the Meetings).
III. Exchange ratio of the shares/Terms of the delivery of the shares
The exchange ratio of the shares in the share capital of the Company is such that at the date of the approval of the
Demerger of the Company by the Meetings, GE Fanuc Automation Corporation, holder of 100% of the shares in the
Company receives:
(i) 270,000 shares in GE Fanuc CNC, representing, after cancellation of the 309 shares subscribed for by the Com-
pany in GE Fanuc CNC at the incorporation of GE Fanuc CNC, in accordance with Section IV below, 90% of the share
capital of GE Fanuc CNC (the remaining 10% being held by Fanuc Ltd.); and
(ii) 990 shares in GE Fanuc Solutions, representing, after cancellation of the 309 shares subscribed for by the Com-
pany in GE Fanuc Solutions at the incorporation of GE Fanuc Solutions, in accordance with Section IV below, 99% of
the share capital of GE Fanuc Solutions (the remaining 1% being held by GE Fanuc Automation Americas, Inc.).
The shares in each of the Recipient Companies being in registered form, GE Fanuc Automation Corporation, will be
registered as holder of an aggregate number of 270,000 shares of GE Fanuc CNC in the shareholders’ register of GE
120
Fanuc CNC and, as holder of an aggregate number of 990 shares of GE Fanuc Solutions in the shareholders’ register of
GE Fanuc Solutions.
IV. Cancellation of the shares
The shares held by the Company in GE Fanuc CNC and GE Fanuc Solutions will be cancelled by the Meetings of GE
Fanuc CNC and GE Fanuc Solutions respectively, to be held in accordance with article 291 of the Law to resolve upon
the Demerger.
V. Effective date of the Demerger
From an accounting point of view and towards the shareholders of the Company, the operations of the Company
will be treated as having been carried out on behalf of the Recipient Companies as from December 31, 2004, and in
accordance with the allocation of the assets and liabilities to each of the Recipient Companies as provided in the present
Demerger Proposal.
The shares of each of the Recipient Companies to be issued to GE Fanuc Automation Corporation shall carry the
right to participate in any distribution of profits by the respective Recipient Company as from December 31, 2004.
VI. Advantages
No special advantage will be granted to the directors and auditors of the Company and of the Recipient Companies
in connection with or as a result of the Demerger of the Company.
The Company has not issued, to any person, any securities other than the shares held by GE Fanuc Automation Cor-
poration.
VII. Allocation of assets and liabilities
All assets and liabilities of the Company will be allocated as follows:
1) GE Fanuc CNC will receive:
Fixed Assets
* All land and buildings owned by the Company;
* Machinery and equipment affected to CNC Business;
* Furniture and fixtures attached to CNC Business, to personnel transferred to GE Fanuc CNC, or related to build-
ings allocated to GE Fanuc CNC but excluding those attached to the Solutions Business, including, but not limited to:
- Computers and IT equipment, including software licenses,
- Demonstration equipment,
- Furniture and office machines,
- Warehouse installations and equipment.
Participating interests
* Shareholdings in subsidiaries transferred to GE Fanuc CNC. Namely:
- GE Fanuc Automation Deutschland GmbH,
- GE Fanuc Automation (UK) Ltd.,
- GE Fanuc Automation Nordic AB,
- GE Fanuc Automation France SAS,
- GE Fanuc Automation Italia Srl,
- GE Fanuc Automation España S.A.,
- GE Fanuc Automation CR s.r.o.,
- GE Fanuc Automation Polska Sp. Zo.o,
- GE Fanuc Automation CNC Switzerland GmbH.
Current Assets
* Inventories related to CNC Business (CNC Systems and components, CNC Renewal parts, Laser systems and com-
ponents, and all other components classified as CNC stock in the stock list produced by the Company);
* Accounts receivable related to sales of CNC products and provision of services related to CNC products, and oth-
er sundry receivables not specific to Solutions Business;
* Amounts owed by subsidiaries the shareholdings in which are transferred to GE Fanuc CNC (see «participating
interests»);
* Cash: An amount of cash calculated as per the following formula:
(TNC x 50%) - CHScnc - CONS = Cash transferred to GE Fanuc CNC
where
TNC:
Total net cash valued in Euro held by the Company and subsidiaries on a consolidated basis
CHScnc: Cash held at subsidiaries transferred to GE Fanuc CNC (see «participating interests»)
CONS:
An amount of cash to be transferred to GE Fanuc Solutions so that the total of cash held by the
Company and subsidiaries on a consolidated basis, increased by the value of the land, buildings and capitalized software
is equally distributed to CNC and Solutions. Below an example of the calculation based on the consolidated balance
sheet of the Company and subsidiaries as at October 31, 2004.
CNC
Solutions
Total
Land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,165
3,165
Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,240
3,240
Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
124
362
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,643
124
6,767
121
Pension plan provision
* Provision for pension related to employees transferred to GE Fanuc CNC;
* Provision for pension related to former employees for which their last position in the Company was associated to
the CNC Business of the Company;
* Provision for pension related to former employees for which their last position in the Company was not associated
neither to the CNC Business nor the Solutions Business of the Company, for which the total provision approximates
50% of the total provision related to former employees.
Reserve for warranty
* Reserves for warranty claims related to sales of CNC products.
Current Liabilities
* Amounts owed to subsidiaries the shareholdings in which are transferred to GE Fanuc CNC (see «participating
interests»);
* Creditors and accruals: Liabilities and reserves related to CNC Business. VAT, income tax payable, social security
contributions and all other taxes accrued. All other reserves and liabilities to be distributed to GE Fanuc CNC and GE
Fanuc Solutions as agreed upon by the parties and reflected in Annex 1.
2) GE Fanuc Solutions will receive:
Fixed Assets
* Machinery and equipment affected to Solutions Business;
* Furniture and fixtures attached to Solutions Business, to personnel transferred to GE Fanuc Solutions, including,
but not limited to:
- Computers and IT equipment, including software licenses,
- Demonstration equipment,
- Furniture and office machines,
- Warehouse installations and equipment.
Participating interests
* GE Fanuc Automation Benelux B.V.
Current Assets
* Inventories related to Solutions Business (Programmable logic controllers, associated renewal parts and compo-
nents, capitalized cost of Solutions projects and services, and all other components classified as Solutions stock in the
stock list produced by the Company);
* All assets (including cash) attached to the Dutch and Swiss Branches;
* Accounts receivable related to sales of PLC products and provision of services related to Solutions;
* Amounts owed by the subsidiary the shareholding in which is transferred to GE Fanuc Solutions (see «participating
interests»);
* Cash: An amount of cash calculated as per the following formula:
(TNC x 50%) - CHSsol + CONS = Cash transferred to GE Fanuc Solutions
where
TNC:
Total net cash valued in Euro held by the Company and subsidiaries on a consolidated basis
CHSsol: Cash held at the Dutch and Swiss branches of the Company
CONS: An amount of cash to be transferred to GE Fanuc Solutions so that the total of cash held by the
Company and subsidiaries on a consolidated basis, increased by the value of the land, buildings and capitalized software
is equally distributed to CNC and Solutions. Below an example of the calculation based on the consolidated balance
sheet of the Company and subsidiaries as at October 31, 2004.
Pension plan provision
* Provision for pension related to employees transferred to GE Fanuc Solutions;
Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98%
2%
100%
Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,447
37,966
69,412
Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45%
55%
100%
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,090
38,090
76,180
Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50%
50%
100%
CNC
Solutions
Total
Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,165
3,165
Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,240
3,240
Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
124
362
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,643
124
6,767
Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98%
2%
100%
Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,447
37,966
69,412
Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45%
55%
100%
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,090
38,090
76,180
Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50%
50%
100%
122
* Provision for pension related to former employees for which their last position in the Company was associated to
the Solutions Business of the Company;
* Provision for pension related to former employees for which their last position in the Company was not associated
neither to the CNC Business nor the Solutions Business of the Company, for which the total provision approximates
50% of the total provision related to former employees.
Reserve for warranty
* Reserves for warranty claims related to sales of PLC products.
Current Liabilities
* Amounts owed to the subsidiary the shareholding in which is transferred to GE Fanuc Solutions (see «participating
interests»);
* Liabilities and reserves allocated to the Dutch and Swiss Branches;
* Creditors and accruals: Liabilities and reserves related to Solutions activities. All other reserves and liabilities to be
distributed to GE Fanuc CNC and GE Fanuc Solutions as agreed upon by the parties and reflected in Annex 1;
* Deferred income related to Solutions sales
it being understood that any assets and liabilities belonging to the Company at the date of the Meetings and not fur-
ther described in this Demerger Proposal shall be allocated to GE Fanuc CNC and GE Fanuc Solutions as follows (the
Allocation rules).
- any cash shall be allocated to Fanuc CNC and GE Fanuc Solutions on a 50/50 basis;
- any other assets and liabilities pertaining to the CNC Business shall be allocated to GE Fanuc CNC; and
- any other assets and liabilities pertaining to the Solutions Business shall be allocated to GE Fanuc Solutions.
For the purpose of illustration, the allocation of the assets and liabilities is documented in Annex 1. For the avoidance
of doubt, any assets and liabilities which are not mentioned in Annex 1 will be transferred to GE Fanuc CNC and GE
Fanuc Solutions in accordance with the Allocation rules.
In Virginia, USA, on December 23, 2004.
ANNEX 1
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08947. – Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(904324.2//238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2004.
REVAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.410.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AV06756, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. / GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. /
GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A.
M. Hardt
<i>Directori>
<i>Assetsi>
GE Fanuc
GE Fanuc
CNC
Solutions
EUR (000)
EUR (000)
Fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,786
662
Participating interests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,091
-
Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,061
19,948
Accounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,368
16,616
Amounts owed by affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,221
2,587
Cash and cash equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,759
37,795
Total Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113,286
77,608
<i>Liabilitiesi>
Pension plan provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
626
625
Reserve for warranty claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,880
1,496
Amounts owed to affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,146
25,064
Creditors and accruals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,784
6,965
Deferred income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
98
Total Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55,436
34,248
Net Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57,850
43,360
123
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087449.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
REVAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.410.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Monsieur Leo Spitzer et Monsieur Pierre
Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06718. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087394.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
SIRAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06754, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087450.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
SIRAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.392.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06717. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087395.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
CIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 68.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06826, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087512.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Signature.
124
AXIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.167.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06752, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087451.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
AXIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.167.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06715. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087398.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
RIVIERA FINANCE 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 79.377.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du
19 juillet 2004 que:
- Le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat au 31 décembre 2003.
Décharge a également été donnée à M. Stéphane Biver pour l’exercice de son mandat d’administrateur au 19 juillet
2004 (date de démission).
- Les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au
73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg, de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle
au 73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg et de Monsieur Camille Paulus, consultant, ayant son adresse professionnelle au
73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société ERNST & YOUNG
S.A., ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire de 2007.
La démission de Monsieur Stéphane Biver, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-
1450 Luxembourg en tant qu’administrateur de la société a été acceptée avec effet immédiat.
L’assemblée a nommé en remplacement Monsieur Elo Rozencwagj, consultant, ayant son adresse professionnelle au
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale des actionnaires de 2007.
Luxembourg le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV04984. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087653.3/751/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
125
DINOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.497.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06751, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087453.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
DINOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.497.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2002i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06712. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087399.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
MISYS OVERSEAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.849.
—
Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07214, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087703.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
MISYS OVERSEAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.849.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée des Associés tenue le 2 septembre 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Les comptes annuels et les notes annexes aux comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 mai 2004
ont été approuvés.
Le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg en tant que commissaire aux comp-
tes a été renouvelé.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée des associés statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant au 31
mai 2005.
Luxembourg, le 27 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07213. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087700.3/275/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 29 octobre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour A. Schmitti>
<i>Mandataire
i>G. Arendt
Avocat à la Cour
126
LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06748, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087454.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.207.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087402.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
FINACLE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 102.869.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINACLE INVESTISSE-
MENTS S.A., tenue l’an deux mille quatre (2004), le 9 septembre, à 15.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que
les actionnaires ont voté la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
A l’unanimité, les actionnaires ont décidé:
Accepter la démission des anciens administrateurs Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune, Mesdames Andrea
Dany et Nicole Thommes.
La nomination de trois nouveaux administrateurs pour cinq (5) ans:
- UVENSIS S.A., Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
- QUESTINA S.A., Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanni-
ques.
- Maître Gilles Bounéou demeurant au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Accepter la démission du commissaire aux comptes CEDERLUX SERVICES, S.à r.l.
La nomination comme nouveau commissaire aux comptes pour trois (3) ans:
- SPR SERVICES INC, registered no 3802-336 in the State of Delaware, 25 Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-
9776 / USA.
Le transfert du siège social à l’adresse suivante:
- 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06401. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088310.3/4181/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
127
SERINHA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.442.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AV06746, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087456.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
SERINHA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.442.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087400.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
PRIVATE LIFE PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.958.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2004i>
1. L’assemblée a accepté, sous condition suspensive de l’approbation du Commissariat aux Assurances, la nomination
en date du 26 mars 2004 en qualité d’administrateur de Monsieur Victor den Hoedt en remplacement de Monsieur F.B.
Deiters, démissionnaire.
L’assemblée ratifie la décision du Conseil d’Administration de nommer Monsieur F.B. Deiters membre honoraire du
conseil d’Administration.
2. L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels pour une période s’achevant lors de l’as-
semblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
3. L’assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an la société KPMG AUDIT, Luxembourg, en qualité de révi-
seur d’entreprises.
Le conseil d’administration de la société se compose actuellement comme suit:
- A. Baronnet (président),
- P. Aelbers (vice-président),
- J. Doyle (administrateur-délégué),
- K. de Koning, Administrateur,
- V. den Hoedt, Administrateur,
- R. von Wedel, Administrateur,
- T. van Beers, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00180. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088370.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait et traduction conformes
PRIVATE LIFE PARTNERS S.A., Société Anonyme
Signature
128
MINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 25.968.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06745, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087457.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
MINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 25.968.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06706. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087413.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
CITORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.534.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07486, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2004.
(088338.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.
CITORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.534.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 13 septembre 2004i>
<i>à 10.00 heures au siège sociali>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean
Quintus, Koen Lozie et de la Société GILDA PARTICIPATIONS S.A. ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes
de Monsieur Noël Didier.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07463. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088314.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
129
WAM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.259.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AV06742, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087459.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
WAM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.259.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087420.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 20.742.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06710, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087783.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 20.742.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1
er
juin 2004, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend dé-
missionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06677. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087730.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
<i>Pour VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
130
SILAWI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.312.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AV06735, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087461.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
SILAWI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.312.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087424.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
TABOGA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 77.265.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07451, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2004.
(088551.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.
TABOGA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 77.265.
—
DISSOLUTION
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2004i>
1. L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité le
rapport du liquidateur, les comptes annuels au 31 décembre 2003 et les comptes de liquidation arrêtés au 12 octobre
2004.
2. L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux
administrateurs.
3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’adresse: 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07450. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088552.3/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
R. Caurla
<i>Liquidateuri>
131
DHP PRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 95.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06070, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2004.
(087468.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
CSEPEL LUXEMBOURG (NO. 1), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 81.613.
Die Gesellschaft wurde am 28. März 2001 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxem-
burg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
986 vom 9. November 2001.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, den 27. Oktober 2004, réf. LSO-AV06983,
wurde am 28. Oktober 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(087479.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
CSEPEL LUXEMBOURG (NO. 1), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 81.613.
Die Gesellschaft wurde am 28. März 2001 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxem-
burg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
986 vom 9. November 2001.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, den 27. Oktober 2004, réf. LSO-AV06985,
wurde am 28. Oktober 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(087501.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
TOOL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 23.271.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 24 septembre 2004, que:
- M
e
Tom Felgen, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, a été élu com-
me nouvel administrateur de la société, en remplacement de M. Manfred G. Braun, 18, rue Henri Pensis, L-2322 Luxem-
bourg, né le 20 juillet 1942 à Berlin, Allemagne, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à
échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.
- M. Lennart Stenke, 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède a été réélu
comme administrateur-délégué de la société, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(087493.3/263/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
132
IP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 6.419.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 22
octobre 2004, que:
- L’Assemblée générale décide de renouveler le mandat du Comité de gérance, à savoir, Messieurs Alain Flammang
et Alain Berwick, pour une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires statuant sur les
comptes de l’exercice 2004.
- L’Assemblée générale décide de renouveler le mandat comme Commissaire aux comptes, de KPMG Audit, Réviseur
d’entreprises, Société civile ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, pour une période d’un an
expirant à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06556. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(087467.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.
SIGVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.010.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 janvier 2005i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 2004.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
I (04756/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.128.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 janvier 2005i> à 11.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04837/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
133
ACCENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 79.874.
—
The shareholders of ACCENTURE S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under the number B 79.874, with a registered office at 1, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg (ACCENTURE S.C.A.), are cordially invited to attend the
GENERAL MEETING
which will be held on <i>January 17, 2005i> at 12.00 noon, local time, at the offices of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG at
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Five ordinary items:i>
1. Presentation of the report on the annual accounts issued by the general partner and the report of the commissaire
aux comptes of ACCENTURE SCA;
2. Approval of the balance sheet, the profit and loss accounts, the notes to the accounts and the allocation of the
results of ACCENTURE SCA as of August 31, 2004;
3. Discharge of the general partner, the commissaire aux comptes and the supervisory board in connection with the
fiscal year ended August 31, 2004;
4. Appointment of the members of the supervisory board; and
5. Re-appointment of KPMG LLP as the independent auditors of ACCENTURE S.C.A.
<i>One extraordinary item:i>
1. Approval of amendments to ACCENTURE S.C.A.’s articles of association.
The foregoing item of business is more fully described in the Schedule attached hereto.
Shareholders may obtain, free of charge, copies of (a) the balance sheet, (b) the profit and loss accounts, (c) the notes
to the accounts, (d) the list of securities held by ACCENTURE S.C.A., (e) the list of shareholders, if any, who have not
fully paid up their shares with an indication of the number of shares and their contact details, (f) the report of the general
partner and (g) the report of the commissaire aux comptes, by making a written request to the general partner at
ACCENTURE Ltd, 1661 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, United States of America, Attention: Secretary.
The general partner has fixed the close of business on December 6, 2004, as the record date for the determination
of shareholders entitled to notice of, and to vote at, the meeting. This means that only those persons who were
registered holders of ACCENTURE S.C.A. Class I common shares or Class II common shares at the close of business
on that date will be entitled to receive notice of the meeting and to attend and vote at the meeting.
The general partner is not asking you for a proxy in connection with the General Meeting and you are requested not
to send us a proxy.
January 4, 2005.
SCHEDULE
<i>Proposed amendments to Articles of Association of ACCENTURE S.C.A.i>
Art. 7. - Redemption of Shares
Amend the second paragraph of Article 7 to read as follows:
«Subject to any contractual restrictions on Transfer by a holder set forth in any contract or agreement to which the
Company or any of its affiliates is a party or set forth in Article 8 of these Articles of Association, Class I Common
Shares shall be redeemable for cash at the option of the holder by giving irrevocable notice of an election for redemption
to the Company.»
New Article 8. - Transfer Restrictions Applicable to Covered Shares:
Add a new Article 8 as follows:
Art. 8. - Transfer Restrictions Applicable to Covered Shares
1. Each Covered Person shall at all times be the Sole Beneficial Owner of all Covered Shares beneficially owned by
such Covered Person as of or prior to the IPO Date, except as provided herein. Any Covered Shares Transferred in
compliance with this Article 8 shall no longer be subject to such provisions. Capitalized terms used in this Article 8 shall
have the meanings ascribed to such terms in paragraph 24 of this Article 8.
2. Notwithstanding paragraph 1, an Employee Covered Person may:
(i) on or prior to the date that is four years after the IPO Date, Transfer an aggregate of up to 35% of the aggregate
number of Covered Shares beneficially owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date;
(ii) commencing on the date that is four years after the IPO Date, Transfer an aggregate (together with all other
Transfers made pursuant to this paragraph 2) of up to 45% of the aggregate number of Covered Shares beneficially
owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date;
(iii) commencing on the date that is five years after the IPO Date, Transfer an aggregate (together with all other
Transfers made pursuant to this paragraph 2) of up to 55% of the aggregate number of Covered Shares beneficially
owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date;
ACCENTURE Ltd
<i>General partner of ACCENTURE S.C.A.i>
134
(iv) commencing on the date that is six years after the IPO Date, Transfer an aggregate (together with all other
Transfers made pursuant to this paragraph 2) of up to 65% of the aggregate number of Covered Shares beneficially
owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date; and
(v) commencing on the date that is seven years after the IPO Date, Transfer an aggregate (together with all other
Transfers made pursuant to this paragraph 2) of up to 75% of the aggregate number of Covered Shares beneficially
owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date.
3. Notwithstanding paragraph 1, a Covered Person may Transfer any Covered Shares beneficially owned by such
Covered Person as of the IPO Date commencing on the later of (i) the date that is eight years after the IPO Date and
(ii) the date that such Covered Person ceases to be an employee of the Company.
4. Notwithstanding paragraph 1, an Employee Covered Person that retires (or has retired) at the age of 50 or older
and is not in contravention of the Non-Competition Agreement (a «Retired Employee») may:
(i) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 50, Transfer up to that number of Covered Shares
beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate
number of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum
of (a) the percentage of Covered Shares eligible for sale at the date of such retirement pursuant to paragraph 2 of this
Article 8 (the «Base Eligible Sales») and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B) 0.25;
(ii) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 51, Transfer up to that number of Covered Shares
beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate
number of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum
of (a) the percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B)
0.375;
(iii) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 52, Transfer up to that number of Covered Shares
beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate
number of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum
of (a) the percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B)
0.50;
(iv) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 53, Transfer up to that number of Covered Shares
beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate
number of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum
of (a) the percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B)
0.625;
(v) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 54, Transfer up to that number of Covered Shares
beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate
number of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum
of (a) the percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B)
0.75;
(vi) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 55, Transfer up to that number of Covered Shares
beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate
number of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum
of (a) the percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B)
0.875; and
(vii) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 56 or above, Transfer 100% of the Covered Shares
beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date.
5. A Retired Employee may also Transfer the Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the
IPO Date in accordance with paragraph 2 of this Article 8 as if such Retired Employee were an Employee Covered
Person.
6. Following the first anniversary of the EPO Date, a Retired Employee that reaches (or has reached) the age of 56
may also Transfer 100% of the Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date.
7. Notwithstanding paragraph 1, a Covered Person that became disabled while an employee of the Company (a
«Disabled Employee») prior to June 15, 2001, may Transfer 100% of Covered Shares beneficially owned by such
Disabled Employee as of the IPO Date. A Covered Person that becomes (or has become) a Disabled Employee following
June 15, 2001 may (i) if such Disabled Employee becomes disabled (or has become disabled) prior to reaching the age
of 50, Transfer Covered Shares beneficially owned by such Disabled Employee as of the IPO Date in accordance with
the provisions of paragraph 2 of this Article 8 as if such Disabled Employee were an Employee Covered Person and (ii)
if such Disabled Employee becomes (or has become) disabled after reaching the age of 50, Transfer Covered Shares
beneficially owned by such Disabled Employee as of the IPO Date in accordance with the provisions of paragraph 4 of
this Article 8 as if such Disabled Employee were a Retired Employee.
8. Notwithstanding paragraph 1, a Covered Person may Transfer Covered Shares beneficially owned by such Covered
Person as of the IPO Date pursuant to bona fide pledges of Covered Shares approved by the Supervisory Board or its
delegate in writing and any foreclosures thereunder, provided that the pledgee has agreed in writing with the
Supervisory Board or its delegate (any such agreement to be satisfactory to the Supervisory Board or its delegate in its
sole discretion) that the Company shall have a right of first refusal to purchase such Covered Shares at the market price
prior to any sale of such Covered Shares by such pledgee.
9. Notwithstanding paragraph 1, commencing on June 15, 2004, the Covered Shares are redeemable at the option of
the Covered Person for a redemption price per share equal to the lower of (i) the Valuation Ratio multiplied by the
Market Price of an ACCENTURE Ltd Class A Common Share and (ii) one United States Dollar.
135
10. Each Covered Person, for so long as such Covered Person is an Employee Covered Person, will comply with any
restrictions on Transfer relating to Class I Common Shares imposed by the Company pursuant to the Company’s insider
trading policies from time to time and notified to such Covered Person from time to time.
11. All Transfers of Covered Shares beneficially owned by a Covered Person as of or prior to the IPO Date made by
such Covered Person before the adoption of this Article 8 shall be aggregated, for purposes of paragraphs 2 through 4,
with all Transfers of Covered Shares beneficially owned by such Covered Person as of or prior to the IPO Date made
by such Covered Person after the adoption of this Article 8.
12. Notwithstanding paragraph 2, each Covered Person will not Transfer any Covered Shares until July 24, 2005,
except (A) to participate in underwritten public offerings, share repurchases, sales or redemptions or other
transactions, in each case as approved in writing by the Company and/or (B) to estate and/or tax planning vehicles, family
members and charitable organizations that become bound to the terms of Article 8 of these Articles of Association by
express agreement in writing, in each case as approved in writing by the Company (which approval may be subject to
other conditions, including upon the requirement that any transferee become bound by any other agreement, that the
Company may require in its sole discretion). The preceeding sentence shall not preclude any Transfer permitted under
paragraph 8 or 9 of this Article 8.
13. All Covered Shares beneficially owned by a Covered Person (in each case other than Covered Shares held of
record by a trustee in a compensation or benefit plan administered by the Company and other Covered Shares that
have been pledged to the Company (or to a third party agreed to in writing by the Company) shall, at the sole discretion
of the Company, be registered in the name of a nominee for such Covered Person and/or shall be held in the custody
of a custodian until otherwise determined by the Company or until such time as such Covered Shares are released
pursuant to paragraph 17 or 18 of this Article 8. The form of the custody agreement and the identity of the custodian
and/or nominee shall be as determined by the Supervisory Board or its delegate from time to time.
14. Whenever any nominee holder shall receive any dividend or other distribution in respect of any Covered Shares,
satisfied otherwise than in Covered Shares, the Company will give or cause to be given notice or direction to the
applicable nominee and/or custodian referred to in paragraph 13 to permit the prompt distribution of such dividend or
distribution to the beneficial owner of such Covered Shares, net of any tax withholding amounts required to be withheld
by the nominee, unless the distribution of such dividend or distribution is restricted by the terms of another agreement
between the Covered Person and the Company (or with any other person with respect to which the Company has
expressly agreed in writing) known to the Company.
15. Any share certificate representing Covered Shares beneficially owned by a Covered Person, and any agreement
or other instrument evidencing restricted share units, options or other rights to receive or acquire Covered Shares
beneficially owned by such Covered Person, may bear a legend noted conspicuously on each such certificate, agreement
or other instrument reading substantially as follows:
«The securities represented by this certificate are subject to transfer restrictions set forth in the company’s articles
of association. The securities represented by this certificate may be sold, exchanged, transferred, assigned, pledged,
participated, hypothecated or otherwise disposed of only in accordance therewith.»
16. The Company shall refuse to register the transfer of Covered Shares not made in compliance with these Articles
of Association and it may enter stop transfer orders against the transfer of Covered Shares not made in compliance
with these Articles of Association.
17. All Covered Shares of each Covered Person who is not an Employee Covered Person which could be Transferred
without contravening any provision of this Article 8 shall be released from the custody of the custodian pursuant to
procedures to be developed by the Company to or at the direction of such Covered Person free and clear of all
restrictions and legends described above.
18. A specified number of Covered Shares of an Employee Covered Person shall be released from the custody of the
custodian, pursuant to procedures to be developed by the Company, upon the request of such Employee Covered
Person and to or at the direction of such Employee Covered Person (free and clear of all restrictions and legends
described in this Article 8), provided that such request is accompanied by a certificate of such requesting Employee
Covered Person (i) indicating such requesting Employee Covered Person’s intention to Transfer promptly such specified
number of Covered Shares and (ii) establishing that such specified number of Covered Shares are then permitted to be
Transferred without contravening any Transfer Restrictions (which evidence must be satisfactory to the Company).
19. Each Covered Person shall be responsible for all expenses of such Covered Person incurred in connection with
compliance by such Covered Person with its obligations under this Article 8, including expenses incurred by the
Company in enforcing the provisions of Article 8 relating to such obligations.
20. In the event of any change in the outstanding Class I Common Shares by reason of stock dividends, stock splits,
reverse stock splits, recapitalizations, combinations, exchanges of shares and the like, the term «Covered Shares» shall
refer to and include the securities received or resulting therefrom, but only to the extent such securities are received
in exchange for or in respect of Covered Shares. Upon the occurrence of any event described in the immediately
preceding sentence, the Company shall make such adjustments to or interpretations of the provisions of this Article 8
as the Company shall deem necessary or desirable to carry out the intent of such provisions). If the Company deems it
advisable, any such adjustments may take effect from the record date, the «when issued trading date,» the «ex dividend
date» or another appropriate date.
21. The provisions of this Article 8 shall be binding upon the respective legatees, legal representatives, successors and
assigns of the Covered Persons; provided, however, that a Covered Person may not assign or otherwise transfer any
of its obligations under such provisions without the prior written consent of the Supervisory Board or its delegate and
any assignment or other transfer of rights and/or obligations under this Article 8 by a Covered Person without such
consent of the Supervisory Board or its delegate shall be void.
136
22. If requested by the Supervisory Board or its delegate, each Covered Person shall execute such documents and
take such further action as may be reasonably necessary to effect the provisions of this Article 8.
23. The Supervisory Board or its delegate may waive any of the provisions of this Article 8 to permit particular
Covered Persons, a particular class of Covered Persons or all Covered Persons to Transfer Covered Shares in particular
situations (such as Transfers to family members, partnerships or trusts) or generally. The Supervisory Board or its
delegate may impose such conditions as the Supervisory Board or its delegate determines on the granting of such
waivers. The determinations of the Supervisory Board or its delegate under this paragraph 23 shall be final and binding
and need not to be uniform and may be made selectively among Covered Persons (whether or not such Covered
Persons are similarly situated).
24. For purposes of this Article 8, the following terms have the following meanings:
A «beneficial owner» of a security includes any person who, directly or indirectly, through any contract, arrangement,
understanding, relationship or otherwise, has or shares: (i) voting power, which includes the power to vote, or to direct
the voting of, such security and/or (ii) investment power, which includes the power to dispose, or to direct the
disposition of, such security, but for purposes of these Articles of Association a person shall not be deemed a beneficial
owner of Covered Shares (A) solely by virtue of the application of the United States Securities Exchange Act of 1934,
as amended from time to time (the «Exchange Act») Rule 13d-3(d) or Exchange Act Rule 13d-5 as in effect on April 18,
2001, (B) solely by virtue of the possession of the legal right to vote securities under applicable law (such as by proxy,
power of attorney or appointment as corporate representative) or (C) held of record by a «private foundation» subject
to the requirements of Section 509 of the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended from time to time,
and the applicable rulings and regulations thereunder (or equivalent in other jurisdictions as determined from time to
time by the Supervisory Board or its delegate). «Beneficially own» and «beneficial ownership» shall have correlative
meanings. For purposes of the determination of beneficial ownership only, the provisions of Article 8 shall not be
deemed to transfer the investment power with respect to any Class I Common Shares.
«Covered Person» or «Covered Persons» shall mean those persons, other than the Company, who were
Shareholders on the IPO Date; provided that any Covered Person who was not also a party to that certain Common
Agreement dated as of April 19, 2002 among the Company and the other parties thereto on the date of adoption of
this Article 8 shall not be subject to paragraph 12 of this Article 8.
«Company» means ACCENTURE S.C.A., together, as the case may be and if the context so requires, with its
Subsidiaries from time to time.
A Covered Person’s «Covered Shares» shall mean any Class I Common Shares beneficially owned by such Covered
Person at the time in question. «Covered Shares» shall also include the securities that are defined to be «Covered
Shares» in paragraph 20 of this Article 8. A Covered Person «acquires» Covered Shares when such Covered Person
first acquires beneficial ownership over such Covered Shares.
The term «disabled» shall mean «disabled» as defined (i) in any employment agreement then in effect between the
employee and the Company, or (ii) if not defined therein, or if there shall be no such agreement, as defined in the
Company’s long-term disability plan as in effect from time to time, or (iii) if there shall be no plan, the inability of an
employee to perform in all material respects his duties and responsibilities to the Company for a period of six (6)
consecutive months or for an aggregate of nine (9) months in any twenty-four (24) consecutive month period by reason
of a physical or mental incapacity. Any question as to the existence of a disability as to which the employee and the
Company cannot agree shall be determined in writing by a qualified independent physician mutually acceptable to the
employee and the Company. If the employee and the Company cannot agree as to a qualified independent physician,
each shall appoint such a physician and those two physicians shall select a third who shall make such determinations in
writing. The determination of disability made in writing to the Company and the employee shall be final and conclusive
for all purposes of this Article 8.
An «employee» shall include, without limitation, the owners and employees of partner personal service companies
in certain countries with which the Company has personal service contracts (in each case as agreed by the Supervisory
Board or its delegate), and any other similarly situated person designated as an «employee» by the Supervisory Board
or its delegate.
«Employee Covered Person» shall mean a Covered Person that is an employee of the Company at the time in
question, provided that if the Company has received notice that any Covered Person intends to terminate such Covered
Person’s employment with the Company (except in the case of notice with respect to retirement or disability), such
Covered Person shall be deemed not to be an Employee Covered Person.
«IPO Date» shall mean July 24, 2001, the date of completion of ACCENTURE Ltd’s initial public offering.
«Non-Competition Agreement» shall mean, collectively, any Non-Competition Agreement, dated as of April 18,
2001, among the Company and the partners from time to time party thereto as such agreement may be amended from
time to time or any agreement having a similar effect.
«Permitted Basket Transaction» shall mean the purchase or sale of, or the establishment of a long or short position
in, a basket or index of securities (or of a derivative financial instrument with respect to a basket or index of securities)
that includes securities of the Company, in each case if such purchase, sale or establishment is permitted under the
Company’s policy on hedging with respect to securities of the Company and other relevant policies, including insider
trading policies, as announced from time to time.
«Sole Beneficial Owner» shall mean a person who is the beneficial owner of Covered Shares, who does not share
beneficial ownership of such Covered Shares with any other person (other than pursuant to these Articles of
Association, the Non-Competition Agreement or applicable community property laws) and who is the only person
(other than pursuant to applicable community property laws) with a direct economic interest in the Covered Shares.
An economic interest of the Company (or of any other person with respect to which the Company has expressly agreed
137
to in writing) as pledgee shall be disregarded for this purpose. A Covered Person that holds Covered Shares indirectly
through a wholly-owned personal holding company shall be considered the «Sole Beneficial Owner» of such Covered
Shares, provided that such personal holding company is a Covered Person hereunder. In respect of Covered Shares held
a personal holding company or a trust structure, the share register shall refer both to the legal entity or trust,
respectively, as the legal owner and record owner of the Covered Shares and the beneficial owner(s) of the legal entity
or trust, respectively.
«Subsidiary» shall mean any person in which ACCENTURE S.C.A. owns, directly or indirectly, at least a majority of
the equity, economic or voting interest.
«Transfer» shall mean any sale, transfer, pledge, hypothecation or other disposition, whether direct or indirect,
whether or not for value, and shall include any disposition of the economic or other risks of ownership of Covered
Shares, including short sales of securities of the Company, option transactions (whether physical or cash settled) with
respect to securities of the Company, use of equity or other derivative financial instruments relating to securities of the
Company and other hedging arrangements with respect to securities of the Company, in each such case other than
Permitted Basket Transactions.
Articles 8 through 23:
Amendments to existing Articles 8 through 23:
Renumber existing Articles 8 through 23, including all references thereto, as new Articles 9 through 24, respectively.
(04849/253/277)
CANILLAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.388.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 janvier 2005i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 août 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (04720/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JPMORGAN FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 89.734.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Shareholders (the «Meeting») of JPMORGAN FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS (the «Company»)
will be held at the registered office of the Company, as set out above, on <i>January 28, 2005i> at 3 p.m. for the purpose of
considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended September 30,
2004.
2. Presentation of the Report of the Auditor for the accounting year ended September 30, 2004.
3. Approval of the financial Statements for the accounting year ended September 30, 2004.
4. Allocation of the results for the accounting year ended September 30, 2004.
5. Discharge of the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended September
30, 2004.
6. Election of Mr Patrick Petitjean, Mr James B Broderick, Mr Jacques Elvinger, Mr Alain Feis and Mr Jean Fuchs to
serve as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders at which the Financial
Statements for the accounting year ended September 30, 2005 are submitted for approval.
7. Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors until the next Annual General Meeting of Sharehold-
ers at which the Financial Statements for the accounting year ended September 30, 2005 are submitted for approv-
al.
8. Approval of Directors’ Fees.
9. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
Shareholders are informed that the resolutions on the agenda for the Meeting do not require any quorum. They will
be passed on a simple majority of the votes of the Shareholders present or represented at the Meeting.
138
Shareholders who cannot personnally attend the Meeting are requested to use the Form of Proxy (available at the
registered office of the Company) and return it no later than January 27, 2004 by the close of business in Luxembourg
to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, to
the attention of the Corporate Secretariat.
The present notice and the prescribed form of proxy are sent to all registered Shareholders on record as at January
7, 2005.
I (04908/755/36)
<i>By order of the Board of Directors.i>
SOROKINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.651.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 janvier 2005i> à 17.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 2004.
4. Divers.
II (04737/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMALTO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.203.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>13 janvier 2005i> à 10.00 heures, au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (04806/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LOG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 83.888.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 janvier 2005i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 septembre 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 septembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (04812/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
139
ACCENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 79.874.
—
The shareholders of ACCENTURE SCA, a Luxembourg société en commandite par actions registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under the number B 79.874, with a registered office at 1, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg («ACCENTURE SCA»), are cordially invited to attend the
GENERAL MEETING
which will be held on <i>January 17, 2005i>, at 12.00 noon, local time, at the offices of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG at
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Five ordinary items:
1. Presentation of the report on the annual accounts issued by the general partner and the report of the commissaire
aux comptes of ACCENTURE SCA;
2. Approval of the balance sheet, the profit and loss accounts, the notes to the accounts and the allocation of the
results of ACCENTURE SCA as of August 31, 2004;
3. Discharge of the general partner, the commissaire aux comptes and the supervisory board in connection with the
fiscal year ended August 31, 2004;
4. Appointment of the members of the supervisory board; and
5. Re-appointment of KPMG LLP as the independent auditors of ACCENTURE SCA.
One extraordinary item:
1. Approval of amendments to ACCENTURE SCA’s articles of association.
The foregoing item of business is more fully described in the Schedule attached hereto.
Shareholders may obtain, free of charge, copies of (a) the balance sheet, (b) the profit and loss accounts, (c) the notes
to the accounts, (d) the list of securities held by ACCENTURE SCA, (e) the list of shareholders, if any, who have not
fully paid up their shares with an indication of the number of shares and their contact details, (f) the report of the general
partner and (g) the report of the commissaire aux comptes, by making a written request to the general partner at AC-
CENTURE LTD, 1661 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, United States of America, Attention: Secretary.
The general partner has fixed the close of business on December 6, 2004, as the record date for the determination
of shareholders entitled to notice of, and to vote at, the meeting. This means that only those persons who were regis-
tered holders of ACCENTURE SCA Class I common shares or Class II common shares at the close of business on that
date will be entitled to receive notice of the meeting and to attend and vote at the meeting.
The general partner is not asking you for a proxy in connection with the General Meeting and you are requested not
to send us a proxy.
Dated: December 22, 2004.
SCHEDULE
PROPOSED AMENDMENTS TO ARTICLES OF ASSOCIATION OF ACCENTURE SCA
Art. 7. Redemption of Shares
Amend the second paragraph of Article 7 to read as follows:
«Subject to any contractual restrictions on Transfer by a holder set forth in any contract or agreement to which the
Company or any of its affiliates is a party or set forth in Article 8 of these Articles of Association, Class I Common
Shares shall be redeemable for cash at the option of the holder by giving irrevocable notice of an election for redemption
to the Company.»
New Article 8-Transfer Restrictions Applicable to Covered Shares
Add a new Article 8 as follows:
Art. 8. Transfer Restrictions Applicable to Covered Shares
1. Each Covered Person shall at all times be the Sole Beneficial Owner of all Covered Shares beneficially owned by
such Covered Person as of or prior to the IPO Date, except as provided herein. Any Covered Shares Transferred in
compliance with this Article 8 shall no longer be subject to such provisions. Capitalized terms used in this Article 8 shall
have the meanings ascribed to such terms in paragraph 24 of this Article 8.
2. Notwithstanding paragraph 1, an Employee Covered Person may:
(i) on or prior to the date that is four years after the IPO Date, Transfer an aggregate of up to 35% of the aggregate
number of Covered Shares beneficially owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date;
(ii) commencing on the date that is four years after the IPO Date, Transfer an aggregate (together with all other
Transfers made pursuant to this paragraph 2) of up to 45% of the aggregate number of Covered Shares beneficially
owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date;
(iii) commencing on the date that is five years after the IPO Date, Transfer an aggregate (together with all other
Transfers made pursuant to this paragraph 2) of up to 55% of the aggregate number of Covered Shares beneficially
owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date;
ACCENTURE LTD
<i>acting as general partner of ACCENTURE SCAi>
140
(iv) commencing on the date that is six years after the IPO Date, Transfer an aggregate (together with all other Trans-
fers made pursuant to this paragraph 2) of up to 65% of the aggregate number of Covered Shares beneficially owned by
such Employee Covered Person as of the IPO Date; and
(v) commencing on the date that is seven years after the IPO Date, Transfer an aggregate (together with all other
Transfers made pursuant to this paragraph 2) of up to 75% of the aggregate number of Covered Shares beneficially
owned by such Employee Covered Person as of the IPO Date.
3. Notwithstanding paragraph 1, a Covered Person may Transfer any Covered Shares beneficially owned by such
Covered Person as of the IPO Date commencing on the later of (i) the date that is eight years after the IPO Date and
(ii) the date that such Covered Person ceases to be an employee of the Company.
4. Notwithstanding paragraph 1, an Employee Covered Person that retires (or has retired) at the age of 50 or older
and is not in contravention of the Non-Competition Agreement (a «Retired Employee») may:
(i) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 50, Transfer up to that number of Covered Shares bene-
ficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate number
of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum of (a) the
percentage of Covered Shares eligible for sale at the date of such retirement pursuant to paragraph 2 of this Article 8
(the «Base Eligible Sales») and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B) 0.25;
(ii) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 51, Transfer up to that number of Covered Shares bene-
ficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate number
of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum of (a) the
percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B) 0.375;
(iii) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 52, Transfer up to that number of Covered Shares ben-
eficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate number
of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum of (a) the
percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B) 0.50;
(iv) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 53, Transfer up to that number of Covered Shares ben-
eficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate number
of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum of (a) the
percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B) 0.625;
(v) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 54, Transfer up to that number of Covered Shares bene-
ficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate number
of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum of (a) the
percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B) 0.75;
(vi) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 55, Transfer up to that number of Covered Shares ben-
eficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date which is equal to the product of (x) the aggregate number
of Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date multiplied by (y) the sum of (a) the
percentage of the Base Eligible Sales and (b) the product of (A) (1 minus Base Eligible Sales) multiplied by (B) 0.875; and
(vii) if such Retired Employee retires (or has retired) at age 56 or above, Transfer 100% of the Covered Shares ben-
eficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date.
5. A Retired Employee may also Transfer the Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the
IPO Date in accordance with paragraph 2 of this Article 8 as if such Retired Employee were an Employee Covered Per-
son.
6. Following the first anniversary of the EPO Date, a Retired Employee that reaches (or has reached) the age of 56
may also Transfer 100% of the Covered Shares beneficially owned by such Retired Employee as of the IPO Date.
7. Notwithstanding paragraph 1, a Covered Person that became disabled while an employee of the Company (a «Dis-
abled Employee») prior to June 15, 2001, may Transfer 100% of Covered Shares beneficially owned by such Disabled
Employee as of the IPO Date. A Covered Person that becomes (or has become) a Disabled Employee following June
15, 2001 may (i) if such Disabled Employee becomes disabled (or has become disabled) prior to reaching the age of 50,
Transfer Covered Shares beneficially owned by such Disabled Employee as of the IPO Date in accordance with the pro-
visions of paragraph 2 of this Article 8 as if such Disabled Employee were an Employee Covered Person and (ii) if such
Disabled Employee becomes (or has become) disabled after reaching the age of 50, Transfer Covered Shares beneficially
owned by such Disabled Employee as of the IPO Date in accordance with the provisions of paragraph 4 of this Article
8 as if such Disabled Employee were a Retired Employee.
8. Notwithstanding paragraph 1, a Covered Person may Transfer Covered Shares beneficially owned by such Covered
Person as of the IPO Date pursuant to bona fide pledges of Covered Shares approved by the Supervisory Board or its
delegate in writing and any foreclosures thereunder, provided that the pledgee has agreed in writing with the Supervi-
sory Board or its delegate (any such agreement to be satisfactory to the Supervisory Board or its delegate in its sole
discretion) that the Company shall have a right of first refusal to purchase such Covered Shares at the market price
prior to any sale of such Covered Shares by such pledgee.
9. Notwithstanding paragraph 1, commencing on June 15, 2004, the Covered Shares are redeemable at the option of
the Covered Person for a redemption price per share equal to the lower of (i) the Valuation Ratio multiplied by the
Market Price of an ACCENTURE LTD Class A Common Share and (ii) one United States dollar.
10. Each Covered Person, for so long as such Covered Person is an Employee Covered Person, will comply with any
restrictions on Transfer relating to Class I Common Shares imposed by the Company pursuant to the Company’s insider
trading policies from time to time and notified to such Covered Person from time to time.
11. All Transfers of Covered Shares beneficially owned by a Covered Person as of or prior to the IPO Date made by
such Covered Person before the adoption of this Article 8 shall be aggregated, for purposes of paragraphs 2 through 4,
141
with all Transfers of Covered Shares beneficially owned by such Covered Person as of or prior to the IPO Date made
by such Covered Person after the adoption of this Article 8.
12. Notwithstanding paragraph 2, each Covered Person will not Transfer any Covered Shares until July 24, 2005, ex-
cept (A) to participate in underwritten public offerings, share repurchases, sales or redemptions or other transactions,
in each case as approved in writing by the Company and/or (B) to estate and/or tax planning vehicles, family members
and charitable organizations that become bound to the terms of Article 8 of these Articles of Association by express
agreement in writing, in each case as approved in writing by the Company (which approval may be subject to other
conditions, including upon the requirement that any transferee become bound by any other agreement, that the Com-
pany may require in its sole discretion). The preceding sentence shall not preclude any Transfer permitted under para-
graph 8 or 9 of this Article 8.
13. All Covered Shares beneficially owned by a Covered Person (in each case other than Covered Shares held of
record by a trustee in a compensation or benefit plan administered by the Company and other Covered Shares that
have been pledged to the Company (or to a third party agreed to in writing by the Company) shall, at the sole discretion
of the Company, be registered in the name of a nominee for such Covered Person and/or shall be held in the custody
of a custodian until otherwise determined by the Company or until such time as such Covered Shares are released pur-
suant to paragraph 17 or 18 of this Article 8. The form of the custody agreement and the identity of the custodian and/
or nominee shall be as determined by the Supervisory Board or its delegate from time to time.
14. Whenever any nominee holder shall receive any dividend or other distribution in respect of any Covered Shares,
satisfied otherwise than in Covered Shares, the Company will give or cause to be given notice or direction to the ap-
plicable nominee and/or custodian referred to in paragraph 13 to permit the prompt distribution of such dividend or
distribution to the beneficial owner of such Covered Shares, net of any tax withholding amounts required to be withheld
by the nominee, unless the distribution of such dividend or distribution is restricted by the terms of another agreement
between the Covered Person and the Company (or with any other person with respect to which the Company has
expressly agreed in writing) known to the Company.
15. Any share certificate representing Covered Shares beneficially owned by a Covered Person, and any agreement
or other instrument evidencing restricted share units, options or other rights to receive or acquire Covered Shares
beneficially owned by such Covered Person, may bear a legend noted conspicuously on each such certificate, agreement
or other instrument reading substantially as follows:
«The securities represented by this certificate are subject to transfer restrictions set forth in the Company’s Articles
of Association. The securities represented by this certificate may be sold, exchanged, transferred, assigned, pledged, par-
ticipated, hypothecated or otherwise disposed of only in accordance therewith.»
16. The Company shall refuse to register the transfer of Covered Shares not made in compliance with these Articles
of Association and it may enter stop transfer orders against the transfer of Covered Shares not made in compliance
with these Articles of Association.
17. All Covered Shares of each Covered Person who is not an Employee Covered Person which could be Transferred
without contravening any provision of this Article 8 shall be released from the custody of the custodian pursuant to
procedures to be developed by the Company to or at the direction of such Covered Person free and clear of all restric-
tions and legends described above.
18. A specified number of Covered Shares of an Employee Covered Person shall be released from the custody of the
custodian, pursuant to procedures to be developed by the Company, upon the request of such Employee Covered Per-
son and to or at the direction of such Employee Covered Person (free and clear of all restrictions and legends described
in this Article 8), provided that such request is accompanied by a certificate of such requesting Employee Covered Per-
son (i) indicating such requesting Employee Covered Person’s intention to Transfer promptly such specified number of
Covered Shares and (ii) establishing that such specified number of Covered Shares are then permitted to be Transferred
without contravening any Transfer Restrictions (which evidence must be satisfactory to the Company).
19. Each Covered Person shall be responsible for all expenses of such Covered Person incurred in connection with
compliance by such Covered Person with its obligations under this Article 8, including expenses incurred by the Com-
pany in enforcing the provisions of Article 8 relating to such obligations.
20. hi the event of any change in the outstanding Class I Common Shares by reason of stock dividends, stock splits,
reverse stock splits, recapitalizations, combinations, exchanges of shares and the like, the term «Covered Shares» shall
refer to and include the securities received or resulting therefrom, but only to the extent such securities are received
in exchange for or in respect of Covered Shares. Upon the occurrence of any event described in the immediately pre-
ceding sentence, the Company shall make such adjustments to or interpretations of the provisions of this Article 8 as
the Company shall deem necessary or desirable to carry out the intent of such provisions). If the Company deems it
advisable, any such adjustments may take effect from the record date, the 'when issued trading date,' the 'ex dividend
date' or another appropriate date.
21. The provisions of this Article 8 shall be binding upon the respective legatees, legal representatives, successors and
assigns of the Covered Persons; provided, however, that a Covered Person may not assign or otherwise transfer any
of its obligations under such provisions without the prior written consent of the Supervisory Board or its delegate and
any assignment or other transfer of rights and/or obligations under this Article 8 by a Covered Person without such
consent of the Supervisory Board or its delegate shall be void.
22. If requested by the Supervisory Board or its delegate, each Covered Person shall execute such documents and
take such further action as may be reasonably necessary to effect the provisions of this Article 8.
23. The Supervisory Board or its delegate may waive any of the provisions of this Article 8 to permit particular Cov-
ered Persons, a particular class of Covered Persons or all Covered Persons to Transfer Covered Shares in particular
situations (such as Transfers to family members, partnerships or trusts) or generally. The Supervisory Board or its del-
142
egate may impose such conditions as the Supervisory Board or its delegate determines on the granting of such waivers.
The determinations of the Supervisory Board or its delegate under this paragraph 23 shall be final and binding and need
not to be uniform and may be made selectively among Covered Persons (whether or not such Covered Persons are
similarly situated).
24. For purposes of this Article 8, the following terms have the following meanings:
A «beneficial owner» of a security includes any person who, directly or indirectly, through any contract, arrangement,
understanding, relationship or otherwise, has or shares: (i) voting power, which includes the power to vote, or to direct
the voting of, such security and/or (ii) investment power, which includes the power to dispose, or to direct the dispo-
sition of, such security, but for purposes of these Articles of Association a person shall not be deemed a beneficial owner
of Covered Shares (A) solely by virtue of the application of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amend-
ed from time to time (the «Exchange Act») Rule 13d-3(d) or Exchange Act Rule 13d-5 as in effect on April 18, 2001,
(B) solely by virtue of the possession of the legal right to vote securities under applicable law (such as by proxy, power
of attorney or appointment as corporate representative) or (C) held of record by a «private foundation» subject to the
requirements of Section 509 of the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended from time to time, and
the applicable rulings and regulations thereunder (or equivalent in other jurisdictions as determined from time to time
by the Supervisory Board or its delegate). «Beneficially own» and «beneficial ownership» shall have correlative meanings.
For purposes of the determination of beneficial ownership only, the provisions of Article 8 shall not be deemed to trans-
fer the investment power with respect to any Class I Common Shares.
«Covered Person» or «Covered Persons» shall mean those persons, other than the Company, who were Sharehold-
ers on the IPO Date; provided that any Covered Person who was not also a party to that certain Common Agreement
dated as of April 19, 2002 among the Company and the other parties thereto on the date of adoption of this Article 8
shall not be subject to paragraph 12 of this Article 8.
«Company» means ACCENTURE SCA, together, as the case may be and if the context so requires, with its Subsid-
iaries from time to time.
A Covered Person’s «Covered Shares» shall mean any Class I Common Shares beneficially owned by such Covered
Person at the time in question. «Covered Shares» shall also include the securities that are defined to be «Covered
Shares» in paragraph 20 of this Article 8. A Covered Person «acquires» Covered Shares when such Covered Person
first acquires beneficial ownership over such Covered Shares.
The term «disabled» shall mean «disabled» as defined (i) in any employment agreement then in effect between the
employee and the Company, or (ii) if not defined therein, or if there shall be no such agreement, as defined in the Com-
pany’s long-term disability plan as in effect from time to time, or (iii) if there shall be no plan, the inability of an employee
to perform in all material respects his duties and responsibilities to the Company for a period of six (6) consecutive
months or for an aggregate of nine (9) months in any twenty-four (24) consecutive month period by reason of a physical
or mental incapacity. Any question as to the existence of a disability as to which the employee and the Company cannot
agree shall be determined in writing by a qualified independent physician mutually acceptable to the employee and the
Company. If the employee and the Company cannot agree as to a qualified independent physician, each shall appoint
such a physician and those two physicians shall select a third who shall make such determinations in writing. The deter-
mination of disability made in writing to the Company and the employee shall be final and conclusive for all purposes of
this Article 8.
An «employee» shall include, without limitation, the owners and employees of partner personal service companies
in certain countries with which the Company has personal service contracts (in each case as agreed by the Supervisory
Board or its delegate), and any other similarly situated person designated as an «employee» by the Supervisory Board
or its delegate.
«Employee Covered Person» shall mean a Covered Person that is an employee of the Company at the time in ques-
tion, provided that if the Company has received notice that any Covered Person intends to terminate such Covered
Person’s employment with the Company (except in the case of notice with respect to retirement or disability), such
Covered Person shall be deemed not to be an Employee Covered Person.
«IPO Date» shall mean July 24, 2001, the date of completion of ACCENTURE LTD’s initial public offering.
«Non-Competition Agreement» shall mean, collectively, any Non-Competition Agreement, dated as of April 18,
2001, among the Company and the partners from time to time party thereto as such agreement may be amended from
time to time or any agreement having a similar effect.
«Permitted Basket Transaction» shall mean the purchase or sale of, or the establishment of a long or short position
in, a basket or index of securities (or of a derivative financial instrument with respect to a basket or index of securities)
that includes securities of the Company, in each case if such purchase, sale or establishment is permitted under the Com-
pany’s policy on hedging with respect to securities of the Company and other relevant policies, including insider trading
policies, as announced from time to time.
«Sole Beneficial Owner» shall mean a person who is the beneficial owner of Covered Shares, who does not share
beneficial ownership of such Covered Shares with any other person (other than pursuant to these Articles of Associa-
tion, the Non-Competition Agreement or applicable community property laws) and who is the only person (other than
pursuant to applicable community property laws) with a direct economic interest in the Covered Shares. An economic
interest of the Company (or of any other person with respect to which the Company has expressly agreed to in writing)
as pledgee shall be disregarded for this purpose. A Covered Person that holds Covered Shares indirectly through a
wholly-owned personal holding company shall be considered the «Sole Beneficial Owner» of such Covered Shares, pro-
vided that such personal holding company is a Covered Person hereunder. In respect of Covered Shares held a personal
holding company or a trust structure, the share register shall refer both to the legal entity or trust, respectively, as the
143
legal owner and record owner of the Covered Shares and the beneficial owner(s) of the legal entity or trust, respec-
tively.
«Subsidiary» shall mean any person in which ACCENTURE SCA owns, directly or indirectly, at least a majority of the
equity, economic or voting interest.
«Transfer» shall mean any sale, transfer, pledge, hypothecation or other disposition, whether direct or indirect,
whether or not for value, and shall include any disposition of the economic or other risks of ownership of Covered
Shares, including short sales of securities of the Company, option transactions (whether physical or cash settled) with
respect to securities of the Company, use of equity or other derivative financial instruments relating to securities of the
Company and other hedging arrangements with respect to securities of the Company, in each such case other than Per-
mitted Basket Transactions.
Articles 8 through 23
Amendments to existing Articles 8 though 23:
Renumber existing Articles 8 through 23, including all references thereto, as new Articles 9 through 24, respectively.
II (04843/253/273)
ALISON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.756.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 janvier 2005i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Annulation du capital autorisé existant et introduction d’un nouveau capital à concurrence de EUR 969.000 pour
porter le capital social de son montant actuel de EUR 31.000 à EUR 1.000.000 et modification subséquente de
l’article 3 des statuts.
2. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-
primer le droit préférentiel de souscription.
3. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs».
4. Suppression à l’article 7 des statuts des termes «agissant par son président ou un administrateur délégué».
5. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de
la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le dernier jour du mois d’avril, à 10.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant».
6. Divers.
Les actionnaires sont avisés qu’un quorum de 50% des actions émises est requis pour délibérer sur le point 5. de
l’ordre du jour. Si le quorum n’était pas atteint, une 2
e
Assemblée portant sur ce point devra être convoquée. Les ré-
solutions pour être valables devront réunir les 2 tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (04844/795/32)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MARIZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.660.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 janvier 2005i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 12 octobre 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quo-
rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04783/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
144
AD SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.833.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place at the registered office of the Company, 69, route d’Esch,
Luxembourg, on <i>January 12, 2005i> at 2.30 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the year ended as at
September 30, 2004;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
September 30, 2004;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
II (04845/755/22)
<i>The Board of Directors.i>
COMGEST PANDA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.116.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders (the «Meeting») of COMGEST PANDA will be held at the registered office of the Fund, as set above:
<i>January 17, 2005i> at 11.00 a.m.,
for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor for the accounting year ended September
30, 2004.
2. Approval of the Annual Accounts for the accounting year ended September 30, 2004.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended September
30, 2004.
5. Composition of the Board of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous.
The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of
the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their shares certificates five days
before the Meeting at the window of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, where
forms of proxy are available.
Registered shareholders have to inform the Board of Directors by mail (letter or form of proxy) of their intention
to attend the Meeting five days before this latter.
II (04804/755/28)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Ratina Participations S.A.
Watts Holdco S.A.
Loffice, S.à r.l.
European Robot, S.à r.l.
Promedent Medical Supplies S.A.
Promedent Medical Supplies S.A.
Promedent Medical Supplies S.A.
Promedent Medical Supplies S.A.
Promedent Medical Supplies S.A.
AZ Express, S.à r.l.
Andromédia, S.à r.l.
Croix Pattée S.A.
Contere S.A.
GE Fanuc Automation Europe S.A.
Reval Investissement S.A.
Reval Investissement S.A.
Siral S.A.
Siral S.A.
Cit International S.A.
Axial Investments S.A.
Axial Investments S.A.
Riviera Finance 1 S.A.
Dinolux S.A.
Dinolux S.A.
Misys Overseas Investments, S.à r.l.
Misys Overseas Investments, S.à r.l.
Lycoris Enterprises S.A.
Lycoris Enterprises S.A.
Finacle Investissements S.A.
Serinha S.A.
Serinha S.A.
Private Life Partners S.A.
Minco S.A.
Minco S.A.
Citore S.A.
Citore S.A.
Wam S.A.
Wam S.A.
Viga Holdings (Luxembourg) S.A.
Viga Holdings (Luxembourg) S.A.
Silawi S.A.
Silawi S.A.
Taboga S.A.
Taboga S.A.
DHP Press S.A.
Csepel Luxembourg (No. 1), S.à r.l.
Csepel Luxembourg (No. 1), S.à r.l.
Tool Invest Holding S.A.
IP Luxembourg, S.à r.l.
Sigval Holding S.A.
Financière de Beaufort S.A.
Accenture S.C.A.
Canillac Holding S.A.
JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds
Sorokina S.A.
Amalto S.A.
Log S.A.
Accenture S.C.A.
Alison Investments S.A.
Mariz Holding S.A.
AD Sicav
Comgest Panda