logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

62929

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1312

22 décembre 2004

S O M M A I R E

Aggreko Luxembourg Management, S.à r.l., Müns-

Holmbury Luxembourg Investments 1, S.à r.l., Lu-

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62951

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62970

Aggreko Luxembourg, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . .

62938

International  Finance  Corporation  S.A.,  Luxem-

Agrati International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62948

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62930

Agrati International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62948

Intertrust Dom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

62971

Altea Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

62947

Intertrust Dom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

62971

Altea Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

62947

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Altea Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

62947

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62968

Altea Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

62947

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Baldi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

62963

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62968

Baltic Ace Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . .

62943

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Banque Hapoalim Suisse S.A., Luxembourg . . . . . .

62973

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62968

Betam International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

62937

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Bimmo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62944

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62968

Bimmo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62944

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Blendo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62965

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62968

BM Diffusion, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

62973

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Broderinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62962

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62968

Broderinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62962

JLM Patrimoine, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

62965

Compu Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62970

JLM Patrimoine, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

62965

Compu Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62971

Kodiak S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62930

Conseil & Management S.A., Bereldange  . . . . . . . .

62974

Kowac S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62930

Corolle Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

62951

Kumna, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62963

Didy Holding S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62966

Kumna, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62963

Euro Concept Mag S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

62974

Kumna, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62963

Eurowatt, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

62974

Lemanik Private Equity Fund, Sicav, Luxembourg

62949

Eurowatt, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

62974

Lemanik Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62972

Fondex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62966

LT Andersson Communications (Luxembourg), 

Giori S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62937

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62967

Giori S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62937

LT Andersson Communications (Luxembourg), 

Giori S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62937

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62967

Guarantee International S.A., Luxembourg . . . . . .

62956

Luxriver S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62964

Guarantee International S.A., Luxembourg . . . . . .

62956

Man RMF Investments Sicav, Luxembourg . . . . . . 

62943

Holdex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62965

Maserati Club Luxembourg, A.s.b.l., Bereldange  . 

62975

Holmbury Luxembourg Investments 1, S.à r.l., Lu-

MHI Consulting, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . 

62974

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62971

Nanterre G, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62970

Holmbury Luxembourg Investments 1, S.à r.l., Lu-

Nareco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62950

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62972

Nareco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62950

Holmbury Luxembourg Investments 1, S.à r.l., Lu-

Noël Pons, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

62969

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62970

Nomex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

62970

62930

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.487. 

<i>Conseil d’administration depuis le 7 juin 2004:

- M

e

 Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, président;

- M

e

 Denis Lenfant, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire;

- Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy, 13, rue Beau Site.

<i>Commissaire:

- Monsieur Sébastien Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue de la Corne au Bois.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05699. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086972.3/255/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

KODIAK, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 83.390. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04017,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085871.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

KOWAC S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 63.592. 

Seit dem 28. August 2003 ist Herr Wilhelm Joh. Burke als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit der tägli-

chen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser Geschäftsführung betraut.

Gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft ist Herr Wilhelm Joh. Burke in dieser Eigenschaft befugt, die Gesell-

schaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch seine Einzelunterschrift Dritten gegenüber rechtskräftig zu ver-
pflichten.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05703. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086976.3/255/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Obélisque S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62944

SOICA S.A., Aéroport de Luxembourg  . . . . . . . . .

62967

Obélisque S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62944

SOPC   Finance   (Luxembourg)   S.A.H.,   Luxem-

Parbat Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

62967

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62973

Parmeria S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

62945

SOPC   Finance   (Luxembourg)   S.A.H.,   Luxem-

Phantex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

62964

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62973

Polychem International S.A.H., Luxembourg  . . . . 

62969

Sodefi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62964

Polychem International S.A.H., Luxembourg  . . . . 

62969

Sodefi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62964

Poudrerie de Luxembourg S.A., Kockelscheuer  . . 

62969

Sofinaca S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62966

Quadrifoglio S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

62949

Sofinaca S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62966

Quadrifoglio S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

62949

Solex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

62942

Sadirac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62948

(La) Tabathèque S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .

62974

Sadirac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62948

Univex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62963

Sigma Capital Energy Holding Company S.A., Lu-

VWR International Europe, S.à r.l., Luxembourg  .

62945

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62931

Sigma  Capital  Energy  Investments  S.A.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62956

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION S.A.
Signature

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Signature.

KOWAC S.A.
Unterschrift

62931

SIGMA CAPITAL ENERGY HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 103.642. 

STATUTES

In the year two thousand four, on the twelfth day of October.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

1. SIGMA CAPITAL ENERGY MANAGEMENT LTD, having its registered office at Wickhams Cay, PO Box 662, Road

Town, Tortola, BVI, (R.C. number 616545),

2. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, having its registered office at Wickhams Cay, PO Box

662, Road Town, Tortola, BVI, (R.C. number 519909),

both here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France) and Miss
Séverine Canova, lawyer, residing in Thionville (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A,

by virtue of two proxies established on October 1st, 2004.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SIGMA CAPITAL ENERGY HOLDING

COMPANY S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

The company may take any action to safeguard its rights and make any transaction whatsoever which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are liable to further their development or extension.

In all operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits estab-

lished by the law of July 31st, 1929.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at fifty thousand euro (50,000.- EUR) represented by five

thousand (5.000) shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each.

The authorised capital of the incorporation is fixed at seventy million euro (70,000,000 EUR) to be divided into seven

million (7,000,000) shares with a par value ten euro (10.- EUR) each.

The authorised and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribe capital within the limits et the authorised capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorised to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

62932

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, with any denomination and

payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital.

Bonds issued by the board of directors must be in a registered form and holders of bonds may not request the con-

version of their registered bonds into bonds in a bearer form.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders. 

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at request of not less

than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of urgency, resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

In the case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years. 

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the tenth day of April at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 

62933

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915, on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory dispositions

1) The first business year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st

of December 2004.

2) The first annual general meeting shall be held in the year 2005.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, represented as men-

tioned hereabove, the appearing parties declare to subscribe the shares as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of fifty thousand euro (50,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915, on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at five and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2009:
a) Mr Vesselin Danev, Banker, residing at 195 Boardwalk Place, London E14 5SQ, United Kingdom, born in Sofia (Bul-

garia), on December 3rd, 1966.

b) Mr Georgi Veltchev, Investment Manager, residing at 56 Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road, London

W8 7BD, United Kingdom, born in Sofia (Bulgaria), on February 26th, 1968.

c) Mr Ivo Evgeniev, Private Equity Manager, residing at 58, Leva str, V4D, Vratza 3.000, Bulgaria, born in Byala (Bul-

garia), on July 1st, 1971.

d) Mr Jivko Savov, Private Equity Manager, residing at 230 Castellain Mansions, London W9 1HD, United Kingdom,

born in Kazankak (Bulgaria), on November 23rd, 1966.

e) Mr Krassimir Katev, Private Equity Manager, residing at Flat 2, Tower Bridge Wharf, 86 St. Katharine’s Way, Lon-

don E1W 1UR, United Kingdom, born in Varna (Bulgaria), on October 11th, 1968.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2009: 

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered offices in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, (R. C.

number B 33.418).

4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den zwölften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

1 SIGMA CAPITAL ENERGY MANAGEMENT LTD, prenamed, four thousand nine hundred and ninety-nine

shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,999

2 SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000

62934

Sind erschienen:

1. SIGMA CAPITAL ENERGY MANAGEMENT LTD, mit Gesellschaftssitz in Wickhams Cay, PO Box 662, Road

Town, Tortola, BVI, (einregistriert unter Nummer 616545), 

2. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, mit Gesellschaftssitz in Wickhams Cay, PO Box 662,

Road Town, Tortola, BVI, (einregistriert unter Nummer 519909),

beide Gesellschaften hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., mit Gesellschaftssitz

in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn José Correia, comptable, wohnhaft in Longwy (France) und Fräulein Séverine
Canova, juriste, wohnhaft in Thionville (France), handelnd in ihrer Eigenschaft als Prokuristen A,

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 1. Oktober 2004,
welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-

gender Urkunde beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorbenannt, ersuchten den amtierenden Notar nachfolgenden durch alle Kompa-

renten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

Titel I.- Bezeichnung, Gesellschaftssitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SIGMA CAPITAL ENERGY HOLDING

COMPANY S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg ver-

legt werden.

Falls aussergewöhnliche politische oder wirtschaftliche Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, welche die

normale Tätigkeit dieses Sitzes oder die Kommunikation dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden, kann die provisori-
sche Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland erklärt werden, dies solange bis zur vollständigen Beendigung der
anormalen Umstände. Eine solche Entscheidung wird die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigen. Die
Erklärung betreffend den Verleg des Gesellschaftssitzes wird Dritten durch das Gesellschaftsorgan mitgeteilt, das unter
den gegebenen Umständen am besten hierfür geeignet ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem

Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuro-
päischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann
diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente
auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Ga-
rantien gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

Titel II.- Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wurde festgesetzt auf fünfzigtausend euro (50.000,- EUR), eingeteilt in fünftausend

(5.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn euro (10,- EUR).

Das genehmigte Gesellschaftskapital wird auf siebzig millionen euro (70.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in sie-

ben millionen (7.000.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn euro (10,- EUR).

Das genehmigte und gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfas-

sung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, wahrend einer Zeitspanne von fünf Jahren vom Datum der Veröf-

fentlichung dieser Satzung an gerechnet, des gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese
Kapitalerhöhungen können gezeichnet und ausgegeben werden mittels Aktien mit oder ohne Ausgabeprämie ganz nach
Belieben des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Aufstockungen vorzunehmen ohne den jetzigen Aktionen ein

Zeichnungsprivileg auf den auszugebenden Aktien vorzubehalten. Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsratsmit-
glied, Direktor oder Prokurist oder jeder anderen ermächtigten Person, Vollmacht erteilen und die Zeichnungen zu
empfangen und die Zahlung des Preises der Aktien welche diese ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, zu
erhalten.

Jedesmal wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung amtlich festgestellt hat, wird dieser Artikel an die

vorgenommene Änderung angepasst.

Die Gesellschaft kann, je nach Wunsch der Aktieninhaber, Global- oder Einzelaktien ausstellen.
Die Aktien können als Namens- oder Inhaberaktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann den Wiederkauf ihrer eignen Aktien unter den gesetzlich gegebenen Bedingungen veranlassen. 
Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, in Form einfacher Anleihen, Optionsanleihen

oder Wandelanleihen, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe,
dass die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Ka-
pitals erfolgen kann.

62935

Vom Verwaltungsrat emittierte Anleihen müssen in der Form von Namensobligationen sein und die Inhaber solcher

Obligationen können nicht die Umwandlung in Inhaberobligationen beantragen.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufen den Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.

Titel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat mit wenigstens drei Mitgliedern, Teilhaber oder nicht, verwaltet, die

von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Zeitspanne genannt sind, die nicht mehr als sechs Jahre betragen
kann. Sie können zu jeder Zeit von der Generalversammlung wiedergewählt oder abberufen werden.

Die Zahl der Verwalter und die Dauer ihres Mandates werden von der Generalversammlung der Gesellschaft fest-

gesetzt.

Im Falle einer unbesetzten Stelle im Verwaltungsrat haben die bleibenden Verwalter das Recht diese provisorisch zu

besetzen, die getroffene Entscheidung wird in der nächsten Versammlung ratifiziert.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung des Vorsitzenden oder auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgeliedern.
Die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheidungen und Beschlüsse sind gültig wenn die Mehrheit der Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Eine Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist möglich und kann durch Brief, Tele-
gramm, Telex oder Fax erfolgen. In Dringlichkeitsfällen können die.

Verwaltungsratsmitglieder per Brief, Telegramm, Telex oder Fax ihre Stimme abgeben. Die Beschlüsse werden durch

Stimmenmehrheit getroffen.

In Dringlichkeitsfällen sind Beschlüsse, die durch alle Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet sind, im gleichen Maße

gültig wie Beschlüsse, die in einer ordentlichen und gültig einberufenen Sitzung genommen werden. Solche Unterschrif-
ten können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleichen Beschlusses erscheinen und können
per Brief, Fax oder Telex erbracht werden.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 8. Dem Verwaltungsrat obliegen die weitreichendsten Befugnisse zur Durchführung aller Verwaltungshandlun-

gen und Beschlüsse, die sich im Rahmen des im vorhergehenden Artikel 4 erläuterten Gesellschaftszweckes befinden.

Er ist zu allen Handlungen ermächtigt, die nicht ausschliesslich durch das Gesetz und die Statuten der Generalver-

sammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt unter den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen, Dividendenvorschüsse auszu-

zahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse
betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandate, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10 der
Satzung erteilt werden. 

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmiglieder übertra-

gen, welche als Delegierte des Verwaltungsrates ernannt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch die Geschäftsführung ganz oder teilweise an einen oder mehrere Direktore übertra-

gen oder einem oder mehreren Bevollmächtigten besondere Vollmachten erteilen. Bei dem Bevollmächtigten oder Di-
rektor muss es sich nicht unbedingt um ein Verwaltungsratsmitglied oder Aktionär handeln.

Die Übertragung von Befugnissen an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Zustimmung der

Generalversammlung.

Art. 11. Alle gerichtlichen Streitigkeiten der Gesellschaft, sei es als Kläger oder als Angeklagter, werden vom Ver-

waltungsrat verfolgt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch eines hierzu ermächtigten Mitgliedes vertreten ist.

Titel IV.- Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Kommissaren

überwacht. Sie setzt ihre Zahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest, welches nicht mehr als sechs Jahre betra-
gen kann.

Sie können zu jedem Zeitpunkt wiedergewählt oder abberufen werden.

Titel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tagt innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an dem in den Ein-

berufungen angegebenen Ort, am 10. April eines jeden Jahres um 10:00 Uhr.

Falls dieses Datum ein gesetzlicher Feiertag ist, tagt die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Arbeitstag.
Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu ha-

ben, kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung stattfinden.

Titel VI.- Geschäftsjahr, Aufteilung des Gewinns

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der positive Überschuss des Jahresabschlusses, nach Abzug der Sozialbeiträge und Abschreibungen bildet

den Nettogewinn der Gesellschaft. Diesem Gewinn werden fünf Prozent für die Erstellung eines legalen Reservefonds
entnommen; diese Entnahme ist nicht mehr erforderlich, wenn die Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapitals beträgt,
muss jedoch wieder aufgenommen werden, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer,
auf den Reservefonds zurückgegriffen wurde.

Die Generalversammlung kann darüberhinaus über den Saldo verfügen.

62936

Titel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere von der Generalversammlung er-

nannten Liquidatoren, deren Befugnisse und Entgeld sie bestimmt.

Titel VIII.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Für alle in den vorliegenden Statuten nicht erfassten Punkte beziehen sich die Parteien auf die Bestimmungen

des luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften wie deren Abänderungen, denen
sie sich unterwerfen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt bei der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2005 statt. 

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt: 

Das gezeichnete Kapital wurde vollständig in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag

von fünfzigtausend euro (50.000,- EUR), worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10.August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Schätzung und Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausendhundert euro (2.000,- EUR).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten einstimmig folgende Be-
schlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf fünf und die Zahl der der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern, deren Mandate bei der Generalversammlung des Geschäftsjahres 2009 enden,

wurden bestellt:

a) Herr Vesselin Danev, Banker, wohnhaft in 195 Boardwalk Place, London E14 5SQ, England, geboren in Sofia (Bul-

garien), am 3. Dezember 1966.

b) Herr Georgi Veltchev, Investment Manager, wohnhaft in 56 Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road, Lon-

don W8 7BD, England, geboren in Sofia (Bulgarien), am 26. Februar 1968.

c) Herr Ivo Evgeniev, Private Equity Manager, wohnhaft in 58, Leva str, V4D, Vratza 3.000, Bulgarien, geboren in Byala

(Bulgarien), am 1. Juli 1971. 

d) Herr Jivko Savov, Private Equity Manager, wohnhaft in 230 Castellain Mansions, London W9 1HD, England, gebo-

ren in Kazankak (Bulgarien), am 23. November 1966.

e) Herr Krassimir Katev, Private Equity Manager, wohnhaft in Flat 2, Tower Bridge Wharf, 86 St. Katharine’s Way,

London E1W 1UR, England, geboren in Varna (Bulgarien), am 11. Oktober 1968.

3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wurde bestellt:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-2453 Luxemburg, 16, rue Eugène Ruppert, (R. C. Nummer

B 33.418).

4) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller. 
Der amtierende Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, bestätigt dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in englischer Sprache gehalten ist gefolgt von einer deutsche Übersetzung, und dass im Falle von
Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit Uns Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Correia, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 18, case 12. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(087320.3/220/366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

1. SIGMA CAPITAL ENERGY MANAGEMENT LTD, vorbenannt: vier Tausend neunhundertneunundneunzig

Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.999

2. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, vorbenannt, eine Aktie   . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: fünftausend Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Luxemburg, den 22. Oktober 2004 

G. Lecuit.

62937

BETAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.854. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02256, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085759.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

GIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 85.147. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05609, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086575.3/815/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

GIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 85.147. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05614, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086577.3/815/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

GIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 85.147. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 2 juin 2003

L’Assemblée procède à l’élection définitive en qualité d’administrateur de Monsieur Riccardo Pisa, demeurant à I-

Monticelli Brusati et de Monsieur James Lawrence Broadhurst, demeurant à I-Milan, cooptés en remplacement de Mes-
sieurs Fabio Armati et Fabrizio Zanardi, administrateurs démissionnaires, par le Conseil d’Administration en date du 4
avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086580.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
Signature

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
Signature

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
Signature

62938

AGGREKO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.624. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eleventh of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

AGGREKO LUXEMBOURG MANAGEMENT, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade Register, with
registered office at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg 

here represented by Linda Korpel, lawyer, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

Grand Duchy of Luxembourg, on October 11, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and

raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt in-
struments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control,

manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner

participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any
company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or enterprise).

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name AGGREKO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schuttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by eight hundred (800) shares

of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B. 

The managers need not to be shareholders. The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the sole

shareholder of the Company.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

62939

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature

of two managers, with obligatorily the signature of one category A and one category B manager. 

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers

to one several ad hoc agents.

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented with obligatorily a simple majority in each category of managers. 

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers to be held in Luxembourg by telephone

or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting. The managers are not authorized to participate physically by any means in any board meetings whilst physically
present in the United Kingdom. 

Art. 13. The manager or the board of managers assumes, by reason of his/its position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by him/it in the name of the Company. 

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular res-

olutions, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolutions. 

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the manager or the board

of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may resolve to pay interim dividends under

the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers showing that sufficient retained profits

are available for distribution. If desired, these interim accounts may be reviewed by an independent professional;

- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2004.

<i>Subscription - Payment

The eight hundred (800) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each have been subscribed by AGGREKO LUXEM-

BOURG MANAGEMENT, S.à r.l., prenamed, and have been fully paid in cash, so that the amount of twenty thousand
Euro (EUR 20,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand and five hundred Euro.

62940

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the followings as managers:

<i>Category A Managers:

* Mr Angus Cockburn, Finance Director, born on June 24, 1963 in Glasgow (United Kingdom), residing at 27, Dreg-

horn Loan, Edinburgh, EH13 ODF, Scottland;

* Mr Nicholas Wharton, Finance Director, born on June 22, 1963 in Newcastle upon Tyne (United Kingdom), residing

at 76, Leuvensestraat, 2587 GK Den Haag, The Netherlands;

<i>Category B Manager:

* Mr Dominique Ransquin, Licencié et Maître en Sciences Economiques et Sociales, born on September 4, 1951 in

Namur (Belgium), residing at 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg as in-

dependent auditor. Its mandate will expire at the general meeting, which will be called to deliberate on the annual ac-
counts as at December 31, 2004.

3. Fix the address of the Company at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le onze octobre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AGGREKO LUXEMBOURG MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie suivant

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg

ici représentée par Linda Korpel, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 11 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet de prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émet-

tre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur
fournir toute assistance (que la Société ait ou n’ait pas de participation dans telle société ou entreprise).

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination AGGREKO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schuttrange).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille Euros (EUR 20.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune. 

62941

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. 

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont nommés et révocables ad nutum par l’associé uni-

que de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société est valablement engagée vis à vis des tiers par la signature de son gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée vis à vis des tiers par les signatures conjointes de

deux gérants, avec obligatoirement la signature d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés avec obligatoirement une majorité dans chaque catégorie de gérants. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil à tenir au Luxembourg par «conference

call» par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. Les gérants ne sont autorisés à participer physiquement par quelque moyens
que ce soit à quelque conseil que ce soit et spécialement à aucun conseil à tenir en Grande Bretagne. 

Art. 13. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle re-

lativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être adoptées par

voie de résolutions circulaires, le texte desquelles devra être envoyé à tous les associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par télégramme, télex, téléfax ou e-mail. Les associés émettront leur vote par la signature du
procès-verbal des résolutions circulaires.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou le conseil

de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. 

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement de dividen-

des intérimaires sous les conditions suivantes:

62942

- Les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou par le conseil de gérance, montrant que des bénéfices repor-

tés suffisants sont disponibles pour distribution. Si désiré, ces comptes intérimaires peuvent être revus par un profes-
sionnel indépendant;

- Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne

sont pas menacés. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2004.

<i>Souscription - Libération

Les huit cents (800) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune ont été souscrites par AGGREKO LUXEM-

BOURG MANAGEMENT, S.à r.l., préqualifiée, et ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que
la somme de vingt mille Euros (EUR 20.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Décision de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants:

<i>Gérants de catégorie A:

* Monsieur Angus Cockburn, Directeur Financier, né le 24 juin 1963 à Glasgow (Royaume-Uni), demeurant au 27,

Dreghorn Loan, Edinburgh, EH13 ODF, Ecosse;

* Monsieur Nicholas Wharton, Directeur Financier, né le 22 juin, 1963 à Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni), de-

meurant au 76, Leuvensestraat, 2587 GK Den Haag, Pays-Bas;

<i>Gérant de catégorie B:

* Monsieur Dominique Ransquin, Licencié et Maître en Sciences Economiques et Sociales, né le 4 septembre 1951 à

Namur (Belgique), demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg aux

fonctions d’auditeur indépendant. Son mandat se terminera lors de l’approbation des comptes annuels de la Société au
31 décembre 2004.

3. Fixer l’adresse du siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: L. Korpel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 21, case 8. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087181.3/211/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

SOLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.411. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04341, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086233.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

62943

BALTIC ACE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 69.428. 

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A Comparu:

La société anonyme FINCONSEIL S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, Allée Léopold Goebel, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.409,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Raymond Henschen, maître en sciences économiques, de-

meurant à Luxembourg.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme BALTIC ACE INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, Allée Léo-

pold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.428, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 avril 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Association numéro 490 du 26 juin 1999.

II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à quarante mille US dollars (USD 40.000,-), représenté par cent

(100) actions d’une valeur nominale de quatre cents US dollars (USD 400,-) chacune, intégralement souscrites et libé-
rées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société BALTIC ACE INVESTMENTS

S.A., qu’en conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main. 

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation

se trouve dès lors définitivement clôturée. 

V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social

à L-1635 Luxembourg, 87, Allée Léopold Goebel,

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme BALTIC ACE INVESTMENTS

S.A., est dissoute de plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les
actions de la société, est investie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors
définitivement clôturée.

A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au

notaire soussigné les cent (100) actions qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant ont été annulées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: R. Henschen, Henri Beck. 
Enregistré à Echternach, le 19 octobre 2004, vol. 358, fol. 23, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(086446.3/201/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

MAN RMF INVESTMENTS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.790. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 octobre 2004

Au Conseil d’Administration de MAN RMF INVESTMENTS SICAV (la «Société»), il a été décidé comme suit:
1. De prendre note de la démission de Monsieur Tim van Dijk en tant qu’Administrateur de la Société,
2. De nommer Monsieur Hans van de Sanden en tant qu’Administrateur de la Société en remplacement de Monsieur

Tim van Dijk, avec effet au 11 octobre 2004 pour un terme expirant lors de la prochaine assemblée générale des ac-
tionnaires de la société.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03878. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086465.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Echternach, le 25 octobre 2004.

H. Beck.

L. de Vet
<i>Administrateur

62944

OBELISQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.047. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03669, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086209.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

OBELISQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.047. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 2004

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MAGAMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg ainsi que le mandat de Commissaire aux comptes de la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au
50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086201.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

BIMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 85.863. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05381, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086909.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

BIMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 85.863. 

Le conseil arrête comme suit l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société qui doit avoir

lieu le 20 octobre 2004 à 11.00 heures:

- Approbation des bilans de la société des exercices clos au 31 décembre 2003;
- Affectation du résultat;
- Décharge d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086912.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Signature.

62945

PARMERIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 5.391. 

Statuts coordonnés en date du 4 juillet 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27

octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(086823.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

VWR INTERNATIONAL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.701.

In the year two thousand and four, on the third of August.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

VWR INTERNATIONAL HOLDINGS, Inc. having its registered office at Little Falls Centre II, Suite 358, 2751 Center-

ville Road, Wilmington, Delaware 19808 USA, registered with the Secretary of State of Delaware under file number
3762662 here represented by Evelyn Maher, attorney at law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in West
Chester, USA, on July 30, 2004, the said proxy having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned
notary will remain annexed to the present deed for the purposes of registration.

The appearing party requested the notary to state that:
I.- VWR INTERNATIONAL HOLDINGS, Inc. is the sole actual shareholder (the «Sole Shareholder») of VWR IN-

TERNATIONAL EUROPE, S.à r.l. (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 28th of
June 2004, not yet published in the Mémorial C.

II.- The Sole Shareholder and the Company have agreed that the Sole Shareholder would contribute on the date here-

of, and on such date the Company would accept from the Sole Shareholder in exchange of shares of the Company all
of the right, title and interest of the Sole Shareholder in and to fourteen thousand seven hundred and ninety-five (14,795)
shares of VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, par value

€ 25.- per share constituting all of the issued and outstanding shares of VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA,
S.à r.l.

III.- The Sole Shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital by three hundred and fifty nine thousand nine hundred

and fifty Euro (EUR 359,950.-) so as to bring it from twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) to three hun-
dred and seventy-two thousand three hundred and fifty Euro (EUR 372,350.-) by the creation and the issue of fourteen
thousand three hundred and ninety-eight (14,398) new shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, each
share carrying a share premium of one hundred and three Euro and forty-four point four zero eight cents (EUR
103.44408) for a total share premium of one million four hundred and eighty-nine thousand three hundred and eighty-
eight Euro (EUR 1,489,388.-) to be allocated to a share premium account.

<i>Second resolution

The fourteen thousand three hundred and ninety eight (14,398) new shares have been subscribed by the Sole Share-

holder and paid in as follows:

by the contribution of fourteen thousand seven hundred and ninety-five (14,795) shares of VWR INTERNATIONAL

NORTH AMERICA, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, par value 

€ 25.- per share constituting all of

the issued and outstanding shares of VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l. (the «assets»).

The assets are totalling one million eight hundred and forty-nine thousand three hundred and thirty-eight Euro

(1,849,338.- EUR) evidence of the value of the assets having been given to the undersigned notary by a balance sheet of
the company dated August 2, 2004 which valuation signed ne varietur by the appearing person and the undersigned no-
tary shall stay affixed to the present deed with which it will be registered.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of article 7 of the articles of incorporation of the Company

in accordance with the foregoing resolutions so that it reads as follows:

«The corporate capital is set at three hundred and seventy-two thousand three hundred and fifty euro (372,350.-

EUR) divided into fourteen thousand eight hundred and ninety-four (14,894) shares having a par value of 25 Euros (25.-
EUR) each.»

<i>Evaluation and Expenses

For the purpose of registration the present increase of capital and the share premium are valued at 

€ 1,849,338.-.

In relation to the contribution in kind consisting of 14,795 shares representing 100% of the share capital of the com-

pany VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l., the Company refers to Article 4-2 of the law of December
29, 1971 which provides for capital tax exemption.

62946

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company

incurs or for which it is liable by reason of its organization, amounts to approximately two thousand eight hundred Euros
(2,800.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trois août.

A comparu:

Devant-nous Maître Paul Bettingen, notaire à Niederanven:
La société VWR INTERNATIONAL HOLDING INC avec siège social au Little Falls Centre II, suite 358, 2751 Cen-

terville Road, Wilmington, Delaware, Etats-Unis immatriculée avec le «Secretary of State of the State of Delaware» sous
le numéro 3762662,

représentée aux présentes par M

e

 Evelyn Maher, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui

conférée à West Chester, Etats-Unis, le 30 juillet 2004. 

Laquelle procuration, ayant été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte aux fins d’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- VWR INTERNATIONAL HOLDING INC. est la seule et unique associée (l’«Associé Unique») de la société VWR

INTERNATIONAL EUROPE, S.à r.l., (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 2 août 2004, non encore publié au Mémorial C.

II.- Que d’un commun accord entre l’Associé Unique et la Société, il a été convenu qu’à la date de ce jour, l’Associé

Unique ferait apport et transférerait à la Société qui accepte, en échange de parts sociales de la Société, tous les droits,
titres et intérêts de l’Associé Unique relatifs à, quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze (14.795) parts sociales de
la société VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,
ayant une valeur nominale de 

€ 25,- chacune et formant la totalité du capital social de la société VWR INTERNATIO-

NAL NORTH AMERICA, S.à r.l.

III.- Que l’associé unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de trois cent cinquante-neuf mille neuf

cent cinquante Euro (

€ 359.950,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents Euro (€ 12.400,-)

à trois cent soixante-douze mille trois cent cinquante Euro (

€ 372.350,-) par la création et l’émission de quatorze mille

trois cent quatre-vingt-dix-huit (14.398) parts nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (

€ 25,-) chacune, as-

sorties chacune d’une prime d’émission de cent trois Euro et quarante-quatre virgule quatre cent huit centimes
(103,44408), totalisant un ensemble de primes d’émission d’un million quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent qua-
tre-vingt-huit Euro (

€ 1.489.388,-) affectées à un poste de primes d’émission.

<i>Deuxième résolution

Toutes les quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (14.398) parts nouvelles ont été souscrites par l’Associé

Unique et entièrement libérées comme suit:

par un apport en nature de quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze (14.795) parts sociales de la société VWR

INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant une valeur
nominale de 

€ 25,- chacune et formant la totalité du capital social de la société VWR INTERNATIONAL NORTH AME-

RICA, S.à r.l. («l’Actif»).

L’Actif s’élève à un million huit cent quarante-neuf mille trois cent trente-huit Euro (

€ 1.849.338) ainsi qu’il résulte

du bilan de la Société arrêté à la date du 2 août 2004 lequel après avoir été signé ne varietur par le notaire instrumentaire
et les comparants, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 7 des statuts qui aura désormais la teneur sui-

vante:

«Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante-douze mille trois cent cinquante Euro (

€ 372.350,-) divisé

en quatorze mille huit cent quatre-vingt-quatorze (14.894) parts sociales de vingt-cinq euro (

€ 25,-) chacune.

<i>Evaluation et Coût

Pour l’enregistrement du présent acte, l’augmentation de capital et les primes d’émission sont évaluées à un million

huit cent quarante-neuf mille trois cent trente-huit Euro (

€ 1.849.338).

En relation avec l’apport en nature des quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze (14.795) parts sociales de la so-

ciété VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l., la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

62947

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à deux mille huit cents euros (2.800,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Maher, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087511.3/202/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

ALTEA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.220. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04935, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086224.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

ALTEA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.220. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04938, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086227.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

ALTEA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.220. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04940, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086234.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

ALTEA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.220. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04943, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086231.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Senningerberg, le 25 octobre 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

62948

AGRATI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.747. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03665, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086207.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

AGRATI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.747. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 août 2004

L’Assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2003.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant 44, rue de la Vallée

à L-2661 Luxembourg, de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant son
siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’as-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 24 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086196.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SADIRAC S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.947. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06076, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086474.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SADIRAC S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,-,

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.947. 

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 1999 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée

en date du 19 octobre 2004 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’As-
semblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobs-
tant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086497.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

R. P. Pels.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

R. P. Pels.

62949

QUADRIFOGLIO S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 85.763. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06050, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086467.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

QUADRIFOGLIO S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 85.763. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06048, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086464.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.352. 

<i>Résolution circulaire du conseil d’administration (Traduction française)

Les soussignés, tous membres du conseil d’administration (le «Conseil») de LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND,

SICAV (la «Sicav»), une société d’investissement à capital variable, constituée conformément à la loi luxembourgeoise,
ont décidé et approuvé, par la signature de la présente résolution, les point suivants:

Attendu que le Conseil a été informé de la démission de M. Yves Bayle comme administrateur de la Sicav avec effet

au 19 février 2004.

Attendu que le Conseil a également été informé de la démission de M. Philippe Meloni comme administrateur de la

Sicav avec effet au 16 avril 2004.

Attendu que le Conseil a décidé de coopter M. Pietro Tasca, Directeur Général d’IBL INVESTMENT BANK LUXEM-

BOURG S.A. et M. Jean Louis Catrysse, Directeur-Adjoint d’IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme ad-
ministrateurs de la Sicav.

Conformément à ce qui a été précédemment cité, le Conseil décide à l’unanimité:
A. Après avoir noté que M. Pietro Tasca, Directeur Général d’IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a déjà

été approuvé par l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

de coopter M. Pietro Tasca, Directeur Général d’IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., comme adminis-

trateur de la Sicav en remplacement de M. Yves Bayle, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la
Sicav, assemblée qui décidera de sa nomination définitive.

B. Après avoir noté que M. Jean Louis Catrysse, Directeur-Adjoint d’IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

a déjà été approuvé par l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

de coopter M. Jean Louis Catrysse, Directeur-Adjoint d’IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., comme ad-

ministrateur de la Sicav en remplacement de M. Philippe Meloni, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires
de la Sicav, assemblée qui décidera de sa nomination définitive.

<i>Circular resolution of the board of directors

The undersigned, being all the members of the board of directors (hereinafter the «Board») of LEMANIK PRIVATE

EQUITY FUND, SICAV (hereinafter the «Sicav»), a société d’investissement à capital variable, created under Luxem-
bourg law, hereby unanimously consent and agree, by signing this written resolution, to the following:

Whereas the Board has been informed of the resignation of Mr Yves Bayle as director of the Sicav with effect as of

19 February 2004.

Whereas the Board has also been informed of the resignation of Philippe Meloni as director of the Sicav with effect

as of 16 April 2004.

Whereas the Board decided to co-opt Mr Pietro Tasca, General Manager, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG

S.A. and Mr Jean Louis Catrysse, First Vice President, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. as directors of the
Sicav.

Having carefully considered the above, the board unanimously resolves:
A. After having noted that Mr Pietro Tasca, General Manager, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. has

already been approved by the Luxembourg Supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Signature.

Signature.

62950

to co-opt Mr Pietro Tasca, General Manager, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. as director of the Sicav

in replacement of Mr Yves Bayle, until the next general meeting of shareholders of the Sicav, which meeting shall make
the permanent appointment.

B. After having noted that Mr Jean Louis Catrysse, First Vice President, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG

S.A. has already been approved by the Luxembourg Supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur
Financier,

to co-opt Mr Jean Louis Catrysse, First Vice President, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. as director of

the Sicav in replacement of Mr Philippe Meloni, until the next general meeting of shareholders of the Sicav, which meet-
ing shall make the permanent appointment.

29 April 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05317. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085559.3/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

NARECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 27.195. 

<i>Extrait du rapport de gestion aux associés sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2001 en date du 1

<i>er

<i> février 2002

L’associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 1

er

 février 2002, a pris les

résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Le résultat global au 31 décembre 2001 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087006.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

NARECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 27.195. 

<i>Extrait du rapport de gestion aux associés sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2002 en date du 10 mars 2003

L’associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 10 mars 2003, a pris les

résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Le résultat global au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087007.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Approved
C. Sagramoso / C. Camperio Ciani / G. Sagramoso
<i>Chairman / Director / Director

- Distribution de dividendes 313,54 EUR/part sociale . . . . . . . . . . 

17.720.089 LUF

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.417.564 LUF

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
NARECO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29,51 EUR

- Distribution de dividendes 346,04 EUR/part sociale . . . . . .

484.802,81 EUR

- Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.575,66 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
NARECO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

62951

COROLLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 98.425. 

EXTRAIT

En date du 27 septembre 2004, il a été décidé de nommer ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à Munsbach

(Grand Duché de Luxembourg), comme Commissaire aux Comptes de la société.

Son mandat prendra fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06395. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087051.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

AGGREKO LUXEMBOURG MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.623. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eleventh day of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

AGGREKO LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, a private limited company incorporated and governed by the

laws of United Kingdom, with registered office at 121, West Regent Street, Glasgow, G2 25D, Scotland, 

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 8,

2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The object of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and

raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt in-
struments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control,

manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner

participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any
company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or enterprise).

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name AGGREKO LUXEMBOURG MANAGEMENT, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schuttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) represented by one thousand two hundred

(1,200) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Pour extrait conforme
<i>Associé unique
Signatures

62952

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B. 

The managers need not to be shareholders. The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the sole

shareholder of the Company.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature

of two managers, with obligatorily the signature of one category A and one category B manager. 

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers

to one several ad hoc agents.

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented with obligatorily a simple majority in each category of managers. 

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers to be held in Luxembourg by telephone

or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting. The managers are not authorized to participate physically by any means in any board meetings whilst physically
present in the United Kingdom. 

Art. 13. The manager or the board of managers assumes, by reason of his/its position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by him/it in the name of the Company. 

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular res-

olutions, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolutions. 

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the manager or the board

of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may resolve to pay interim dividends under

the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers showing that sufficient retained profits

are available for distribution. If desired, these interim accounts may be reviewed by an independent professional;

- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration. 

62953

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2004.

<i>Subscription - Payment

The one thousand two hundred (1,200) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each have been subscribed by AGGRE-

KO LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, prenamed, and have been fully paid in cash, so that the amount of thirty
thousand Euro (EUR 30,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand and five hundred euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the followings as managers:

<i>Category A Manager:

* Mr Nicholas Wharton, Finance Director, born on June 22, 1963 in Newcastle upon Tyne (United Kingdom), residing

at 76, Leuvensestraat, 2587 GK Den Haag, The Netherlands;

<i>Category B Manager:

* Mr Dominique Ransquin, Licencié et Maître en Sciences Economiques et Sociales, born on September 4, 1951 in

Namur (Belgium), residing at 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg as in-

dependent auditor. Its mandate will expire at the general meeting, which will be called to deliberate on the annual ac-
counts as at December 31, 2004.

3. Fix the address of the Company at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Déclaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le onze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AGGREKO LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée et régie suivant

les lois de Grande-Bretagne ayant son siège social au 121, West Regent Street, Glasgow, G2 25D, Ecosse

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le

8 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet de prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émet-

tre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur
fournir toute assistance (que la Société ait ou n’ait pas de participation dans telle société ou entreprise).

62954

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination AGGREKO LUXEMBOURG MANAGEMENT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schuttrange). 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille Euros (EUR 30.000,-) représenté par mille deux cents (1.200) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. 

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont nommés et révocables ad nutum par l’associé uni-

que de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société est valablement engagée vis à vis des tiers par la signature de son gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée vis à vis des tiers par les signatures conjointes de

deux gérants, avec obligatoirement la signature d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés avec obligatoirement une majorité dans chaque catégorie de gérants. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil à tenir au Luxembourg par «conference

call» par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. Les gérants ne sont autorisés à participer physiquement par quelque moyens
que ce soit à quelque conseil que ce soit et spécialement à aucun conseil à tenir en Grande Bretagne. 

Art. 13. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle re-

lativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être adoptées par

voie de résolutions circulaires, le texte desquelles devra être envoyé à tous les associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par télégramme, télex, téléfax ou e-mail. Les associés émettront leur vote par la signature du
procès-verbal des résolutions circulaires.

62955

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou le conseil

de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. 

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement de dividen-

des intérimaires sous les conditions suivantes:

- Les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou par le conseil de gérance, montrant que des bénéfices repor-

tés suffisants sont disponibles pour distribution. Si désiré, ces comptes intérimaires peuvent être revus par un profes-
sionnel indépendant;

- Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne

sont pas menacés. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2004.

<i>Souscription - Libération

Les mille deux cents (1.200) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune ont été souscrites par AGGREKO

LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, et ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte
que la somme de trente mille Euros (EUR 30.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Décision de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants:

<i>Gérant de catégorie A:

* Monsieur Nicholas Wharton, Directeur Financier, né le 22 juin, 1963 à Newcastle upon Tyne (Royaume Uni), de-

meurant au 76, Leuvensestraat, 2587 GK Den Haag, Pays Bas;

<i>Gérant de catégorie B:

* Monsieur Dominique Ransquin, Licencié et Maître en Sciences Economiques et Sociales, né le 4 septembre 1951 à

Namur (Belgique), demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg aux

fonctions d’auditeur indépendant. Son mandat se terminera lors de l’approbation des comptes annuels de la Société au
31 décembre 2004.

3. Fixer l’adresse du siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 21, case 7. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087182.3/211/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

J. Elvinger.

62956

GUARANTEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.527. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03687, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086211.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

GUARANTEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.527. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 2004

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2003.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de Commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège
social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086204.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SIGMA CAPITAL ENERGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 103.641. 

STATUTES

In the year two thousand four, on the twelfth day of October.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

1. SIGMA CAPITAL ENERGY HOLDING COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, constituted on this day, not yet registered in the Registre de Commerce at Luxembourg,

2. SIGMA CAPITAL ENERGY MANAGEMENT LTD, having its registered office at Wickhams Cay, PO Box 662, Road

Town, Tortola, BVI (R.C. number 616545),

both here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France) and Miss
Séverine Canova, lawyer, residing in Thionville (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A,

by virtue of two proxies.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SIGMA CAPITAL ENERGY INVESTMENTS

S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

62957

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented

by three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each.

The authorised capital of the incorporation is fixed at seventy million euro (EUR 70,000,000.-) to be divided into sev-

en million (7,000,000) shares with a par value ten euro (EUR 10.-) each.

The authorised and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribe capital within the limits et the authorised capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine. 

The board of directors is specifically authorised to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, with any denomination and

payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital.

Bonds issued by the board of directors must be in a registered form and holders of bonds may not request the con-

version of their registered bonds into bonds in a bearer form.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders. 

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at request of not less

than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of urgency, resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

In the case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

62958

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years. 

They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the first day of March at 11 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory dispositions

1) The first business year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st

of December 2004.

2) The first annual general meeting shall be held in the year 2005.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, represented as men-

tioned hereabove, the appearing parties declare to subscribe the shares as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

1. SIGMA CAPITAL ENERGY HOLDING COMPANY S.A., prenamed: three thousand ninety-nine shares  . . 3,099
2. SIGMA CAPITAL ENERGY MANAGEMENT LTD, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

62959

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand seven hundred
and fifty (1,750.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2009:
a) Mr Vesselin Danev, Banker, residing at 195 Boardwalk Place, London E14 5SQ, United Kingdom, born in Sofia (Bul-

garia), on December 3rd, 1966.

b) Mr Georgi Veltchev, Securities Dealer, residing at 56 Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road, London W8

7BD, United Kingdom, born in Sofia (Bulgaria), on February 26th, 1968.

c) Mr Ivo Evgeniev, Manager, residing at 58, Leva str, V4D, Vratza 3.000, Bulgaria, born in Byata (Bulgaria), on July 1st,

1971.

d) Mr Jivko Savov, Private Equity Manager, residing at 230 Castellain Mansions, London W9 1HD, United Kingdom,

born in Kazankak (Bulgaria), on November 23rd, 1966.

e) Mr Krassimir Katev, Private Equity Manager, residing at Flat 2, Tower Bridge Wharf, 86 St. Katharine’s Way, Lon-

don E1W 1UR, United Kingdom, born in Varna (Bulgaria), on October 11th, 1968.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2009: 

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered offices in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, (R. C.

number B 33.418).

4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den zwölften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. SIGMA CAPITAL ENERGY HOLDING COMPANY S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller,

welche heute gegründet wurde, noch nicht im Handelsregister eingetragen,

2. SIGMA CAPITAL ENERGY MANAGEMENT LTD, mit Gesellschaftssitz in Wickhams Cay, PO Box 662, Road

Town, Tortola, BVI, (R. C. Nummer 616545),

beide Gesellschaften hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., mit Gesellschaftssitz

in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn José Correia, comptable, wohnhaft in Longwy (France) und Fräulein Séverine
Canova, juriste, wohnhaft in Thionville (France), handelnd in ihrer Eigenschaft als Prokuristen A,

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift.
welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-

gender Urkunde beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorbenannt, ersuchten den amtierenden Notar nachfolgenden durch alle Kompa-

renten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

Titel I.- Bezeichnung, Gesellschaftssitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SIGMA CAPITAL ENERGY INVEST-

MENTS S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg ver-

legt werden.

Falls aussergewöhnliche politische oder wirtschaftliche Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, welche die

normale Tätigkeit dieses Sitzes oder die Kommunikation dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden, kann die provisori-
sche Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland erklärt werden, dies solange bis zur vollständigen Beendigung der
anormalen Umstände. Eine solche Entscheidung wird die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigen. Die
Erklärung betreffend den Verleg des Gesellschaftssitzes wird Dritten durch das Gesellschaftsorgan mitgeteilt, das unter
den gegebenen Umständen am besten hierfür geeignet ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer gegründet.

62960

Art. 4. Die Gesellschaft ist ermächtigt alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Ue-

berträge von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchzuführen.

Gesellschaftszweck sind ausserdem alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen

Unternehmen verbundenen Operationen, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser
Beteiligungen.

Sie kann ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus allen Titeln und Patenten jeglicher

Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men teilnehmen, jegliche Titel und Patente durch Übertragung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche
andere Art erstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise veräussern, diese Geschäfte und
Patente verwerten lassen, den Gesellschaften, an denen sie Interesse hat, sämtliche Hilfe, Darlehen, Vorschüsse oder
Garantien geben.

Titel II.- Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wurde festgesetzt auf einundreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in drei-

tausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR).

Das genehmigte Gesellschaftskapital wird auf siebzig Millionen Euro (EUR 70.000.000,-) festgesetzt, eingeteilt in sie-

ben millionen (7.000.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

Das genehmigte und gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfas-

sung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, wahrend einer Zeitspanne von fünf Jahren vom Datum der Veröf-

fentlichung dieser Satzung an gerechnet, des gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese
Kapitalerhöhungen können gezeichnet und ausgegeben werden mittels Aktien mit oder ohne Ausgabeprämie ganz nach
Belieben des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Aufstockungen vorzunehmen ohne den jetzigen Aktionen ein

Zeichnungsprivileg auf den auszugebenden Aktien vorzubehalten. Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsratsmit-
glied, Direktor oder Prokurist oder jeder anderen ermächtigten Person, Vollmacht erteilen und die Zeichnungen zu
empfangen und die Zahlung des Preises der Aktien welche diese ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, zu
erhalten.

Jedesmal wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung amtlich festgestellt hat, wird dieser Artikel an die

vorgenommene Änderung angepasst.

Die Gesellschaft kann, je nach Wunsch der Aktieninhaber, Global- oder Einzelaktien ausstellen.
Die Aktien können als Namens- oder Inhaberaktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann den Wiederkauf ihrer eignen Aktien unter den gesetzlich gegebenen Bedingungen veranlassen.
Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, in Form einfacher Anleihen, Optionsanleihen

oder Wandelanleihen, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe,
dass die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Ka-
pitals erfolgen kann.

Vom Verwaltungsrat emittierte Anleihen müssen in der Form von Namensobligationen sein und die Inhaber solcher

Obligationen können nicht die Umwandlung in Inhaberobligationen beantragen.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufen den Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.

Titel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat mit wenigstens drei Mitgliedern, Teilhaber oder nicht, verwaltet, die

von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Zeitspanne genannt sind, die nicht mehr als sechs Jahre betragen
kann. Sie können zu jeder Zeit von der Generalversammlung wiedergewählt oder abberufen werden.

Die Zahl der Verwalter und die Dauer ihres Mandates werden von der Generalversammlung der Gesellschaft fest-

gesetzt.

Im Falle einer unbesetzten Stelle im Verwaltungsrat haben die bleibenden Verwalter das Recht diese provisorisch zu

besetzen, die getroffene Entscheidung wird in der nächsten Versammlung ratifiziert.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung des Vorsitzenden oder auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgeliedern.
Die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheidungen und Beschlüsse sind gültig wenn die Mehrheit der Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Eine Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist möglich und kann durch Brief, Tele-
gramm, Telex oder Fax erfolgen. In Dringlichkeitsfällen können die.

Verwaltungsratsmitglieder per Brief, Telegramm, Telex oder Fax ihre Stimme abgeben. Die Beschlüsse werden durch

Stimmenmehrheit getroffen.

In Dringlichkeitsfällen sind Beschlüsse, die durch alle Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet sind, im gleichen Maße

gültig wie Beschlüsse, die in einer ordentlichen und gültig einberufenen Sitzung genommen werden. Solche Unterschrif-
ten können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleichen Beschlusses erscheinen und können
per Brief, Fax oder Telex erbracht werden. 

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 8. Dem Verwaltungsrat obliegen die weitreichendsten Befugnisse zur Durchführung aller Verwaltungshandlun-

gen und Beschlüsse, die sich im Rahmen des im vorhergehenden Artikel 4 erläuterten Gesellschaftszweckes befinden.

62961

Er ist zu allen Handlungen ermächtigt, die nicht ausschliesslich durch das Gesetz und die Statuten der Generalver-

sammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt unter den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen, Dividendenvorschüsse auszu-

zahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse
betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandaten, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10
der Satzung erteilt werden. 

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmiglieder übertragen,

welche als Delegierte des Verwaltungsrates ernannt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch die Geschäftsführung ganz oder teilweise an einen oder mehrere Direktore übertra-

gen oder einem oder mehreren Bevollmächtigten besondere Vollmachten erteilen. Bei dem Bevollmächtigten oder Di-
rektor muss es sich nicht unbedingt um ein Verwaltungsratsmitglied oder Aktionär handeln.

Die Übertragung von Befugnissen an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Zustimmung der

Generalversammlung.

Art. 11. Alle gerichtlichen Streitigkeiten der Gesellschaft, sei es als Kläger oder als Angeklagter, werden vom Ver-

waltungsrat verfolgt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch eines hierzu ermächtigten Mitgliedes vertreten ist.

Titel IV.- Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Kommissaren

überwacht. Sie setzt ihre Zahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest, welches nicht mehr als sechs Jahre betra-
gen kann.

Sie können zu jedem Zeitpunkt wiedergewählt oder abberufen werden.

Titel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tagt innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an dem in den Ein-

berufungen angegebenen Ort, am 1. März eines jeden Jahres um 11 Uhr.

Falls dieses Datum ein gesetzlicher Feiertag ist, tagt die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Arbeitstag.
Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu ha-

ben, kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung stattfinden.

Titel VI.- Geschäftsjahr, Aufteilung des Gewinns

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der positive Überschuss des Jahresabschlusses, nach Abzug der Sozialbeiträge und Abschreibungen bildet

den Nettogewinn der Gesellschaft. Diesem Gewinn werden fünf Prozent für die Erstellung eines legalen Reservefonds
entnommen; diese Entnahme ist nicht mehr erforderlich, wenn die Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapitals beträgt,
muss jedoch wieder aufgenommen werden, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer,
auf den Reservefonds zurückgegriffen wurde.

Die Generalversammlung kann darüber hinaus über den Saldo verfügen.

Titel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere von der Generalversammlung er-

nannten Liquidatoren, deren Befugnisse und Entgelt sie bestimmt.

Titel VIII.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Für alle in den vorliegenden Statuten nicht erfassten Punkte beziehen sich die Parteien auf die Bestimmungen

des luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften wie deren Abänderungen, denen
sie sich unterwerfen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2005 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt: 

Das gezeichnete Kapital wurde vollständig in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag

von einunddreissigtausend euro (31.000,- EUR), worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Schätzung und Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendsiebenhundertfünfzig euro
(1.750,- EUR).

1. SIGMA CAPITAL ENERGY HOLDING COMPANY S.A., vorbenannt: dreitausendneunundneunzig Aktien

3.099

2. SIGMA CAPITAL ENERGY MANAGEMENT LTD, vorbenannt: eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreitausendeinhundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

62962

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten einstimmig folgende Be-
schlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die Zahl der der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern, deren Mandate bei der Generalversammlung des Geschäftsjahres 2009 enden,

wurden bestellt:

a) Herr Vesselin Danev, Banker, wohnhaft in 195 Boardwalk Place, London E14 5SQ, England, geboren in Sofia (Bul-

garien), am 3. Dezember 1966.

b) Herr Georgi Veltchev, Securities Dealer, wohnhaft in 56 Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road, London

W8 7BD, England, geboren in Sofia (Bulgarien), am 26. Februar 1968.

c) Herr Ivo Evgeniev, Manager, wohnhaft in 58, Leva str, V4D, Vratza 3.000, Bulgarien, geboren in Byala (Bulgarien),

am 1. Juli 1971.

d) Herr Jivko Savov, Private Equity Manager, wohnhaft in 230 Castellain Mansions, London W9 1HD, England, gebo-

ren in Kazankak (Bulgarien), am 23. November 1966.

e) Herr Krassimir Katev, Private Equity Manager, wohnhaft in Flat 2, Tower Bridge Wharf, 86 St. Katharine’s Way,

London E1W 1UR, England, geboren in Varna (Bulgarien), am 11. Oktober 1968.

3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wurde bestellt:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-2453 Luxemburg, 16, rue Eugène Ruppert, (R. C. Nummer

B 33.418).

4) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller. 
Der amtierende Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, bestätigt dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in englischer Sprache gehalten ist gefolgt von einer deutsche Übersetzung, und dass im Falle von
Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentenn, haben diese mit Uns Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Correia, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 19, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(087321.3/220/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

BRODERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.946. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05584, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2004.

(086430.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

BRODERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.946. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 15 juin 2004 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de la

société COSAFIN S.A. ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale approu-

vant les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086335.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Luxemburg, den 22. Oktober 2004.

G. Lecuit.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

62963

UNIVEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.412. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04338, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086239.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

KUMNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 85.140. 

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03892, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086342.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

KUMNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 85.140. 

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04809, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086343.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

KUMNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 85.140. 

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086345.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

BALDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.259. 

Avec effet au 1

er

 octobre 2004, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social au 14,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplace-
ment de Madame Sabine Plattner, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Madame Marie-José Reyter, Administrateur
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086305.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

62964

SODEFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.389. 

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05599, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086438.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SODEFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.389. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>qui s’est tenue le jeudi 16 septembre 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Koen Lozie, Jean Quin-

tus et de la société COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’assemblée approu-

vant les comptes au 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086407.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

PHANTEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.410. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04335, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086243.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

LUXRIVER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.852. 

Avec effet au 1

er

 octobre 2004, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social au 14,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplace-
ment de Madame Sabine Plattner, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Madame Marie-José Reyter, Administrateur
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05498. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086308.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signatures.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

62965

JLM PATRIMOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 93.594. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05594, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086435.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

JLM PATRIMOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 93.594. 

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 7 octobre 2004

Les mandats des Gérants étant arrivés à échéance, l’associé unique décide de renouveler les mandats de:
- Monsieur Jean-Luc Macaud, gérant A;
- Monsieur Jean Quintus, gérant B;
- COSAFIN S.A., gérant B,
pour une durée expirant lors de la décision approuvant les comptes sociaux de l’exercice arrêtés au 31 décembre

2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086356.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

HOLDEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.404. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04337, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086241.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

BLENDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.588. 

Avec effet au 1

er

 octobre 2004, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social au 14,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplace-
ment de Madame Sabine Plattner, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Moyse Dargaa, Administrateur
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086309.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Gérants

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

62966

SOFINACA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.653. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05587, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

(086432.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SOFINACA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.653. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 10 mars 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

- L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes pour

une durée d’un an.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005 approuvant les comptes arrêtés

au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086351.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

FONDEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.402. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04339, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086237.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

DIDY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 78.714. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 8 octobre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 21 octobre 2004, volume 529, folio 46, case 6;

I- Que la société anonyme DIDY HOLDING S.A., ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Meder-

nach, R.C.S. Luxembourg section B, numéro 78714, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 7 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 357 du 16 mai 2001.

II- Qu’il s’ensuit que ladite société anonyme DIDY HOLDING S.A. est et restera dissoute avec effet en date de ce

jour;

que le comparant déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liqui-

dation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

III- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société

dissoute.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086837.3/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
E. Jastrow / M. A. Jastrow
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Junglinster, le 25 octobre 2004.

J. Seckler.

62967

LT ANDERSSON COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 67.604. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05448, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086586.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

LT ANDERSSON COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 67.604. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05447, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086585.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

PARBAT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 41.084. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1992, acte publié au 

Mémorial C n

°

 560 du 1

er

 décembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05556, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086334.3/1261/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SOICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.277. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le vendredi 28 mai 2004

L’Assemblée Générale décide sur proposition du Conseil d’Administration de reconduire le mandat d’Administrateur

de Monsieur Guillaume Welbes venu à échéance pour un nouveau terme de trois années, venant à échéance à l’Assem-
blée Générale de l’an 2007.

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086329.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

<i>Pour LT ANDERSSON COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour LT ANDERSSON COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour PARBAT FINANCE S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres
A. Heiderscheid
<i>Administrateur-délégué

62968

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04331,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086250.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04333, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086256.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

Les comptes consolidés au 31 décembree 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04320,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086247.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04324, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086254.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04317,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086245.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04329, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086252.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

62969

POLYCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.424. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 21 mai 2004 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, pour une nou-

velle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrê-
tés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086370.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

POLYCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.424. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 21 mai 2004 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateurs de Monsieur E.J. Scherrer, de Madame N. Hausmann Inder-

bitzin et de GUYMONT SERVICES LIMITED pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086372.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

POUDRERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 5.955. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le jeudi 13 mai 2004

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de reconduire le mandat d’administra-

teur de Monsieur Charles-Louis Ackermann, Président du Conseil d’Administration, pour un terme de 6 années, venant
à échéance à l’Assemblée Générale de l’an 2010.

Kockelscheuer, le 13 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086310.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

NOEL PONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.782. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04664, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086817.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Extrait sincère et conforme
POLYCHEM INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur 

Extrait sincère et conforme
POLYCHEM INTERNATIONAL S.A.
P. Sprimont
<i>Président de l’Assemblée

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres
J.-P. Hardt / T. Felgen
<i>Vice-Président / Administrateur

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

62970

HOLMBURY LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.925,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.814. 

Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2004,

réf. LSO-AV05732, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086635.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

HOLMBURY LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.925,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.814. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 30 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2004,

réf. LSO-AV05729, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086636.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

NOMEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.408. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04340, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086236.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

NANTERRE G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.401. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04666, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086822.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

COMPU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.125. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05607, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086442.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

<i>Pour HOLMBURY LUX. PARTICIPATIONS 1, S.à r.l.
C. Smith
<i>Gérant

<i>Pour HOLMBURY LUX. PARTICIPATIONS 1, S.à r.l.
C. Smith
<i>Gérant

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

FIDUPAR
Signatures

62971

COMPU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.125. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05577, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

(086425.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

INTERTRUST DOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.106. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf.

LSO-AV05737, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086633.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

INTERTRUST DOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.106. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 18 octobre 2004, le mandat du Com-

missaire aux comptes:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Colm Smith, Administrateur;
- Monsieur Eppe Koopmans, Administrateur;
- Monsieur Bastiaan Schreuders, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086632.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

HOLMBURY LUXEMBOURG INVESTMENTS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 55.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.576. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf.

LSO-AV05725, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086638.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour INTERTRUST DOM S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

<i>Pour INTERTRUST DOM S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

<i>Pour HOLMBURY LUX. INVESTMENTS 1, S.à r.l.
C. Smith
<i>Gérant

62972

HOLMBURY LUXEMBOURG INVESTMENTS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 55.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.576. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf.

LSO-AV05727, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086639.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

LEMANIK SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.893. 

<i>Résolution circulaire du Conseil d’Administration (Traduction française)

Les soussignés, tous membres du conseil d’administration (le «Conseil») de LEMANIK SICAV (la «Sicav»), une société

d’investissement à capital variable, constituée conformément à la loi luxembourgeoise, ont décidé et approuvé, par la
signature de la présente résolution, les points suivants:

Attendu que le Conseil a été informé de la démission de M. Yves Bayle comme administrateur de la Sicav avec effet

au 19 février 2004.

Attendu que le Conseil a également été informé de la démission de M. Philippe Meloni comme administrateur de la

Sicav avec effet au 16 avril 2004.

Attendu que le Conseil a décidé de coopter M. Pietro Tasca, CEO de GESTNORD FONDI SGR S.p.A. et M. Jean

Louis Catrysse, Directeur-Adjoint d’IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme administrateurs de la Sicav.

Conformément à ce qui a été précédemment cité, le Conseil décide à l’unanimité:
A. Après avoir noté que M. Pietro Tasca, CEO de GESTNORD FONDI SGR S.p.A. a déjà été approuvé par l’autorité

de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

de coopter M. Pietro Tasca, CEO de GESTNORD FONDI SGR S.p.A. comme administrateur de la Sicav en rempla-

cement de M. Yves Bayle, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Sicav, assemblée qui décidera
de sa nomination définitive.

B. Après avoir noté que M. Jean Louis Catrysse, Directeur-Adjoint d’IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

a déjà été approuvé par l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

de coopter M. Jean Louis Catrysse, Directeur-Adjoint d’IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme ad-

ministrateur de la Sicav en remplacement de Monsieur Philippe Meloni, jusqu’à la prochaine assemblée générale des ac-
tionnaires de la Sicav, assemblée qui décidera de sa nomination définitive.

<i>Circular resolution of the board of directors

The undersigned, being all the members of the board of directors (hereinafter the «Board») of LEMANIK SICAV

(hereinafter the «Sicav»), a société d’investissement à capital variable, created under Luxembourg law, hereby unani-
mously consent and agree, by signing this written resolution, to the following:

Whereas the Board has been informed of the resignation of Mr Yves Bayle as director of the Sicav with effect as of

19 February 2004.

Whereas the Board has also been informed of the resignation of Philippe Meloni as director of the Sicav with effect

as of 16 April 2004.

Whereas the Board decided to co-opt Mr Pietro Tasca, Chief Executive Officer, GESTNORD FONDI and Mr Jean

Louis Catrysse, First Vice President, IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. as directors of the Sicav.

Having carefully considered the above, the board unanimously resolves:
A. After having noted that Mr Pietro Tasca, Chief Executive Officer, GESTNORD FONDI has already been approved

by the Luxembourg Supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier,

to co-opt Mr Pietro Tasca, Chief Executive Officer, GESTNORD FONDI as director of the Sicav in replacement of

Mr Yves Bayle, until the next general meeting of shareholders of the Sicav, which meeting shall make the permanent
appointment.

B. After having noted that Mr Jean Louis Catrysse, First Vice President, IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG

S.A. has already been approved by the Luxembourg Supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur
Financier,

<i>Pour HOLMBURY LUX. INVESTMENTS 1, S.à r.l.
C. Smith
<i>Gérant

IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. / C. Sagramoso / C. Camperio Ciani / G. Sagramoso
<i>- / Président / Administrateur / Administrateur
Signature / - / - / - 

62973

to co-opt Mr Jean Louis Catrysse, First Vice President, IBL, INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. as director

of the Sicav in replacement of Mr Philippe Meloni, until the next general meeting of shareholders of the Sicav, which
meeting shall make the permanent appointment.

On 26 May, 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05319. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085541.3/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

SOPC FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.211. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05592, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

(086434.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SOPC FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.211. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 7 juin 2004 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat d’administrateur de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus

et de la société COSAFIN S.A. et le mandat du commissaire aux comptes, EURAUDIT, S.à r.l.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086353.3/1172/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

BM DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 96.817. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06170, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087151.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

BANQUE HAPOALIM SUISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.475. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02073, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(087191.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

C. Sagramoso / C. Camperio Ciani / G. Sagramoso
<i>Chairman / Director / Director

FIDUPAR
Signatures

Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Son mandataire

62974

EUROWATT, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 48.019. 

Les statuts coordonnés au 20 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2004, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087144.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

EUROWATT, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 48.019. 

Les statuts coordonnés au 8 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2004, ont été déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087147.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

CONSEIL &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7260 Bereldange, 16, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 58.546. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06171, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087173.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

EURO CONCEPT MAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4033 Esch-sur-Alzette, 30, rue Nic Biever.

R. C. Luxembourg B 66.815. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06169, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087176.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

MHI CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8013 Strassen, 14, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 88.914. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06166, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087180.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

LA TABATHEQUE S.A., Sociéte Anonyme.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.-P. Bausch.

R. C. Luxembourg B 29.827. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06164, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087186.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature.

62975

MASERATI CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg F 736. 

STATUTS

1- Dénomination et Siège

Il est formé une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et

les établissements d’utilité publique telle qu’elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984, du 4 mars 1994 et du 19
décembre 2002, régie par les présents statuts, sous la dénomination de:

MASERATI CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l.
L’Association a son siège à Luxembourg.
L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre. 

2- Objet et Durée

L’Association a pour objet: de promouvoir l’image de la marque automobile MASERATI et de réunir tous les pro-

priétaires et détenteurs de voitures MASERATI, d’organiser des réunions et manifestations sportives et culturelles, tant
sur le plan national qu’international. Sa durée est illimitée.

3- Membres

Peut être admis comme membre, tout propriétaire ou détenteur d’une voiture MASERATI, parrainé par un membre

du conseil d’administration et par un membre de l’A.s.b.l. qui en fait la demande au Conseil d’Administration lequel sta-
tue sur cette candidature à la majorité simple.

Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services significatifs à l’association. Ils sont nommés par le Conseil

d’Administration, et ont les mêmes droits que les membres actifs et sont exonérés de cotisation à vie.

Les cotisations annuelles pour membres actifs sont fixées chaque année par l’Assemblée Générale. La cotisation an-

nuelle ne saura excéder 700 Euros.

La qualité de membre se perd:
- par la démission adressée par écrit au Conseil d’Administration.
- par le non-paiement de la cotisation avant le 1

er

 mai de l’exercice en cours.

- par l’exclusion prononcée par l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents sur propo-

sition du Conseil d’Administration.

- par le fait de ne plus être propriétaire ou détenteur d’une voiture MASERATI pendant 12 mois consécutifs.
Le membre sortant ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement de ses coti-

sations.

4- L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale ordinaire se réunira une fois par an au cours du 1

er

 trimestre, toute convocation à l’Assemblée

Générale est portée à la connaissance des membres 15 jours avant la réunion avec indication de l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire est régulièrement constituée si un tiers des membres est présent

ou représenté. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le vote par procuration est admis.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. II est rendu compte de l’exercice écoulé et de la si-
tuation financière. L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice écoulé et propose le budget de l’exercice
à venir. Elle procède aux élections prévues par les statuts et aux modifications éventuelles des statuts. Elle désignera
deux commissaires aux comptes.

5- Le Conseil d’Administration

L’association est gérée par un Conseil d’Administration comprenant au moins cinq et au plus neuf membres, élus par

l’Assemblée Générale pour une durée de 2 ans.

Les mandats sont renouvelables. Les administrateurs désignent entre eux, le président, le vice-président, le secrétaire

et le trésorier.

Le Conseil d’Administration peut déléguer, mais sous sa propre responsabilité, les pouvoirs qu’il juge opportuns à

tous employés ou tiers.

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’exigent les intérêts de l’association sur convocation du pré-

sident ou de trois de ses membres.

Le Conseil d’Administration pourra convoquer une Assemblée Générale extraordinaire chaque fois qu’il le jugera uti-

le ou nécessaire. A la suite d’une demande écrite de la part d’un cinquième des membres, le Conseil d’Administration
doit convoquer dans le délai d’un mois une Assemblée Générale extraordinaire en portant à l’ordre du jour le motif de
la demande.

L’association est engagée en toutes circonstances par la signature du président ou, en cas d’empêchement par celle

conjointe, du vice-président et d’un autre membre du Conseil d’Administration ainsi que par toute autre personne spé-
cialement mandatée par le Conseil d’Administration, lequel peut instituer, pour la gestion journalière, un bureau, sous
sa propre responsabilité.

Les président, vice-président, secrétaire et trésorier sont élus pour un mandat de deux années. Les président et se-

crétaire sont d’office démissionnaires et rééligibles lors de l’Assemblée Générale ordinaire des années paires, les vice-
président et trésorier lors de l’Assemblée Générale ordinaire des années impaires.

62976

6- Rémunération

Les membres du Conseil d’Administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs et après accord

du Président et du trésorier de l’association. Toute autre activité exercée par une personne au nom de l’association
sera considérée comme du bénévolat, une charte sera établie, par le Président, signée par celui-ci et le ou la bénévole.

Les personnes qui auront un statut d’employé privé percevront une rémunération mensuelle et bénéficieront d’un

contrat à durée indéterminée.

7- Dissolution

En cas de dissolution de l’association, l’actif subsistant après extinction du passif, sera versé à une association à but

similaire.

8- Règlement d’ordre intérieur

Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur établi par le bureau et approuvé par l’assem-

blée générale pour fixer les modalités d’exécution des présents statuts. Il s’imposera à tous les membres de l’association
en contrepartie d’une signature de leur part.

Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée sont applicables pour tous les cas non prévus par les

présents statuts.

9- Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice prend effet en date des présentes et se termine le 31.12.2005 

10- Assemblée Constitutive

Les fondateurs préqualifiés se sont ensuite réunis en Assemblée Générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des

voix les décisions suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq. 

<i>Sont élus administrateurs: 

1) Monsieur de Watazzi Alexis - Président
Directeur Marketing MASERATI 
59, Val Ste Croix L-1371 Luxembourg 
Nationalité: Luxembourgeoise 

 2) Monsieur Schlesser Carlo - Vice Président
Expert-Comptable
72, rue Dr. Joseph Peffer L-2319 Howald
Nationalité: Luxembourgeoise

3) Monsieur Fioravanzo Alessandro - Trésorier
Coordinateur Garage MASERATI
4 Beiderbrech L-6180 Gonderange 
Nationalité: Italienne 

 4) Madame Fioravanzo-Bertoli Patricia
 Secrétaire Général - Directrice Garage Maserati
4 Beiderbrech L-6180 Gonderange
Nationalité: Italienne

5) Monsieur Bertoli Franco - Administrateur
 Pensionné
4 Beiderbrech L-6180 Gonderange
 Nationalité: Italienne

Il. Le siège social de l’association est établi à L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01433. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084265.3/000/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

International Finance Corporation S.A.

Kodiak

Kowac S.A.

Sigma CAPITAL Energy Holding Company S.A.

Betam International S.A.

Giori S.A.

Giori S.A.

Giori S.A.

Aggreko Luxembourg, S.à r.l.

Solex Holding S.A.

Baltic Ace Investments S.A.

Man RMF Investments Sicav

Obelisque S.A.

Obelisque S.A.

Bimmo Holding S.A.

Bimmo Holding S.A.

Parmeria S.A.

VWR International Europe, S.à r.l.

Altea Europe S.A.

Altea Europe S.A.

Altea Europe S.A.

Altea Europe S.A.

Agrati International S.A.

Agrati International S.A.

Sadirac S.A.

Sadirac S.A.

Quadrifoglio S.A.

Quadrifoglio S.A.

Lemanik Private Equity Fund

Nareco, S.à r.l.

Nareco, S.à r.l.

Corolle Holding, S.à r.l.

Aggreko Luxembourg Management, S.à r.l.

Guarantee International S.A.

Guarantee International S.A.

Sigma Capital Energy Investments S.A.

Broderinvest S.A.

Broderinvest S.A.

Univex Holding S.A.

Kumna, S.à r.l.

Kumna, S.à r.l.

Kumna, S.à r.l.

Baldi Holding S.A.

Sodefi S.A.

Sodefi S.A.

Phantex Holding S.A.

Luxriver S.A.

JLM Patrimoine, S.à r.l.

JLM Patrimoine, S.à r.l.

Holdex Holding S.A.

Blendo S.A.

Sofinaca S.A.

Sofinaca S.A.

Fondex Holding S.A.

Didy Holding S.A.

LT Andersson Communications (Luxembourg), S.à r.l.

LT Andersson Communications (Luxembourg), S.à r.l.

Parbat Finance S.A.

SOICA S.A.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Polychem International S.A.

Polychem International S.A.

Poudrerie de Luxembourg S.A.

Noël Pons, S.à r.l.

Holmbury Luxembourg Participations 1, S.à r.l.

Holmbury Luxembourg Participations 1, S.à r.l.

Nomex Holding S.A.

Nanterre G, S.à r.l.

Compu Holding S.A.

Compu Holding S.A.

Intertrust Dom S.A.

Intertrust Dom S.A.

Holmbury Luxembourg Investments 1, S.à r.l.

Holmbury Luxembourg Investments 1, S.à r.l.

Lemanik Sicav

S.O.P.C. Finance (Luxembourg) S.A.

SOPC Finance (Luxembourg) S.A.

BM Diffusion, S.à r.l.

Banque Hapoalim Suisse S.A.

Eurowatt, S.à r.l.

Eurowatt, S.à r.l.

Conseil &amp; Management S.A.

Euro Concept Mag S.A.

MHI Consulting, S.à r.l.

La Tabathèque S.A.

Maserati Club Luxembourg, A.s.b.l.