This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
51505
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1074
26 octobre 2004
S O M M A I R E
Abilène S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51552
Immobauwerke S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
51542
AD Consulting International, S.à r.l., Helmsange . .
51533
Kiwi II Management Company S.A., Luxembourg
51535
Anine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51530
Landesbank Saar Girozentrale, Luxembourg . . . .
51547
AP HMGT Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
51548
Lilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51551
Axafil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51551
Lionsgate Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
51550
Baluiki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51544
Lusana Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
51548
Banbury Cross DC1, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . .
51541
Lysandre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51541
Barfi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51533
Mobility International Holding S.A., Luxembourg
51546
BDO Compagnie Fiduciaire S.A., Luxembourg . . .
51547
Morgan Stanley Asset Management S.A., Sennin-
Bolero International Holding S.A., Luxembourg . .
51547
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51551
C.I.P.A.F. S.A., Compagnie Internationale de Par-
Murfet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51543
ticipations Bancaires et Financières, Luxem-
Omnion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51535
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51541
Paczowski et Fritsch Architectes, S.à r.l., Luxem-
Cadimex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51526
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51549
Caves Bernard-Massard S.A., Grevenmacher . . . . .
51547
Parimmo Lux Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
51536
Clavita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51549
Pars Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51551
Corvin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51549
Porto F. Investment & Participation S.A., Luxem-
Dax Investments S.A. Holding, Luxembourg . . . . .
51552
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51527
Devana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51537
Privilège Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51549
Douglas & Bix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51546
Quadriga Superfund, Sicav, Senningerberg . . . . . .
51506
Euro Les Tours, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . .
51540
Roermond Holding (No. 1), S.à r.l., Luxembourg .
51546
Exclusive Automobiles S.A., Windhof . . . . . . . . . . .
51549
Roermond Holding (No. 3), S.à r.l., Luxembourg .
51547
Feu d’Artifice André S.A., Reckange/Mersch . . . . .
51530
Rofa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51543
Figemo S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51550
RQ Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
51526
Financière des Alpes S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
51532
SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxem-
Finaxia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51552
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51552
Glendorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51529
Security Capital European Services S.A., Luxem-
Glover International Investments S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51551
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51540
Showtime Int., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
51548
Hellaby S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51541
Sonic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51548
Hesperkutsch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51539
SQHEX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51540
I-Corp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51550
Sutton B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51540
I.V.B. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51543
Tonon International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
51550
Ifies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51542
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., Lu-
Immo AL35/37, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51543
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51537
Immo PDP2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51543
World Business Technology W.B.T. S.A., Luxem-
Immo PDP4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51546
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51546
Immobauwerke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51542
World Fashion International S.A., Luxembourg . .
51544
Immobauwerke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51542
Zidcom Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
51527
Immobauwerke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51542
51506
QUADRIGA SUPERFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST).
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 54.921.
—
In the year two thousand four, on the eleventh of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED
TRUST (the «Company»), having its registered office in Senningerberg.
The Company was incorporated by a deed before Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg on May
20th, 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of June 28th, 1996, number 316 and
amended for the last time by a deed of Maître Edmond Schroeder, notary former residing in Mersch, on October 22,
2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of December 7, 2001, number 1129.
The meeting was presided by Mr Emmanuel Begat, private employee, professionally residing in Senningerberg.
The chairman appointed as secretary Mr Jorge Fernandes, private employee, professionally residing in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sylvie Becker, private employee, professionally residing in Senningerberg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The agenda of this extraordinary meeting is the following:
«Decision of the amendments of the Articles of Incorporation in order to:
1. change the name of the Company to QUADRIGA SUPERFUND SICAV, and subsequent amendment of Article 1;
2. replace any reference to the law of March 30, 1988 by a reference to the law of December 20, 2002 and subsequent
amendment of article 3;
3. amend the description of the investment possibilities by extending the investment scope of the Company and sub-
sequent amendment of article 3;
4. delete any reference to the Luxembourg Francs by replacing it by a reference to the Euro and subsequent amend-
ment of article 5;
5. integrate in the articles of incorporation the possibility to issue within each sub-fund different «classes» of shares
and subsequent amendment of the articles 5, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 28 and 29;
6. allow the Company to issue fractions of shares and subsequent amendment of articles 6;
7. delete the sentence «A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorized officer» and subse-
quent amendment of article 11;
8. add the possibility that a board meeting may be convened «by similar mean of communication» and subsequent
amendment of article 14;
9. amend the provisions concerning the suspension of redemption requests in order to render these provisions more
broad and in order to delete any reference to a time limit and subsequent amendment of article 21;
10. amend the period within which the redemption price has to be paid from five bank business days to 45 Luxem-
bourg bank business days and subsequent amendment of article 21;
11. define a bank holiday in Luxembourg as a full or half holiday and subsequent amendment of Article 22;
12. define the valuation criteria’s for units of other investment funds and amend the valuation criteria’s for derivatives,
redefine the description of operational expenses under point B. (b), foresee the establishment of a pools of assets and
subsequent amendment of article 23;
13. amend the period within which the issue price has to be paid from four to ten bank business days, foresee a pro-
vision enabling the Board of Directors to impose restrictions on the frequency at which shares may be issued and sub-
sequent amendment of article 24;
14. reformulate Article 28 concerning the dissolution of the Company, the termination and merger of Sub-Funds
15. insert a heading for the various articles
16. redraft completely the articles of incorporation in accordance with above mentioned agenda points.»
II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-
tendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
III.- The present meeting has been convened by notices containing the agenda and published:
- in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the:
13th and 27th of September 2004,
- in the «Luxemburger Wort», on the:
13th and 27th of September 2004;
- in the Tageblatt, on the:
13th and 27th of September 2004
- in the «Der Standart» (in Austria), on the:
13th and 27th of September 2004;
IV.- It appears from the attendance list that out of 339,902.979 shares, 10,608.019 shares are present or represented
at the present extraordinary general meeting.
A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as
the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on the 9th September 2004 and could not validly de-
cide on the items of the agenda for lack of the legal quorum.
51507
According to articles 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorized to take
resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the name of the Company to QUADRIGA SUPERFUND SICAV, and subsequent to
amend Article 1.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to replace any reference to the law of March 30, 1988 by a reference to the law of December
20, 2002 and subsequent amendment of article 3.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to amend the description of the investment possibilities by extending the investment scope of
the Company and subsequent amendment of article 3.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to delete any reference to the Luxembourg Francs by replacing it by a reference to the Euro
and subsequent amendment of article 5.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to integrate in the articles of incorporation the possibility to issue within each sub-fund different
«classes» of shares and subsequent amendment of the articles 5, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 28 and 29;
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to allow the Company to issue fractions of shares and subsequent amendment of articles 6.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting decides to delete the sentence «A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorized
officer» and subsequent amendment of article 11.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting decides to add the possibility that a board meeting may be convened «by similar mean of communica-
tion» and subsequent amendment of article 14.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting decides to amend the provisions concerning the suspension of redemption requests in order to render
these provisions more broad and in order to delete any reference to a time limit and subsequent amendment of article
21.
<i>Tenth resolutioni>
The meeting decides to amend the period within which the redemption price has to be paid from five bank business
days to 45 Luxembourg bank business days and subsequent amendment of article 21;
<i>Eleventh resolutioni>
The meeting decides to define a bank holiday in Luxembourg as a full or half holiday and subsequent amendment of
Article 22;
<i>Twelfth resolutioni>
The meeting decides to define the valuation criteria’s for units of other investment funds and amend the valuation
criteria’s for derivatives, redefine the description of operational expenses under point B. (b), foresee the establishment
of a pools of assets and subsequent amendment of article 23.
<i>Thirteenth resolutioni>
The meeting decides to amend the period within which the issue price has to be paid from four to ten bank business
days, foresee a provision enabling the Board of Directors to impose restrictions on the frequency at which shares may
be issued and subsequent amendment of article 24;
<i>Fourteenth resolutioni>
The meeting decides to reformulate Article 28 concerning the dissolution of the Company, the termination and merg-
er of Sub-Funds.
<i>Fifteenth resolutioni>
The meeting decides to insert a heading for the various articles.
<i>Sixteenth resolutioni>
The meeting decides to redraft completely the articles of incorporation in accordance with above mentioned agenda
points, which are now as follows:
Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a Company in
the form of a limited company («société anonyme») qualifying as a société d’investissement à capital variable («Sicav»)
under the name of QUADRIGA SUPERFUND SICAV.
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
51508
Art. 3. Purpose. The exclusive object of the Company is to place the funds available in futures on commodities or
financial instruments, in options, in units or shares of other undertakings for collective investments (UCI’s), in securities,
currencies or any other financial assets permitted by law with the purpose of spreading investment risk and affording its
shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company takes any measures and carries out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of December 20, 2002, regarding collective in-
vestment undertakings or any legislative replacements or amendments thereof (the «Law»).
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established at Senningerberg, in the Grand
Duchy of Luxembourg. Branches or other office may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the Board of Directors (the «Board»).
In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent
that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communica-
tion between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the com-
plete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall, be represented by shares of no par
value (the «Shares») and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined hereafter.
The minimum capital of the Company shall be not less than the equivalent in Dollars of the United States of America
(«USD») of one million two hundred and fifty thousand euro (1,250,000.- EUR).
The Board is authorised without limitation to issue Shares at any time at an issue price per Share (the «Issue Price»)
of the relevant Sub-Fund, as defined in Article 24, without reserving the existing shareholders a preferential right to
subscription to the shares to be issued.
The Board may delegate to any duly authorized director of the Company (a «Director») or officer of the Company
or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for
such shares.
Such new shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Sub-Funds (hereinafter referred to
as the («Sub-Funds») and the proceeds of the issue of each Sub-Fund of shares shall be invested, pursuant to Article 3
hereof, in securities or other assets such as futures corresponding to such geographical areas, industrial sectors or mon-
etary zones, or to such specific types of derivatives instruments, as the Board of Directors shall from time to time de-
termine in respect of each Sub-Fund.
The Board may further decide to create within each Sub-Fund of Shares two or more classes whose assets will be
commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a specific sales and
redemption charge structure, fee structure, hedging policy or other specificity is applied to each class. In these Articles,
any reference to «Sub-Fund» shall also mean a reference to «class» unless the context otherwise requires.
The Board of Directors may reduce the capital of the Company by closing one or several Sub-Funds: the shares of
the respective Sub-Fund shall be cancelled and the value of such shares shall be refunded to the shareholders of such
Sub-Fund.
Art. 6. Form of Shares. The Director shall issue Shares in registered or bearer form at the option of the Share-
holders in respect of each Sub-Fund. If a bearer shareholder requests the exchange into registered Shares, no cost will
be charged to him in relation to such exchange. Registered shares will be issued in non-certificated or certificated form.
Unless investors specify to the contrary they will receive non-certificated shares. Bearer shares will be represented by
global certificates which may be deposited in clearing systems such as CLEARSTREAM or EUROCLEAR.
Share certificates shall be signed by two Directors or by a Director and an official duly authorised by the Board for
such purpose. Signatures of the Directors may be either manual or printed or by facsimile. The signature of the author-
ised official shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board may from
time to time determine.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in
Article 24 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive Share certificates or, subject as
aforesaid, a confirmation of his shareholding.
Payments of dividends, if any, will be made in respect of registered Shares, to the holders of Shares, at their mandated
addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Directors in writing.
All issued Shares of the Company other than bearer Shares shall be recorded in the Register of Shareholders, which
shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register shall
contain the name of each holder of registered Shares, his residence or elected domicile so far as notified to, the Com-
pany and the number of Shares held by him in the respective Sub-Fund. Every transfer of a Share other than a bearer
Share shall be entered in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved
by the Directors for registering any other document relating to or affecting the title to any Share.
The Company shall be free of all responsibility or liability to third parties in dealing with such Shares and shall be
justified in considering any right, interest or claim of any other person in or upon such Shares to be non-existing, pro-
vided that the foregoing shall deprive no person of any right which it might properly have to demand the registration to
a change in the registration of registered Shares.
Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.
Transfer of bearer Shares shall be effected by delivery of the relevant bearer Share certificates or Certificate repre-
senting them and if applicable with all unmatured coupons attached thereto. Transfer of registered Shares shall be ef-
51509
fected by way of a notice of the transfer to be entered in the Register of Shareholders of the Company by such
shareholder, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.
Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint hold-
ers of Shares, only one address will be inserted and any notice will be sent to that address only.
In the event that the shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to
be entered in the Register of Shareholders and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office
of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered
in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such
other address as may be set by the Company from time to time.
The Company may decide to issue fractional Shares. Such fractional Shares shall not be entitled to vote but shall be
entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund on a pro rata basis.
Art. 7. Mislaid or destroyed Shares certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Com-
pany that his Share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicata Share certificate
may be issued under such conditions and guarantees, as the Company may determine. At the issuance of the new Share
certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one
has been issued shall become void.
The Company may, at its election, charge the shareholder any exceptional out-of-pocket expenses incurred in issuing
a duplicate or a new Share certificate in substitution for one mislaid, mutilated or destroyed.
Art. 8. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of Shares
by any person, firm or corporate body, namely any person in breach of any law or requirement of any country or gov-
ernmental authority and any person which is not qualified to hold such shares by virtue of such law or requirement or
if, as a result of the person owning such Shares the Company would suffer taxation or other pecuniary disadvantage
which it would not otherwise do or, if the Board so decides and discloses in the current prospectus hereof, a United
States Person as defined hereinafter (all together defined as «Restricted Person») and for such purpose the Company
may:
(a) decline to issue any Share or to register any transfer of Shares where it appears to it that such issue or registry
would or might result in beneficial ownership of such Shares by a Restricted Person, and
(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares
on, the Register to furnish it with any information which it may consider necessary for the purpose of determining
whether or not beneficial ownership of such shareholder’s Shares rests or will rest in a Restricted Person, and
(c) where it appears to the Company that any Restricted Person, either alone or in conjunction with any other per-
son, is a beneficial owner of Shares, compulsorily redeem from such shareholder all Shares held by him in the following
manner:
1. The Company shall serve a notice (hereinafter called the «Purchase Notice») upon the shareholder appearing in
the Register as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased as aforesaid, the price
to be paid for such Shares, and the place where the purchase price in respect of such Shares is payable. Any such notice
may be served upon such shareholders by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to the share-
holder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the Company the Certificate or Certificates, if any, relating to the Shares specified in
the Purchase Notice. Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Share-
holder shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice and his name shall be removed from the Reg-
ister.
2. The price at which the Shares specified in any Purchase Notice shall be purchased (herein called «the Purchase
Price») shall be an amount equal to the per Share Net Asset Value, determined in accordance with Article 23 hereof.
3. Payment of the Purchase Price will be made to the owner of such Shares in the reference currency of the respective
Sub-Fund, except during periods of currency exchange restrictions with respect thereto, and will be deposited by the
Company in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Purchase Notice) for payment to such owner upon surrender
of the Certificate(s), if any issued, relating to the Shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid
no person interested in the Shares specified in such Purchase Notice shall have any further interest in such Shares or
any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the person appearing
as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) upon effective surrender of the Certificate or
Certificates, if issued, as aforesaid.
4. The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true own-
ership of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase Notice, provided that
in such case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
(d) decline to accept the vote of any Restricted Person at any meeting of shareholders of the Company.
Whenever used in these Articles, the term «United States Person» or «U.S. Person» shall mean a citizen or resident
of the United States of America, a partnership organised or existing in any state, territory or possession of the United
States of America, a corporation organised under the laws of the United States of America or of any state, territory or
possession thereof, or any estate or trust.
Art. 9. General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Com-
pany or of a Sub-Fund represents the entire body, of shareholders of the Company or of the shareholders of a Sub-Fund
51510
as the case may be. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company or of the relevant Sub-Fund.
It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 10. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with
Luxembourg law, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in
the notice of meeting, at the first Monday in May at 11.00 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg the
annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual meeting may
be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 11. Quorum and delays. The quorums and delays required by law shall govern the notice for and conduct of
the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any
meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax
message.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present and voting.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any
meeting of shareholders.
As long as the share capital is divided into different Sub-Funds, any resolution of the general meeting of shareholders
of the Company, affecting the rights of the holders of shares of any Sub-Fund vis-à-vis the rights of the holders of shares
of any other Sub-Fund, shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such Sub-Fund or Sub-
Funds in compliance with Article 68 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. This provision
does apply mutatis mutandis to classes of shares.
Art. 12. Convening notices. Shareholders will meet upon call by the Board, pursuant to a notice setting forth the
agenda, sent at least 8 days prior to the meeting to each shareholders at the shareholders’ address in the Register of
Shareholders, provided the Company shall not be bound to evidence the accomplishment of such notice, if the conven-
ing notice is as well published in accordance with Luxembourg law.
As long as bearer Shares are in issue notice shall, in addition, be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, in a Luxembourg newspaper and in such other newspaper as the Board may decide.
However, if all shareholders are present or represented at a shareholders meeting and if they declare themselves to
be fully informed of its agenda, the meeting may be held without notice or publicity having been given or made.
Art. 13. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board composed of not less than three mem-
bers; members of the Board need not be shareholders of the Company.
Subject as provided below, the directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, for a period ending
at the next annual general meeting and until their successors are elected and have accepted such appointment or, if later,
ending at the date of such election and acceptance, provided, however, that a director may be removed with or without
cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the event of a vacancy in the office of
director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect by way of co-
optation, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 14. Board Meetings. The Board may choose from among its members a chairman, and may choose from
among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not be a Director, who shall
be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon
call by any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
If a chairman is appointed, he shall preside over all meetings of shareholders and at the Board, but failing a chairman
or in his absence the shareholders or the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the ma-
jority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the hour
set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the notice of meeting.
This notice may be waived by the consent in writing by cable, telegram, telex or telefax or any such similar mean of
communication of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, telefax or any
such similar mean of communication another Director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by
cable, telegram, telex, telefax message or any such similar mean of communication.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of Directors are present (which may be by the way
of a conference telephone call) or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the
votes of the Directors present or represented at such meeting. The elected chairman shall have a casting vote.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms which may be
signed on one or more counterparts by telex, telegram or fax message (in each such case confirmed in writing) by all
the Directors.
51511
The Board may from time to time appoint the officers of the Company, including a General Manager, a secretary, and
any assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Company.
Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors or shareholders of the
Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given
them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any com-
mittee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as its thinks fit.
Art. 15. Board Minutes. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by any person who presided over
such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two Directors.
Art. 16. Power of the Board of Directors. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present
Articles to the meeting of the shareholders are in the competence of the Board.
The Board shall have the power to do all things on behalf of the Company which are not expressly reserved to the
shareholders in general meeting by these Articles and shall, without limiting the generality of the aforegoing, have the
power to determine the corporate and investment policy for investments based on the principle of spreading of risks,
subject to such investment restrictions as may be imposed by the Law or by regulations or as described in any prospec-
tus relating to the offer of shares.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board, acting under the supervision of the Board.
Art. 17. Personal Interest. No contract or other transaction between the Company and any other Company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company are
interested in, or is a Director, associates, officers or employees of such other company or firm. Any Director or officer
of the Company who serves as a Director, officer or employee of any company or finn with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not by reason of such affiliation with such other company or firm but
subject as hereinafter provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.
In the event any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Com-
pany, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on
any such transaction, and such transaction, and such Director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders.
The term «personal interest», as used in the preceding subparagraph, shall not include any relationship with or inter-
est in any matter, position or transaction involving the asset manager, the asset administrator, the asset advisor or any
subsidiary thereof, or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board at its
discretion.
Art. 18. Indemnification of the Directors. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs,
executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or pro-
ceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company
or, at its request of any other company of which the Company is a shareholder or creditor or from which he is not
entitled to be indemnified. Such person shall be indemnified in all circumstances, except in relation to matters as to
which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 19. Power of signature. The Company will be bound by the joint signatures of any two Directors of which
one must be a representative of BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. and the other one being a representative
of QUADRIGA ASSET MANAGEMENT Ges.m.b.H.
Art. 20. Auditor. The general meeting of shareholders of the Company shall appoint an auditor, («réviseur d’en-
treprises agréé») who shall carry out the duties prescribed by the Law.
Art. 21. Redemption of Shares. Any shareholder may at any time ask for the redemption of his shares.
As more specifically stated hereinbelow, the Company has the power to redeem its own Shares at any time within
the sole limitations set forth by law. The redemption price of each share is equal to the net asset value per share of the
respective class within each Sub-Fund as determined by the Company.
Any redemption request having as a consequence that the total holding of a shareholder falls below the minimum
such as may be decided by the Board of Directors for any class or any Sub-Fund will be treated as a redemption request
for the total holding of that investor.
Any shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company, provided that the Company
shall not be bound to redeem on any Valuation Date (as hereafter defined) more than a certain percentage as deter-
mined by the Board of Directors in relation to the number of shares in issue in a specific Sub-Fund. Such redemption
51512
requests may be deferred for a period and in a manner that the Board of Directors considers to be in the best interest
of the Company.
Such limitation will apply to all shareholders having tendered their shares in such Sub-Fund for redemption on such
valuation date pro rata of the shares in such Sub-Fund tendered by them for redemption.
For this purpose conversions are considered as redemptions.
The Redemptions Price shall be paid within a period as determined by the Board of Directors which shall not exceed
45 Luxembourg bank business days after the relevant Valuation Date or on the date the share certificates (if issued)
have been received by the Company, if later, and shall be based on the Net Asset Value per Share determined in ac-
cordance with the provisions of Article 23 hereof less a redemption charge as may be decided by the Board from time
to time.
If in exceptional circumstances the liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of the shares of a Sub-
Fund being redeemed is not sufficient to enable the payment to be made within such a period, such payment shall be
made as soon as reasonably practicable thereafter, but without interest.
Any such request must be filed or confirmed by such shareholder in written form at the registered office of the Com-
pany in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of Shares.
The certificates if issued, for such Shares in proper form and accompanied by proper evidence of transfer or assignment
must be received by the Company or its agent appointed for that purpose before the Redemption Price may be paid.
Shares redeemed by the Company shall be cancelled.
Art. 22. Suspension of the Calculation of the Net Asset Value. The net asset value per Share (the «Net Asset
Value») and the Issue and Redemption Prices of Shares of any class within a Sub-Fund shall be determined by the Com-
pany not less than once monthly, as the Board by resolution may direct (every such day or time for determination there-
of being referred to herein as a «Valuation Date»), but so that no day observed as a full or half holiday by banks in
Luxembourg be a Valuation Date.
The Company may suspend the determination of the Net Asset Value, and the issue, redemption and conversion of
the Shares of any Sub-Fund:
(a) during any period when any market or stock exchange, on which a substantial portion of a Sub-Fund’s investments
are quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings are restricted or sus-
pended; or
(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valua-
tion of the Company’s assets attributable to any Sub-Fund is not reasonably practical or without seriously prejudicing
the interest of the shareholders of the Company; or
(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of
any of the investments attributable to any Sub-Fund or the current prices on any market or stock exchange; or
(d) during any period when remittance of moneys which will or may be involved in the realisation of, or in the pay-
ment for, any of the investments attributable to any Sub-Fund is not possible or cannot be effected at normal prices or
rates or exchange; or
(e) during any period where in the opinion of the Directors there exist unusual circumstances where it would be
impracticable or unfair towards the shareholders to continue dealing with Shares of any Sub-Fund; or
(f) in case of a decision to liquidate the Company, on or after the day of publication of the first notice convening the
general meeting of shareholders for this purpose.
(g) upon the suspension of trading in accordance with article 27.
Shareholders having requested redemption of their Shares shall be notified of any such suspension and will be prompt-
ly notified of the termination of such suspension.
The suspension as to any Sub-Fund will have no effect on the calculation of Net Asset Value and the issue, conversion
and redemption of the Shares of any other Sub-Fund.
Art. 23. Calculation of the Net Asset Value. The Net Asset Value of each Share of any class within each Sub-
Fund shall be expressed in the relevant Dealing Currency of each Sub-Fund as a per Share figure and to the extend ap-
plicable within a Sub-Fund, expressed in the unit currency for the relevant class of shares within such Sub-Fund. It shall
be determined in respect of any Valuation Date by dividing the net assets attributable to this class within the Sub-Fund
less the liabilities attributable to the respective class within that Sub-Fund by the number of outstanding Shares in such
class.
The valuation of the Net Asset value of Shares within each Sub-Fund shall be made in the following manner:
A. The assets in each Sub-Fund of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash and cash equivalents in hand receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not collected);
(c) all securities, shares, bonds, debentures, options, subscription rights, warrants, the market value of all open posi-
tions and other investments and securities belonging to the Company;
(d) all units or shares of UCI including hedge funds,
(e) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company (the
Company may, however, adjust the valuation by fluctuations in the market value of securities due to trading practices
such as trading ex-dividends or ex-rights);
(f) all accrued interest on any interest-bearing securities held by the Company, except to the extent such interest is
comprised in the principal amount of such security;
(g) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such pre-
liminary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and
51513
(h) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses. The value of such assets shall be determined
as follows:
1. The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Directors may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof
2. Portfolio securities which are listed on an official stock exchange or traded on a regulated or organised market will
be determined on the basis of the last available price on which such securities are traded, as furnished by a pricing service
approved by the Directors. If such prices are not representative of their fair market value, such securities, as well as any
of the portfolio securities which are not so listed or traded will be valued on the reasonable foreseeable sales prices
determined prudently in good faith by and under the direction of the Directors;
3. Units or shares in undertakings for collective investments, including hedge funds, shall be valued on the basis of
their last determined and available net asset value (an official net asset value), or if such price is not representative of
the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Board of Directors on a fair and equitable
basis. If such an official net asset value is not available, such investments may be valued on an estimated net asset value
(i.e. which are not generally used for the purpose of subscription and redemption of shares) as provided by the relevant
administrator if more recent than the official net asset value, provided that the Directors have sufficient assurance that
the valuation method used by the relevant administrator for said estimated net asset value is coherent as compared to
the official one. If events have occurred which may have resulted in a material change in this estimated net asset value
since this last report date, the value of such investments may be adjusted in order to reflect in the reasonable opinion
of the Board of Directors such change.
4. The liquidating value of options and forwards contracts not traded on exchanges or on other regulated markets
shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of Directors, on a
basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options con-
tracts traded on exchanges or on other regulated markets shall be based upon the last available settlement prices of
these contracts on the relevant exchange and regulated market on which the particular contract is traded, provided that
if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the relevant Valuation Day, the basis for determining
the liquidating value of such contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable. Swaps
will be valued at their market value. The Directors may rely on confirmation from the principal broker and its affiliates
in determining the value of assets held for the Company’s account.
5. All other securities and other assets will be valued at their fair market value as determined in good faith pursuant
to the procedures established by the Board of Directors.
6. Any assets or liabilities in currencies other than the currency in which the net asset value of the relevant Sub-Fund
is expressed will be converted using the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination
of the Net Asset Value of Shares
The Directors, at their discretion, may permit some other method of valuation to be used if they consider that such
valuation better reflects the fair value of any asset. The Company’s income and expenses will be determined on an ac-
crual basis.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) all operational costs which shall include but are not limited to trading manager fees, trading administrator fees,
CTA fees, performance fees, fees and expenses payable to its auditors and accountants, Custodian and its correspond-
ents, Administration, Listing Agent, if any, paying agents and distributors, fees payable to permanent representatives in
such countries where the Company and/or its Sub-Funds are authorised for public offering, any other agent employed
by the Company, the remuneration of directors and officers of the Company and their reasonable out-of-pocket ex-
penses, insurance coverage and reasonable travelling costs in connection with board meetings, fees for legal and auditing
services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any gov-
ernmental agencies, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or pre-
paring and printing of Prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, taxes or government changes,
the cost of listing the Shares at any stock exchange or its quotation on another Regulated Market, the costs for the
publication of the issue and redemption prices and all other operating expenses, including the cost of buying and selling
assets, interest, bank charges, brokerage, postage, telephone and telex;
(c) all known liabilities due or not yet due, including the amount of dividends declared, if any, but unpaid;
(d) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves author-
ised and approved by the Directors; and
(e) all other liabilities of the Company of whatever kind due towards third parties.
(f) in the case where any liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund,
such liability shall be allocated to all the Sub-Funds pro rata to the net asset values of the Sub-Fund.
For the purposes of the valuation of its liabilities, the Company may duly take into account all administrative and other
expenses of a regular or periodical character by valuing them for the entire year or any other period and by dividing the
amount concerned proportionately for the relevant fractions of such period.
C. There shall be established a pool of assets for each class of Shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of Shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Company to the pool
of assets established for that Sub-Fund of Shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this Article;
51514
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same pool as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;
c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;
d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be equally divided between all the pools or, insofar as justified by the amounts, shall be
allocated to the pools pro rata to the Net Asset Values;
e) upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund of Shares, the Net Asset Value of such Sub-
Fund of Shares shall be reduced by the amount of such dividends.
If there have been created, as more fully described in Article 5 hereof, within the same Sub-Fund of Shares two or
several classes, the allocation rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to such classes.
E. For the purpose of valuation under this Article:
(a) Shares to be redeemed and to be issued shall be treated as existing and taken into account until immediately after
the closing of the Valuation on which the redemption or subscription order has been accepted and until paid or received
the price therefore shall be deemed to be a liability respectively a receivable of the Sub-Fund;
(b) effect shall be given on any Valuation date to any purchase or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Date, to the extent practicable.
Art. 24. Subscription of Shares. Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share
at which such Shares shall be offered and sold, shall be based on the Net Asset Value per Share of the relevant class
within each Sub-Fund, as hereinabove defined, increased by a subscription fee (if and to the extent the Directors so
decide) and any remuneration to agents active in the placing of the Shares shall be paid out of the sales charge (which
shall not exceed such amount as may be permitted by all applicable laws), added thereto. The price so determined (the
«Issue Price») shall be payable within a period as determined by the Directors which shall not exceed ten (10) bank
business days after the date on which the Shares were allotted.
The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of
shares; the Board of Directors may in particular decide that shares of any class shall be issued during one or more of-
fering periods, at such periodicity or up to a certain level as the Board may determine in respect of each Sub-Fund, as
provided in the sales documents of the Company.
The Issue Price may, upon approval of the Board, and subject to all applicable laws, namely with respect to a special
audit report confirming the value of any assets contributed in kind, be paid by contributing to the Company securities
acceptable to the Board, consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company.
Art. 25. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year
and shall terminate on the last day of December of the same year.
The accounts of the Company shall be expressed in USD.
Art. 26. Distributions. The meeting of shareholders of the relevant Sub-Funds shall, upon the proposal of the board
of directors in respect of Sub-Fund determine how the annual results shall be disposed of. The results of the Company
may be distributed, subject to the minimum capital of the Company as defined under Article 5 hereof being maintained.
Interim dividends may be paid out on the shares of any Sub-Fund upon decision of the board of directors.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant Sub-Fund is expressed or, excep-
tionally in such other currency as selected by the board of directors, and shall be paid at such places and times as may
be determined by the board of directors which may make a final determination of the rate of exchange applicable to
translate dividend funds into the currency of their payment.
The Board may also decide that there shall be issued, within the same Sub-Fund of Shares, two classes where one
class is represented by capitalization Shares and the second class is represented by dividend Shares. No dividends shall
be declared in respect of capitalization Shares issued as aforesaid.
Art. 27. Suspension of Trading. Issues, redemptions and conversions in respect of one Sub-Fund will be suspend-
ed as soon as Sub-Fund suffers trading losses which reduces its net asset value per share to less than 50% of its highest
previous net asset value per share. In such cases, all existing contracts and options will be liquidated and no further trad-
ing will occur until the date of the shareholders’ meeting referred to in the paragraph below.
In the event of a trading suspension as a result of the foregoing provision, all shareholders of the concerned Sub-Fund
will be convened within forty days following the suspension date to a separate Sub-Fund meeting to decide by a three
quarter majority vote of the outstanding shares of such Sub-Fund on the possible closing of such Sub-Fund or its merger
with another Sub-Fund. In the case of non-liquidation or merger of the Sub-Fund as a result of the shareholders’ decision,
the suspension will be lifted immediately.
Art. 28. Dissolution of the Company and Termination or Amalgamation of Sub-Funds. In the event of
dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers
and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each class within each Sub-Fund shall be dis-
tributed by the liquidators to the holders of Shares in proportion of their holding of shares in that Sub-Fund.
Amounts which would not have been claimed by shareholders at the close of liquidation will be deposited in escrow
at the Caisse et Consignations. Amounts not claimed from escrow within the limitation period would be liable to be
forfeited in accordance with the provisions of Luxembourg law.
51515
In the event that for any reason the value of the total net assets in any Sub-Fund or any class has decreased to, or
has not reached an amount as determined by the Board of Directors to be the minimum level of such Sub-Fund or class
or in case the Board of Directors deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting
a Sub-Fund, or as a matter of economic rationalization, the Board may, redeem all the shares of the relevant Sub-Fund
respectively class on the valuation day at which such decision shall take effect.
Under the same circumstances as provided in the paragraph above, the Board of Directors may decide to merge that
Sub-Fund, or class, with another Sub-Fund or class of the Company or with another Luxembourg undertaking for col-
lective investment (UCI).
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors in the preceding paragraph a termination of a Sub-
Fund, or class with compulsory redemption of all relevant shares or its merger with another Sub-Fund or class of the
Company or with another Luxembourg UCI, may in any other circumstances be decided upon, by the shareholders of
the Sub-Fund or class to be terminated or merged at a duly convened Sub-Fund or class meeting which may be validly
held without quorum and decide at a majority of 50 per cent of the shares present or represented.
A termination so decided by the Board of Directors or approved by the shareholders will be notified to shareholders
of the relevant Sub-Fund or class prior to the effective date for the compulsory redemption, which notification will in-
dicate the reasons of and the procedure for the redemption operations. The Company shall inform holders of the bearer
shares, if any, by publication of a notice in newspapers to be determined by the board unless all such shareholders and
their addresses are known to the Company. Unless it is otherwise decided in the interest of, or to keep equal treatment
between the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or the class concerned may continue to request redemp-
tion of their shares free of charge (but taking into account actual realization prices and expenses), prior to the date
effective for the compulsory redemption.
A merger so decided by the Board of Directors or approved by the shareholders of the relevant Sub-Fund or class
will be binding on the holders of shares of the relevant Sub-Fund or class upon thirty days’ prior notice thereof given
to them during which period shareholders may redeem their shares without redemption charge (but taking into account
actual realization prices and expenses), unless it is otherwise decided in the interests of the shareholders or to ensure
equal treatment of the shareholders. The Company shall inform holders of the bearer shares, if any, by publication of a
notice in newspapers to be determined by the board unless all such shareholders and their addresses are known to the
Company.
Any amounts not claimed by the shareholders at the termination of a Sub-Fund or a class will be deposited with the
custodian for a period not exceeding six months from the date of closing of the liquidation operations. After such period
the amounts will be deposited with the «Caisse des Consignations».
Art. 29. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from
time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of
Luxembourg.
Any amendment affecting the rights of the holders of Shares of any class vis-à-vis those of any other class shall be
subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant class.
Art. 30. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10th August, 1915 on commercial companies and amendments thereto and the Law.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-
ing persons, this deed is worded in English, followed by a German translation and that in case of any divergencies be-
tween the English and the German text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Follows the German version:
Im Jahre zweitausendvier, den elften Oktober.
Vor Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz zu Niederanven.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft QUADRIGA
GLOBAL CONSOLIDATED TRUST mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch
Notar André Schwachtgen, am 20. Mai 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Num-
mer 316 vom 28. Juni 1996, ein letztes Mal abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder,
mit damaligem Amtssitz in Mersch, am 22. Oktober 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1129 vom 7. Dezem-
ber 2001.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Emmanuel Begat, Privatbeamter, mit professioneller Adresse in Sennin-
gerberg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Jorge Fernandes, Privatbeamter, mit professioneller Adresse in Senningerberg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Sylvie Becker, Privatbeamtin, mit professioneller Adresse in Sennin-
gerberg.
Sodann gab der Vorsitzende die Tagesordnung mit folgendem Wortlaut bekannt:
I) Tagesordnung
Abstimmung über folgende Änderungen der Satzung um:
1. «den Namen der Gesellschaft auf QUADRIGA SUPERFUND SICAV zu ändern, und folglich Änderung von Artikel
1;
51516
2. jedwede Referenz auf das Gesetz vom 30. März 1988 durch eine Referenz auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002
zu ersetzen, und folglich Änderung von Artikel 3;
3. die Beschreibung der Anlagemöglichkeiten zu ändern durch Erweiterung des Anlagehorizonts der Gesellschaft und
folglich Änderung von Artikel 3;
4. jedwede Referenz auf den Luxemburger Franken zu streichen und durch eine Referenz auf den Euro zu ersetzen
und folglich Änderung von Artikel 5;
5. die Möglichkeit in der Satzung vorzusehen, um innerhalb eines jeden Teilfonds verschiedene Aktienklassen auszu-
geben und folglich Änderung der Artikel 5, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 28 und 29;
6. die Ausgabe von Aktienbruchteilen vorzusehen und folglich Änderung von Artikel 6;
7. den Satz zu streichen: «Eine Gesellschaft kann durch Unterschrift eines dazu befugten Amtsinhabers einen Stell-
vertreter ernennen.», und folglich Änderung von Artikel 11;
8. die Möglichkeit vorzusehen, dass Verwaltungsratssitzungen auch durch «ähnliche Kommunikationsmittel» einberu-
fen werden können und folglich Änderung von Artikel 14;
9. die Bestimmung betreffend die Aussetzung von Rücknahmeanträgen abzuändern um diese Bestimmung weiter zu
fassen und um jedwede Referenz auf eine Zeitperiode zu streichen und folglich Änderung von Artikel 21;
10. die Zeitfrist innerhalb welcher der Rücknahmepreis zu bezahlen ist von fünf Bankarbeitstagen auf 45 Luxemburger
Bankarbeitstage abzuändern und folglich Änderung von Artikel 21;
11. einen Luxemburger Bankarbeitstag als einen ganzen oder halben Feiertag zu definieren und folglich Änderung von
Artikel 22;
12. die Bewertungsgrundsätze für Anteile von anderen Anlagefonds zu definieren und die Bewertungsgrundsätze für
Derivative abzuändern, die Beschreibung der Geschäftskosten unter Punkt B (b) neu zu definieren, die Möglichkeit Ver-
mögensmassen zu bilden vorzusehen und folglich Änderung von Artikel 23,
13. die Zeitfrist innerhalb welcher der Ausgabepreis zu zahlen ist von vier auf zehn Bankarbeitstage abzuändern, eine
Bestimmung vorzusehen die es dem Verwaltungsrat ermöglicht Begrenzungen betreffend die Frequenz mit welcher Ak-
tien ausgeben werden vorzusehen und folglich Änderung von Artikel 24;
14. Artikel 28 betreffend die Auflösung der Gesellschaft, die Beendigung oder Verschmelzung von Teilfonds neu zu
gestalten;
15. eine Überschrift für die verschiedenen Artikel der Satzung vorzusehen;
16. die Satzung in Übereinstimmung mit den vorhergehenden Beschlüssen neu zu fassen.»
II) Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, sowie der
Stückzahl der vertretenen Aktien auf eine Anwesenheitsliste mit ihren Unterschriften eingetragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-
net. Sie wird dem gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
III) Diese Versammlung wurde mittels Einberufungsschreiben einberufen, wie folgt veröffentlicht:
- im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 13. und 27. September 2004,
- in der Tageszeitung «Luxemburger Wort» am 13. und 27. September 2004,
- in der Tageszeitung «Tageblatt» am 13. und 27. September 2004,
- im «Der Standard» (Österreich), am 13. und 27. September 2004,
IV) Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 339.902,979 Aktien, 10.608,019 Aktien anläss-
lich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind, und dass gemäss Tagesordnung und den Bestimmungen von
Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften, die gegenwärtige Generalversammlung rechtsgültig zu-
sammengesetzt ist und demgemäss über die in der Tagesordnung aufgeführten Punkte abstimmen kann.
Eine erste ausserordentliche Versammlung, mit der gleichen Tagesordnung wurde bereits am 9. September 2004, zu-
sammenberufen aber konnte, wegen des fehlenden gesetzlichen Quorums, vorbenannte Beschlüsse nicht abstimmen.
Gemäss den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften, kann die gegenwärtige
Generalversammlung folgende Beschlüsse nehmen, unabhängig des anwesenden Quorums, welche wie folgt lauten:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft auf QUADRIGA SUPERFUND SICAV zu ändern, und folg-
lich die Änderung von Artikel 1.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst jedwede Referenz auf das Gesetz vom 30. März 1988 durch eine Referenz auf das Ge-
setz vom 20. Dezember 2002 zu ersetzen, und folglich die Änderung von Artikel 3.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Beschreibung der Anlagemöglichkeiten zu ändern durch Erweiterung des Anlageho-
rizonts der Gesellschaft und folglich die Änderung von Artikel 3.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst jedwede Referenz auf den Luxemburger Franken zu streichen und durch eine Referenz
auf den Euro zu ersetzen und folglich die Änderung von Artikel 5.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Möglichkeit in der Satzung vorzusehen, um innerhalb eines jeden Teilfonds verschie-
dene Aktienklassen auszugeben und folglich die Änderung der Artikel 5, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 28 und 29.
51517
<i>Sechster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Ausgabe von Aktienbruchteilen vorzusehen und folglich die Änderung von Artikel 6.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Satz zu streichen: «Eine Gesellschaft kann durch Unterschrift eines dazu befugten
Amtsinhabers einen Stellvertreter ernennen.»; und folglich die Änderung von Artikel 11.
<i>Achter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Möglichkeit vorzusehen, dass Verwaltungsratssitzungen auch durch «ähnliche Kom-
munikationsmittel» einberufen werden können und folglich die Änderung von Artikel 14.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Bestimmung betreffend die Aussetzung von Rücknahmeanträgen abzuändern um
diese Bestimmung weiter zu fassen und um jedwede Referenz auf eine Zeitperiode zu streichen und folglich die Ände-
rung von Artikel 21.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Zeitfrist innerhalb welcher der Rücknahmepreis zu bezahlen ist von fünf Bankar-
beitstagen auf 45 Luxemburger Bankarbeitstage abzuändern und folglich die Änderung von Artikel 21.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst einen Luxemburger Bankarbeitstag als einen ganzen oder halben Feiertag zu definieren
und folglich die Änderung von Artikel 22.
<i>Zwölfter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Bewertungsgrundsätze für Anteile von anderen Anlagefonds zu definieren und die
Bewertungsgrundsätze für Derivative abzuändern, die Beschreibung der Geschäftskosten unter Punkt B (b) neu zu de-
finieren, die Möglichkeit Vermögensmassen zu bilden vorzusehen und folglich die Änderung von Artikel 23.
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Zeitfrist innerhalb welcher der Ausgabepreis zu zahlen ist von vier auf zehn Bank-
arbeitstage abzuändern, eine Bestimmung vorzusehen die es dem Verwaltungsrat ermöglicht Begrenzungen betreffend
die Frequenz mit welcher Aktien ausgeben werden vorzusehen und folglich die Änderung von Artikel 24.
<i>Vierzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst Artikel 28 betreffend die Auflösung der Gesellschaft, die Beendigung oder Verschmel-
zung von Teilfonds neu zu gestalten.
<i>Fünfzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst eine Überschrift für die verschiedenen Artikel der Satzung vorzusehen.
<i>Sechzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Satzung in Übereinstimmung mit den vorhergehenden Beschlüssen neu zu fassen,
welche nunmehr folgendermassen lautet:
Art. 1. Name. Zwischen den Unterzeichnern und jenen Personen, die zukünftig Aktien erwerben, besteht eine Ge-
sellschaft in Form einer Aktiengesellschaft («Société anonyme») in der Form einer «Société d’investissement à capital
variable» («SICAV») unter dem Namen QUADRIGA SUPERFUND SICAV.
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Ausschließlicher Gegenstand der Gesellschaft ist es, die ihr verfügbaren Mittel in Ter-
mingeschäften- auf Waren oder auf Finanzinstrumente sowie in Optionen, in Anteile von anderen Organismen für ge-
meinsame Anlagen (OGA), in Wertpapiere, Devisen oder andere Finanzinstrumente so wie vom Gesetz erlaubt,
anzulegen, um so das Investitionsrisiko zu streuen und ihren Aktionären die durch die Portfolioverwaltung erwirtschaf-
teten Gewinne zuteil werden zu lassen.
Die Gesellschaft ergreift alle Maßnahmen und führt alle Geschäfte aus die für die Erreichung und Umsetzung ihrer
Ziele notwendig sind und die im vollen Ausmaße des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemein-
same Anlagen bzw. gemäß den gesetzlichen Ergänzungen und Änderungen dieses Gesetz (das «Gesetz») zulässig sind.
Art. 4. Firmensitz. Der Firmensitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, im Großherzogtum Luxemburg. Zweig-
niederlassungen oder andere Geschäftsräume können durch Beschluss des Verwaltungsrates (der «Verwaltungsrat»)
entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
Wenn nach Ermessen des Verwaltungsrates außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse, welche die
normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Firmensitz oder den Nachrichtenverkehr mit dem Ausland beein-
trächtigen, auftreten bzw. bevorstehen, so kann der Finnensitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese au-
ßergewöhnlichen Umstände wieder zur Gänze beseitigt sind. Derlei vorübergehende Maßnahmen wirken sich nicht auf
die Nationalität der Gesellschaft aus, welche, unbeschadet einer solchen vorübergehenden Verlegung des Firmensitzes,
eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.
Art. 5. Aktienkapital- Aktienklassen. Das Kapital der Gesellschaft wird durch nennwertlose Aktien (die «Akti-
en») dargestellt und entspricht jederzeit dem Gesamtnettovermögen der Gesellschaft, so wie nachstehend definiert.
51518
Das Mindestkapital der Gesellschaft ist der Gegenwert in US-Dollar («USD») von einer Million zweihundertfünfzig-
tausend Euro (1.250.000,- EUR).
Der Verwaltungsrat ist jederzeit ohne Einschränkung berechtigt, Aktien zu einem Ausgabepreis (der «Ausgabepreis»)
pro Aktie des jeweiligen Teilfonds, so wie in Artikel 24 definiert, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht
auf Zeichnung von Aktien einzuräumen, auszugeben.
Der Verwaltungsrat kann an jeden ordnungsgemäß bevollmächtigten Direktor der Gesellschaft («Direktor») oder
Angestellten der Gesellschaft sowie an jede andere ordnungsgemäß dazu bevollmächtigte Person die Aufgabe übertra-
gen, Zeichnungen zu akzeptieren sowie die Zahlung des Ausgabepreises und die Zahlung des Preises von solchen Aktien
vorzunehmen bzw. anzunehmen.
Diese neuen Aktien können, wie der Verwaltungsrat es bestimmt, verschiedenen Teilfonds (hiernach «Teilfonds» ge-
nannt) angehören, und die Gelder aus der Ausgabe eines jeden Teilfonds werden gemäß obenstehendem Artikel 3 in
Wertpapiere oder andere Vermögenswerte wie Termingeschäfte eines geographischen Gebietes, industriellen Sektors,
eines Währungsgebietes oder einer spezifischen Art von derivativen Finanzinstrumenten wie es der Verwaltungsrat hin-
sichtlich eines jeden Teilfonds bestimmt, angelegt.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls entscheiden, dass innerhalb eines jeden Teilfonds eine oder mehrere Klassen an-
geboten werden deren Vermögenswerte gemeinschaftlich folgend der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds angelegt
werden, aber für welche verschiedene Ausgabe- oder Rücknahmegebühren, Gebührenstrukturen, Absicherungspolitik
oder andere Besonderheiten für diese Klasse gelten. In der vorliegenden Satzung bezieht sich jede Referenz auf einen
«Teilfonds» auch auf eine «Klasse» außer der Inhalt würde es anders verlangen.
Der Verwaltungsrat kann das Kapital der Gesellschaft herabsetzen in dem er einen oder mehrere Teilfonds schließt:
die Aktien des entsprechenden Teilfonds werden annulliert und der Gegenwert dieser Aktien wird den Aktionären die-
ses Teilfonds überwiesen.
Art. 6. Form der Aktien. Der Verwaltungsrat begibt Aktien in Form von Namens- oder Inhaberaktien nach Wahl
des Aktionärs hinsichtlich jedes Teilfonds. Verlangt ein Inhaberaktionär den Umtausch in Namensaktien, werden ihm für
diesen Umtausch keine Kosten in Rechnung gestellt. Namensaktien können in verbriefter oder nicht-verbriefter Form
ausgegeben werden. Sie werden in nicht-verbriefter Form ausgegeben außer ein Anleger verlangt die Ausgabe eines Zer-
tifikates. Inhaberaktien werden durch Globalzertifikate verbrieft, welche bei Abwicklungssystemen wie CLEARSTREAM
oder EUROCLEAR hinterlegt werden.
Aktienzertifikate sind von zwei Direktoren oder einem Direktor und einem vom Verwaltungsrat für solche Zwecke
rechtmäßig bevollmächtigten Vertreter zu unterzeichnen. Unterschriften von Direktoren können entweder eigenhändig
oder gedruckt bzw. per Faksimile erfolgen. Die Unterschrift eines bevollmächtigten Stellvertreters ist handschriftlich zu
leisten. Die Gesellschaft kann zeitweilige Aktienzertifikate in einer vom Verwaltungsrat gegebenenfalls festzulegenden
Form begeben.
Die Aktienausgabe erfolgt bei der Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Bezahlung des Preises so wie in
Artikel 24 bestimmt. Dem Zeichnenden wird in einem angemessenen Zeitraum das definitive Aktienzertifikat bzw. ge-
mäß vorstehendem eine Bestätigung seines Aktienbesitzes übermittelt.
Dividendenausschüttungen erfolgen, im Falle von Namensaktien zugunsten des Aktienbesitzers, an dessen Mandats-
adresse im Aktionärsregister bzw. an eine andere den Direktoren schriftlich bekanntgegebenen Adresse.
Mit Ausnahme von Inhaberaktien werden alle Aktien der Gesellschaft im Aktionärsregister verzeichnet, welches
durch die Gesellschaft bzw. eine oder mehrere dafür von der Gesellschaft bestellte Person/en geführt wird. In diesem
Register sind die Namen der Besitzer von Namensaktien, deren ständiger Wohnort oder gewählter Wohnsitz, sofern
der Gesellschaft bekanntgegeben, sowie die Anzahl der erworbenen Aktien im jeweiligen Teilfonds angegeben. Alle Ak-
tienübertragungen, ausgenommen Inhaberaktien, werden im Aktionärsregister festgehalten, gegen Bezahlung einer dafür
üblichen und von den Direktoren für die Eintragung von allen anderen mit der Aktienberechtigungen verbundenen Do-
kumenten anerkannten Gebühr.
Die Gesellschaft hat in Zusammenhang mit Aktientransaktionen gegenüber Dritten keinerlei Haftung oder Verpflich-
tungen und ist berechtigt, alle mit diesen Aktien verbundenen Rechte, Ansprüche oder Forderungen von Dritten als
nicht gegeben anzusehen, sofern die Gesellschaft niemandem ein Recht aberkennt, welcher dieser in Zusammenhang
mit der Eintragung einer Änderung im Aktienregister rechtmäßig zustünde.
Es gibt keine Einschränkung des Rechtes auf Übertragung von Aktien und kein Zurückbehaltungsrecht zugunsten der
Gesellschaft.
Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch Übergabe der entsprechenden Inhaberaktienzertifikate bzw. des
Zertifikates das diese verbrieft und falls anwendbar mit allen dazu gehörigen, noch nicht fälligen Kupons. Die Übertra-
gung von Namensaktien erfolgt durch eine diesbezügliche Mitteilung im Aktionärsregister der Gesellschaft durch den
Aktienbesitzer oder durch hierzu ordnungsgemäß berechtigte Personen.
Jeder Namensaktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft eine Adresse bekanntzugeben, an welche alle Mitteilungen und
Bekanntmachungen der Gesellschaft gesandt werden können. Die jeweiligen Adressen werden in das Aktionärsregister
eingetragen. Im Falle von gemeinsamem Aktienbesitz wird lediglich eine Adresse verzeichnet und alle Mitteilungen er-
folgen ausschließlich an diese Adresse.
Gibt ein Aktionär im Aktionärsregister keine Adresse an, so kann die Gesellschaft gestatten, im Aktionärsregister
einen diesbezüglichen Vermerk anzubringen und es wird angenommen, dass die Adresse des Aktienbesitzers beim Fir-
mensitz der Gesellschaft oder an einer anderen von der Gesellschaft hierzu angegebenen Adresse ist und zwar so lange
bis der Aktienbesitzer der Gesellschaft eine neue Adresse bekanntgibt. Die Aktionäre können ihre im Aktionärsregister
eingetragenen Adressen jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an den Firmensitz der Gesellschaft bzw. an die allenfalls
von der Gesellschaft hierzu festgelegten Adresse ändern.
51519
Die Gesellschaft kann entscheiden, dass Aktienbruchteile ausgegeben werden. Diese Aktienbruchteile sind nicht
stimmberechtigt aber sind prozentuale am jeweiligen Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds beteiligt.
Art. 7. Verlegte oder verstümmelte Zertifikate. Ist ein Aktionär in der Lage, in einem für die Gesellschaft be-
friedigendem Masse nachzuweisen, dass sein Aktienzertifikat verlegt, verunstaltet oder zerstört wurde, so kann auf sein
Verlangen ein Aktienzertifikat in 2. Ausfertigung ausgestellt werden, und zwar unter den von der Gesellschaft bestimm-
ten Bedingungen und Garantien. Nach Übergabe des neuen, mit dem Wort «Duplikat» zu versehenden Aktienzertifika-
tes, wird das original Aktienzertifikat, an dessen Stelle das neue ausgestellt wurde, ungültig.
Die Gesellschaft hat das Recht, einem Aktionär für die Ausstellung eines Duplikats oder eines neuen Aktienzertifika-
tes, (wenn das alte verlegt, verunstaltet oder zerstört wurde) angefallene Sonder-Barauslagen nach eigenem Ermessen
zu verrechnen.
Art. 8. Einschränkung des Aktienbesitzes. Die Gesellschaft kann den Besitz von Aktien durch bestimmte na-
türliche oder juristische Personen einschränken oder verbieten, insbesondere wenn es sich um eine Person handelt, die
gegen das Gesetz bzw. gesetzliche Auflagen eines Staates oder einer Staatsbehörde verstoßen hat oder die kraft eines
Gesetzes oder gesetzlicher Auflagen für den Besitz von Aktien nicht qualifiziert ist, oder wenn wegen der Person des
Aktienbesitzers der Gesellschaft eine Besteuerung oder ein anderer finanzieller Nachteil erwachsen würden, welcher
sonst nicht gegeben wäre, oder wenn der Verwaltungsrat dies entscheidet und im aktuellen Prospekt bekanntgibt, dass
es sich um eine wie unten näher angeführte Person der Vereinigten Staaten von Amerika (insgesamt definiert als «Un-
befugte Person») handelt.
In diesen Fällen kann die Gesellschaft:
(a) die Ausgabe, oder die Registrierung einer Übertragung von Aktien ablehnen, wenn sie der Meinung ist, dass eine
solche Ausgabe oder Registrierung der Übertragung zum Besitz von Aktien durch eine Unbefugte Person führt und
(b) jederzeit von allen Personen, deren Namen im Register verzeichnet sind oder die eine Aktienübertragung regi-
strieren lassen möchten, sämtliche Angaben verlangen, welche die Gesellschaft als notwendig erachtet, um feststellen
zu können, ob der wirtschaftlich Berechtigte dieser Aktien eine Unbefugte Person ist oder hierdurch werden könnte
und
(c) wenn es sich herausstellt, dass eine Unbefugte Person (ob alleine oder gemeinsam mit einem Dritten) Aktien be-
sitzt, wird die Gesellschaft diese Aktien auf folgende Art und Weise zwingend rückkaufen:
1. Die Gesellschaft macht eine Ankündigung (im weiteren genannt Kaufankündigung) über den Aktienbesitzer, wel-
cher im Register als Besitzer zu erwerbender Aktien angeführt ist und führt dabei die o.g. und zu erwerbenden Aktien,
deren Preis sowie den Zahlungsort an. Die Ankündigung wird dem Aktienbesitzer frankiert und eingeschrieben an des-
sen zuletzt genannte bzw. in den Verzeichnissen der Gesellschaft angeführte Adresse gesandt. Der besagte Aktionär
wird so aufgefordert, das Zertifikat oder mit der Aktie verbundene und in der Kaufsankündigung näher ausgeführte Zer-
tifikate, falls ausgestellt, umgehend der Gesellschaft zu übergeben. Unverzüglich nach Geschäftsschluss des in der
Kaufsankündigung genannten Tages erlischt der Aktienbesitz des in der Ankündigung bezeichneten Aktionärs und des-
sen Namen wird aus dem Register gestrichen.
2. Die für den Erwerb einer solchen Aktie in der Kaufsankündigung angeführte Summe (hier genannt «Kaufpreis»)
beläuft sich in Übereinstimmung mit Artikel 23 des vorliegenden Dokuments auf den Nettoinventarwert der entspre-
chenden Aktie.
3. Mit Ausnahme von Devisenbeschränkungszeiten erfolgt die Zahlung des Kaufpreises an den Aktienbesitzer in der
Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds. Der Kaufpreis wird bei der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem ande-
ren (in der Kaufsankündigung angeführten) Ort hinterlegt und dem Besitzer gegen Auslieferung des Zertifikates, falls
ausgegeben ausbezahlt. Bei Hinterlegung des Kaufpreises im oben angeführten Modus besteht für die in der Kaufsankün-
digung angeführten Personen kein weiterer Anspruch auf diese Aktien; sie haben gegenüber der Gesellschaft und deren
Vermögen keinerlei Ansprüche zu stellen und haben lediglich ein Anrecht auf die hinterlegte Summe (ohne Zinsen) als
Gegenleistung für die rechtswirksame Übergabe des Zertifikates bzw. der oben angeführten Zertifikate, falls ausgegeben.
4. Die Ausübung der der Gesellschaft in diesem Artikel verliehenen Vollmachten soll keinesfalls mit der Begründung,
dass der Besitz einer Aktie nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte oder der tatsächliche Besitz einer Aktie von
dem durch die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufsankündigung angeführten Besitz abweicht, in Frage gestellt oder für
ungültig erklärt werden - vorausgesetzt, dass die besagten Vollmachten in einem solchen Fall von der Gesellschaft gut-
gläubig ausgeübt wurden; und
(d) einer Unbefugten Person bei Hauptversammlungen der Gesellschaft das Stimmrecht entziehen.
Die Bezeichnung «Person der Vereinigten Staaten von Amerika» oder U.S Person steht in der vorliegenden Satzung
für einen Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika, für eine Gesellschaft in einem Bundesstaat,
auf dem Territorium oder in Besitz der USA, oder für nach dem Gesetz der Vereinigten Staaten von Amerika organi-
sierte, sich auf dortigem Territorium oder in Besitz der USA befindliche Körperschaften, Besitztümer oder Unterneh-
menszusammenschlüsse.
Art. 9. Ordentlich Generalversammlung der Aktionäre. In der ordentlich einberufenen Hauptversammlung
der Gesellschaft oder eines Teilfonds sind alle Aktionäre der Gesellschaft oder die Aktionäre eines Teilfonds vertreten.
Hierbei gefasste Beschlüsse gelten für alle Aktionäre der Gesellschaft oder des entsprechenden Teilfonds als verbindlich.
Die Hauptversammlung verfügt über weitestgehende Vollmachten zur Anordnung, Durchführung oder Ratifizierung von
Verordnungen in geschäftlichen Belangen der Gesellschaft.
Art. 10. Jahreshauptversammlung. Die Jahresversanunlung wird in Übereinstimmung mit dem Luxemburgischen
Gesetz im Großherzogtum Luxemburg am Firmensitz der Gesellschaft oder an einem in der Einberufung angeführten
anderen Ort, jeweils am ersten Montag im Monat Mai um 11.00 Uhr vormittags abgehalten. Ist dieser Tag in Luxemburg
kein Bankarbeitstag, so findet die Jahreshauptversammlung an dem darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.
51520
Die Jahreshauptversammlung kann auch im Ausland durchgeführt werden, wenn dies gemäß absoluter und endgültiger
Entscheidung des Verwaltungsrates aufgrund von außergewöhnlichen Umständen notwendig erscheint.
Ort und Zeit anderer Aktionärsversammlungen werden gemäß Angaben in den entsprechenden Einberufungen
durchgeführt.
Art. 11. Beschlussfähigkeit und Einberufungsfristen. Für die Ankündigung und Durchführung von Aktionärs-
versammlungen der Gesellschaft gelten bezüglich Fristen und Beschlussfähigkeit die gesetzlichen Regeln, sofern im vor-
liegenden Dokument nichts anderes festgelegt ist.
Jede Aktie verbrieft ein Stimmrecht, vorbehaltlich der in dieser Satzung verfügten Beschränkungen. Ein Aktionär ist
berechtigt, in schriftlicher Form, telegrafisch, via Telegramm, Telex oder Telefax für Aktionärsversammlungen an seiner
Stelle einen Stimmrechtsbevollmächtigten zu ernennen.
Wenn nicht gesetzlich oder in der vorliegenden Satzung anders bestimmt, erfolgt die Beschlussfassung bei rechtmäßig
einberufenen Aktionärsversammlungen durch eine einfache Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Aktionä-
re.
Der Verwaltungsrat bestimmt alle weiteren Voraussetzungen für die Teilnahme von Aktionären an Aktionärsver-
sammlungen.
Solange das Kapital zwischen verschiedenen Teilfonds aufgeteilt ist, und ein Beschluss einer Generalversammlung der
Aktionäre der Gesellschaft, die Rechte der Aktieninhaber eines Teilfonds gegenüber den Rechten der Aktieninhaber
eines anderen Teilfonds berührt, unterliegt einem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre eines solchen oder
der solchen Teilfonds in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 68 des Gesetzes vom 10. August 1915
betreffend Handelsgesellschaft, einschließlich Änderungen. Diese Bestimmung gilt gleichermaßen für Aktienklassen.
Art. 12. Einberufungsschreiben. Versammlungen der Aktionäre werden durch den Verwaltungsrat einberufen,
mittels Einberufungsschreiben das die Tagesordnung bekanntgibt und jedem Aktionär an dessen Adresse aus dem Ak-
tionärsverzeichnis spätestens 8 Tage vor der Versammlung zugesandt wird. Die Gesellschaft muss jedoch eine solche
Mitteilung nicht nachweislich durchführen, wenn die Einberufung gemäß Luxemburgischem Gesetz auch veröffentlicht
worden ist.
Solange Inhaberaktien in Umlauf sind, wird die Einberufung zusätzlich im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, in einer luxemburgischen Zeitung und in einer weiteren Zeitung nach Beschluss des Verwaltungsrates veröf-
fentlicht werden.
Wenn jedoch bei einer Versammlung alle Aktionäre oder deren Stellvertreter anwesend sind und angeben dass sie
die Tagesordnung kennen, kann eine Versammlung ohne vorhergehende Mitteilung oder Veröffentlichung abgehalten
werden.
Art. 13. Verwaltungsrat. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch den Verwaltungsrat, der sich aus
mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt. Verwaltungsratsmitglieder müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein.
Wie unten näher ausgeführt, erfolgt die Wahl des Verwaltungsrates durch die Aktionäre im Rahmen einer Hauptver-
sammlung für die Zeit bis zur darauffolgenden Jahreshauptversammlung und bis ihre Nachfolger gewählt worden sind
und ihre Ernennung angenommen haben, oder - wenn zu einem späteren Zeitpunkt - bis zum Ende einer solchen Wahl
und Annahme derselben. Vorausgesetzt, dass ein Direktor mit oder ohne Angabe von Gründen jederzeit auf Beschluss
der Aktionäre abgesetzt oder ersetzt werden kann. Wird die Stelle eines Direktors durch Tod, Pension oder anderes
frei, so sollen die anderen Direktoren zusammentreffen und in einer Ergänzungswahl mit einfacher Mehrheit diesen Po-
sten bis zur nächsten Aktionärsversammlung wieder nachbesetzen.
Art. 14. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzen-
den wählen und unter seinen Mitgliedern einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende ernennen. Der Verwaltungs-
rat kann zudem einen Schriftführer wählen, der nicht Direktor sein muss und der bei Versammlungen des
Verwaltungsrates und der Aktionäre für die Protokollführung zuständig ist. Auf Verlangen von zwei Direktoren hat der
Verwaltungsrat an einem in der Versammlungsmitteilung angeführten Ort zusammenzutreffen.
Ist ein Vorsitzender ernannt, hat dieser bei allen Aktionärsversammlungen und Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz
zu übernehmen. Ist kein Vorsitzender ernannt bzw. anwesend, so können die Aktionäre oder der Verwaltungsrat eine
beliebige Person pro tempore durch Mehrheitswahl aller an einer Versammlung teilnehmenden Personen zum Vorsit-
zenden wählen.
Eine schriftliche Einladung hat zumindest 24 Stunden vor einer Verwaltungsratssitzung an alle Direktoren zu ergehen.
Dies gilt nicht für äußerst dringliche Fälle, wobei dann diese Umstände in der Versammlungsankündigung zu erläutern
sind.
Von diesem Einladungsschreiben kann bei Einverständnis aller Direktoren (schriftlich, telegrafisch, per Telegramm,
Telex, Telefax oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel) Abstand genommen werden. Für einzelne Versamm-
lungen, deren Zeit und Ort im vornhinein durch Verwaltungsratsbeschluss in schriftlicher Form festgelegt wurden, ist
keine eigene Einladung mehr erforderlich.
Direktoren können sich bei jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, telegrafisch per Telegramm, Telex, Telefax oder
durch eine ähnliches Kommunikationsmittel einen anderen Direktor zu ihrer Vertretung bestellen. Außerdem steht es
Direktoren zu, ihre Stimme schriftlich, telegrafisch, durch Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein ähnliches Kommu-
nikationsmittel abzugeben.
Die Direktoren sind nur bei ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handlungsfähig. Einzelne Ent-
scheidungen der Direktoren sind für die Gesellschaft nicht bindend, es sei denn, sie werden durch einen Beschluss des
Verwaltungsrates gebilligt.
Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur dann rechtsgültig, wenn zumindest die Mehrheit der
Direktoren anwesend ist (was durch eine Konferenzschaltung telefonisch auch gegeben sein kann) bzw. sich vertreten
51521
lässt. Entscheidungen werden durch Mehrheitswahl der bei einem solchen Treffen anwesenden oder vertretenen Direk-
toren getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Beschlüsse des Verwaltungsrats können auch danach zustande kommen, dass zustimmende Erklärungen gleichen In-
halts auf ein- oder mehrfacher Ausfertigung durch Telex, Telegramm oder Telefax (in jedem dieser Fälle schriftlich be-
stätigt) von allen Direktoren unterschrieben werden.
Der Verwaltungsrat kann auf Zeit Führungskräfte der Gesellschaft ernennen, unter ihnen den Generaldirektor, Ge-
schäftsführern sowie deren Stellvertreter und weitere leitende Funktionäre, die für die Durchführung und Leitung der
Gesellschaft notwendig sind. Alle Ernennungen dieser Art können durch den Verwaltungsrat jederzeit wieder aufgeho-
ben werden. Leitende Kräfte müssen nicht Direktoren oder Aktionäre der Gesellschaft sein. Die ernannten leitenden
Funktionäre erhalten die ihnen vom Verwaltungsrat zugeteilten Vollmachten und Pflichten, sofern in der vorliegenden
Satzung nichts anderes bestimmt ist.
Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten im Bereich der täglichen Geschäftsführung und für allgemeine Angele-
genheiten der Gesellschaft, sowie jene zur Förderung der Belange und Ziele der Gesellschaft physischen Personen oder
Rechtspersönlichkeiten, die keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, übertragen. Der Verwaltungsrat kann weiter
alle Vollmachten, Vertretungskompetenzen und Entscheidungsgewalten jedem Komitee übertragen, dessen Mitglieder
(gleich ob Verwaltungsratsmitglieder oder nicht) ihnen als dazu geeignet erscheinen.
Art. 15. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen. Das Protokoll jeder einzelnen Versammlung ist von der Per-
son, die dabei den Vorsitz innehatte, zu unterschreiben.
Kopien oder Auszüge aus solchen Protokollen, die in Gerichtsverfahren oder anderswo vorgelegt werden, sind vom
Vorsitzenden, Geschäftsführer oder von zwei Direktoren zu signieren.
Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten zur Aus-
übung aller im Interesse der Gesellschaft liegenden administrativen und dispositionellen Schritte ausgestattet. Alle nicht
ausdrücklich kraft Gesetz oder kraft vorliegender Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Voll-
machten liegen im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat hat das Recht, im Namen der Gesellschaft alle Schritte zu unternehmen, welche nicht durch die
vorliegende Satzung den Aktionären in einer Hauptversammlung vorbehalten sind und hat - ohne die Allgemeingültigkeit
des vorher Gesagten einzuschränken - die Befugnis, die Firmen- und Investitionspolitik für die Anlagen zu bestimmen,
welche auf dem Prinzip der Risikostreuung basieren, vorbehaltlich jener Investitionsbeschränkungen, die von Gesetzes
wegen oder durch Regulierungen oder wie im Verkaufsprospekt betreffend das Angebot von Aktien zu beachten sind.
Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten zur Leitung täglicher Geschäfte und Angelegenheiten der Gesellschaft
sowie zur Umsetzung von Schritten zur Förderung der Politik und Ziele der Gesellschaft physische Personen oder Kör-
perschaften übertragen, welche nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und welche der Oberaufsicht des
Verwaltungsrates unterstehen.
Art. 17. Persönliches Interesse. Vertragsabschlüsse und sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und
anderen Unternehmen bzw. Firmen dürfen nicht durch die Tatsache, dass einer oder mehrere der Direktoren oder
Funktionäre der Gesellschaft ein Interesse an diesem anderen Unternehmen bzw. dieser anderen Firma haben oder dort
Direktoren, Funktionäre, Teilhaber oder Angestellte sind, beeinflusst werden oder als ungültig erklärt werden. Direk-
toren oder leitende Kräfte der Gesellschaft, die Direktoren, leitende Funktionäre oder Angestellte einer anderen Ge-
sellschaft oder Firma sind, mit der die Gesellschaft einen Vertrag oder anderweitige Geschäfte abschließen soll, sind
aufgrund einer solchen Verschmelzung mit einer anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran zu hindern, Angelegen-
heiten in bezug auf solche Verträge oder Geschäfte zu überprüfen und darüber abzustimmen.
Hat ein Direktor oder leitender Funktionär der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Ge-
sellschaft, so hat er diesen Interessenkonflikt dem Verwaltungsrat bekanntzugeben und an der Prüfung und Abstimmung
solcher Transaktionen nicht teilzunehmen. Solche Transaktionen sind unter Bekanntgabe des befangenen Direktors
oder leitenden Funktionärs bei der darauffolgenden Hauptversammlung der Aktionäre vorzubringen.
Die im vorhergehendem Unterabschnitt verwendete Bezeichnung «persönliches Interesse» bezieht sich nicht auf Ge-
schäftsbeziehungen zu oder das Interesse an Angelegenheiten, Posten oder Transaktionen mit dem Anlagemanager, An-
lageverwalter, Anlageberater oder einer mit ihnen verbundenen Gesellschaft oder sonstige gegebenenfalls vom
Verwaltungsrat der Gesellschaft nach seinem Ermessen bestimmten Körperschaften oder Rechtspersönlichkeiten.
Art. 18. Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft ist befugt, Direktoren oder leitende
Funktionäre sowie deren Rechtsnachfolger, Nachlassverwalter und Administratoren für Ausgaben schadlos zu halten,
welche ihnen in Verbindung mit Strafverfahren, Prozessen oder Rechtsstreitigkeiten aufgrund ihrer Tätigkeit als Direk-
tor oder leitender Funktionär bei der Gesellschaft oder auf Verlangen derselben bei einer anderen Gesellschaft erwach-
sen sind, von welcher die Gesellschaft Aktienbesitzer oder Gläubiger ist oder von der sie sich nicht schadlos halten
können. Die Schadloshaltung einer solchen Person erfolgt unter allen Umständen mit Ausnahme von jenen Strafverfah-
ren, Prozessen oder Rechtsstreitigkeiten, bei denen sie wegen grober Fahrlässigkeit oder schwerer Dienstverfehlung
rechtskräftig verurteilt wird; im Falle einer Beilegung wird die Entschädigung nur hinsichtlich Angelegenheiten, die von
der Beilegung betroffen sind gezahlt und über welche die Gesellschaft von ihrem Rechtsberater beraten worden ist, daß
die zu entschädigende Person nicht eine solche Pflichtverletzung begangen hat. Das oben angeführte Recht auf Schad-
loshaltung schließt andere Rechte der betreffenden Person nicht aus.
Art. 19. Unterschriftsbefugnis. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Direktoren
gebunden: eine von einem Stellvertreter der BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. und eine von einem Stellver-
treter der QUADRIGA ASSET MANAGEMENT Ges.m.b.H.
51522
Art. 20. Wirtschaftsprüfer. In der Hauptversammlung der Aktionäre ist ein Wirtschaftsprüfer zu ernennen, wel-
cher die gesetzlich festgelegten Pflichten zu erfüllen hat.
Art. 21. Rücknahme von Aktien. Jeder Aktionär hat das Recht, jederzeit die Rücknahme seiner Aktien zu verlan-
gen.
Wie im Folgenden näher erläutert, hat die Gesellschaft mit Ausnahme einzelner gesetzlich geregelter Einschränkun-
gen die Macht, ihre eigenen Aktien jederzeit zurückzunehmen. Der Rücknahmepreis einer jeden Aktie ist gleich dem
von der Gesellschaft festgesetzten Nettoinventarwert pro Aktienklasse des jeweiligen Teilfonds.
Jeder Rücknahmeantrag welcher als Folge hätte, dass die Gesamtposition eines Aktionärs unter einen Mindestbetrag,
wie dieser Verwaltungsrat hinsichtlich eines jeden Aktienklasse oder eines jeden Teilfonds festgelegt werden kann, fällt,
wird als Rücknahmeantrag für die Gesamtposition dieses Anlegers behandelt.
Ein Aktionär kann die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Gesellschaft verlangen, vorausge-
setzt, die Gesellschaft muss an einem Bewertungstag (wie im folgendem definiert) nicht mehr als einen gewissen Pro-
zentsatz, so wie vom Verwaltungsrat bestimmt, berechnet auf die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen
Teilfonds, zurücknehmen. Solche Rücknahmeanträge werden ausgesetzt für einen Zeitraum und in der Art und Weise
wie es der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft festlegt.
Eine derartige Beschränkung gilt für alle Aktionäre, die ihre Aktien in einem Teilfonds und einem Bewertungstag zur
Rücknahme angeboten haben anteilsmäßig an den zur Rücknahme angebotenen Aktien an diesem Teilfonds.
Für diesen Zweck werden Umwandlungen als Rücknahmen betrachtet.
Der Rücknahmepreis, berechnet auf den Nettoinventarwert pro Aktie, sowie im nachstehenden Artikel 23 bestimmt,
abzüglich einer vom Verwaltungsrat festgelegten Rücknahmegebühr, ist innerhalb einer Frist, wie vom Verwaltungsrat
bestimmt, die nicht 45 Luxemburger Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag überschreiten darf oder,
wenn zu einem späteren Zeitpunkt, am Tag des Erhaltes der Aktienzertifikate (falls welche ausgestellt wurden) zu be-
zahlen.
Wenn in außergewöhnlichen Umständen, die Liquiditäten eines Portfoliovermögens eines Teilfonds, für den Rück-
nahmeanträge eingegangen ist, nicht genügend sind um die Zahlung des Rücknahmepreises vorzunehmen, so wird diese
Zahlung zum nächstmöglichen Termin jedoch, ohne Zinsen, vorgenommen.
Rücknahmeanträge sind vom Aktionär in schriftlicher Form beim Firmensitz der Gesellschaft in Luxemburg oder bei
von der Gesellschaft dafür ernannten Dritten oder Körperschaften, welche als Stellvertreter für die Rücknahme von
Aktien fungieren, vorzulegen. Das Zertifikat bzw. die Zertifikate, falls ausgegeben, für die entsprechenden Aktien sind
in angemessener Form und zusammen mit einem stichhaltigen Beweis über die Übertragung bzw. Abtretung an die Ge-
sellschaft oder an einen für diesen Zweck ernannten Stellvertreter zu übermitteln und erst dann erfolgt die Zahlung des
Rücknahmepreises.
Von der Gesellschaft zurückgenommene Aktien verfallen.
Art. 22. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes. Der Nettoinventarwert pro Aktie («Net-
toinventarwert») und Ausgabe- sowie Rücknahmepreis einer Aktienklasse innerhalb des jeweiligen Teilfonds werden
von der Gesellschaft mindestens ein Mal pro Monat festgesetzt, was per Beschluss des Verwaltungsrates angeordnet
werden kann (der Tag oder Zeitpunkt für eine solche Festsetzung wird hierin als «Bewertungstag» bezeichnet), jedoch
so, dass kein Tag der ganzer oder halber Bankfeiertag in Luxemburg ist ein Bewertungstag ist.
Die Gesellschaft ist befugt, die Festsetzung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, Umwandlung oder die Rück-
nahme von Aktien eines jeden Teilfonds in folgenden Fällen einzustellen:
(a) wenn ein Markt oder eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Anlagen eines Teilfonds notiert oder gehandelt
wird, an anderen als den landesüblichen Feiertagen geschlossen ist, oder der Geschäftsverkehr an solchen Tagen einge-
schränkt bzw. zur Gänze eingestellt wird; oder
(b) bei Auftreten eines Notfalls, in deren Folge die Übertragung der Vermögenswerte der Gesellschaft eines Teilfonds
nicht unter zumutbaren Bedingungen und ohne dabei die Interessen der Aktionäre der Gesellschaft zu verletzen möglich
ist; oder
(c) wenn die Kommunikationsmittel versagen, welche für die Festsetzung des Preises oder Wertes der Anlagen eines
Teilfonds oder für die Festsetzung der aktuellen Preise an den Börsen bzw. Wertpapierbörsen notwendig sind; oder
(d) wenn die Überweisung von Geldern im Zusammenhang mit dem Verkauf von oder Zahlung von, Anlagen eines
Teilfonds nicht möglich ist oder nicht zu den üblichen Preisen oder Wechselkursen möglich ist; oder
(e) nach Meinung der Direktoren ungewöhnlichen Bedingungen, in denen es unmöglich oder gegenüber den Aktio-
nären nicht vertretbar wäre, den Handel mit Aktien eines Teilfonds fortzusetzen; oder
(f) im Falle eines Beschlusses, die Gesellschaft aufzulösen, ab (einschließlich) dem Tag der Veröffentlichung der ersten
Ankündigung zur Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre zu diesem Zwecke.
(g) bei Einstellung der Handelstätigkeit gemäß Artikel 27.
Aktionäre, welche die Rücknahme ihrer Aktien beantragt haben, werden von einer solchen Suspendierung unterrich-
tet und von der Aufhebung derselben unverzüglich in Kenntnis gesetzt.
Eine solche Suspendierung für einen Teilfonds hat keinerlei Auswirkungen auf die Berechnung des Nettoinventarwer-
tes sowie auf Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Aktien eines anderen Teilfonds.
Art. 23. Berechnung des Nettoinventarwertes. Der Nettoinventarwert einer jeden Aktienklasse innerhalb ei-
nes jeden Teilfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds als eine pro Aktien Zahl angegeben und wird,
falls anwendbar, innerhalb eines Teilfonds in der Rechnungseinheit der jeweiligen Aktienklasse innerhalb dieses Teilfonds
angegeben. Dieser Wert wird an jedem Bewertungstag dadurch ermittelt, dass das Vermögen der Gesellschaft, welches
der jeweiligen Aktienklasse innerhalb des jeweiligen Teilfonds zuzuordnen ist, abzüglich der dieser Aktienklasse inner-
51523
halb des jeweiligen Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten, durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien dieser Ak-
tienklasse dividiert wird.
Der Nettoinventarwert einer Aktie eines jeden Teilfonds wird wie folgt ermittelt:
A. Die Vermögenswerte jedes Teilfonds der Gesellschaft umfassen:
(a) sämtliches Bargeld und alle in bar ausstehenden Forderungen oder Guthaben, einschließlich aufgelaufener Zinsen;
(b) sämtliche Wechsel und Zahlungsforderungen sowie alle fälligen Beträge (einschließlich der Erträge aus verkauften,
aber noch nicht bezahlten Wertpapieren);
(c) alle Wertpapiere, Aktien, Schuldverschreibungen, Obligationen, Bezugsrechte, Pfandscheine, der Marktwert aus
allen offenen Posten und anderen Kapitalanlagen und Wertpapieren, die der Gesellschaft gehören;
(d) alle Anteile oder Aktien von OGA einschließlich alternativer Anlagefonds;
(e) alle Dividenden und Gewinne, die der Gesellschaft in bar oder Naturalien zustehen in der von der Gesellschaft
bekannten Höhe (die Gesellschaft kann jedoch die Bewertung den Fluktuationen des Börsenkurses von Wertpapieren
infolge von Handelspraktiken wie dem Handel mit Ex-Dividenden oder Ex-Rechten anpassen);
(f) alle aufgelaufenen Zinsen aus verzinslichen Wertpapieren der Gesellschaft mit Ausnahme der im Hauptbetrag sol-
cher Wertpapiere eingeschlossenen Zinsen;
(g) vorläufige Ausgaben der Gesellschaft, sofern diese noch nicht abgeschrieben worden sind und unter der Voraus-
setzung, dass solche vorläufigen Ausgaben direkt vom Kapital der Gesellschaft abgeschrieben werden können; und
(h) alle anderen Vermögenswerte aller Art einschließlich vorausbezahlter Ausgaben.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird folgendermaßen ermittelt:
1. Der Wert von Barbeständen, Guthaben, Wechseln und Zahlungsforderungen, Forderungen, im voraus bezahlten
Ausgaben, Barausschüttungen und wie o.a. deklarierten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht
dem jeweiligen Nennwert, außer es erscheint unwahrscheinlich, daß der Nennwert ganz bezahlt oder erzielt werden
kann, in welchem Fall vom Nennwert ein solcher Betrag abzuziehen ist, daß nach Einschätzung des Verwaltungsrates der
wahre Wert zum Ausdruck kommt;
2. An einer offiziellen Wertpapierbörse notierte oder an einem geregelten oder organisiertem Markt gehandelte
Wertpapiere werden mittels eines Seitens des Verwaltungsrats genehmigten Preisinformationsdienstes auf Basis des zu-
letzt verfügbaren Preises festgesetzt. Wenn diese Preise nicht dem Marktwert entsprechen, werden solche Wertpapie-
re, genauso wie alle Wertpapiere im Portfolio, die nicht gelistet oder gehandelt werden, gemäß dafür angemessenen und
voraussehbaren Verkaufspreisen sorgfältig nach Treu und Glauben unter Aufsicht des Verwaltungsrates bewertet.
3. Anteile oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich alternativer Anlagefonds werden auf
Grundlage ihres letzten ermittelten und verfügbaren Nettoinventarwertes bewertet, (ein offizieller Nettoinventarwert),
oder falls ein solcher Preis nicht marktgerecht ist, dann wird dieser Preis vom Verwaltungsrat auf einer gerechten und
angemessenen Basis festgelegt. Falls eine solcher offizieller Nettoinventarwert nicht zur Verfügung steht, können solche
Anlagen auf Grundlage eines geschätzten Nettoinventarwertes (auf dessen Grundlage normalerweise keine Zeichnungs-
und Rücknahmeanträge von Aktien vorgenommen werden) wie von der jeweiligen Zentralverwaltungsstelle geliefert
und falls ein solcher Preis aktueller als der letzte offizielle Nettoinventarwert ist, bewertet werden. Voraussetzung ist
jedoch, dass der Verwaltungsrat genügend Zusicherung hat, dass die Bewertungsmethode der jeweiligen Zentralverwal-
tungsstelle für einen solchen geschätzten Nettoinventarwert, kohärent mit der Bewertungsmethode für den offiziellen
Nettoinventarwert ist. Wenn jedoch Umstände aufgetreten sind, die einen erheblichen Einfluss auf diesen geschätzten
Nettoinventarwert haben können, wird der Wert einer solchen Anlage so korrigiert, um nach besten Glauben des Ver-
waltungsrates einen solchen Einfluss wiederzuspiegeln.
4. Der Liquidationswert von Optionen und Termingeschäften die auf keiner Börse bzw. einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwal-
tungsrates, auf einer konstanten Basis so wie für einen alle verschieden Arten von Verträgen angewandten Grundlage
festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Termin- oder Optionsgeschäften die auf einer Börse bzw. einem
anderen geregelten Markt gehandelt werden, basiert auf dem zuletzt verfügbaren Abwicklungspreis eines solchen Ge-
schäftes auf der jeweiligen Börse oder geregelten Markt wo dieser Kontrakt gehandelt wird, vorausgesetzt dass, wenn
ein Futures, Termin- oder Optionsgeschäfte nicht an dem jeweiligen Bewertungstag liquidiert werden kann, wird die
Bewertungsgrundlage für ein solches Geschäft vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Bei der Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft, können sich
die Direktoren auf die Bestätigung des Hauptmaklers oder dessen Partners verlassen.
5. Alle andere Wertpapiere und andere Vermögenswerte werden zu ihrem gerechten Marktwert bewertet nach Treu
und Glauben gemäß dem vom Verwaltungsrat ausgestellten Verfahrens.
6. Alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die nicht in derselben Währung wie der Nettoinventarwert
des jeweiligen Teilfonds angegeben sind, werden mittels des Marktkurses bzw. mittels des am Tag und zum Zeitpunkt
der Festsetzung des Nettoinventarwertes der Anteile gültigen Börsenkurses umgerechnet.
Der Verwaltungsrat kann nach seinem eigenen Ermessen andere Bewertungsmethoden einsetzen wenn er erachtet,
dass diese Methoden besser den Wert eines Vermögenswertes widerspiegeln. Für die Einkommens- und Aufwandsrech-
nung werden Rückstellungen gebildet.
Alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten,
B. Die Verbindlichkeiten eines Teilfonds der Gesellschaft enthalten:
(a) sämtliche Schulden, Wechsel und andere fällige Beträge;
(b) alle Geschäftskosten welche folgende Kosten, ohne auf diese beschränkt zu sein, einschließen: die Kosten des An-
lagemanagers, Anlageverwalters, Handelsberaters, die erfolgsbezogene Gebühr, Gebühren und Kosten der Wirtschafts-
prüfer und Buchführer, Gebühren der Depotbank und ihrer Korrespondentsbanken, Kosten der Verwaltungsstelle,
Börsennotierungsagenten, falls anwendbar, Zahlstellen und Vertriebsstellen, Kosten zahlbar an ihre ständigen Repräsen-
51524
tanten in jenen Ländern wo die Gesellschaft oder einer ihrer Teilfonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, sowie
jedem anderen von der Gesellschaft beauftragten Agenten, die Vergütung an die Direktoren und Angestellten der Ge-
sellschaft sowie deren angemessenen Auslagen, Versicherungskosten sowie die vertretbaren Reisekosten in Zusammen-
hang mit Verwaltungsratssitzungen, die Honorare der Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer, die Kosten und Gebühren
in Zusammenhang mit der Anmeldung und fortwährenden Registrierung der Gesellschaft mit jedweder staatlichen Auf-
sichtsbehörden, Werbungs-, Druck-, Berichts, und Veröffentlichungskosten einschließlich der Kosten für die Veröffent-
lichung, die Werbung und den Druck von Prospekten, erläuternden Berichten oder Anmeldeformulare, Steuern und
andere staatliche Kosten, die Kosten um die Aktien der Gesellschaft an einer Wertpapierbörse zu notieren, oder deren
Notierung an einem anderen geregelten Markt, die Kosten der Veröffentlichung des Zeichnungs- und des Rücknahme-
preises, alle anderen Geschäftskosten, einschließlich der Kosten die beim Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten an-
fallen, Zins- und Bankkosten, Maklergebühren, Kosten für Porto, Telefon und Telex;
(c) alle der Gesellschaft bekannten fälligen oder noch nicht fälligen Verbindlichkeiten einschließlich angekündigter,
aber noch nicht ausgezahlter Dividenden;
(d) ein entsprechender, rückgestellter Betrag für am Bewertungstag fällige Steuern sowie andere von den Direktoren
zugelassene und genehmigte Rückstellungen und Reserven; und
(e) aller weiteren Verbindlichkeiten der Gesellschaft aller Art gegenüber Dritten;
(f) im Falle wo eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds zugeschrieben werden kann,
wird diese Verbindlichkeit allen Teilfonds verhältnismäßig zum Nettoinventarwert der jeweiligen Teilfonds zugeschrie-
ben.
Für die Bewertung der Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft alle regulär oder periodisch anfallenden Verwaltungs-
oder andere Kosten für das gesamte Jahr bzw. einen anderen Zeitraum veranschlagen und dann auf den entsprechenden
Berechnungszeitraum proportional verteilen.
C. Es wird für jede Aktienklasse ein Vermögensmasse wie folgt gebildet:
(a) Die Einkünfte aus der Ausgabe von Aktien in jedem Teilfonds sind in den Büchern der Gesellschaft der für diesen
Teilfonds eingerichteten Vermögensmasse auszuweisen und die dort zurechenbaren Vermögenswerten und Verbind-
lichkeiten sowie Einnahmen und Ausgaben sind dieser Vermögensmasse in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
dieses Artikels zuzuteilen.
(b) Wo ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet wird, ist ein solcher abgeleiteter Vermö-
genswert in den Büchern der Gesellschaft derselben Vermögensmasse zuzuteilen wie die Vermögenswerte, von denen
er abgeleitet wurde. Bei Neubewertung eines Vermögenswertes ist die Wertsteigerung bzw. -minderung der entspre-
chenden Vermögensmasse zuzuteilen.
(c) Eine Verbindlichkeit der Gesellschaft, die sich auf einen bestimmten Vermögenswerten eines Teilfonds bezieht,
oder die sich auf eine Maßnahme bezieht, die in Verbindung mit dem Vermögenswert einer bestimmten Vermögensmas-
se ergriffen wurde, ist der entsprechenden Vermögensmasse zuzurechnen;
(d) Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft keiner bestimmten Vermögensmasse zuge-
teilt werden kann, so wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Vermögenswerten gleichmäßig zuge-
teilt, oder soweit der Betrag es erlaubt anteilsmäßig auf den Nettoinventarwert der jeweiligen Vermögensmassen
zugeteilt;
(e) Am Stichtag der Ausschüttung einer Dividende von einer Aktie eines Teilfonds ist der Nettoinventarwert des be-
treffenden Teilfonds um den Betrag einer solchen Dividende zu reduzieren.
Wenn innerhalb der jeweiligen Teilfonds, sowie im Artikel 5 ausführlicher beschrieben, zwei oder mehrere Aktien-
klassen ausgegeben werden, so gelten die oben beschriebenen Verteilungsregeln mutatis mutandis für diese Klassen.
E. Für den Zweck der Bewertung in diesem Artikel gilt folgendes:
(a) Rückzunehmende und auszugebende Aktien sind als vorhanden anzusehen, und bis einschließlich nach dem Schluss
des Bewertungstages an dem die Rücknahme- und Zeichnungsanträge angenommen worden sind und bezahlt bzw. er-
halten wurden, ist der Preis hierfür als eine Verbindlichkeit bzw. eine Einnahme des jeweiligen Teilfonds anzusehen.
(b) Käufe und Verkäufe von Wertpapieren die von der Gesellschaft an einem Bewertungstag gehandelt werden, wer-
den soweit ausführbar berücksichtigt.
Art. 24. Zeichnung von Aktien. Bei Zeichnung von Aktien der Gesellschaft basiert der Verkaufspreis einer Aktie
- wie oben ausgeführt - auf dem Nettoinventarwert pro Aktie einer jeden Aktienklasse innerhalb des betreffenden Teil-
fonds zuzüglich einer Zeichnungsgebühr (falls vorgesehen und über die Höhe derselben Verwaltungsrat entscheidet) und
dem etwaigen Honorar, das den an der Aktienverkauf aktiv beteiligten Personen aus den Verkaufsumsätzen zu bezahlen
ist (welches die in den entsprechenden Gesetzen vorgesehenen Beträge nicht überschreiten soll). Der so ermittelte
Preis (Ausgabepreis) ist in einer von den Direktoren festgesetzten Zeitspanne zahlbar, die nicht länger als zehn Bankar-
beitstage nach Zuteilung der Aktien sein darf.
Der Verwaltungsrat kann Beschränkungen hinsichtlich der Frequenz mit welcher Aktien einer jeden Aktienklasse aus-
gegeben werden vorsehen, der Verwaltungsrat kann insbesondere vorsehen, dass Aktien einer jeden Aktienklasse in-
nerhalb von einer oder mehreren Ausgabeperioden angeboten werden, innerhalb einer solchen Periodizität oder bis zu
einem gewissen Betrag wie vom Verwaltungsrat hinsichtlich eines jeden Teilfonds bestimmt, und wie weiter in den Ver-
kaufsunterlagen beschrieben.
Der Ausgabepreis kann, nach Genehmigung durch den Verwaltungsrat und unter Einhaltung aller hierbei anwendba-
ren Gesetzen sowie unter Bezugnahme auf einen speziellen Prüferbericht, in welchem der Wert aller Vermögensposten
bestätigt wird, auch durch Einbringung von solchen Sachwerten in den Aktienbestand der Gesellschaft bezahlt werden,
die vom Verwaltungsrat im Einklang mit den Anlagestrategien und -beschränkungen der Gesellschaft hierfür akzeptiert
werden.
51525
Art. 25. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am ersten Tag des Monats Januar des
betreffenden Jahres und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD erstellt.
Art. 26. Ausschüttung. Auf Vorschlag des Verwaltungsrates ist im Rahmen einer Aktionärsversammlung des je-
weiligen Teilfonds zu entscheiden, wie der Jahresertrag des jeweiligen Teilfonds verwendet werden soll. Die Gesell-
schaftserträge können unter Beibehaltung des in Artikel 5 der vorliegenden Satzung näher ausgeführten Mindestkapitals
der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
Auf Beschluss des Verwaltungsrates können auf Aktien eines Teilfonds Zwischendividenden ausgezahlt werden.
Die angekündigten Dividenden werden im Normalfall in der Währung des entsprechenden Teilfonds ausgezahlt oder
aber in einer vom Verwaltungsrat entsprechend gewählten Währung. Ort und Zeit der Auszahlung wird von den Ver-
waltungsratsmitgliedern bestimmt. Die Direktoren legen weiter den Wechselkurs für die Übertragung der Dividenden
in die entsprechende Währung endgültig fest.
Der Verwaltungsrat kann entscheiden, dass innerhalb eines einzigen Teilfonds zwei Aktienklassen angeboten werden,
wobei die eine Klasse durch thesaurierende Aktien und die andere Klasse durch Ausschüttungsaktien dargestellt wird.
Für die thesaurierenden Aktien werden keine Dividenden wie vorher beschrieben ausgeschüttet.
Art. 27. Einstellung des Handels. Ausgabe, Rücknahme und Umwandlung von Aktien eines Teilfonds werden so-
fort eingestellt, wenn der betreffende Teilfonds Handelsverluste erleidet, bei denen der Nettoinventarwert einer Aktie
dieses Teilfonds um mehr als 50% des zuletzt höchsten Nettoinventarwertes fällt. In solchen Fällen werden bis zur Ab-
haltung der im folgenden Absatz beschriebenen Aktionärsversammlung alle bestehenden Kontrakte und Optionen liqui-
diert und jede weitere Handelstätigkeit eingestellt.
Kommt es infolge einer solchen Maßnahme zu einer Suspendierung der Geschäfte, so werden alle Aktionäre des be-
treffenden Teilfonds innerhalb von 40 Tagen nach dieser Suspendierung zu einer Sondersitzung einberufen, um mit einer
3/4-Mehrheit der ausgegebenen Aktien des Teilfonds über eine mögliche Schließung oder Verschmelzung desselben mit
einem anderen Teilfonds zu entscheiden. Wird von den Aktionären ein Weiterbestehen bzw. eine Verschmelzung be-
schlossen, so erfolgt die unmittelbare Aufhebung der Suspendierung.
Art. 28. Auflösung der Gesellschaft und Beendigung oder Verschmelzung von Teilfonds. Im Falle einer
Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche physische oder juri-
stische Personen sein können), welche im Rahmen einer Aktionärsversammlung ernannt werden und deren Vollmachten
und Honorare hierbei festzulegen sind. Der Nettoerlös aus der Liquidation einer bestimmten Aktienklasse innerhalb
eines Teilfonds ist durch die Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis ihres Aktienbesitzes am entsprechenden Teil-
fonds zu verteilen.
Beträge, die von den Aktionären bis zum Ende des Liquidationsverfahrens nicht beansprucht werden, sind treuhändig
bei der Caisse des Consignations zu hinterlegen. Entsprechend den Bestimmungen des Luxemburgischen Rechts verfal-
len die vom Treuhänder nicht fristgerecht geforderten Summen.
Im Falle wo und unabhängig vom Grund, das Nettovermögen eines Teilfonds oder einer Aktienklasse unter oder die
Mindestgröße, wie vom Verwaltungsrat hinsichtlich eines jeden Teilfonds oder Aktienklasse festgelegt, gefallen ist bzw.
nicht erreicht hat, oder falls der Verwaltungsrat es für angebracht hält auf Grund der Veränderung der wirtschaftlichen
und politischen Umfeldes, welche den entsprechenden Teilfonds betreffen, oder Aufgrund von wirtschaftlichen Einspa-
rungsmaßnahmen, kann der Verwaltungsrat alle ausstehenden Aktien des betroffenen Teilfonds oder der betroffenen
Aktienklasse an dem Bewertungstag an dem die Entscheidung wirksam wird zurückkaufen.
Unter den selben Umständen wie im oberen Absatz beschrieben, kann der Verwaltungsrat entscheiden, verschiedene
Teilfonds oder Aktienklassen mit anderen Teilfonds oder Aktienklassen der Gesellschaft oder mit einem anderen Lu-
xemburger Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zu verschmelzen.
Unabhängig der auf den Verwaltungsrat, innerhalb des oberen Absatzes, zugeteilten Befugnissen, kann eine Beendi-
gung eines Teilfonds, oder einer Aktienklasse mit Zwangsrückkauf aller ausstehenden Aktien oder einer Verschmelzung
mit einem anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienklasse der Gesellschaft oder mit einem anderen Luxemburger
OGA, in allen anderen Umständen durch die Aktionäre des Teilfonds oder der Aktienklasse welche aufgelöst oder ver-
schmolzen werden soll, auf einer ordnungsgemäß einberufenen Versammlung der Aktionäre dieses Teilfonds oder die-
ser Aktienklasse beschlossen werden. Eine solche Versammlung kann ohne Mindestanwesenheit stattfinden und die
Entscheidungen werden mit einer Mehrheit von 50% der zugegenen oder vertretenen Aktionären genommen.
Eine Beendigung welche durch Beschluss des Verwaltungsrates oder durch Annahme der Aktionäre beschlossen wur-
de, wird den Aktionären des jeweiligen Teilfonds oder Aktienklasse vor dem Inkrafttreten des Zwangsrückkaufs bekannt
gegeben. Diese Bekanntmachung wird die Ursache und die Vorgehensweise des Zwangsrückkaufs erläutern. Die Gesell-
schaft wird die Inhaber von Inhaberaktien, falls es solche gibt, durch Veröffentlichung einer Anzeige in den vom Verwal-
tungsrat zu bestimmenden Zeitungen informieren, außer die Gesellschaft verfügt über die Adresse aller solcher
Aktionäre. Bis zum Datum des Zwangsrückkaufs, können die Aktionäre des jeweiligen Teilfonds oder Aktienklasse den
Rückkauf ihrer Aktien, ohne Rücknahmegebühr, jedoch unter Einberechnung des aktuellen Veräußerungspreises und
Gebühren, anfordern, außer es wird im Interesse der Aktionäre oder um eine Gleichstellung aller Aktionäre zu gewäh-
ren anders beschlossen.
Eine Verschmelzung welche durch Beschluss des Verwaltungsrates oder durch Annahme der Aktionäre des entspre-
chenden Teilfonds oder der entsprechenden Aktienklasse beschlossen wurde, ist 30 Tage ab Ankündigung derselben für
alle Besitzer von Aktien des betroffenen Teilfonds oder Aktienklasse bindend. In diesem Zeitraum können Aktienbesit-
zer ihre Aktien ohne zusätzliche Gebühr zur Rücknahme einreichen, (jedoch unter Einberechnung des aktuellen Veräu-
ßerungspreises und Gebühren) außer anderswertig, im Interesse der Aktionäre oder um eine Gleichstellung aller
Aktionäre zu gewähren, beschlossen. Die Gesellschaft wird die Inhaber von Inhaberaktien, falls es solche gibt, durch Ver-
51526
öffentlichung einer Anzeige in den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Zeitungen informieren, außer die Gesellschaft
verfügt über die Adresse aller solcher Aktionäre.
Beträge die bei der Auflösung eines Teilfonds nicht von den Aktionären angefordert worden sind werden ab dem
Datum der Schließung der Auflösungsoperationen bei der Depotbank für einen Zeitraum von nicht mehr als sechs Mo-
nate hinterlegt ab. Nach diesem Zeitraum werden die Beträge bei der Caisse de Consignations hinterlegt.
Art. 29. Satzungsänderung. Die vorliegende Satzung kann im Rahülen einer Aktionärsversammlung unter Einhal-
tung des nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mindestanwesenheits- und der Mehrheitsbestimmungen abgeän-
dert werden.
Jedwede Änderung die die Rechte der Aktieninhaber einer bestimmten Klasse gegenüber denen einer anderen Akti-
enklasse betrifft, muss den oben erwähnten Mindestanwesenheits- und Mehrheitsbestimmungen innerhalb einer jeden
betroffenen Aktienklasse entsprechen.
Art. 30. Alle in dieser Satzung nicht erfassten Belange sind in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften samt dessen Novellen und dem Gesetz. zu behandeln.
Der unterzeichnete Notar, der englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen des vorerwähnten
Komparenten die vorliegende Urkunde in englisch abgefaßt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersu-
chen des genannten Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekamst, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Begat, Fernandes, Becker, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 10, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084110.3/202/1298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.
CADIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.329.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03557, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068380.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
RQ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 97.517.
—
<i>Extrait rectificatif des résolutions de l’unique associé, daté du 9 août 2004i>
Suite à une modification dans la décision de l’Unique Associé de RQ LUXEMBOURG, S.à r.l. la «Société», l’extrait
des résolutions de l’Unique Associé enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004 sous la référence LSO-AT02123 sera mo-
difié comme suit:
L’Associé Unique de la «Société», a donc décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, né le 3 février 1968 à Tortola (Iles Vierges Britanniques), avec
adresse professionnelle, au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction de gérant et ce avec effet au 4 août 2004;
- de donner décharge au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer Monsieur Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort (Pays-Bas), avec adresse professionnelle,
au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en qualité de gérant de la société et ce avec effet au 4 août 2004.
Le Conseil de gérance se compose comme suit:
Michel van Krimpen, Gérant
Herman Boersen, Gérant
Luxembourg, le 9 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02927. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067898.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2004.
Senningerberg, den 15. Oktober 2004.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 18 août 2004.
CADIMEX HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
51527
PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 79.214.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2004 que:
- Le siège social est transféré au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg;
- les démissions de Maître Victor Elvinger, de Maître Geert de Neef et de Monsieur Christian Master en tant qu’Ad-
ministrateurs sont acceptées;
- la démission de la société CORAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED en tant que commissaire aux comptes
est acceptée;
- Messieurs Bart Zech, Patrice Gallasin et Roeland P. Pels, ayant comme adresse professionnelle 12, rue Léon Thyes
à L-2636 Luxembourg, sont élus nouveaux Administrateurs. Ils termineront le mandat des Administrateurs précédents,
soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2009.
- La société ELPERS & CO REVISEUR D’ENTREPRISES, ayant son siège social au 11, bd. du Prince Henri à L-1724
Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes pré-
cédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2009.
Luxembourg, le 22 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067710.3/724/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2004.
ZIDCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 102.430.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques ZAGADIR INTERNATIONAL LTD, avec siège social à Road
Town Tortola, R.G. Hodge Plazza 2nd floor, Upper Main Street, Wickhams Cay numéro 1 (Iles Vierges Britanniques),
inscrite au Registre de Commerce de Tortola (Iles Vierges Britanniques) sous le numéro 534953,
ici dûment représentée par Maître Eyal Grumberg, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée.
2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, né à Jérusalem (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-
6, avenue de la Gare.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ZIDCOM INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous immeubles, droits immobiliers et tous brevets et autres
droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Pour extrait conforme
B. Zech
51528
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix euros (310,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’Article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un des administrateurs de la société ou par la seule signa-
ture de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
51529
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Eyal Grumberg, avocat, né à Jérusalem (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6,
avenue de la Gare;
b) Maître Nicolas Bannasch, avocat, né à Wuppertal (Allemagne), le 17 octobre 1964, demeurant à L-1610 Luxem-
bourg, 4-6, avenue de la Gare;
c) Mademoiselle Stéphanie Collmann, avocat, née à Creutzwald, (France), le 16 janvier 1977, demeurant à L-1610
Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Pascal Wagner, comptable, né à Pétange, le 8 février 1966, demeurant à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-
Baptiste Gillardin.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2010.
5.- Le siège social est établi à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Grumberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 août 2004, vol. 527, fol. 85, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069493.3/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
GLENDORN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 95.517.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16 août 2004i>
1. Il résulte d’une lettre envoyée à la société en date du 15 août 2004 que Mademoiselle Beatriz Gonzáles Raposo a
démissionné de sa fonction d’administrateur de la société.
2. Le Conseil d’Administration décide la cooptation de Monsieur Mamadou Pene, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonction d’administrateur de la société.
Luxembourg, le 16 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03852. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068539.3/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques ZAGADIR INTERNATIONAL LTD, préqualifiée,
quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Maître Eyal Grumberg, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Junglinster, le 16 août 2004.
J. Seckler.
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
51530
ANINE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 59.196.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale du 12 août 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour
leurs fonctions durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale du 12 août 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge
pour sa fonction durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale ordinaire du 12 août 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.
Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
Luxembourg, le 12 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03227. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067810.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2004.
FEU D’ARTIFICE ANDRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7595 Reckange/Mersch, 45, route Principale.
R. C. Luxembourg B 102.431.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le douze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Dominique Gossart, employé privé, né à Tournai (Belgique), le 19 mai 1965, demeurant à B-6700 Arlon,
71, avenue Victor Tesch (Belgique).
2.- La société à responsabilité limitée MGI LUXEMBOURG, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon,
(R. C. Luxembourg section B numéro 20.114),
ici dûment représentée par son gérant Monsieur Dominique Gossart, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FEU D’ARTIFICE ANDRE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Reckange/Mersch.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la vente de gadgets, location de conteneurs, commerce et location de tentes et de
chapiteaux, commerce d’articles d’art de table et de décoration, organisation de manifestations culturelles et de feux
d’artifice, vente d’articles pyrotechniques et d’accessoires.
La société a en outre pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
<i>Pour ANINE
Société Anonyme Holding
i>Signature
51531
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 13.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
51532
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Joé André, employé, né à Ettelbrück, le 24 mars 1947, demeurant à L-7515 Mersch, 1, rue Comte Jean-
Frédéric d’Autel.
b) Madame Josée Muller, ouvrière, née à Luxembourg, le 18 mars 1957, demeurant à L-7595 Reckange/Mersch, 43,
rue Principale.
c) Madame Monique Felgen, ouvrière, née à Pétange, le 12 avril 1963, demeurant à L-7570 Mersch, 41, rue Nicolas
Welter.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE, ayant son siège social à L-1150
Luxembourg, 84, route d’Arlon, (R. C. Luxembourg section B numéro 44.696).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2010.
5.- Le siège social est établi à L-7595 Reckange/Mersch, 45, rue Principale.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société Monsieur Joé André, préqualifié, lequel pourra engager la société en toutes circonstan-
ces sous sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Gossart, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 août 2004, vol. 527, fol. 88, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069494.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
FINANCIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 36.081.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03611, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068372.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
1. La société à responsabilité limitée MGI LUXEMBOURG,
avec siège social L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon,
(R. C. Luxembourg section B numéro 20.114), trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. M. Dominique Gossart, employé privé, né à Tournai (Belgique), le 19 mai 1965,
demeurant à B-6700 Arlon, 71, avenue Victor Tesch (Belgique), une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Junglinster, le 23 août 2004.
J. Seckler.
Luxembourg, le 18 août 2004.
<i>Pour FINANCIERE DES ALPES S.A. (en liquidation)
i>M
e
F. Entringer
<i>Liquidateuri>
51533
BARFI, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 44.051.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale du 12 août 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour
leurs fonctions durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale du 12 août 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge
pour sa fonction durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale ordinaire du 12 août 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.
Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
Luxembourg, le 12 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03228. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067811.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2004.
AD CONSULTING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 102.433.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Alain Depluvrez, informaticien, né à Mons, (Belgique), le 9 août 1972, demeurant à L-7258 Helmsange, 2,
rue des Pommiers.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée qu’il constitue par la présente:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de AD CONSULTING INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet la gestion de salles de séminaires, l’organisation de formations et d’évènements spor-
tifs, ludiques et éducatifs.
La société a en outre pour objet la consultance et le développement d’informatique, de multimédia et de télécom-
munication.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Helmsange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.
<i>Pour BARFI
Société Anonyme Holding
i>Signature
51534
Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Alain Depluvrez, informaticien, demeurant à L-
7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions Générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.
51535
<i>Résolutions prises par l’Associé uniquei>
Et aussitôt l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris les réso-
lutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Alain Depluvrez, informaticien, né à Mons, (Belgique), le 9 août 1972, demeurant à L-7258 Helmsange, 2,
rue des Pommiers.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Depluvrez, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 août 2004, vol. 527, fol. 86, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069504.3/231/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
KIWI II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 74.998.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du
28 mai 2004, que:
- le bilan et compte de pertes et profits (comptes consolidés) au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l’Assem-
blée générale,
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat au 31 décembre 2003.
- les mandats d’administrateur de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de
la Vallée L-2661 Luxembourg, de Monsieur Camille Paulus, consultant, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg et de Maître Jean Steffen, avocat-avoué, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la
Vallée L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert comptable,
ayant son adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2004.
Luxembourg le 28 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03319. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067851.3/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2004.
OMNION S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 48.039.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT03011, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068291.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Junglinster, le 23 août 2004.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 16 août 2004.
Signature.
51536
PARIMMO LUX INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 83.668.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le dix août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PARIMMO LUX INVEST S.A. en liquidation,
ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R. C. Luxembourg section B numéro 83.668,
constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 16 août
2001, publié au Mémorial C numéro 189 du 4 février 2002,
et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 juillet 2004, en cours de publication
au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne com-
me secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social de EUR 31.000,- (trente et un mille euros),
divisé en 100 (cent) actions de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune, est représentée à la présente assemblée.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
IV.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2.- Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur.
3.- Décision sur la clôture de la liquidation.
4.- Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’elle a pris connaissance du rapport du commissaire vérificateur sur l’examen des documents
de la liquidation et sur la gestion du liquidateur, et des pièces à l’appui.
Le susdit rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
Il restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui après avoir été signé ne varietur par les comparants et
le notaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction au liquidateur de la société, Monsieur Guillaume Bernard, responsable comptable,
demeurant à Metz (France).
Décharge pleine et entière est également accordée au commissaire vérificateur.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme PARIMMO LUX INVEST S.A.
en liquidation, avec siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, a cessé d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une période de cinq années
au siège social.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cents euros, sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Dostert, A. Thill, F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 août 2004, vol. 527, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069439.3/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
Junglinster, le 23 août 2004.
J. Seckler.
51537
DEVANA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 60.665.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale du 12 août 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour
leurs fonctions durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale du 12 août 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge
pour sa fonction durant l’exercice clos au 31 décembre 2003.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale ordinaire du 12 août 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.
Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
Luxembourg, le 12 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067814.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2004.
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.471.
—
L’an deux mille quatre, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNION BANCAIRE PRI-
VEE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, (R. C. Luxembourg sec-
tion B numéro 9.471), constituée sous la dénomination sociale de DISCOUNT BANK S.A. suivant acte reçu par Maître
Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 1971, publié au Mémorial C numéro 34 du
15 mars 1971,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 2 mai 1986, publié au Mémorial C numéro 218 du 2 août 1986;
- en date du 8 mai 1987, publié au Mémorial C numéro 244 du 5 septembre 1987;
- en date du 19 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 96 du 12 avril 1989;
- en date du 19 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 209 du 26 juin 1990;
- en date du 4 mai 1990, publié au Mémorial C numéro 414 du 10 novembre 1990;
- en date du 26 avril 1991, publié au Mémorial C numéro 409 du 26 octobre 1991;
- en date du 6 mai 1993, publié au Mémorial C numéro 383 du 23 août 1993;
- en date du 28 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 116 du 24 février 1999,
- en date du 22 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 15 du 6 janvier 2000,
- en date du 7 février 2003, publié au Mémorial C numéro 292 du 19 mars 2003; contenant notamment le changement
de la dénomination sociale en UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.;
- en date du 6 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 421 du 17 avril 2003,
ayant un capital social de trente-cinq millions euros (35.000.000,- EUR), divisé en cent quarante mille (140.000) ac-
tions de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune, après conversion décidée par l’assemblée générale extraordi-
naire du 13 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 225 du 1
er
avril 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Benzeno, administrateur-délégué, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Vérane Waltregny, adjoint à la direction, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateurs:
1.- Monsieur Jean-Pierre Schalik, cadre, demeurant professionnellement à Luxembourg, et
2.- Monsieur Eric Stilmant, membre de la direction, demeurant professionnellement à Luxembourg.
<i>Pour DEVANA S.A.
Société Anonyme Holding
i>Signature
51538
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de EUR en CHF, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2004.
3.- Réduction du capital souscrit par remboursement aux actionnaires d’un montant de 34.545.000,- CHF, en vue de
ramener le capital social souscrit de 54.565.000,- CHF à 20.020.000,- CHF par remboursement aux actionnaires et sans
réduire le nombre des actions, mais en réduisant le pair comptable des actions représentatives du capital social.
4.- Remplacement des 140.000 actions existantes sans expression de valeur nominale par 140.000 actions d’une va-
leur nominale de 143,- CHF chacune.
5.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
6.- Réduction de la réserve légale.
7.- Nominations statutaires.
8.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent quarante mille (140.000) actions représentant le capital
social de trente-cinq millions euros (35.000.000,- EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2004, la devise d’expression du capital social, ac-
tuellement fixé à trente-cinq millions euros (35.000.000,- EUR), pour l’exprimer dorénavant en francs suisses, au cours
du 31 décembre 2003 de 1,559 CHF = 1,- EUR, en cinquante-quatre millions cinq cent soixante-cinq mille francs suisses
(54.565.000,- CHF).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trente-quatre millions cinq cent quarante-cinq mille
francs suisses (34.545.000,- CHF), pour le ramener de son montant actuel de cinquante-quatre millions cinq cent soixan-
te-cinq mille francs suisses (54.565.000,- CHF) à vingt millions vingt mille francs suisses (20.020.000,- CHF) par la réduc-
tion du pair comptable des cent quarante mille (140.000) actions représentatives du capital social.
Cette réduction de capital est réalisée par remboursement du montant de trente-quatre millions cinq cent quarante-
cinq mille francs suisses (34.545.000,- CHF) aux actionnaires.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et
au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après
la publication du présent acte au Mémorial C.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les cent quarante mille (140.000) actions existantes sans expression de valeur no-
minale par cent quarante mille (140.000) actions d’une valeur nominale de cent quarante-trois francs suisses (143,- CHF)
chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq
(5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à vingt millions vingt mille francs suisses (20.020.000,- CHF), repré-
senté par cent quarante mille (140.000) actions d’une valeur nominale de cent quarante-trois francs suisses (143,- CHF)
chacune, entièrement libérées.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire la réserve légale à deux millions deux mille francs suisses (2.002.000,- CHF); le solde
de cette réduction étant remboursé aux actionnaires.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
51539
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph Assaraf, directeur de banque, demeurant à Genève, (Suisse)
comme administrateur et lui exprime sa reconnaissance pour les éminents services rendus à la banque.
La décharge pour l’exécution de son mandat sera prévue à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordi-
naire.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Maurice Benezra, directeur général et membre du Comité exécutif de
Union Bancaire Privée, Genève, né à Milan, (Italie), le 30 septembre 1956, demeurant professionnellement à CH-1204
Genève, 96-98, rue du Rhône, (Suisse), comme administrateur de la société.
Le mandat de l’administrateur ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2003.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée constate que le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
a) Monsieur Andreas Stricker, directeur général et membre du Comité exécutif de Union Bancaire Privée, Genève,
né à Grabs, (Suisse), le 31 mars 1959, demeurant professionnellement à CH-1204 Genève, 96-98, rue du Rhône, (Suis-
se);
b) Monsieur Jacques Benzeno, membre de la direction générale, né à Meknes, (Maroc), le 1 mars 1941, demeurant
professionnellement à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal;
c) Monsieur Maurice Benezra, directeur général et membre du Comité exécutif de Union Bancaire Privée, Genève,
né à Milan, (Italie), le 30 septembre 1956, demeurant professionnellement à CH-1204 Genève, 96-98, rue du Rhône,
(Suisse);
d) Monsieur Alex Schmitt, avocat, né à Luxembourg, le 24 mars 1953, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de
la Vallée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille huit cents euros.
Pour les besoins de l’enregistrement la réduction de capital social est évaluée à la somme de 22.158.434,89 EUR.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Benzeno, V. Waltregny, J.-P. Schalik, E. Stilmant, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 janvier 2004, vol. 525, fol. 81, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069384.3/231/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.
HESPERKUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.579.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 août 2004i>
Les associés de la société à responsabilité limitée HESPERKUTSCH, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraor-
dinaire au siège social le 11 août 2004, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Oronzo Lobefaro, employé privé, demeurant à L-2310 Luxembourg, 4A, avenue Pasteur,
de son poste de gérant de la société est acceptée.
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
- Est nommé gérant en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Donato Polluce, cuisinier, demeurant à L-
3510 Dudelange, 2, rue de la Libération.
- Le nouveau gérant déclare accepter son mandat.
La société reste engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Luxembourg, le 11 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02818. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(068647.3/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Junglinster, le 16 août 2004.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signatures
51540
GLOVER INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 81.942.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 6 août 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GLOVER INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A. (la «Socié-
té»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 26.942,82 dans le compte perte à reporter;
- de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée pour 2001 excédant 75% du capital souscrit;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-
rations effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 6 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02934. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067899.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2004.
SQHEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 80.218.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 2002i>
Ratification de la nomination de Christel Girardeaux au poste d’administrateur de la société.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2006.
Luxembourg, le 6 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02977. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068285.3/655/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
SUTTON B. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.743.
—
Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 25 février 1998 que Monsieur Hans Dermont, expert-comptable,
demeurant à CH-6984 Canobbio, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de Madame Brigitte
Schädler.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT03004. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068298.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
EURO LES TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 99.186.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068356.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
Certifié sincère et conforme
SQHEX S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 août 2004.
Signature.
Signature.
51541
LYSANDRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 34.808.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société en date du 2 août 2004i>
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 est reportée à une date
ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 2 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02960. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068353.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
BANBURY CROSS DC1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Münsbach.
R. C. Luxembourg B 86.126.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
(068354.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
HELLABY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 65.990.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société en date du 8 juillet 2004i>
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02959. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068357.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
C.I.P.A.F. S.A., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS BANCAIRES ET
FINANCIERES, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.823.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 14 mai 2001i>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-Pierre Laurent-Josi datée du 9 janvier 2001. Il n’a pas pourvu à
son remplacement.
Le Conseil d’Administration est à ce jour composé de huit membres.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07722. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(068393.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
51542
IMMOBAUWERKE S.A., Société Anonyme,
(anc. RIMALEX S.A.H.)
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 45.438.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 16 décembre 1993.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05519, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068404.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
IMMOBAUWERKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 45.438.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 16 décembre 1993.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06630, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068406.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
IMMOBAUWERKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 45.438.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 16 décembre 1993.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06632, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068408.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
IMMOBAUWERKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 45.438.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 16 décembre 1993.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06635, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068409.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
IFIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03564, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068378.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
<i>Pour IMMOBAUWERKE S.A. (anc. RIMALEX S.A.H.)
i>Signature
<i>Pour IMMOBAUWERKE S.A. (anc. RIMALEX S.A.H.)
i>Signature
<i>Pour IMMOBAUWERKE S.A. (anc. RIMALEX S.A.H.)
i>Signature
<i>Pour IMMOBAUWERKE S.A. (anc. RIMALEX S.A.H.)
i>Signature
Luxembourg, le 18 août 2004.
IFIES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
51543
ROFA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 33.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03914, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068405.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
IMMO AL35/37, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 95.447.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03648, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068407.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
IMMO PDP2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 95.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03642, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068412.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
I.V.B. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 34.873.
Acte de constitution publié au Mémorial C, le 23 février 1991.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06626, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068420.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
MURFET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.149.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société en date du 10 août 2004i>
- La délibération sur les comptes annuels aux 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décem-
bre 2002 et 31 décembre 2003 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02961. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068360.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Luxembourg, le 16 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 19 août 2004.
F. Hamen / G. Schmitt.
Luxembourg, le 19 août 2004.
F. Hamen / G. Schmitt.
<i>Pour I.V.B. S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
51544
BALUIKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.137.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société en date du 10 août 2004i>
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 est reportée à une date
ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 10 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02962. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068363.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 62.931.
—
In the year two thousand four, on the eleventh of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., with
registered office in L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, incorporated by deed of the notary public Alphonse
Lentz, dated January 26th, 1998, published in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 313 of May
6th,1998, amended by a deed of the same notary, dated February 25th, 1998, published in Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C number 391 of May 29th 1998 and by a deed of the same notary, dated June 2nd, 1998 published in
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 598 of August 18th, 1998, amended by a deed of the notary
public Joseph Elvinger dated March 10th 2000, published in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number
471 of July 4th, 2000, and amended by a deed of the same notary, dated January 7th 2002, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations C number 249 of March 7th 2003.
The meeting is presided by Maître Marianne Goebel, attorney at law, residing in Luxembourg, who appoints as sec-
retary Maître Eric Pralong, attorney at law, residing in Luxembourg. The meeting elects as scrutineer Mr Guillaume de
Villenaut, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record
that:
I. The present Extraordinary General Meeting of shareholders has been convened by notices published in:
1) the «Luxemburger Wort», on May 25th, 2004 and June 3rd, 2004;
2) the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 538 dated May 25th, 2004 and number 569 dated
June 3rd, 2004.
Evidences of such publications have been presented to the meeting.
II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary, will
be registered with this deed together with the proxies signed ne variatur by the office and the notary.
III. It appears from the attendance list that 27,766 shares out of a total of 30,000 shares are present or represented.
The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. Dissolution and liquidation of the company
2. Nomination of a liquidator of the company
3. Determination of the powers conferred upon the liquidator
4. Miscellaneous.
V. After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously took the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to appoint as liquidator, Mr Patrizio Ziggiotti, economist, residing in Milano (Italy).
<i>Third resolutioni>
The liquidator has the broadest powers for the exercise of his mission, especially those indicated in articles 144 to
148 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
51545
The document having been read to the appearing persons, they signed with Us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same persons
and in case of any divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le onze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WORLD FASHION IN-
TERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu
par le Notaire Alphonse Lentz, en date du 26 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 313 du 6 mai 1998, modifié suivant acte du même Notaire, en date du 25 février 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 391 du 29 mai 1998, et suivant acte du même Notaire, en date du 2 juin
1998 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 598 du 18 août 1998, modifié suivant acte
reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 10 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 471 du 4 juillet 2000 et modifié et suivant acte du même Notaire, en date du 7 janvier 2002 publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 249 du 7 mars 2003.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui dési-
gne comme secrétaire Maître Eric Pralong, avocat, demeurant à Luxembourg. L’assemblée choisit comme scrutateur
Monsieur Guillaume de Villenaut, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée par des convocations publiées
dans:
1) le journal «Luxemburger Wort» du 25 mai 2004 et du 3 juin 2004
2) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 538 du 25 mai 2004 et numéro 569 du 3 juin 2004.
Les preuves de ces publications sont déposées sur le bureau de l’Assemblée.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que 27.766 actions sur un total de 30.000 actions sont présentes ou repré-
sentées. Dès lors, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour.
IV. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Dissolution et liquidation de la société
2. Nomination d’un liquidateur de la société
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur
4. Divers.
V. Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur de la société, Monsieur Patrizio Ziggiotti, économiste, demeurant
à Milan (Italie).
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-
ticles 144 à 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès verbal passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Et après lecture faite ils ont tous signés avec
Nous, Notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et qui parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants,
le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la requête des mêmes compa-
rants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Signé: M. Goebel, E. Pralong, G. de Villenaut, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, vol. 21CS, fol. 43, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068146.3/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.
Luxembourg, le 30 juin 2004.
J. Elvinger.
51546
IMMO PDP4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 95.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03634, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068421.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
DOUGLAS & BIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.841.
Acte de constitution publié au Mémorial C le 10 avril 2000.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05522, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068422.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
WORLD BUSINESS TECHNOLOGY W.B.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 86.392.
Acte de constitution publié au Mémorial C le 12 juin 2002.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05527, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068425.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
MOBILITY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 73.861.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03907, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068430.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
ROERMOND HOLDING (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.836.
—
EXTRAIT
<i>Commissaire aux comptes:i>
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 août 2004, le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de com-
missaire aux comptes de la société a été reconduit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire décidant de l’approbation des
comptes annuels de l’année sociale se terminant au 31 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03936. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068658.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Luxembourg, le 19 août 2004.
F. Hamen / G. Schmitt.
<i>Pour DOUGLAS & BIX S.A.
i>Signature
<i>Pour WORLD BUSINESS TECHNOLOGY W.B.T. S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 11 août 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
51547
CAVES BERNARD-MASSARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Grevenmacher, 6-8, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 4.057.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04064, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068432.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 52.915.
—
Le bilan de la maison mère LANDESBANK SAAR au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004,
réf. LSO-AT03637, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068434.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.178.
—
Avec effet au 28 juillet 2004, Monsieur Gerdy Roose a démissionné de son mandat d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03413. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068438.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.479.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03984, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068468.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
ROERMOND HOLDING (No. 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.296.
—
EXTRAIT
<i>Commissaire aux comptes:i>
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 août 2004, le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de com-
missaire aux comptes de la Société a été reconduit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire décidant de l’approbation des
comptes annuels de l’année sociale se terminant au 31 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03939. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068665.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Luxembourg, le 19 août 2004.
C. Clausse.
Luxembourg, le 19 août 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 août 2004
Signature.
Luxembourg, le 19 août 2004.
BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la Société
i>Signature
51548
LUSANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.484.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03981, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068469.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
SONIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.122.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03978, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068470.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
AP HMGT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.018.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue le 1i>
<i>er i>
<i>juillet 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique d’AP HMGT HOLDING, S.à r.l. (la «Société») qui s’est tenue
le 1
er
juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que
Gérant B de la société, avec effet au 1
er
juillet 2004, et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités
quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1
er
juillet 2004;
- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant
B de la société avec effet au 1
er
juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.
Les gérants sont désormais:
- William S. Benjamin, Gérant A,
- Lee Stuart Neibart, Gérant A,
- M. Hans van de Sanden, Gérant B,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Gérant B.
Luxembourg, le 9 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02711. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068472.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
SHOWTIME INT., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.328.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01492, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068500.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Luxembourg, le 19 août 2004.
LUSANA PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 19 août 2004.
SONIC S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant B
<i>Signaturesi>
Signature.
51549
CLAVITA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 56.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AT03870, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068502.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
EXCLUSIVE AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 90.064.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01484, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068506.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
CORVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 59.993.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AT03880, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068507.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
PACZOWSKI ET FRITSCH ARCHITECTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01490, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068509.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
PRIVILEGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.837.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1
er
juin 2004 que:
Leurs mandats étant arrivés à échéance, Monsieur Germain Turpel, demeurant L-3542 Dudelange, 20, rue du Parc,
Monsieur Jean-Marie Kontz, demeurant L-3348 Dudelange, 36, rue Dicks et Monsieur Adriann de Feijter, directeur, de-
meurant professionnellement à L-2241 Bridel, 4, rue Tony Neuman ont été réélus aux postes d’Administrateur de la
société pour une durée de 5 ans.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04437. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068701.3/1285/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Luxembourg, le 19 août 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 19 août 2004.
Signature.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
51550
I-CORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 41.446.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AT03876, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068512.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
FIGEMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 66.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01113, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(068517.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
TONON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.560.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04144, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068537.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
LIONSGATE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.155.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue le 1i>
<i>er i>
<i>juillet 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de LIONSGATE PROPERTIES, S.à r.l. (la «Société») qui s’est
tenue le 1
er
juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que
Gérant C de la société, avec effet au 1
er
juillet 2004, et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités
quant à l’exercice de son mandat jusqu’à la date du 1
er
juillet 2004;
- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant
C de la société avec effet au 1
er
juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.
Les gérants sont désormais:
- William S. Benjamin, Gérant A,
- Stuart Koenig, Gérant A,
- Maurice M. Benaby, Gérant B,
- Desmond Reoch, Gérant B,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY, Gérant C,
- Hans van de Sanden, Gérant C.
Luxembourg, le 9 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02709. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068474.3/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Luxembourg, le 19 août 2004.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Banque Domiciliataire
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant C
i>Signatures
51551
LILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03850, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068540.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
AXAFIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.322.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03848, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068541.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 58.514.
- La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
18 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 339 du 1
er
juillet 1997.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04107, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068545.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.193.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08484, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(068670.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
PARS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 34.314.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01612, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2004.
(068586.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Luxembourg, le 19 août 2004.
<i>Pour LILUX S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 août 2004.
<i>Pour AXAFIL S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
51552
DAX INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 46.625.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01613, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2004.
(068587.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
ABILENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 79.625.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01614, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2004.
(068589.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
FINAXIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 37.579.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01615, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2004.
(068590.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 65.243.
- La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
18 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 682 du 23 septembre 1998.
—
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04107,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068546.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Quadriga Superfund, Sicav
Cadimex Holding S.A.
RQ Luxembourg, S.à r.l.
Porto F. Investment & Participation S.A.
Zidcom Investments S.A.
Glendorn S.A.
Anine
Feu d’Artifice André S.A.
Financière des Alpes S.A.
Barfi
AD Consulting International, S.à r.l.
Kiwi II Management Company S.A.
Omnion S.A.
Parimmo Lux Invest S.A.
Devana S.A.
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Hesperkutsch, S.à r.l.
Glover International Investments S.A.
SQHEX S.A.
Sutton B. Holding S.A.
Euro Les Tours, S.à r.l.
Lysandre S.A.
Banbury Cross DC1, S.à r.l.
Hellaby S.A.
C.I.P.A.F. S.A., Compagnie Internationale de Participations Bancaires et Financières
Immobauwerke S.A.
Immobauwerke S.A.
Immobauwerke S.A.
Immobauwerke S.A.
Ifies S.A.
Rofa
Immo AL35/37, S.à r.l.
Immo PDP2, S.à r.l.
I.V.B. S.A.
Murfet S.A.
Baluiki S.A.
World Fashion International S.A.
Immo PDP4, S.à r.l.
Douglas & Bix S.A.
World Business Technology W.B.T. S.A.
Mobility International Holding S.A.
Roermond Holding (No. 1), S.à r.l.
Caves Bernard-Massard S.A.
Landesbank Saar Girozentrale
BDO Compagnie Fiduciaire
Bolero International Holding S.A.
Roermond Holding (No. 3), S.à r.l.
Lusana Participations S.A.
Sonic S.A.
AP HMGT Holding, S.à r.l.
Showtime Int., S.à r.l.
Clavita S.A.
Exclusive Automobiles S.A.
Corvin S.A.
Paczowski et Fritsch Architectes, S.à r.l.
Privilège Holding S.A.
I-Corp S.A.
Figemo S.A.
Tonon International S.A.
Lionsgate Properties, S.à r.l.
Lilux S.A.
Axafil S.A.
Security Capital European Services S.A.
Morgan Stanley Asset Management S.A.
Pars Financial S.A.
Dax Investments S.A. Holding
Abilène S.A.
Finaxia S.A.
SC-ER Special Opportunity Holdings S.A.