This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
48577
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1013
12 octobre 2004
S O M M A I R E
ABC CONTAINER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.
R. C. Luxembourg B 69.382.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064317.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.
ABC Container, G.m.b.H., Grevenmacher . . . . . . .
48577
Maxitim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48592
Alpine Copyright, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . .
48599
Moyens et Capitaux Européens S.A., Luxem-
Ardizzone International S.A., Luxembourg . . . . . .
48616
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48620
Bellefontaine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
48620
Opal, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48617
Caeser House S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48611
Panorama, S.à r.l. - Agence de Voyages et de Tou-
Cartola Shipping Investment, S.à r.l., Luxem-
risme, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48592
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48614
Precis Interactive Language Learning, S.à r.l.,
Cartola Shipping Investment, S.à r.l., Luxem-
Weiler-la-Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48612
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48616
Prim Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
48593
CFC Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48616
Promvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48620
Classe Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48609
Quantico Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
48621
Cofima Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48624
Quasar International Holding S.A., Luxembourg .
48621
Crédit Agricole Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . .
48618
Robeco Capital Growth Funds, Sicav, Luxem-
Crédit Agricole Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . .
48622
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48617
Duemme Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48622
Robeco Multimanager Funds, Sicav, Luxembourg
48617
Grossmann Bau, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . .
48608
Samgwym Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48593
Grossmann Bau, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . .
48609
Samgwym Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48598
Halbi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48598
Special Risk Insurance and Reinsurance Luxem-
Halbi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48598
bourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48579
Heralda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48621
Special Risk Insurance and Reinsurance Luxem-
Hines European Value Added Fund . . . . . . . . . . . . .
48578
bourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48578
I.B.F. S.A., Informatique Bancaire et Financière,
Strawberry Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . .
48593
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48621
Timo Lux S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48588
Lecoutere Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
48624
Trust International Luxembourg S.A., Luxem-
Lupico International Holding S.A., Luxembourg . .
48624
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48610
MAURITEL, Société Mauritanienne et Luxem-
Trust International Luxembourg S.A., Luxem-
bourgeoise d’Engineering et de Télécommuni-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48611
tions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48623
VAM Holdings S.A., Dommeldange . . . . . . . . . . . .
48579
Maxitim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48590
Yxsis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48618
Senningerberg, le 29 juillet 2004.
P. Bettingen.
48578
HINES EUROPEAN VALUE ADDED FUND, Fonds Commun de Placement.
—
Le Règlement de Gestion au 15 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01023, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081796.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
SPECIAL RISK INSURANCE AND REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25A, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 86.964.
—
Im Jahre zweitausendvier, den neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre von SPECIAL RISK INSURANCE AND
REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25A, boulevard Royal,
gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, im Amtssitz in Junglinster, am 4. April 2002,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1029 vom 5. Juli 2002,
abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar Paul Decker, am 17. Oktober 2003, veröffent-
licht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1293 vom 4. Dezember 2003,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 86.964.
Die Versammlung wurde eröffnet um 15.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Régis Galiotto, Privat-
beamter, mit Berufsadresse in Luxemburg-Eich.
Der Präsident bestimmte zum Sekretär Dame Danielle Origer, Privatbeamtin, mit Berufsadresse in Luxemburg-Eich.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Dietmar Stenzel, Versicherungsdirektor, wohnhaft in L-2514 Lu-
xembourg, 1, rue J.-P. Sauvage.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft SPECIAL RISK INSURANCE AND REIN-
SURANCE LUXEMBOURG S.A. sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt
sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 30.000.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital dar-
stellen, in gegenwärtiger außerordentlicher Gesellschafterversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versamm-
lung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Kapitalverminderung um das bestehende Kapital von dreihundert Millionen Euro (300.000.000,- EUR) auf dreissig
Millionen Euro (30.000.000,- EUR) herabzusetzen durch Annullierung von 27.000.000 Aktien und Rückzahlung an den/
die Eigentümer der annullierten Aktien. Machend die Nummern 545.456-5.454.545 der ALLIANZ AKTIENGESELL-
SCHAFT, München; die Nummern 6.000.001-10.909.090 der HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGSAKTIENGESELL-
SCHAFT, Hannover; die Nummern 11.454.546-16.363.635 der SWISS REINSURANCE COMPANY, Zürich; die
Nummern 16.909.091-21.818.180 der AKTIENGESELLSCHAFT ASSURICUM, Zürich, die Nummern 22.363.636-
27.272.725 für XL CAPITAL LTD., Grand Cayman; die Nummern 27.545.451 -30.000.000 für SCOR, Paris.)
2.- Abänderung von Artikel 5, Punkt 5.1. der Statuten wie folgt:
In englischer Fassung:
«5.1. The Company has an issued share capital of thirty million Euro (30,000,000.- EUR), divided into three million
(3,000,000) shares, with a par value of ten Euro (10.- EUR) each, (hereafter the «Shares», and each a «Share»).»
In deutscher Fassung:
«5.1 Das gezeichnete Kapital beträgt dreissig Millionen Euro (30.000.000,- EUR) und ist eingeteilt in drei Millionen
(3.000.000) Aktien, jede mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR), (hiernach die «Aktien» oder einzeln eine «Ak-
tie»).»
Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstim-
mig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um zweihundertsiebzig Millionen Euro (270.000.000,- EUR)
herabzusetzen, womit das bestehende Kapital von dreihundert Millionen Euro (300.000.000,- EUR) auf dreissig Millionen
Euro (30.000.000,- EUR) reduziert werden soll.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt nach Ablauf von einem Monat ab Datum der Veröffentlichung gegenwärtiger Ur-
kunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, die Aktien von Nr. 545.456-Nr 5.454.545, Nr 6.000.001-
10.909.090, Nr 11.454.546-16.363.635, Nr 16.909.091-21.818.180, Nr 22.363.636-27.272.725 und die Nr 27.545.451-
30.000.000 des Aktienbuches zu annullieren und den nach Abzug des Verlustbetrages verbleibenden Betrag von 2,12
EUR pro Aktie an die Eigentümer zurückzuzahlen.
<i>Pour HINES FUND MANAGEMENT COMPANY I, S.à r.l.
i>Signature
48579
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst infolgedessen Artikel 5, Punkt 5.1. der Statuten abzuändern wie folgt:
In englischer Fassung:
«5.1. The Company has an issued share capital of thirty million Euro (30,000,000.- EUR), divided into three million
(3,000,000) shares, with a par value of ten Euro (10.-EUR) each, (hereafter the «Shares», and each a «Share»).»
In deutscher Fassung:
«5.1 Das gezeichnete Kapital beträgt dreissig Millionen Euro (30.000.000,- EUR) und ist eingeteilt in drei Millionen
(3.000.000) Aktien, jede mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR), (hiernach die «Aktien» oder einzeln eine «Ak-
tie»).»
Das Kapital wurde zu einem Viertel eingezahlt, machend sieben Millionen fünfhunderttausend Euro (7.500.000,- EUR)
und steht der Gesellschaft zur Verfügung.
Die Aktien bleiben jedenfalls Namensaktien bis zur vollständigen Einzahlung des gezeichneten Kapitals, machend die
Restsumme in Höhe von zweiundzwanzig Millionen fünfhunderttausend Euro (22.500.000,- EUR) welche auf erste An-
frage der Gesellschaft hin eingezahlt werden muss.
Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 15.30 Uhr.
<i>Schätzung der Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 2.000,- EUR.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Galiotto, D. Origer, D. Stenzel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, vol. 22CS, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(080623.3/206/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SPECIAL RISK INSURANCE AND REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.964.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 5 octobre 2004.
(080625.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
VAM HOLDINGS S.A., Société Anonyme,
(anc. VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD).
Registered office: L-1466 Dommeldange, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 103.228.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the thirtieth day of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Narelle Dorothy de Putron, Apartment 42, The President, 2 Alexander Road, 8005 Bantry Bay, South Africa, rep-
resented by Manuèle Biancarelli, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
2) Peter John de Putron, Apartment 42, The President, 2 Alexander Road, 8005 Bantry Bay, South Africa, represented
by Manuèle Biancarelli, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-
ument to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, being the directors of VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD., have requested the notary
to state that:
I. VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. is a company duly registered since May 9, 1995 in the British Virgin Islands
with registered office at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Is-
lands.
Luxemburg-Eich, den 5. Oktober 2004.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
48580
II. The share capital of VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. amounts to fifty thousand US Dollars (USD 50,000)
and is represented by fifty thousand (50,000) shares with a nominal value of one US Dollars (USD 1).
III. AGNEW TRUST, c/o LOMBARD TRUST S.A., CITCO (SUISSE) S.A., 19A, rue de la Croix-d’Or, P.B. 3124, 1211
Geneva 3, Switzerland, is the owner of forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (49,999) shares and Mr Peter
John de Putron, prenamed, is the owner of one (1) share.
IV. Further to a decision of the board of directors of VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. as of 24 June, 2004,
approved thereafter by the shareholders of VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD., resolving, in accordance with
clause 77 of the articles of association, to transfer the registered office to Luxembourg, the registered office of VERITAS
FINANCIAL HOLDINGS LTD. is hereby transferred from Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands to Apartment 17A, 12, rue Jean Engling, L-1466 Dommeldange, Grand-Duché de
Luxembourg, as of the day of this meeting and VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. adopts the Luxembourg na-
tionality as of the same day.
V. Such transfer does not operate dissolution or change in the legal person of VERITAS FINANCIAL HOLDINGS
LTD.
VI. On 24 June 2004, the board of directors of VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. resolved to appoint the fol-
lowing persons as directors of the Luxembourg continued corporation:
- Nigel Kenneth Cayzer, residing Thriepley House, Lundie, Dundee DD2 5PA, Scotland, born on 30 April 1954, Lon-
don, nationality British;
- Peter John de Putron, residing Apartment 42, The President, 2 Alexander Road, 8005 Bantry Bay, South Africa, born
on 11 December 1942, Evesham (UK), nationality British;
- Narelle Dorothy de Putron, residing Apartment 42, The President, 2 Alexander Road, 8005 Bantry Bay, South Af-
rica, born on 4 December 1955, Brisbane (Australia), nationality Australian
- Anthony Charles Galliers-Pratt, c/o VAM Funds plc, St James’s Chambers, Athol Street, Douglas, Isle of Man, British
Virgin Islands, born on 15 December 1958, London, nationality British.
VII. On 24 June 2004, the board of directors of VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. resolved to restate the ar-
ticles of association of VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. in order to comply with the Luxembourg law, which
shall henceforth read as follows:
«Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of VAM HOLDINGS S.A. (the «Corporation»).
Art. 2. Duration
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-
lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof.
Art. 3. Object
The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open
to the public. The Corporation may however participate in the establishment and development of any industrial or com-
mercial enterprises and may render to companies in which it has a material interest every assistance whether by way of
loans, guaranties or otherwise.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. The Corporation may
lend the proceeds of such borrowings or bond issues to any company in which it has a material equity interest and may
give security for any borrowings or bond issues of such companies.
Within the limits provided by applicable laws and regulations, the Corporation may hold interests in limited partner-
ships.
In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-
lished by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.
Art. 4. Registered office
The registered office of the Corporation is established in Dommeldange, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred within the same commune by decision of the board of directors. Branches or other
offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. Capital - Shares and share certificates
The subscribed capital of the Corporation is fifty thousand US Dollars (USD 50,000) divided into fifty thousand
(50,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) per share.
Shares will be in registered form.
48581
All issued shares of the Corporation shall be registered in the register of shareholders which shall contain the name
of each holder of registered shares, his residence or elected domicile, the number of shares held by him and the amount
paid in on each such share.
Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-
fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.
The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 6. Increase of capital
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-
ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.
Furthermore the board of directors of the Corporation is authorized and instructed to issue future shares up to the
total authorized capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine, within a period ex-
piring on the fifth anniversary of the publication of the present Articles of Incorporation in the Mémorial by deciding the
issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting subscriptions for such shares from time to
time. The board of directors is further authorized and instructed to determine the conditions of any such subscription.
Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as author-
ized by the foregoing provisions, Article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result
of such action and that the board of directors shall take or authorize any necessary steps for the purpose of obtaining
execution and publication of such amendment in accordance with law.
Art. 7. Meetings of shareholders - General
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders
of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Corporation.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Tues-
day of the month of December in each year at 11.00 am.
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 9. Board of directors
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be
shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting until the next annual meeting or for a pe-
riod of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-
ers.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 10. Procedures of meeting of the board
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-
holders or the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
48582
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex
another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present or represented at a
meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or repre-
sented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
A director may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of directors by means of a
telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the
meeting can hear each other and speak to each other.
The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate in-
struments in writing or by telex, cable, telegram or facsimile transmission confirmed in writing which shall together con-
stitute appropriate minutes evidencing such decision.
Art. 11. Minutes of meetings of the board
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-
man pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two directors.
Art. 12. Powers of the board
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms
as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be di-
rectors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 13. Binding signatures
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation or by the joint or single
signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.
Art. 14. Statutory auditor
The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The
statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next annual general meeting of shareholders.
The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Corporation shall begin on the first of July of each year and shall terminate on the 30th
June of the following year.
Art. 16. Appropriation of profits
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-
rectors.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such
share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders
of shares.
48583
Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. Amendment of Articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting
requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 19. Governing law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August
tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies (as amended) and by the law of July thirty-first nineteen
hundred and twenty-nine governing holding companies.»
<i>Valuationi>
For the purpose of registration the capital and surplus is valued at 41,531.69 EUR.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its transfer from the British Virgin Islands are estimated at approximately 3,000.- EUR.
The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen
hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The meeting is presided over by Bertrand Reimmel, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Antonios Nezetitis, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the undersigned notary to record that:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the shareholders, the proxies and
the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.
The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the appearing persons
will also remain annexed to the present deed.
II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are present or represented at the extraordinary gen-
eral meeting and that the shareholders declaring having had prior knowledge of the agenda no convening notice was
necessary.
III. The present meeting may validly deliberate on the following agenda:
1. Restructuring of the share capital of the Corporation by (i) the conversion of the share capital of the Corporation
into Euro with effect on 30th July, 2004 at the Euro / United States Dollar exchange rate prevailing at 12.00 noon (Lux-
embourg time) on 30th July, 2004 and (ii) the restatement of the Share capital of the Corporation at forty thousand
Euro (EUR 40,000), the balance of the existing capital being allocated to be paid in surplus.
2. Amendment of the par value per share from one (1) US Dollar to two (2) Euro so that the share capital of the
Corporation be divided into twenty thousand (20,000) shares.
3. Reallocation of the shares of the Corporation as follows:
- Nineteen thousand nine hundred and ninety-nine (19,999) shares to be owned by THE AGNEW TRUST
- one (1) share to be owned by Peter John de Putron.
4. Consequential amendment of paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation.
5. Insertion of a provision on authorised capital as first paragraph of article 5 of the articles of incorporation to read
as follows:
«The authorized capital of the Corporation is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000) comprising one hun-
dred thousand (100,000) authorized shares with a par value of two Euro (EUR 2) per share.»
After having deliberated, the meeting takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to (i) convert the capital of the Corporation into Euro with effect on 30th July, 2004 at the Euro / United
States Dollar exchange rate prevailing at 12.00 noon (Luxembourg time) on 30th July, 2004 (i.e. USD 1.2039 for EUR
1) so that the amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000) representing the capital is converted into
EUR 41,531.69 and (ii) restate the share capital of the Corporation at forty thousand Euro (EUR 40,000), the balance
of the existing capital consisting in EUR 1,531.69 being allocated to be paid in surplus.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend the par value per share from one (1) US Dollar to two (2) Euro so that the share capital of
the Corporation be divided into twenty thousand (20,000) shares.
<i>Third resolutioni>
It is resolved to reallocate the shares of the Corporation as follows:
- Nineteen thousand nine hundred and ninety-nine (19,999) shares to be owned by THE AGNEW TRUST
- one (1) share to be owned by Peter John de Putron.
<i>Fourth resolutioni>
It is resolved to amend the current first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation as follows:
48584
«The subscribed capital of the Corporation is set at forty thousand Euro (EUR 40,000) divided into twenty thousand
(20,000) shares with a par value of two Euro (EUR 2) per share.»
<i>Fifth resolutioni>
It is resolved to insert as first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation the following sentence:
«The authorized capital of the Corporation is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000) comprising one hun-
dred thousand (100,000) authorized shares with a par value of two Euro (EUR 2) per share.»
There being no further business on the agenda, the meeting were thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille quatre, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Narelle Dorothy de Putron, Appartement 42, The President, 2 Alexander Road, 8005 Bantry Bay, Afrique du Sud,
représentée par Manuèle Biancarelli, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
2) Peter John de Putron, Appartement 42, The President, 2 Alexander Road, 8005 Bantry Bay, Afrique du Sud, re-
présenté par Manuèle Biancarelli, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront an-
nexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, étant les administrateurs de VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD, ont demandé au no-
taire d’arrêter que:
I. VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. est une société dûment immatriculée depuis le 9 mai 1995 aux Iles Vierges
Britanniques avec son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands.
II. Le capital social de VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. est fixé à cinquante mille US dollars (USD 50.000) et
est représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale d’un US dollar (USD 1).
III. AGNEW TRUST, c/o LOMBARD TRUST S.A., CITCO (SUISSE) S.A., 19A, rue de la Croix-d’Or, P.B. 3124, 1211
Genève 3, Suisse, est le propriétaire de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (49.999) actions et M. Peter
John de Putron, prénommé, est le propriétaire d’une (1) action.
IV. Suite à une décision du conseil d’administration de VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. du 24 juin 2004, ap-
prouvée par la suite par les actionnaires de VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD., décidant, conformément à la clau-
se 77 des statuts, de transférer le siège social à Luxembourg, le siège social de VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD,
est transféré par le présent acte de Akara Building, 24, De Castro Street, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles
Vierges Britanniques à Appartement 17A, 12, rue Jean Engling, L-1466 Dommeldange, Grand-Duché de Luxembourg, à
partir du jour de cette assemblée et VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD adopte la nationalité luxembourgeoise à
partir du même jour.
V. Ce transfert n’entraîne pas la dissolution ni le changement de la personnalité juridique de VERITAS FINANCIAL
HOLDINGS LTD.
VI. En date du 24 juin 2004, le conseil d’administration de VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD. a décidé de nom-
mer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la société luxembourgeoise:
- Nigel Kenneth Cayzer, demeurant Thriepley House, Lundie, Dundee DD2 5PA, Scotland, né le 30 avril 1954, Lon-
dres, nationalité britannique;
- Peter John de Putron, demeurant à Appartement 42, The President, 2, Alexander Road, 8005 Bantry Bay, Afrique
du Sud, né le 11 décembre 1942, Evesham (UK), de nationalité britannique;
- Narelle Dorothy de Putron, demeurant à Appartement 42, The President, 2, Alexander Road, 8005 Bantry Bay,
Afrique du Sud, née le 4 décembre 1955, Brisbane (Australie), de nationalité australienne
- Anthony Charles Galliers-Pratt, c/o VAM Funds plc, St James’s Chambers, Athol Street, Douglas, Isle of Man, Isles
Vierges Britanniques, né le 15 décembre 1958, Londres, de nationalité britannique.
VII. En date du 24 juin 2004, le conseil d’administration de VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD, a décidé de re-
formuler les statuts de VERITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD, afin de les rendre conformes à la loi luxembourgeoise,
qui dorénavant auront la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Forme, Dénomination
Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-
tion de VAM HOLDINGS S.A. (la «Société»).
Art. 2. Durée
La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale
statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 18 ci-après.
48585
Art. 3. Objet
La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises, associations et autres
sociétés établies au Luxembourg ou à l’étranger, l’acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres, d’obligations, de titres de créance, de billets et
autres valeurs de toutes espèces et la détention, l’administration, le développement et la gestion de ces investissements.
La Société ne devra avoir de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un établis-
sement commercial. La Société peut cependant participer dans l’établissement ou le développement de toute entreprise
commerciale ou industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une
assistance que ce soit par prêts, garantie ou de toute autre façon.
La Société pourra emprunter sous toute forme et émettre des obligations ou autres titres représentatifs d’emprunts.
La Société peut prêter le produit de tels emprunts ou émissions obligataires à toute société dans laquelle elle a une
participation significative et peut accorder des garanties pour tout emprunt ou émission obligataire de telles sociétés.
Dans les limites déterminées par les lois et les règlements applicables, la société peut détenir des participations dans
des sociétés en commandite simple.
D’une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opéra-
tion qu’elle juge utile à l’accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Dommeldange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être trans-
féré à l’intérieur de la même commune par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital - Actions et certificats
Le capital souscrit de la Société est de cinquante mille US dollars (USD 50.000) représenté par cinquante mille
(50.000) actions d’une valeur nominale d’un US dollar (USD 1) par action.
Les actions sont émises sous forme nominative.
Toutes les actions émises de la Société seront inscrites dans le registre des actionnaires qui contiendra le nom de
chaque détenteur d’actions nominatives, sa résidence ou le domicile qu’il aura élu, le nombre d’actions détenu et le mon-
tant libéré de chaque action.
Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera
par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire. Dans les limites prévues par la loi, la Société
part racheter ses propres actions.
Art. 6. Augmentation du capital
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.
D’autre part, le conseil d’administration est en droit et chargé d’émettre à son gré des actions futures à concurrence
de l’intégralité du capital autorisé, en une fois ou en tranches périodiques, endéans une période expirant le cinquième
anniversaire de la publication des présents statuts au Mémorial, ceci par décision d’émettre des actions représentant la
totalité ou une partie de l’augmentation du capital et par acceptation au fur et à mesure des souscriptions pour ces ac-
tions. Le conseil d’administration est en outre autorisé et chargé de déterminer les conditions de pareilles souscriptions.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d’administration dans le cadre
de l’autorisation précitée, l’article 5 des statuts sera modifié de manière à correspondre à cette augmentation; le conseil
d’administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d’obtenir la constatation et la publication de cet-
te modification conformément à la loi.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l’ensemble des actionnaires de
la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.
Les dispositions légales pour le quorum et les délais de convocation régiront la convocation aux assemblées des ac-
tionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.
Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une
autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront
adoptées à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à
une assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.
48586
Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de
la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de
décembre de chaque année à 11.00 heures.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 9. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du
conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de la prochaine assem-
blée annuelle ou pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision
des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Procédures des réunions du conseil
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs
vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura com-
me fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des action-
naires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un pré-
sident pro tempore pour ces assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-
copie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis
par écrit, par télécopie, télégramme ou télex, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé
par écrit.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si deux administrateurs sont présents ou représentés. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu’un
intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre partie contractante)
cet administrateur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera, ni ne prendra
part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil adminis-
trateur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Un administrateur peut assister à et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil d’administration
par conférence téléphonique ou par un autre équipement de télécommunication permettant à toutes les personnes par-
ticipantes à la réunion d’entendre et de parler aux autres personnes.
Les administrateurs agissant à l’unanimité par résolution circulaire, peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs
instruments par écrit, télex, télégramme ou par télécopie, confirmés par écrit, qui ensemble constituent le procès-verbal
de la prise de cette décision.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro
tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par
le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition
dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-
présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à chacun des membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions
fixées par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes per-
48587
sonnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et
fixer leurs émoluments.
Art. 13. Signatures autorisées
La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou la
signature individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil
d’administration.
Art. 14. Commissaire
Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.
Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.
Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de l’année
suivante.
Art. 16. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la Société.
Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera
disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil
d’administration.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu
qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des
dividendes en la devise de leur paiement.
Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le
propriétaire d’une telle action, sera perdu et retournera à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte
des actionnaires.
Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-
tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Art. 19. Loi applicable
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la
loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) et de la loi du trente et un juillet
mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding»
<i>Evaluationi>
Le capital et les primes d’émission sont évalués à 41.531,69 EUR.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
à la suite de son transfert des Iles Vierges Britanniques sont estimés approximativement à 3.000,- EUR.
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires i>
L’assemblée est présidée par Bertrand Reimmel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Antonios Nezeritis, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit à la fonction de scrutatrice Manuèle Biancarelli, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président expose et prie le notaire soussigné de noter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires, les
mandataires des actionnaires et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte et sera soumise avec lui aux for-
malités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
48588
II. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à l’assemblée
générale extraordinaire et que les actionnaires déclarent avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assem-
blée, il a donc pu être fait abstractions des convocations d’usage.
III. La présente l’assemblée peut délibérer valablement sur l’ordre du jour suivant:
1. Restructuration du capital social de la Société par (i) la conversion du capital social de la Société en Euro avec effet
au 30 juillet 2004 au taux de change Euro/US dollar prévalant à midi (heures de Luxembourg) au 30 juillet 2004 et (ii) la
refixation du capital social de la Société à quarante mille Euros (EUR 40.000), le solde du capital existant étant porté en
réserve.
2. Modification de la valeur nominale par action d’un (1) US dollar à deux (2) Euros, pour que le capital social de la
Société soit divisé en vingt mille (20.000) actions.
3. Répartition des actions de la Société comme suit:
* Dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) actions détenues par THE AGNEW TRUST,
* une (1) action détenue par Peter John de Putron.
4. Modification consécutive du paragraphe 1 de l’article 5 des statuts.
5. Insertion d’une clause concernant le capital autorisé en tant que premier paragraphe de l’article 5 des statuts com-
me suit:
«Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent mille Euros (EUR 200.000) composé de cent mille (100.000)
actions autorisées d’une valeur nominale de deux Euros (EUR 2) par action.»
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est résolu de (i) convertir le capital social de la Société en Euro avec effet au 30 juillet 2004 au taux de change Euro/
US dollar prévalant à midi (heure de Luxembourg) au 30 juillet 2004 (soit USD 1,2039 pour EUR 1.-) le montant de
cinquante mille US dollar (USD 50.000) représentant le capital étant converti en 41.531,69 Euros et (ii) refixer le capital
social de la Société à quarante mille Euros (EUR 40.000), le solde de EUR 1.531,69 du capital existant étant porté en
réserve.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est résolu de modifier la valeur nominale par action d’un (1) US dollar à deux (2) Euros pour que le capital de la
société soit divisé en vingt mille (20.000) actions.
<i>Troisième résolutioni>
Il est résolu de répartir les actions de la Société comme suit:
* dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) actions détenues par THE AGNEW TRUST,
* une (1) action détenue par Peter John de Putron.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est résolu de modifier le premier paragraphe actuel de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à quarante mille Euros (EUR 40.000) divisé en vingt mille (20.000) actions
d’une valeur nominale de deux Euros (EUR 2) par action.»
<i>Cinquième résolutioni>
Il est résolu d’insérer comme premier paragraphe de l’article 5 des statuts la phrase suivante:
«Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent mille Euros (EUR 200.000) composé de cent mille (100.000)
actions autorisée d’une valeur nominale de deux Euros (EUR 2) par action.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. Reimmel, A. Nezeritis, M. Biancarelli, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 21CS, fol. 83, case 1. – Reçu 415,32 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080654.3/211/578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
TIMO LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 12, Parc d’Activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 89.576.
—
Im Jahre zweitausendvier, den vierzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft TIMO LUX S.A.,
mit Sitz in L-5365 Münsbach, 12, Parc d’Activité Syrdall, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 89.576).
Luxembourg, le 25 août 2004.
J. Elvinger.
48589
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, No-
tar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 22. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 470 vom 25.
März 2002,
deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar André Jean-Joseph
Schwachtgen am 5. September 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1584 vom 5. November 2002,
mit einem Gesellschaftskapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310)
Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian Dostert, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Marco Thorn, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster.
Die Versammlung bestellt als Stimmenzähler Herrn Marco Heim, Immobilienbetriebswirt, wohnhaft in Aach, (Bun-
desrepublik Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Immobilienagentur sowie die Förderung jeglicher Immobili-
enverwirklichungen («promotion immobilière»), insbesondere der An- und Verkauf von bebauten und nichtbebauten
Immobilien.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck den An- und Verkauf, die Vermietung und Verwaltung, die Vermittlung von
Immobilien im In- und Ausland.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel für den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung, einschliesslich der Veräusse-
rung, ihres eigenen Mobiliar- und Immobiliarvermögens verwenden.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften
Bürgschaften leisten.
Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer
Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»
2.- Abänderung der statutarischen Gesellschaftszeichnungsberechtigung.
3.- Dementsprechende Abänderung des letzten Absatzes von Artikel 6 der Satzung.
4.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern um dementsprechend Artikel zwei (2) der
Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Immobilienagentur sowie die Förderung jeglicher Immobili-
enverwirklichungen («promotion immobilière»), insbesondere der An- und Verkauf von bebauten und nichtbebauten
Immobilien.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck den An- und Verkauf, die Vermietung und Verwaltung, die Vermittlung von
Immobilien im In- und Ausland.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften
Bürgschaften leisten.
Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer
Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die statutarische Zeichnungsberechtigung der Verwaltungsratsmitglieder abzu-
ändern und dementsprechend dem letzten Absatz von Artikel sechs (6) folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 6. (letzter Absatz). Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten durch die obligatorische
und unumgängliche Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die
hiervor im Gesellschaftszweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des lu-
xemburgischen Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmit-
gliedes und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf etwa siebenhundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der
Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
48590
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: C. Dostert, M. Thorn, M. Heim, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mai 2004, vol. 527, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(045631.4/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
MAXITIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.677.
—
L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAXITIM S.A., avec siège
social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 10 décembre 1997,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 271 du 23 avril 1998, et dont les statuts ont été
modifiés par le notaire instrumentant en date du 12 mai 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 598 du 2 juin 2003,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 62.677,
ayant un capital social de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-), représenté par huit mille (8.000)
actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150
Luxembourg, 207, route d’Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement
à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet au 1
er
janvier 2004 de sorte que
le capital social s’élève actuellement à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents
(EUR 198.314,82).
3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents (EUR
314,82) pour le porter de son montant actuel de cent quatre vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-
deux cents (EUR 198.314,82) au montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 198.000,-) par le rembourse-
ment aux actionnaires d’un montant correspondant, conformément aux dispositions de l’article 69.2 de la loi sur les
sociétés commerciales.
4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital
social au montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 198.000,-) est divisé en mille neuf cent quatre-vingt
(1.980) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
5.- Création d’un capital autorisé avec un montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) représenté par vingt
mille (20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
6.- Autorisation au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé
pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d’usage.
7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
8.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. II résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
Junglinster, den 3. Juni 2004.
J. Seckler.
48591
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de
sorte que le capital social s’élève actuellement à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-
deux cents (EUR 198.314,82).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de trois cent quatorze euros
quatre-vingt-deux cents (EUR 314,82) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-dix-huit mille trois
cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82) au montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille euros
(EUR 198.000,-) par le remboursement aux actionnaires d’un montant correspondant, conformément aux dispositions
de l’article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de ce cent euros (EUR 100,-) par
action, de sorte que le capital social au montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 198.000,-) est divisé en
mille neuf cent quatre-vingt (1.980) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer un capital autorisé d’un montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-),
représenté par vingt mille (20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du ca-
pital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités
d’usage.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts,
qui auront dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 198.000,-), divisé en mille neuf cent
quatre-vingt (1.980) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) par
la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
<i>Huitième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à
cet effet.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, S. Spadafora, H. Beck.
48592
Enregistré à Echternach, le 21 juillet 2004, vol. 356, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(060544.3/201/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
MAXITIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.677.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060548.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
PANORAMA, S.à r.l. - AGENCE DE VOYAGES ET DE TOURISME,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 9.189.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1° Mademoiselle Marie-Gabrielle dite Gaby Maul, gérante de sociétés, née à Luxembourg, le 23 octobre 1944, de-
meurant à L-8134 Bridel, 9, rue Hemes;
2° la SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA, société anonyme, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.081, ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de
l’Alzette,
ici représentée par Monsieur Fernand Simon, administrateur de sociétés, demeurant à L-8028 Strassen, 10, rue Ma-
thias Goergen, agissant en sa qualité d’administrateur de la société et de mandataire d’un deuxième administrateur savoir
Monsieur Alphonse Ley, gérant de sociétés, demeurant à L-1323 Luxembourg, 16, rue des Champs, en vertu d’une pro-
curation en date du 19 juillet 2004.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée PA-
NORAMA, S.à r.l. - AGENCE DE VOYAGES ET DE TOURISME, ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue
des Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9.189, constituée suivant
acte sous seing privé en date du 31 août 1970, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro
197 du 27 novembre 1970, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date
du 15 avril 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 552 du 21 mai 2003, déclarent se
réunir en assemblée générale et prennent à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Suite à la cession par Mademoiselle Gaby Maul de six cent douze (612) parts sociales dans la Société à la société ano-
nyme SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA, prénommée, l’assemblée constate que la répartition
des parts sociales telle qu’elle existe à partir du 7 janvier 2004 est la suivante:
Les comparants, en leur qualité de seuls et uniques associés, acceptent expressément cette cession de parts. Made-
moiselle Gaby Maul déclare en outre en sa qualité de gérante de la Société accepter également la cession de part inter-
venue au nom et pour compte de la Société conformément à l’article 1690 du Code civil.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Maul, F. Simon, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, vol. 144S, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(064292.3/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.
Echternach, le 22 juillet 2004.
H. Beck.
Echternach, le 22 juillet 2004.
H. Beck.
1) Mademoiselle Gaby Maul: six cent treize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
613
2) SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA: mille huit cent quatre-vingt-sept parts sociales . 1.887
Total: deux mille cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
Luxembourg, le 2 août 2004.
F. Baden.
48593
STRAWBERRY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08210, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063362.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
PRIM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.312.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08215, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063364.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
SAMGWYM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.933.
—
In the year two thousand and four, on the thirteenth day of the month of July.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, (Grand Duchy of
Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the holding company SAMGWYM HOLDINGS
S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey, R. C. Luxembourg B 20.933, incorporated following a deed of Me Jean-Paul Hencks, notary residing in Lux-
embourg, dated October 26, 1983, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 359 dated
December 6, 1983 (the «Company»).
The meeting is declared open at 11.30 a.m. by Mrs Isabelle Schul, private employee, residing professionally at L-2086
Luxembourg, 23, avenue Monterey, acting as chairman, and appointing Mr Luis Tavares, private employee, residing pro-
fessionally at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey as secretary of the meeting.
The meeting appoints as scrutineer Mrs Martine Lopez, private employee, residing professionally at L-2086 Luxem-
bourg, 23, avenue Monterey.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1- Amendment of the company’s duration up to an unlimited duration and subsequent amendment of article 1 of the
company’s articles of incorporation.
2- Addition of the following paragraphs to article 1 of the company’s articles of incorporation and subsequent mod-
ification of the said article:
«Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,
or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding
such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.»
3- Suppression of the 2nd paragraph of article 3 of the company’s Articles of Incorporation.
4- Modification of article 5 of the company’s articles of incorporation to read as follows:
«With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incor-
poration, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the
company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.»
5- Modification of article 6 of the company’s articles of incorporation to read as follows:
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.
Signature.
48594
«The Board of Directors may delegate all or part of its powers relating to the daily management and the represen-
tation of the company in relation with this management to one or several directors, officers, managers or other agents,
being shareholders or not.
The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to prior authorization of the general meeting.
The company is bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the joint signature of two di-
rectors.»
6- Suppression of article 8 of the company’s articles of incorporation regarding the pledge of a share on behalf of the
directors and statuary auditors.
7- Addition of a new article of the company’s article of incorporation regarding the authorisation to the Board of
Directors to pay interim dividends.
8- Suppression of the second sentence of art 9 of the company’s article of incorporation;
9- Modification of article 11 of the company’s articles of incorporation to read as follows:
«The annual meeting of shareholders shall be held on the fourth Monday of May at 11.30 a.m. in Luxembourg at the
registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting
will be held the next following business day.»
10- Modification of article 12 of the company’s articles of incorporation to read as follows:
«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of Au-
gust 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31, 1929, on Holding Companies.»
11- Subsequent renumbering of the articles of incorporation and entire rewriting of the company’s articles of incor-
poration.
12- Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list after having been signed ne varietur by the shareholders
present, the proxies of the represented shareholders and by the bureau of the meeting and the notary, will remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the
notary will also remain annexed to the present deed.
(iii) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting of shareholders took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to proceed to an entire rewriting of the Articles of Incorporation of
the Company in order namely to:
- Amend the company’s duration up to an unlimited duration.
- Decide that the annual meeting of shareholders shall be held on the fourth Monday of May at 11.30 a.m. and for the
first time in 2005.
- Modify the articles 1, 3, 5, 6, 9, 11 and 12 of the company’s articles of incorporation.
- Suppress the article 8 of the company’s articles of incorporation.
- Add of a new article of the company’s article of incorporation regarding the authorisation to the Board of Directors
to pay interim dividends.
<i>Second resolutioni>
Following the foregoing resolution the meeting decides to give the following wording to the new Articles of Incor-
poration of the Company in English version:
«Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be
SAMGWYM HOLDINGS S.A.»
Said company shall have its principal office in Luxembourg.
The company shall have an unlimited duration.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,
or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding
such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.
Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg
or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of all kinds, the management, supervision
and development of these interests. Il may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived
from or complemental to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision
of any company, remaining however always within the limits of the Law of July 31, 1929, on holding companies.
48595
Art. 3. The corporate capital shall be thirty thousand US dollars (30,000.- USD), divided into five hundred (500)
shares of sixty US dollars (60.- USD) each.
The shares have been all fully paid in cash, in such manner that the sum of thirty thousand U.S. Dollars is now available
to the company, evidence thereof having been given to the notary.
Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company; they shall be appointed for a period to be determined by the shareholders’ meeting
which cannot exceed six years.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its powers relating to the daily management and the rep-
resentation of the company in relation with this management to one or several directors, officers, managers or other
agents, being shareholders or not.
The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to prior authorization of the general meeting.
The company is bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the joint signature of two di-
rectors.
Art. 7. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors; they shall be appointed for
a period to be determined by the shareholders’ meeting which cannot exceed six years.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December.
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company. It shall determine the allocation or
distribution of the net profits. Each shareholder may participate in the deliberations of the general meeting either in
person or by proxy.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the fourth Monday of May at 11.30 o’clock in Luxem-
bourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday,
the meeting will be held the next following business day.
Art. 12. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31, 1929, on Holding Companies.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at one thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le treize juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duché de
Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société holding SAMGWYM HOLDINGS
S.A., une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Mon-
terey, R. C. Luxembourg B 20.933 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1983, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
359 du 6 décembre 1983.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant
professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, qui désigne comme secrétaire Monsieur Luis Tavares,
employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Martine Lopez, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
48596
<i>Ordre du jour:i>
1- Modification de la durée de la société en durée illimitée et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts de
la société.
2- Ajout des paragraphes suivants à l’article 1
er
des statuts de la société et modification subséquente dudit article:
«Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»
3- Suppression du second paragraphe de l’article 3 des statuts de la société.
4- Modification de l’article 5 des statuts de la société qui se lira désormais comme suit:
«Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne
pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-
sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.»
5- Modification de l’article 6 des statuts de la société qui se lira désormais comme suit:
«Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants ou autres agents, actionnaire ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil d’Administration, soit par la signature
collective de deux administrateurs.»
6- Suppression de l’article 8 des statuts de la société relatif au cautionnement d’une action pour compte des adminis-
trateurs et commissaire aux comptes.
7- Ajout d’un nouvel article autorisant le Conseil d’Administration à payer des dividendes intérimaires.
8- Suppression de la seconde phrase de l’article 9 des statuts de la société.
9- Modification de l’article 11 des statuts de la société qui se lira désormais comme suit:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à
Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 4
ème
lundi du mois de mai à 11.30 heures. Si ce jour est férié, l’assem-
blée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
10- Modification de l’article 12 des statuts de la société qui se lira désormais comme suit:
«La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts ainsi que la loi du 31 juillet 1929, sur les sociétés
holding.»
11- Par conséquent rénumérotation des articles des statuts de la société et refonte complète des statuts de la société.
12- Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire.
(iii) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et que les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour notamment:
- Modifier la durée de la société en durée illimitée;
- Décider que l’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira le quatrième lundi du mois de mai à 11.30
heures et pour la première fois en 2005.
- Modifier les articles 1, 3, 5, 6, 9, 11 et 12 des statuts de la société.
- Supprimer l’article 8 des statuts de la société.
- Ajouter un nouvel article aux statuts de la société autorisant le Conseil d’Administration à payer des dividendes
intérimaires.
48597
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de donner la teneur suivante aux nouveaux statuts de la Société
en version française:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de SAMGWYM HOLDINGS S.A.»
Cette société aura son siège à Luxembourg.
La société aura une durée illimitée.
Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille dollars US (30.000,- USD) représenté par cinq cents (500) actions d’une
valeur nominale de soixante dollars US (60,- USD) chacune.
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
mille dollars US se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non; ils sont
nommés par l’assemblée générale pour une durée à déterminer par elle, mais ne pouvant pas excéder six ans.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-
sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.
Art. 6. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaire ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil d’Administration, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés par l’assemblée gé-
nérale pour une durée à déterminer par elle, mais ne pouvant pas excéder six ans.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 4
ème
lundi du mois de mai à 11.30 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts ainsi que la loi du 31 juillet 1929, sur les
sociétés holding.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
48598
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Schul, L. Tavares, M. Lopez, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, vol. 144S, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(064485.3/222/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.
SAMGWYM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.933.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064486.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.
HALBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 68.808.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07773, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063658.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
HALBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 68.808.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juillet 2004i>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2002.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2003.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 12 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07772. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(063660.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 août 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 août 2004.
T. Metzler.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
48599
ALPINE COPYRIGHT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 81.917.
—
In the year two thousand and four, the sixteenth day of July.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, (Grand Duchy of Lux-
embourg).
There appeared:
The company ALPINE MEDIEN AG, a joint stock company, having its registered office in D-82031 Grünwald, 15,
Tölzer Strasse, organized under the laws of Germany,
duly represented by Maître Annette Brewer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a private power of attorney, given on the 15th July, 2004.
Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.
The appearing party, represented as stated here above, requests the undersigned notary to record that it is the sole
unitholder of the company ALPINE COPYRIGHT, GmbH, a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office in L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, (hereinafter referred to as the
«Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary, on 14th May, 2001, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, N° 1069 dated 27th November, 2001.
The appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole unitholder of the Company and repre-
senting the entire share capital of the Company, requests the undersigned notary to record its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole unitholder resolves to transfer the registered office and the effective seat of management of the Company,
from the Grand Duchy of Luxembourg to the Isle of Man, and concomitantly to change the nationality of the Company
by abandoning the Luxembourg nationality and adopting the nationality of the Isle of Man, without liquidation nor inter-
ruption of the legal personality of the Company, subject to the receipt by the Company of the certificate of registration
of the Memorandum of Continuance to be issued by the Isle of Man Financial Supervision Commission (hereinafter the
«Certificate») and with effect as of the date of issue of the Certificate (hereinafter the «Transfer Date»).
A notarial deed will be executed upon fulfilment of the condition precedent, i.e. the receipt by the Company of the
Certificate (the «Condition»), to confirm the effective date of the transfer of the Company’s registered office and effec-
tive seat of management from the Grand Duchy of Luxembourg to the Isle of Man.
<i>Second resolutioni>
Subject to the fulfilment of the Condition and with effect as of the Transfer Date, the sole unitholder resolves to
transform the Company into the form of a private limited liability company governed by the laws of the Isle of Man.
<i>Third resolutioni>
Subject to the fulfilment of the Condition and with effect as of the Transfer Date, the sole unitholder resolves to
approve the restatement of the articles of association of the Company in order to conform to the laws of the Isle of
Man, which shall read as follows:
Preliminary
1. The Regulations contained in Table A in the Schedule to the Companies (Memorandum and Articles of Association)
Regulations 1988 (such Table being hereinafter «Table A») shall apply to the Company save in so far as they are excluded
or modified hereby and such Regulations (save as so excluded or modified) and the Articles hereinafter contained shall
be the regulations of the Company.
Private Company
2. The Company is a «Private Company» within the meaning of the Companies Act, 1986 and accordingly no invitation
shall be issued to the public to subscribe for any shares, debentures or debenture stock of the Company.
Audit requirement
3. The Company, for as long as it is either an exempt company, an audit exempt company or a non-resident company
as those terms are interpreted in the Companies (Exempt and Non-Resident Private Companies) (Audit Exemption)
Regulations 1993 and the Companies (Exempt and Non-Resident Private Companies) (Audit Exemption) (Amendment)
Regulations 1994 hereby elects, subject always to the provisions of the said Regulations and as they may be amended
from time to time, to dispense with the requirements of the Companies Acts 1931 to 1992 which relate to the audit of
the accounts of companies.
Shares
4. The shares shall be at the disposal of the Directors, and they may allot or otherwise dispose of them to such per-
sons at such times and generally on such terms and conditions as they think proper, subject always to Clause 2 hereof,
and provided no shares shall be issued at a discount except as provided by the Companies Act, 1931, Section 47. The
Directors may from time to time make calls upon the members in respect of any moneys unpaid on their shares, such
money unpaid to include any premium attached to any issue of shares. A call may be for the whole of the moneys unpaid
or such lesser sum as the Directors shall decide and shall be payable within 30 days of the making of any call.
48600
5. The lien conferred by Clause 8 in Table A shall attach also to fully paid-up shares, and the Company shall also have
a first and paramount lien on all shares, whether fully paid or not, standing registered in the name of the person indebted
or under liability to the Company, whether he shall be the sole registered holder thereof or shall be one or two or
more joint holders, for all moneys presently payable by him or his estate to the Company. Clause 8 in Table A shall be
modified accordingly.
Proceedings at General Meetings
6.
(a) The Company shall in each year hold a General Meeting as its Annual General Meeting in addition to any other
meetings in that year and not more than fifteen months shall elapse between the date of one Annual General Meeting
of the Company and the next; provided that so long as the Company holds its first Annual General Meeting within eight-
een months of its incorporation it need not hold it in the calendar year of its incorporation or in the following calendar
year.
(b) A notice convening a General Meeting shall be required to specify the general nature of the business to be trans-
acted only in the case of special business and clause 38 of Table A shall be modified accordingly.
(c) All business shall be deemed special that is transacted at an Annual General Meeting, with the exception of de-
claring a dividend, the consideration of accounts, balance sheets, and the reports of the Directors and Auditors, and the
appointment of and the fixing of the remuneration of the Auditors.
7.
(a) No business shall be transacted at any General Meeting unless a quorum of members is present at the time when
the meeting proceeds to business. Subject to paragraph (b) below two members present in person or by proxy shall be
a quorum.
(b) If and for so long as the Company has only one Member, that Member present in person or, if that Member is a
corporation, by a duly authorised representative, shall be a quorum.
(c) If and for so long as the Company has only one Member and that Member takes any decision which is required
to be taken in General Meeting or by means of a written resolution that decision shall be as valid and effectual as if
agreed by the Company in General Meeting, save that this paragraph shall not apply to resolutions passed pursuant to
Section 141A of the Companies Act 1931, or of Section 13 of the Companies Act 1982.
(d) Any decision taken by a sole Member pursuant to paragraph (a) above shall be recorded in writing and delivered
by that Member to the Company for entry in the Company’s Minute book.
8. Clause 38 in Table A shall be read and construed as if the words «or removing» were added after the word «ap-
pointing» in the first sentence.
9. The Chairman of the Board of Directors shall preside at every General Meeting, but if at any meeting he shall not
be present within fifteen minutes after the time appointed for holding the same, or shall be unwilling to act as Chairman,
the members present shall choose some Director, or if no Director be present, or if all the Directors present decline
to take the chair, they shall choose some member present to be Chairman of the meeting.
10. At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands, unless
a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded by at least two members or by the
holder or holders present in person or by proxy of at least one-twentieth part of the issued share capital of the Com-
pany, and unless a poll is so demanded a declaration by the Chairman that a resolution has on a show of hands been
carried, or carried unanimously, or by a particular majority, or lost, or not carried by a particular majority, and an entry
to that effect in the minute book of the Company shall be conclusive evidence thereof without proof of the number or
proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution and Clause 46 of Table A shall be construed
accordingly.
11. A resolution in writing signed by every shareholder of the Company, shall have the same effect and validity as a
unanimous resolution of shareholders at a meeting of the Company duly convened and constituted.
Directors
12.
(a) The maximum number of Directors may be determined from time to time by Ordinary Resolution in General
Meeting of the Company. Subject to and in default of any such determination there shall be no maximum number of
Directors and the minimum number of Directors shall be two.
(b) The Chairman shall not have a casting vote unless and until otherwise determined by the Directors and Article
88 of Table A shall be modified accordingly.
(c) All directors of the Company shall be entitled to receive prior notice of meetings of Directors, such notice may
be given by telephone, telex and telefax.
(d) The Company may by Ordinary Resolution in General Meeting appoint any person who is willing to act to be a
Director, either to fill a vacancy or as an additional Director.
(e) In any case where as the result of death of a sole Member of the Company the Company has no Members and no
Directors the personal representatives of such deceased Member shall have the right by notice in writing to appoint a
person to be a Director of the Company and such appointment shall be as effective as if made by the Company in Gen-
eral Meeting pursuant to paragraph (d) of this Article.
13. The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in General Meeting.
14. It shall not be necessary for a person appointed as a Director to hold any shares of the Company to qualify him
to act.
15. The Directors shall not be required to retire by rotation and clauses 73 to 80 inclusive shall not apply to the
Company.
48601
Alternate Directors
16. Any Director may in writing appoint any person who is approved by the majority of the Directors, to be his al-
ternate to act in his place at any meeting of the Directors at which he is unable to be present. Every such alternate shall
be entitled to notice of meetings of the Directors and to attend and vote thereat as a Director when the person ap-
pointing him is not personally present, and where he is a Director to have a separate vote on behalf of the Director he
is representing in addition to his own vote. A Director may at any time in writing revoke the appointment of an alternate
appointed by him. Every such alternate shall be an officer of the Company and shall not be deemed to be the agent of
the Director appointing him.
Powers and duties of Directors
17. If and whenever the number of Directors shall be reduced below the minimum number it will be the duty of the
remaining Director to appoint one or more Directors and pending such appointment any other powers vested in the
Directors by Statute or otherwise shall be suspended.
18. The Directors from time to time, and at any time, may provide through Local Boards, Attorneys or Agencies for
the management of the affairs of the Company abroad, and may appoint any persons to be members of such Local
Boards, or as Attorneys or Agents and may remove any persons so appointed and appoint others in their place and may
fix their remuneration. The Company may exercise the powers conferred by Sections 32 and 104 of the Companies
Act, 1931, and those powers shall accordingly be exercisable by the Directors.
19. The Directors from time to time at their discretion may raise or borrow any sum or sums of money without the
consent of the members in General Meeting for the purposes of the Company, and may raise or secure the repayment
of such money in such manner, and upon such terms and conditions in all respects as they think fit, and in particular by
the issue of debentures or debenture stock or any mortgage, charge or other security in the undertaking of the whole
or any part of the property of the Company (both present and future) including its uncalled capital for the time being.
20. The Directors may appoint a person who is willing to act to be Director, either to fill a vacancy or as an additional
Director, provided that the appointment does not cause the number of Directors to exceed any number determined
in accordance with clause 11 of these Articles as the maximum number of Directors for the time being in force.
21. The Company may by Ordinary Resolution in General Meeting remove any Director notwithstanding any other
provision contained in these Articles or in any agreement between the Company and such Director. The removal of a
Director pursuant to this Article shall be without prejudice to any claim he may have for damages for breach of any
contract of service between him and the Company.
Disqualification of Directors
22. The office of a Director shall be vacated if:-
(a) he ceases to be a Director by virtue of any provision of the Act or he becomes prohibited by law from being a
Director; or
(b) he is, or may be, suffering from mental disorder and either -
(i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act
1974, or
(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the Isle of Man or elsewhere) in matters concerning
mental disorder for his detention or for the appointment of a receiver, curator bonis or other person to exercise pow-
ers with respect to his property or affairs; or
(c) he resigns his office by notice to the Company.
23. A Director may hold any other office or place of profit under the Company except that of Auditor, upon such
terms as to remuneration, tenure of office, and otherwise as may be determined by the Board.
24. No Director shall be disqualified by his office from contracting with the Company, either as vendor, purchaser
or otherwise, nor shall any such contract or any contract or arrangement entered into or on behalf of the Company in
which any Director shall be in any way interested be avoided, nor shall any Director so contracting, or being interested
be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement by reason of such
Director holding office or the fiduciary relation thereby established, nor shall any such Director be precluded from vot-
ing in respect of any such contract or arrangement and clauses 94 to 97 inclusive in Table A shall be construed accord-
ingly.
Proceedings of Directors
25. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors and
unless so fixed the number shall be two.
26. A resolution in writing signed by every member of the board shall have the same effect and validity as a resolution
of the Board duly passed at a meeting of the Board duly convened and constituted.
27. A director shall be deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone or other elec-
tronic means and all directors participating in the meeting are able to hear each other.
Capital reserve
28. The Directors may establish a Capital Reserve, and either carry to the credit of such reserve from time to time
all monies realised on the sale of any Capital assets of the Company in excess of the price at which the same stand in
the books of the Company at the time, or apply the same in providing for depreciation or contingencies or other Capital
purposes. The Capital Reserve shall be available for dividend and may be used for any purpose to which the Capital of
the Company may be applied, including, without prejudice to the generality hereof, the writing down of the expenses
of Capital Debenture issues, and any discount on issues of Debentures. Any losses realised on the sale of any Capital
48602
Assets may be carried to the debit of the Capital Reserve, except in so far as the Directors shall in their discretion
decide to make good the same out of other funds of the Company.
Indemnity
29. Every Director or other officer or auditor of the Company shall be entitled to be indemnified out of the assets
of the Company against all losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of the duties of
his office or otherwise in relation thereto, and no Director or other officer shall be liable for any loss, damage or mis-
fortune which may happen to or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office or in relation
thereto, but this Article shall only have the effect in so far as its provisions are not avoided by Section 151 of the Com-
panies Act, 1931 and clause 118 of Table A shall be construed accordingly.
The Directors may execute, in the name and on behalf of the Company in favour of any Director or other person
who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company, such debentures or mortgages
of the Company’s property (present and future) as they think fit and any such mortgages may contain a power of sale
and such other powers, covenants and provisions as shall be agreed upon.
Dividends
30.
(a) Any General Meeting declaring a dividend may resolve that such dividend be paid wholly or in part by the distri-
bution of specific assets and in particular of paid-up shares, debentures or debenture stock of the Company or paid-up
shares, debentures or debenture stock of any other company or in any one or more of such ways.
Any General Meeting may resolve that any moneys, investments or other assets forming part of the undivided profits
of the Company standing to the credit of the Reserve Fund or in the hands of the Company and available for dividend
be capitalised and distributed among the shareholders in accordance with their rights on the footing that they become
entitled thereto as capital, and that all or any part of such capitalised fund be applied on behalf of the shareholders in
paying up in full unissued shares of the Company and that such unissued shares so fully paid be distributed accordingly
amongst the shareholder in the proportion in which they are entitled to receive dividends, and shall be accepted by
them in full satisfaction of their interest in the said capitalised sum.
For the purpose of giving effect to any resolution under this Article the Directors may settle any difficulty which may
arise in regard to the distribution as they think expedient and, in particular, may issue fractional certificates and may fix
the value or distribution of any specific assets, and may determine that cash payments shall be made to any members
upon the footing of the value so fixed, or that fractions of less value than GBP 1 may be disregarded in order to adjust
the rights of all parties, and may vest any such cash or specific assets in trustees upon such trusts for the persons entitled
to the dividend or capitalised fund as may seem expedient to the Directors. Where requisite a proper contract shall be
filed in accordance with Section 42 of the Companies Act, 1931, and the Directors may appoint any person to sign such
contract on behalf of the persons entitled to the dividend or capitalised fund, and such appointment shall be effective.
(b) Any dividend which has remained unclaimed for six years from the date when it became due for payment shall, if
the Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company and clause 108 of the Table shall be
construed accordingly.
Notices
31. A notice may be given by the Company to any member either personally or by sending it by post or fax to him
to his registered address. Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by prop-
erly addressing, prepaying and posting a letter containing the notice, and to have been effected in the case of a notice
of a Meeting at the expiration of 48 hours after the letter containing the same is posted and in any other case at the
time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post. Clause 111 of Table A shall not apply to the
Company.
32. A notice may be given by the Company to the joint holders of a share by giving notice to the joint holder named
first in the register of members in respect of the share.
Official seal of the Company
33. The Company may exercise all the powers given by Section 32 of the Act subject to the regulations of the Com-
pany for the time being.
Transfer of shares
34. The Directors may, in their absolute discretion and without assigning any reason therefore, decline to register
the transfer of a share, whether or not it is a fully paid share, and the first sentence of clause 24 in Table A shall not
apply to the Company.».
<i>Fourth resolutioni>
Subject to the fulfilment of the Condition and with effect as of the Transfer Date, the sole unitholder resolves to
terminate all activities of the Company in Luxembourg and close the financial accounts of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
Subject to the fulfilment of the Condition and with effect as of the Transfer Date, the sole unitholder resolves to
terminate the mandate of Mrs Jeannette Payer, Mr Stefan Ziegler and Mr Larry Levinson, as managers of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
Subject to the fulfilment of the Condition and with effect as of the Transfer Date, the sole unitholder resolves to set
the number of directors at three and to appoint Mr Stefan Ziegler, Mr Chris Eaton and Mr Larry Levinson as new di-
rectors of the Company for an undetermined period.
48603
<i>Seventh resolutioni>
Subject to the fulfilment of the Condition and with effect as of the Transfer Date, the sole unitholder resolves to
terminate the mandate of KPMG AUDIT, Société Civile, as auditor of the Company.
<i>Eighth resolutioni>
Subject to the fulfilment of the Condition and with effect as of the Transfer Date, the sole unitholder resolves to set
the number of statutory auditors at one and to appoint BROWNE CRAINE & CO., residing at Burleigh Manor, Peel
Road, Douglas, Isle of Man, as new statutory auditor of the Company until the date of the annual general meeting of the
members of the Company which shall be held in 2005.
<i>Ninth resolutioni>
Subject to the fulfilment of the Condition and with effect as of the Transfer Date, the sole unitholder resolves to set
the registered office of the Company at 1st Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4RW.
<i>Tenth resolutioni>
The sole unitholder resolves to empower and to authorize Mrs Therese Ryan or any other agent of the CORPO-
RATE SERVICE PROVIDER ILS (ISLE OF MAN) LIMITED to pass and sign all deeds, documents, minutes, papers, cer-
tificates and to perform any action or do all acts necessary under Part 1 of the Companies (Transfer of Domicile) Act
1998, for the transfer of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Isle of Man and in relation with
the above resolutions.
<i>Eleventh resolutioni>
The sole unitholder resolves to empower and to authorize any lawyer of WILDGEN & PARTNERS to pass and sign
all deeds, documents, minutes, papers, certificates and to perform any action required in the Grand Duchy of Luxem-
bourg for the transfer of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Isle of Man and in relation with
the above resolutions.
<i>Twelfth resolutioni>
The sole unitholder resolves to acknowledge and approve the entering into the following agreements:
1) a purchase agreement (the «Purchase Agreement»), dated 19th April, 2004, between MEDIA RELEASING INTER-
NATIONAL LTD. («MEDIA»), as purchaser, and the Company, represented by its Swiss Branch Manager, as seller,
whereby the Company agreed to sell to Media the right to release the motion picture entitled «Love’s Enduring Prom-
ise»;
2) a production services agreement (the «Production Agreement»), dated 19th April, 2004, between LARRY LEVIN-
SON PRODUCTIONS, INC. («LLP»), and the Company, represented by its Swiss Branch Manager, with respect to pro-
duction services to be performed by LLP at the request of the Company, in connection with a television movie-of-the-
week entitled «Love’s Enduring Promise»;
3) a short form purchase agreement, dated 19th April, 2004, between MEDIA and the Company, represented by its
Swiss Branch Manager, in accordance with paragraph 7 (Delivery; Redelivery) of the Purchase Agreement; and
4) a copyright mortgage and assignment for purposes of security, dated 19th April, 2004, between MEDIA and the
Company, represented by its Swiss Branch Manager, whereby the Company has granted to MEDIA a security interest
in the Company’s right, title and interest in and to the motion picture entitled «Love’s Enduring Promise», in order to
secure the Company’s present and future obligations under the Purchase Agreement.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately two thousand Euro
(EUR 2,000.-).
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, represented as here
above stated, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between
the English and the French text, the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, she signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duché de
Luxembourg).
A comparu:
La société ALPINE MEDIEN AG, une société anonyme, ayant son siège social à D-82031 Grünwald, 15, Tölzer Stras-
se, constituée selon le droit allemand,
dûment représentée par Maître Annette Brewer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration privée, donnée le 15 juillet 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant au nom de la partie comparante
et par le notaire soussigné, sera annexée au présent acte, pour être enregistrée en même temps auprès de l’administra-
tion de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme susmentionné, requiert le notaire soussigné de prendre acte qu’elle est
l’associée unique de la société ALPINE COPYRIGHT, GmbH, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à
48604
L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, (ci-après «la Société»), constituée par acte du notaire soussigné le
14 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 1069 en date du 27 novembre 2001.
La partie comparante, représentée comme susmentionné, en sa qualité d’associée unique de la Société et représen-
tant l’ensemble du capital de la Société, requiert le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de transférer le siège social et le siège d’administration effective de la Société, du Grand-
Duché du Luxembourg vers l’Ile de Man, et concomitamment de changer la nationalité de la Société en abandonnant la
nationalité luxembourgeoise pour adopter la nationalité de l’Ile de Man, sans liquidation ni interruption de la personnalité
légale de la Société, sous réserve de la réception par la Société du «certificate of registration of the Memorandum of
Continuance» émis par «The Isle of Man Financial Supervision Commission» (ci-après le «Certificat») et avec effet à la
date d’émission du Certificat (ci-après la «Date du Transfert»).
Un acte notarié sera dressé dès l’accomplissement de la condition suspensive, à savoir la réception par la Société du
Certificat (la «Condition»), pour confirmer la date effective du transfert du siège social et du siège d’administration ef-
fective du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Ile de Man.
<i>Deuxième résolutioni>
Sous réserve de l’exécution de la Condition et avec effet de la Date de Transfert, l’associée unique décide de trans-
former la Société en une société à responsabilité limitée privée régie par le droit de l’Ile de Man.
<i>Troisième résolutioni>
Sous réserve de la réalisation de la Condition et avec effet de la Date du Transfert, l’associée unique décide d’approu-
ver la reformulation des statuts de la Société pour se conformer avec le droit de l’Ile de Man, qui sont à lire comme suit:
Preliminary
1. The Regulations contained in Table A in the Schedule to the Companies (Memorandum and Articles of Association)
Regulations 1988 (such Table being hereinafter «Table A») shall apply to the Company save in so far as they are excluded
or modified hereby and such Regulations (save as so excluded or modified) and the Articles hereinafter contained shall
be the regulations of the Company.
Private Company
2. The Company is a «Private Company» within the meaning of the Companies Act, 1986 and accordingly no invitation
shall be issued to the public to subscribe for any shares, debentures or debenture stock of the Company.
Audit requirement
3. The Company, for as long as it is either an exempt company, an audit exempt company or a non-resident company
as those terms are interpreted in the Companies (Exempt and Non-Resident Private Companies) (Audit Exemption)
Regulations 1993 and the Companies (Exempt and Non-Resident Private Companies) (Audit Exemption) (Amendment)
Regulations 1994 hereby elects, subject always to the provisions of the said Regulations and as they may be amended
from time to time, to dispense with the requirements of the Companies Acts 1931 to 1992 which relate to the audit of
the accounts of companies.
Shares
4. The shares shall be at the disposal of the Directors, and they may allot or otherwise dispose of them to such per-
sons at such times and generally on such terms and conditions as they think proper, subject always to Clause 2 hereof,
and provided no shares shall be issued at a discount except as provided by the Companies Act, 1931, Section 47. The
Directors may from time to time make calls upon the members in respect of any moneys unpaid on their shares, such
money unpaid to include any premium attached to any issue of shares. A call may be for the whole of the moneys unpaid
or such lesser sum as the Directors shall decide and shall be payable within 30 days of the making of any call.
5. The lien conferred by Clause 8 in Table A shall attach also to fully paid-up shares, and the Company shall also have
a first and paramount lien on all shares, whether fully paid or not, standing registered in the name of the person indebted
or under liability to the Company, whether he shall be the sole registered holder thereof or shall be one or two or
more joint holders, for all moneys presently payable by him or his estate to the Company. Clause 8 in Table A shall be
modified accordingly.
Proceedings at General Meetings
6.
(a) The Company shall in each year hold a General Meeting as its Annual General Meeting in addition to any other
meetings in that year and not more than fifteen months shall elapse between the date of one Annual General Meeting
of the Company and the next; provided that so long as the Company holds its first Annual General Meeting within eight-
een months of its incorporation it need not hold it in the calendar year of its incorporation or in the following calendar
year.
(b) A notice convening a General Meeting shall be required to specify the general nature of the business to be trans-
acted only in the case of special business and clause 38 of Table A shall be modified accordingly.
(c) All business shall be deemed special that is transacted at an Annual General Meeting, with the exception of de-
claring a dividend, the consideration of accounts, balance sheets, and the reports of the Directors and Auditors, and the
appointment of and the fixing of the remuneration of the Auditors.
48605
7.
(a) No business shall be transacted at any General Meeting unless a quorum of members is present at the time when
the meeting proceeds to business. Subject to paragraph (b) below two members present in person or by proxy shall be
a quorum.
(b) If and for so long as the Company has only one Member, that Member present in person or, if that Member is a
corporation, by a duly authorised representative, shall be a quorum.
(c) If and for so long as the Company has only one Member and that Member takes any decision which is required
to be taken in General Meeting or by means of a written resolution that decision shall be as valid and effectual as if
agreed by the Company in General Meeting, save that this paragraph shall not apply to resolutions passed pursuant to
Section 141A of the Companies Act 1931, or of Section 13 of the Companies Act 1982.
(d) Any decision taken by a sole Member pursuant to paragraph (a) above shall be recorded in writing and delivered
by that Member to the Company for entry in the Company’s Minute book.
8. Clause 38 in Table A shall be read and construed as if the words «or removing» were added after the word «ap-
pointing» in the first sentence.
9. The Chairman of the Board of Directors shall preside at every General Meeting, but if at any meeting he shall not
be present within fifteen minutes after the time appointed for holding the same, or shall be unwilling to act as Chairman,
the members present shall choose some Director, or if no Director be present, or if all the Directors present decline
to take the chair, they shall choose some member present to be Chairman of the meeting.
10. At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands, unless
a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded by at least two members or by the
holder or holders present in person or by proxy of at least one-twentieth part of the issued share capital of the Com-
pany, and unless a poll is so demanded a declaration by the Chairman that a resolution has on a show of hands been
carried, or carried unanimously, or by a particular majority, or lost, or not carried by a particular majority, and an entry
to that effect in the minute book of the Company shall be conclusive evidence thereof without proof of the number or
proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution and Clause 46 of Table A shall be construed
accordingly.
11. A resolution in writing signed by every shareholder of the Company, shall have the same effect and validity as a
unanimous resolution of shareholders at a meeting of the Company duly convened and constituted.
Directors
12.
(a) The maximum number of Directors may be determined from time to time by Ordinary Resolution in General
Meeting of the Company. Subject to and in default of any such determination there shall be no maximum number of
Directors and the minimum number of Directors shall be two.
(b) The Chairman shall not have a casting vote unless and until otherwise determined by the Directors and Article
88 of Table A shall be modified accordingly.
(c) All directors of the Company shall be entitled to receive prior notice of meetings of Directors, such notice may
be given by telephone, telex and telefax.
(d) The Company may by Ordinary Resolution in General Meeting appoint any person who is willing to act to be a
Director, either to fill a vacancy or as an additional Director.
(e) In any case where as the result of death of a sole Member of the Company the Company has no Members and no
Directors the personal representatives of such deceased Member shall have the right by notice in writing to appoint a
person to be a Director of the Company and such appointment shall be as effective as if made by the Company in Gen-
eral Meeting pursuant to paragraph (d) of this Article.
13. The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in General Meeting.
14. It shall not be necessary for a person appointed as a Director to hold any shares of the Company to qualify him
to act.
15. The Directors shall not be required to retire by rotation and clauses 73 to 80 inclusive shall not apply to the
Company.
Alternate Directors
16. Any Director may in writing appoint any person who is approved by the majority of the Directors, to be his al-
ternate to act in his place at any meeting of the Directors at which he is unable to be present. Every such alternate shall
be entitled to notice of meetings of the Directors and to attend and vote thereat as a Director when the person ap-
pointing him is not personally present, and where he is a Director to have a separate vote on behalf of the Director he
is representing in addition to his own vote. A Director may at any time in writing revoke the appointment of an alternate
appointed by him. Every such alternate shall be an officer of the Company and shall not be deemed to be the agent of
the Director appointing him.
Powers and duties of Directors
17. If and whenever the number of Directors shall be reduced below the minimum number it will be the duty of the
remaining Director to appoint one or more Directors and pending such appointment any other powers vested in the
Directors by Statute or otherwise shall be suspended.
18. The Directors from time to time, and at any time, may provide through Local Boards, Attorneys or Agencies for
the management of the affairs of the Company abroad, and may appoint any persons to be members of such Local
Boards, or as Attorneys or Agents and may remove any persons so appointed and appoint others in their place and may
fix their remuneration. The Company may exercise the powers conferred by Sections 32 and 104 of the Companies
Act, 1931, and those powers shall accordingly be exercisable by the Directors.
48606
19. The Directors from time to time at their discretion may raise or borrow any sum or sums of money without the
consent of the members in General Meeting for the purposes of the Company, and may raise or secure the repayment
of such money in such manner, and upon such terms and conditions in all respects as they think fit, and in particular by
the issue of debentures or debenture stock or any mortgage, charge or other security in the undertaking of the whole
or any part of the property of the Company (both present and future) including its uncalled capital for the time being.
20. The Directors may appoint a person who is willing to act to be Director, either to fill a vacancy or as an additional
Director, provided that the appointment does not cause the number of Directors to exceed any number determined
in accordance with clause 11 of these Articles as the maximum number of Directors for the time being in force.
21. The Company may by Ordinary Resolution in General Meeting remove any Director notwithstanding any other
provision contained in these Articles or in any agreement between the Company and such Director. The removal of a
Director pursuant to this Article shall be without prejudice to any claim he may have for damages for breach of any
contract of service between him and the Company.
Disqualification of Directors
22. The office of a Director shall be vacated if:-
(a) he ceases to be a Director by virtue of any provision of the Act or he becomes prohibited by law from being a
Director; or
(b) he is, or may be, suffering from mental disorder and either -
(i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act
1974, or
(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the Isle of Man or elsewhere) in matters concerning
mental disorder for his detention or for the appointment of a receiver, curator bonis or other person to exercise pow-
ers with respect to his property or affairs; or
(c) he resigns his office by notice to the Company.
23. A Director may hold any other office or place of profit under the Company except that of Auditor, upon such
terms as to remuneration, tenure of office, and otherwise as may be determined by the Board.
24. No Director shall be disqualified by his office from contracting with the Company, either as vendor, purchaser
or otherwise, nor shall any such contract or any contract or arrangement entered into or on behalf of the Company in
which any Director shall be in any way interested be avoided, nor shall any Director so contracting, or being interested
be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement by reason of such
Director holding office or the fiduciary relation thereby established, nor shall any such Director be precluded from vot-
ing in respect of any such contract or arrangement and clauses 94 to 97 inclusive in Table A shall be construed accord-
ingly.
Proceedings of Directors
25. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors and
unless so fixed the number shall be two.
26. A resolution in writing signed by every member of the board shall have the same effect and validity as a resolution
of the Board duly passed at a meeting of the Board duly convened and constituted.
27. A director shall be deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone or other elec-
tronic means and all directors participating in the meeting are able to hear each other.
Capital reserve
28. The Directors may establish a Capital Reserve, and either carry to the credit of such reserve from time to time
all monies realised on the sale of any Capital assets of the Company in excess of the price at which the same stand in
the books of the Company at the time, or apply the same in providing for depreciation or contingencies or other Capital
purposes. The Capital Reserve shall be available for dividend and may be used for any purpose to which the Capital of
the Company may be applied, including, without prejudice to the generality hereof, the writing down of the expenses
of Capital Debenture issues, and any discount on issues of Debentures. Any losses realised on the sale of any Capital
Assets may be carried to the debit of the Capital Reserve, except in so far as the Directors shall in their discretion
decide to make good the same out of other funds of the Company.
Indemnity
29. Every Director or other officer or auditor of the Company shall be entitled to be indemnified out of the assets
of the Company against all losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of the duties of
his office or otherwise in relation thereto, and no Director or other officer shall be liable for any loss, damage or mis-
fortune which may happen to or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office or in relation
thereto, but this Article shall only have the effect in so far as its provisions are not avoided by Section 151 of the Com-
panies Act, 1931 and clause 118 of Table A shall be construed accordingly.
The Directors may execute, in the name and on behalf of the Company in favour of any Director or other person
who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company, such debentures or mortgages
of the Company’s property (present and future) as they think fit and any such mortgages may contain a power of sale
and such other powers, covenants and provisions as shall be agreed upon.
48607
Dividends
30.
(a) Any General Meeting declaring a dividend may resolve that such dividend be paid wholly or in part by the distri-
bution of specific assets and in particular of paid-up shares, debentures or debenture stock of the Company or paid-up
shares, debentures or debenture stock of any other company or in any one or more of such ways.
Any General Meeting may resolve that any moneys, investments or other assets forming part of the undivided profits
of the Company standing to the credit of the Reserve Fund or in the hands of the Company and available for dividend
be capitalised and distributed among the shareholders in accordance with their rights on the footing that they become
entitled thereto as capital, and that all or any part of such capitalised fund be applied on behalf of the shareholders in
paying up in full unissued shares of the Company and that such unissued shares so fully paid be distributed accordingly
amongst the shareholder in the proportion in which they are entitled to receive dividends, and shall be accepted by
them in full satisfaction of their interest in the said capitalised sum.
For the purpose of giving effect to any resolution under this Article the Directors may settle any difficulty which may
arise in regard to the distribution as they think expedient and, in particular, may issue fractional certificates and may fix
the value or distribution of any specific assets, and may determine that cash payments shall be made to any members
upon the footing of the value so fixed, or that fractions of less value than GBP 1 may be disregarded in order to adjust
the rights of all parties, and may vest any such cash or specific assets in trustees upon such trusts for the persons entitled
to the dividend or capitalised fund as may seem expedient to the Directors. Where requisite a proper contract shall be
filed in accordance with Section 42 of the Companies Act, 1931, and the Directors may appoint any person to sign such
contract on behalf of the persons entitled to the dividend or capitalised fund, and such appointment shall be effective.
(b) Any dividend which has remained unclaimed for six years from the date when it became due for payment shall, if
the Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company and clause 108 of the Table shall be
construed accordingly.
Notices
31. A notice may be given by the Company to any member either personally or by sending it by post or fax to him
to his registered address. Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by prop-
erly addressing, prepaying and posting a letter containing the notice, and to have been effected in the case of a notice
of a Meeting at the expiration of 48 hours after the letter containing the same is posted and in any other case at the
time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post. Clause 111 of Table A shall not apply to the
Company.
32. A notice may be given by the Company to the joint holders of a share by giving notice to the joint holder named
first in the register of members in respect of the share.
Official seal of the Company
33. The Company may exercise all the powers given by Section 32 of the Act subject to the regulations of the Com-
pany for the time being.
Transfer of shares
34. The Directors may, in their absolute discretion and without assigning any reason therefore, decline to register
the transfer of a share, whether or not it is a fully paid share, and the first sentence of clause 24 in Table A shall not
apply to the Company.»
<i>Quatrième résolutioni>
Sous réserve de la réalisation de la Condition et avec effet à la Date du Transfert, l’associée unique décide de cesser
toutes les activités de la Société à Luxembourg et de clôturer les comptes de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
Sous réserve de la réalisation de la Condition et avec effet à la Date du Transfert, l’associée unique décide de mettre
fin aux mandats de Madame Jeannette Payer, Monsieur Stefan Ziegler et Monsieur Larry Levinson, en tant que gérants
de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
Sous réserve de l’exécution de la Condition et avec effet à la Date du Transfert, l’associée unique décide de fixer le
nombre d’administrateurs à trois et de nommer Monsieur Stefan Ziegler, Monsieur Chris Eaton et Monsieur Larry Le-
vinson comme nouveaux administrateurs de la Société pour une durée indéterminée.
<i>Septième résolutioni>
Sous réserve de la réalisation de la Condition et avec effet à la Date du Transfert, l’associée unique décide de mettre
fin au mandat de KPMG AUDIT, Société Civile, en tant que commissaire aux comptes de la Société.
<i>Huitième résolutioni>
Sous réserve de la réalisation de la Condition et avec effet à la Date du Transfert, l’associée unique décide de fixer
le nombre des commissaires aux comptes à un et de nommer BROWNE CRAINE & CO., demeurant à Burleigh Manor,
Peel Road, Douglas, Ile de Man, comme nouveau commissaire aux comptes de la Société jusqu’à la tenue de la prochaine
assemblée générale annuelle de la Société, qui se tiendra en 2005.
<i>Neuvième résolutioni>
Sous réserve de la réalisation de la Condition et avec effet à la Date du Transfert, l’associée unique décide de fixer
le siège social de la Société à 1st floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4RW.
48608
<i>Dixième résolutioni>
L’associée unique décide de donner pouvoir et d’autoriser Madame Therese Ryan ou tout autre agent de CORPO-
RATE SERVICE PROVIDER ILS (ISLE OF MAN) LIMITED d’effectuer et de signer tous actes, documents, procès-ver-
baux, papiers, certificats et d’exercer toute action ou d’exécuter tout acte requis par «Part 1 of the Companies (Transfer
of Domicile) Act 1988» pour le transfert de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Ile de Man et en relation
avec les résolutions susmentionnées.
<i>Onzième résolutioni>
L’associée unique décide de donner pouvoir et d’autoriser tout avocat de WILDGEN & PARTNERS d’effectuer et
signer tous actes, documents, procès-verbaux, papiers, certificats et d’exercer toutes actions requises par le Grand-
Duché de Luxembourg pour le transfert de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Ile de Man et en relation
avec des résolutions susmentionnées.
<i>Douzième résolutioni>
L’associée unique décide de reconnaître et d’approuver l’adhésion aux contrats suivants:
1) un contrat d’achat (le «Contrat d’achat»), daté du 19 avril 2004 et conclu entre MEDIA RELEASING INTERNA-
TIONAL LTD. («MEDIA»), l’acheteur, et la Société, représentée par le gérant de sa branche suisse, le vendeur, aux ter-
mes desquels la Société accepte de vendre à MEDIA le droit de sortir le film «Love’s Enduring Promise»;
2) un contrat de service de production (le «Contrat de production»), daté du 19 avril 2004 et conclu entre LARRY
LEVINSON PRODUCTIONS INC. («LLP»), et la Société, représentée par le gérant de sa branche suisse, en relation
avec les services de production à effectuer par LLP sur la demande de la Société, dans le cadre d’un film télévisé de la
semaine intitulé «Love’s Enduring Promise»;
3) un contrat d’achat sommaire, daté du 19 avril 2004, conclu entre MEDIA et la Société, représentée par le gérant
de sa branche suisse, conformément au paragraphe 7 (Delivery, Redelivery) du Contrat d’achat, et
4) un contrat intitulé «Copyright mortgage and assignment for purposes of security», daté du 19 avril 2004, conclu
entre MEDIA et la Société, représentée par le gérant de sa branche suisse, aux termes desquels la Société a accordé à
MEDIA une sûreté sur les droits, titres et intérêts de la Société dans le film intitulé «Love’s Enduring Promise», dans le
but d’assurer les obligations présentes et futures de la Société relevant du Contrat d’achat.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou pour lesquels elle a la charge en raison du présent acte, est évalué à deux mille euros (EUR 2.000,-).
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, représentée tel que
susmentionné, le présent acte est dressé en anglais, suivi d’une version française et en cas de contradictions entre le
texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date susmentionnée en tête du présent document.
Le présent acte ayant été lu à la mandataire, elle a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Brewer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, vol. 144S, fol. 48, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(064032.2/222/598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.
GROSSMANN BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen.
H. R. Luxemburg B 98.954.
—
Im Jahre zweitausendvier, den einundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Ist erschienen:
Herr Hans Karl Grossmann, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54441 Temmels, Bahnhofstrasse 3,
hier vertreten durch Herrn Dan Epps, Buchhalter, wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, auf Grund
einer Vollmacht unter Privatschrift vom 20. Juli 2004,
welche Vollmacht, von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Ur-
kunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Alleiniger Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GROSSMANN BAU, S.à r.l., mit Sitz in L-5553 Re-
mich, 48, Quai de la Moselle,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 98.954,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitze in Luxemburg, am
30. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 322 vom 20. März
2004.
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile
von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-), welche integral durch Herrn Hans Karl Grossmann, vorgenannt, übernom-
men wurden.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 août 2004.
T. Metzler.
48609
Herr Hans Karl Grossmann, vertreten wie eingangs erwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat
den unterzeichneten Notar ersucht nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber, vertreten wie eingangs erwähnt, beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Remich nach Mer-
tert zu verlegen.
Die genaue Anschrift lautet: Zone Industrielle Fausermillen, L-6689 Mertert.
<i>Zweiter Beschlussi>
Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 5 der Statuten abgeändert um folgenden Wort-
laut zu erhalten:
Art. 5. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Mertert.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber, vertreten wie eingangs erwähnt, beschliesst Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm fol-
genden Wortlaut zu geben:
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), eingeteilt in einhundert (100)
Anteile von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-), welche integral durch Herrn Hans Karl Grossmann, Geschäftsfüh-
rer, wohnhaft in D-54441 Temmels, Bahnhofstrasse 3, übernommen wurden.
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Anteilhaber, vertreten wie eingangs erwähnt, beschliesst Artikel 15 der Statuten abzuändern um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr fünfhundertfünfzig Euro (EUR 550,-).
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: D. Epps, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 juillet 2004, vol. 358, fol. 1, case 8.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für Gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(063532.3/201/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
GROSSMANN BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen.
H. R. Luxemburg B 98.954.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063533.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
CLASSE ETOILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 67.461.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07843, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063381.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Echternach, den 29. Juli 2004.
H. Beck.
Echternach, le 29 juillet 2004.
H. Beck.
Luxembourg, le 3 août 2004.
<i>Pour CLASSE ETOILE S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
48610
TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 45.757.
—
L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRUST INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1
er
étage, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 45.757, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 26 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 34 du 27 janvier 1994. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumen-
tant, en date du 17 juin 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rika Mamdy, administrateur-délégué, demeurant profession-
nellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Priem, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Ferrer, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quinze mille (15.000) actions représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification de l’article 13 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs
dont celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dans les limites de ses
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.»
Suit la traduction anglaise:
«Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signature of two directors includ-
ing the signature of the managing director or by the single signature of the managing director acting within the limits of
his powers. In their current relations, with the public administrations, the company is validly represented by one direc-
tor, whose signature legally commits the company.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Mamdy, A. Priem, O. Ferrer, H. Hellinckx.
48611
Enregistré à Mersch, le 16 juillet 2004, vol. 428, fol. 25, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063540.3/242/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 45.757.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063541.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
CAESER HOUSE S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 193, route de Longwy.
R. C. Luxembourg E421.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg soussigné.
Ont comparu:
1) Monsieur Dominic Critchley, comptable, né à Colchester/Grande-Bretagne, le 6 octobre 1968, demeurant à
F-57480 Kerling les Sierck, 1, rue Principale.
2) Madame Judith Critchley-Wilson, professeur d’anglais, épouse Dominic Critchley, née à Londres/Grande-Bretagne,
le 10 septembre 1968, demeurant à F-57480 Kerling les Sierck, 1, rue Principale.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre
eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de CAESER HOUSE S.C.I.
Art. 2. La société a pour objet, pour son propre compte, la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles
qu’elle pourrait détenir ou acquérir. La société pourra, dans le cadre de son activité, constituer toute garantie hypothé-
caire ou autre à ses créanciers éventuels et même se porter caution réelle ou personnelle en faveur de tiers.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents Euros (2.500,- EUR) divisé en cinquante (50) parts sociales
d’une valeur de cinquante Euros (50,-) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sociales sont souscrites comme suit:
Les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents Euros
(2.500,00 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi que la preuve par attestation bancaire
en ayant été apportée au notaire qui le constate.
Art. 6. La société est administrée et gérée par:
1) Monsieur Dominic Critchley, comptable, né à Colchester/Grande-Bretagne, le 6 octobre 1968, demeurant à
F-57480 Kerling les Sierck, 1, rue Principale.
2) Madame Judith Critchley-Wilson, professeur d’anglais, épouse Dominic Critchley. née à Londres/Grande-Bretagne,
le 10 septembre 1968, demeurant à F-57480 Kerling les Sierck, 1, rue Principale.
Le ou les gérant(s) est (sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir individuellement au nom de la société
en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Il(s) peut(vent) acheter, vendre ou échanger tous immeubles, contracter tous prêts, consentir toutes hypothèques,
accorder toutes mainlevées avec ou sans constatation de paiement, consentir toutes postpositions.
Il(s) peut(vent) conférer à telles personnes que bon lui/leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déter-
minés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 7. Les décisions des associés sont prises à la majorité absolue. Toutefois, les décisions entraînant une modifica-
tion statutaire ou les décisions y assimilées requièrent l’unanimité.
Mersch, le 27 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 27 juillet 2004.
H. Hellinckx.
1) Monsieur Dominic Critchley, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2) Madame Judith Critchley-Wilson, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
48612
Art. 8. En cas de décès d’un des associés, la société ne sera pas dissoute mais continuera entre les associés survivants
et les héritiers de l’associé dûment agréés.
Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément exprès de
tous les autres associés. Elles ne peuvent être transmises à cause de mort que moyennant agrément donné par l’ensem-
ble des associés survivants. Cet agrément n’est pas requis si les parts sont transmises à des associés.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat
des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
Art. 10. Les parts sociales sont indivisibles. Lorsqu’elle appartiennent à plusieurs propriétaires de façon indivise, les
associés co-indivisaires doivent être représentés, dans leurs relations avec la société, par un mandataire unique désigné
par les indivisaires.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et il sera dressé un inventaire compre-
nant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessai-
res ou utiles, constitue le bénéfice net de la société.
Art. 12. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, il est fait référence aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont
estimés à 1.000,- Euros.
<i>Déclarationi>
Les constituants déclarent que, Monsieur Dominic Critchley et Madame Judith Critchley-Wilson, étant époux et
épouse, la société est à considérer comme société familiale au sens de la loi du 29 décembre 1971.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
Signé: D. Critchley, J. Wilson, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 66, case 1. – Reçu 12,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064046.3/216/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.
PRECIS INTERACTIVE LANGUAGE LEARNING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5772 Weiler-la-Tour, 16, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 102.073.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Judith Critchley-Wilson, professeur d’anglais, épouse Dominic Critchley, née à Londres/Grande-Bretagne,
le 10 septembre 1968, demeurant à F-57480 Kerling-les-Sierck, 1, rue Principale.
Laquelle comparante a requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions légales
en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la gestion d’un organisme de formation professionnelle continue.
Elles peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension, sans
pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.
Art. 3. La société prend la dénomination de PRECIS INTERACTIVE LANGUAGE LEARNING, S.à r. l., Société à res-
ponsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Weiler-la-Tour. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.
Luxembourg, le 2 août 2004.
J.-P. Hencks.
48613
Toutes ces parts sont attribuées à l’associée unique Madame Judith Critchley-Wilson, professeur d’anglais, épouse
Dominic Critchley, née à Londres/Grande-Bretagne, le 10 septembre 1968, demeurant à F-57480 Kerling les Sierck, 1,
rue Principale.
Art. 7. Tant que la société ne compte qu’un seul associé, les parts sociales sont librement cessibles. Si la société
compte plus d’un associé les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que con-
formément aux dispositions légales.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’associé unique ou, selon le
cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum par l’assemblée générale des associés.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-
blies par écrit.
De même, les contrats conclu entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse un
inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Mesure transitoirei>
La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2004.
<i>Coûti>
Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont
mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à 1.100,- Euros.
<i>Constatationi>
Le notaire constate, sur le vu d’une attestation bancaire, que les parts sociales ont été entièrement libérées par un
versement en espèce, en sorte que le capital social se trouve à la disposition de la société.
<i>Résolutionsi>
Les statuts ayant été arrêtés, l’associé unique prend les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un.
2) Est nommé gérante unique pour une durée illimitée:
Madame Judith Critchley-Wilson, professeur d’anglais, épouse Dominic Critchley, née à Londres/Grande-Bretagne,
le 10 septembre 1968, demeurant à F-57480 Kerling-les-Sierck, 1, rue Principale.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
3) Le siège social est établi à L-5772 Weiler-la-Tour, 16, rue du Cimetière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, la comparante a signé avec le notaire.
Signé: D. Critchley, J. Wilson, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 66, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064047.3/216/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.
Luxembourg, le 2 août 2004.
J.-J. Hencks.
48614
CARTOLA SHIPPING INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 86.682.
—
In the year two thousand four, on the seventh day of July.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) MARUBENI CORPORATION, having its registered office 4-2 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8088,
Japan;
2) ITOCHU CORPORATION, with registered office at 4-1-3, Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan,
both here represented by Mr Angelo Schenkers, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of two proxies given respectively on April 2, 2004 and March 31, 2004.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-
ing:
The appearing parties,
holding together 100% of the share capital of CARTOLA SHIPPING INVESTMENT, S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, incorporated by deed of the notary Gérard Lecuit, residing then in Hesperange, on the 14th of March 2002,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 967 on June 25, 2002, the articles of which have
been amended by deed of the same notary Lecuit on August 7, 2002, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations, number 1528 on October 23, 2002,
represented as stated hereabove, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have
taken by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to suppress the nominal value of the shares.
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to convert the corporate capital of the company from its current amount of twelve thou-
sand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into 250 «A» Ordinary Shares and 250 «B» Ordinary Shares, into fifteen
thousand three hundred fifty-six point twenty United States dollars (15,356.20 USD) at the rate of exchange of 1 USD
for 0.8140 EUR prevailing on July 6, 2004.
The proof of the rate of exchange existing between the United States Dollar and the Euro on July 6, 2004 has been
given to the undersigned notary.
The shareholders decide to convert all accounts in the books of the Company from Euro (EUR) into United States
Dollars (USD).
<i>Third resolutioni>
The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of one hundred forty-three point eighty
United States dollars (143.80 USD) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will
amount to USD 15,500.- represented by 250 «A» Ordinary Shares and 250 «B» Ordinary Shares without designation
of a nominal value.
This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders each proportionally
to his respective actual participation in the share capital, so that the amount of one hundred forty-three point eighty
United States dollars (143.80 USD) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the un-
dersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders decide the reintroduction of a nominal value to thirty-one United States dollars (31.- USD) per
share.
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders decide the subsequent amendment of:
- Article 1 point (1) fourth and ninth sentences of the articles of incorporation which will read as follows:
<i>fourth sentencei>:
«A» Ordinary Shares means the «A» Ordinary Shares of USD 31 each in the capital of the Company;
<i>ninth sentencei>:
«B» Ordinary Shares means the «B» Ordinary Shares of USD 31 each in the capital of the Company;
- Article 3 point (a) of the articles of incorporation which will read as follows:
«3. Share capital
(a) The share capital of the Company at the date of the adoption of these Articles is USD 15,500 divided into 250
«A» Ordinary Shares and 250 «B» Ordinary Shares, with a par value of USD 31 each, all of which «A» Ordinary Shares
and «B» Ordinary Shares have been subscribed for, paid up and issued to their respective holders.»
There being no further business, the meeting is terminated.
48615
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed of capital, is approximately EUR 2,000.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quatre, le sept juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. MARUBENI CORPORATION, ayant son siège social au 4-2 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japon;
2. ITOCHU CORPORATION, ayant son siège social au 4-1-3, Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka, Japon,
toutes deux ici représentées par Monsieur Angelo Schenkers, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations datées respectivement du 2 avril 2004 et du 31 mars 2004.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Les comparantes, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- les parties comparantes, détenant ensemble 100% du capital de CARTOLA SHIPPING INVESTMENT, S.à r.l., so-
ciété à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit alors de résidence à Hesperange, en date
du 14 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 967 du 25 juin 2002, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire Lecuit en date du 7 août 2002, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1528 du 23 octobre 2002,
représentées comme dit-est, ont immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et ont
pris, par vote unanime, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Les associés décident de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident la conversion du capital social de la société de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) divisé en 250 parts ordinaires de catégorie «A» et 250 parts ordinaires de catégorie «B», en quinze
mille trois cent cinquante-six virgule vingt dollars des Etat-Unis (15.356,20 USD) représenté par 250 parts ordinaires de
catégorie «A» et 250 parts ordinaires de catégorie «B», au cours de conversion du 6 juillet 2004, à savoir 1,- USD pour
0,8140 Euro.
La preuve du cours de change existant à la date du 6 juillet 2004 entre le dollar des Etats Unis et l’euro a été apportée
au notaire soussigné.
Les associés décident de convertir tous les comptes dans les livres de la société d’Euro (EUR) en dollars des Etats-
Unis (USD).
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital de la société d’un montant de cent quarante trois virgule quatre-vingts
dollars des Etat-Unis (143,80 USD), sans émission de parts sociales nouvelles, de sorte qu’après l’augmentation, le capital
social s’élèvera à quinze mille cinq cents dollars des Etat-Unis (15.500,- USD) représenté par 250 parts ordinaires de
catégorie «A» et 250 parts ordinaires de catégorie «B» sans désignation de valeur nominale.
L’augmentation de capital ainsi réalisée a été entièrement libérées par des versements en espèces par les associés
actuels de la société, de sorte que la somme de cent quarante trois virgule quatre-vingts dollars des Etat-Unis (143,80
USD), se trouve à la libre disposition de la société, preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de réintroduire une désignation de la valeur nominale de trente et un dollars des Etat-Unis (31,-
USD) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident en conséquence de modifier:
- l’article 1
er
point 1, phrases 4 et 9 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:
<i>phrase 4i>:
Parts ordinaires «A» désigne les parts ordinaires de catégorie «A» de USD 31 chacune dans le capital de la Société;
<i>phrase 9i>:
Parts ordinaires «B» désigne les parts ordinaires de catégorie «B» de USD 31 chacune dans le capital de la Société;
- l’article 3 point (a) des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
48616
«3. Capital social
(a) A la date des présentes, le capital social s’élève à USD 15.500 divisé en 250 parts ordinaires de catégorie «A» et
250 parts ordinaires de catégorie «B», d’une valeur nominale de USD 31 chacune; toutes ces parts ordinaires «A» et
toutes ces parts ordinaires «B» ont été souscrites, libérées et émises à leurs propriétaires respectifs.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. Schenkers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, vol. 144S, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064419.3/220/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.
CARTOLA SHIPPING INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 86.682.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064420.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.
CFC REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.304.
—
Les comptes annuels au 31 octobre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03053, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063428.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
ARDIZZONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 57.452.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2004i>
Conseil d’Administration:
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Goerges Gredt, comptable, demeurant à Luxembourg,
- Madame Claude Kraus, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Commissaire aux Comptes:
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Siège social:
Le siège social se trouve à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Luxembourg, le 7 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07841. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé) Signature:
(063377.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.
Luxembourg, le 3 août 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 3 août 2004.
G. Lecuit.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
48617
ROBECO MULTIMANAGER FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 95.470.
—
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders to be held on Thursday <i>21 October 2004i> at the registered office of the Company, at 10.30 a.m.
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and auditor’s report;
2. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2003/2004;
3. Consideration and approval of the profit appropriation for the sub-funds for the financial year 2003/2004;
4. To give discharge to the members of the Board of Directors;
5. Statutory appointments;
6. Any other business.
Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken at a simple majority of the shares
present or represented at the meeting.
The annual report 2003/2004 may be obtained at the registered office of the Company and is also available via
www.robeco.com.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform the bank or institution through which the
shares are held in writing of their intention not later than Wednesday, 13 October 2004. Shareholders who hold their
shares in another way should inform the Board of Directors of the Company at the registered office in writing of their
intention not later than Wednesday, 13 October 2004.
Luxembourg, 12 October 2004.
(04191/584/24)
<i>The Board of Directors.i>
OPAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.977.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of OPAL will be held at its registered office at 40, avenue Monterey, Luxembourg on Tuesday <i>19 October
2004i> at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Audited Annual Report and acceptance of the Auditor’s Report for the year ended 30 June 2004.
2. Ratification of Decision on Directors’ Fees.
3. Election of Directors.
4. Election of the Auditor.
5. Miscellaneous.
<i>Voting:i>
Resolutions on the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of
the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.
<i>Voting Arrangements:i>
Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the registered office of the Company to arrive not later than 18 October 2004. Proxy forms will be sent to registered
shareholders with a copy of this Notice and can also be obtained from the registered office.
7 October 2004.
(04386/041/23)
<i>The Board of Directors.i>
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 58.959.
—
The Board of Directors of the Company hereby convenes
EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS
of Shareholders of
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco North American Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco European Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Chinese Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Financials Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Food & Agri Equities (EUR) - Class A Shares;
48618
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco IT Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Telecom Services Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco European MidCap Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Media Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Consumer Goods Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Capital Goods Equities (EUR) - Class A Shares;
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Energy Equities (EUR) - Class A Shares,
to be held on <i>21 October 2004i> at the registered office of the Company at 69, route d’Esch in Luxembourg at 11.00 a.m.
to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Extraordinary resolutioni>
To approve the amalgamation of Class A Shares of the abovementioned sub-funds (Class A Shares) into Class D
Shares of the same sub-fund (Class D Shares) pursuant to Article 5 of the Articles of Association of the Company and
the subsequent cancellation of all existing Class A Shares against the issue of Class D Shares on the basis of the net asset
value of the two shares classes of the same sub-fund, effective on 26 November 2004.
There is no quorum required for these Extraordinary General Meetings, and the Extraordinary Resolution will be
adopted if approved by a simple majority of the shares present or represented.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Shareholders wishing to attend and vote at the Meeting should inform the bank or institution through which their
shares are held in writing of their intention not later than 14 October 2004. Shareholders holding their shares in another
way, who wish to attend and vote at the Meeting should inform the Board of Directors of the Company at its registered
office in writing of their intention not later than 14 October 2004.
For any further questions, you may contact your financial adviser or usual Robeco sales representative.
Luxembourg, 12 October 2004.
(04282/584/40)
<i>The Board of Directors.i>
YXSIS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 69.675.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le jeudi <i>28 octobre 2004i> à 11.30 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2003;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.
I (04354/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CREDIT AGRICOLE FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 68.806.
—
The aforementioned Company Board of Directors hereby has the honour to invite the Shareholders to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on Friday, <i>29 October 2004i> at 11.00 a.m. at the Head Office of the Company for the purposes of
deliberating upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1.
Acknowledgement of the reports of the Chairman of the Board of Directors and the Independent Auditor.
2.
Approval of the financial statements including the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts as at June 30,
2004.
3.
Allotment of results, as proposed by the Board of Directors:
- Dividend per share paid to Shareholders holding distribution Shares of the Classic and Private Sub-Class:
<i>Privatei>
<i>Classici>
<i>Sub-Class Sub-Classi>
48619
Shareholders are advised that the Meeting does not have to be quorate in order to pass valid resolutions. To be ac-
cepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented.
Shareholders bearing shares in the name of the bearer and wishing to take part in the Regular General Meeting are
kindly requested to provide documentary evidence of their certificates at the main offices of the Company by no later
than 25 October 2004.
<i>Equity Portfolios
i>CA Funds Europe Sector Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.18
0.40
CA Funds Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.22
0.09
CA Funds Iberia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-
0.08
CA Funds Europe Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-
0.05
<i>Bond Portfolios
i>CA Funds Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.07
0.43
CA Funds Euro Corporate Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.13
0.48
CA Funds Global Bond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0.04
0.37
CA Funds Swiss Franc Bond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
0.07
0.25
CA Funds US Dollar Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0.07
0.30
CA Funds Emerging Markets Debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0.56
0.55
CA Funds European High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.54
-
<i>Reserve Portfolios
i>CA Funds Euro Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.04
0.17
Record date:
20 September 2004
Ex-date:
21 September 2004
Payment date: 30 September 2004
- Dividend per share paid to the Shareholders holding distribution Shares of Institutional II Sub-Class from No-
vember 2003 until September 2004 included:
<i>Portfolioi>
<i>Currency Amounti>
CA Funds Euro Corporate Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.50
CA Funds Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.50
The ex-date is set on the 2
nd
of each relevant month, the payment made within five business days.
- Dividend per share paid to the Shareholders holding distribution Shares of CA Funds European High Yield
Bond Institutional II Sub-Class:
<i>Datesi>
<i>Currency Amounti>
April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.22
From May until August 2004 included . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.64
The ex-date is set on the 2
nd
of each relevant month, the payment made within five business days.
- Payment of a final dividend of EUR 0.50 per share to the Shareholders holding Distribution Shares of CA
Funds Euro Corporate Bond and CA Funds Euro Bond Institutional II Sub-Class and a final dividend of EUR
0.64 per share paid to the Shareholders holding Distribution Shares of CA Funds European High Yield Bond
Institutional II Sub-Class on the 7th of September 2004 and the ex-date is fixed on the 2nd of September
2004.
- Statement that, from the 1st of October 2004, a dividend will be paid monthly to the Shareholders holding
distribution Shares of Institutional II Sub-Class as following:
<i>Portfolioi>
<i>Currency Amounti>
CA Funds Euro Corporate Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.50
CA Funds Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0.50
CA Funds European High Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
0.64
The ex-date is set on the 2
nd
of each relevant month, the payment made within five business days.
4.
Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ending on June
30, 2004.
5.
Statutory nominations:
- resignation of Mr Charles Hamer dated of the 30th of September 2004;
- nomination of Mr Michel de Robillard as Director in replacement of Mr Charles Hamer;
- nomination of Mr Pascal Voisin as Director;
- renewal of the mandate of Messrs Alain Massiera, Paul-Henri de La Porte du Theil, Bruno de Felcourt, Francis
Candylaftis, Bruno Calmettes, Etienne Clement, Michel Escalera, Gérard Griseti, Gilles Martinengo, Ian Mc-
Evatt, Saverio Perissinotto, Jean-François Pinçon as Directors.
6.
Renewal of the mandate of the Independent Auditor.
7.
Allocation of the Directors’ fees as proposed by the Board (i.e. 3,000.- EUR to be allotted to Directors non
employed by CREDIT AGRICOLE Group).
8.
Miscellaneous.
48620
Shareholder proxies wishing to take part in the Regular General Meeting are kindly requested to inform the Company
at least three clear days prior to the holding of the Shareholders Meeting of their intention to attend. They shall be
admitted subject to verification of their identity.
The June 2004 report is available to shareholders at the head offices of the Company.
I (04353/755/82)
<i>The Board of Directorsi>.
BELLEFONTAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.721.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>20 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
II (04126/788/17)
PROMVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.721.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 octobre 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 avril 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (04162/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.022.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 octobre 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 31 mars 2004;
b. Rapport du Commissaire de Surveillance;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 mars 2004;
d. Affectation du résultat;
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. Démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. Délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. Divers.
II (04220/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48621
HERALDA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 15.872.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 octobre 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2004.
4. Divers.
II (04202/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
QUASAR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.990.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>21 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2004,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
6. Réélections statutaires,
7. Divers.
II (04203/520/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
QUANTICO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 27.630.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (04250/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.B.F. S.A., INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 30.538.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires de notre société qui se tiendra par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
au siège social, en date du <i>20 octobre 2004i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. En vue de compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2003 d’un montant de EUR 142.494,07 (cent quarante-
deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros sept centimes) au vu du bilan de la société relatif à l’exercice
clos au 31 décembre 2003, réduction et augmentation de capital d’un même montant de EUR 142.494,07 (cent
48622
quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros sept centimes), par la réduction et l’augmentation
correspondante à la valeur nominale des actions existantes, l’augmentation de capital étant souscrite par les ac-
tionnaires existants au prorata des actions détenues, et libérées par la conversion d’une créance de ces actionnai-
res sur la société, au vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprises;
2. Divers.
II (04300/1161/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DUEMME SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.834.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the «Meeting») of DUEMME SICAV (the «Fund») will be held at the registered office of the Fund, as
set out above, on <i>October 21, 2004i> at 2 p.m., for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the board of directors and of the auditor for the accounting year ended June 30, 2004.
2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended June 30, 2004.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended June 30,
2004.
5. Composition of the board of directors.
6. Re-election of the auditor.
7. Miscellaneous.
The present notice and a form of proxy are sent to all registered shareholders on record as at October 4, 2004.
In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates five busi-
ness days before the Meeting at the windows of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxem-
bourg, where forms of proxy are available.
Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed proxy form and return
it at least five business days prior to the date of the Meeting to the registered office of the Fund.
II (04277/755/25)
<i>By order of the board of directors.i>
CREDIT AGRICOLE FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 68.806.
—
Shareholders are kindly invited to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held at the offices of CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg on <i>20i>
<i>thi>
<i> October, 2004i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To amend the articles of incorporation in order to submit the Company to Part I of the law of 20 December 2002
regarding undertakings for collective investments.
As a consequence to amend the following Articles:
Article 3 in order to read as follows: «the exclusive object of the Company is to place the monies available to it
in transferable securities of all types and all other permitted assets such as referred to in Article 41 (1) of the law
of 20 December 2002 regarding undertakings for collective investments or any legislative replacements or amend-
ments thereof (the «2002 Law») with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its portfolio.
Article 5, second paragraph, in order to reflect that the minimum capital of the Company shall not be less than
one million two hundred and fifty thousand euros.
Article 16, third paragraph, in order to replace the reference to the law of 30 March 1988 by a reference to the
law of 20 December 2002. Amendment of the fourth paragraph of the same Article, in order to insert the new
investment restrictions in accordance with the law of 20 December 2002 on undertakings for collective invest-
ments.
Article 20 in order to replace the reference to Article 89 of the 1988 Law by a reference to Article 113 of the
2002 Law.
Article 28, second paragraph, in order to replace the reference to Article 83 of the 1988 Law by a reference to
Article 107 of the 2002 Law.
Article 30, first paragraph, in order to replace the reference to the 1988 Law by the 2002 Law.
48623
2. To amend the articles of incorporation in order to delete all references to bearer shares and state that shares are
issued in registered form only, with effect from 1 December 2004.
To authorise the board of directors to convert all bearer shares outstanding, with effect from 1 December 2004
into registered shares and to register such shares in the share register in the name of their owner upon presenta-
tion to the transfer agent of the relevant bearer share certificates with all unmatured coupons attached thereto
and to cancel all bearer share certificates with effect from 1 December 2004.
As a consequence to amend the following Articles:
Article 6, replace all references to bearer shares by reference to registered shares.
Article 7, deletion of the provisions on the loss of shares certificates and deletion of references to Article 7 and
renumbering of subsequent articles.
3. To amend the articles of incorporation in order to change the reference currency from US Dollars to EUR.
As a consequence to amend the following Articles:
Article 5, sixth paragraph, in order to replace the references to US dollars with EUR.
Article 20, eighth paragraph, in order to replace the references to US dollars with EUR.
Article 22, first paragraph, in order to replace the references to US dollars with EUR.
Article 24, second paragraph, in order to replace the references to US dollars with EUR.
4. To amend Article 9, first paragraph, in order to delete the reference to the first annual general meeting.
5. To amend Article 11, second paragraph, in order to mention that convening notices may be sent by ordinary mail
if the publications required by law are made.
6. To amend Article 13, fourth paragraph, in order to provide the possibility for directors to vote at board meetings
by way of conference call or visio-conference.
7. To amend Article 20 section (ii) and paragraph three in order to delete the reference to «or in any period of seven
consecutive Dealing Days in order to read as follows:
«(ii) the Company shall not be bound to redeem on any Dealing Day more than 10% of the number of Shares of
any Portfolio in issue on such Valuation Day.
If on any Dealing Day the company receives requests for redemptions of a greater number of Shares, it may declare
that such redemptions are deferred until a Dealing Day not more than seven Dealing Days following such time.
On such Dealing Day, such requests for redemptions will be complied with, with priority to later requests».
8. To resolve that the effective date of the resolutions 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the above agenda shall become effective
on the date of the extraordinary general meeting and that the resolution 2 shall become effective on 1 December
2004.
The draft text of the restated Articles of Incorporation is available on request at the registered office of the Fund.
Shareholders are advised that at the extraordinary meeting a quorum of at least one half of the shares issued is re-
quired at the first meeting, which will otherwise be reconvened. Decisions may be approved by a majority of two-thirds
of the shares present and/or represented and voting.
If you are unable to attend the meeting in person, a proxy form giving authorisation to another named individual, can
be obtained from the principal office.
II (04314/755/67)
<i>The Board of Directorsi>.
MAURITEL, SOCIETE MAURITANIENNE ET LUXEMBOURGEOISE D’ENGINEERING ET DE
TELECOMMUNICATIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.006.
—
Messieurs les Actionnaires et Messieurs les Administrateurs sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MIXTE
des Actionnaires et des Administrateurs de la société, qui se tiendra le jeudi <i>21 octobre 2004i> à 15.00 heures, 3B, bou-
levard du Prince Henri (5
ème
étage).
<i>Ordre du jour:i>
– régularisation de la société au point de vue administratif et comptable;
– délibération sur la décision de la mise en liquidation de la société ou de la poursuite de ses activités.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au siège social.
II (04278/000/18)
G. Glesener
<i>Administrateuri>
48624
LUPICO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 23.707.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 octobre 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (04287/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COFIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.922.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra devant notaire au siège social, le <i>21 octobre 2004i>, à 14.30 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 29.200.000,- (vingt-neuf millions deux cent mille euros), par ré-
duction du pair des actions existantes, pour porter le capital de son montant actuel de EUR 30.000.000,- (trente
millions d’euros) à EUR 800.000,- (huit cent mille euros) par remboursement aux actionnaires d’un montant de
EUR 29.200.000,- (vingt-neuf millions deux cent mille euros), le but de la réduction étant d’adapter les moyens
financiers de la société à ses activités futures.
2. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 10,- chacune.
3. Modification de l’article 5, alinéa 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital souscrit est fixé à EUR 800.000,- (huit cent mille euros), représenté par 80.000
(quatre-vingt mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
4. Constitution d’une réserve indisponible de EUR 23.200.000,- par prélèvement d’un montant de EUR 2.920.000,-
de la réserve légale et d’un montant de EUR 20.280.000,- des résultats reportés.
II (04307/534/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LECOUTERE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.836.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du <i>21 octobre 2004i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination d’un commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels (bilans et comptes de résultat) pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001 et
2002
3. Divers
II (04276/502/17)
<i>Pour le Conseil d’Administration
Le Présidenti>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
ABC Container, G.m.b.H.
Hines European Value Added Fund
Special Risk Insurance and Reinsurance Luxembourg S.A.
Special Risk Insurance and Reinsurance Luxembourg S.A.
VAM Holdings S.A.
Timo Lux S.A.
Maxitim S.A.
Maxitim S.A.
Panorama, S.à r.l. - Agence de Voyages et de Tourisme
Strawberry Investment, S.à r.l.
Prim Investment, S.à r.l.
Samgwym Holdings S.A.
Samgwym Holdings S.A.
Halbi S.A.
Halbi S.A.
Alpine Copyright, GmbH
Grossmann Bau, S.à r.l.
Grossmann Bau, S.à r.l.
Classe Etoile S.A.
Trust International Luxembourg S.A.
Trust International Luxembourg S.A.
Caeser House S.C.I.
Precis Interactive Language Learning, S.à r.l.
Cartola Shipping Investment, S.à r.l.
Cartola Shipping Investment, S.à r.l.
CFC Reinsurance S.A.
Ardizzone International S.A.
Robeco Multimanager Funds
Opal
Robeco Capital Growth Funds
Yxsis Holding
Crédit Agricole Funds
Bellefontaine S.A.
Promvest S.A.
Moyens et Capitaux Européens S.A.
Heralda S.A.
Quasar International Holding S.A.
Quantico Finance S.A.
I.B.F. S.A., Informatique Bancaire et Financière
Duemme Sicav
Crédit Agricole Funds
MAURITEL, Société Mauritanienne et Luxembourgeoise d’Engineering et de Télécommunications
Lupico International Holding S.A.
Cofima Holding S.A.
Lecoutere Finance S.A.