This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
30529
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 637
21 juin 2004
S O M M A I R E
Aberdeen International Holdings S.A., Luxem-
Emerge Capital, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
30572
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30560
Etoile Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
30561
Aberdeen International Holdings S.A., Luxem-
Euronimbus S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . .
30548
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30560
Euronimbus S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . .
30551
Aberdeen International Holdings S.A., Luxem-
Europ Assistance, Société d’Assistance S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30560
bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30563
Aberdeen International Holdings S.A., Luxem-
Europartners Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
30570
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30560
Europartners Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . .
30570
Actaris Expansion S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
30549
Europrop Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
30562
Agar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30558
Fly-Tech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30557
Althize Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . .
30556
Fly-Tech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30557
Althize Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . .
30556
Fly-Tech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30557
Althize Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . .
30556
Fly-Tech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30557
Avenue de Wolvendael 61 Holding S.A., Luxem-
Gennaio Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30555
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30555
Glacier Luxembourg One, S.à r.l., Luxembourg . .
30531
Bank Leumi (Luxembourg) S.A., Senningerberg . .
30553
Glacier Luxembourg Two, S.à r.l., Luxembourg . .
30543
Banque du Gothard (Luxembourg) S.A., Luxem-
Hampden Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
30554
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30559
Handelsgest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30530
BCILUX, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30576
Handelsgest, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
30530
Bebop, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30561
Horizon Systems S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30559
Bebop, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30561
Immo Sud Partners S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . .
30550
Belcar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
30558
International Marine Travel S.A., Luxembourg . .
30565
Biel Fund Management Company S.A., Luxem-
Invirex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30549
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30562
Islands Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30557
Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
30576
Islands Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30557
Blue Steam & Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . .
30566
Jado Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . .
30566
Blue Wings Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
30556
Jessi International Holding S.A., Luxembourg. . . .
30567
Chiesi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
30559
JLEC Acquisition Company (Luxembourg), S.à r.l.,
COPARCOMI, Consortium de Participations
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30530
Commerciales et Industrielles S.A., Luxembourg
30567
Joh. Berenberg, Gossler & Co, Niederlassung Lu-
Colugest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30555
xemburg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30559
Comont Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
30549
Lux Communications S.A., Bertrange . . . . . . . . . .
30563
Cranbury Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
30575
Luxembourg Cambridge Holding Group S.A., Lu-
Cranbury Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
30575
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30575
D.R. (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30571
Luxembourg European and American Fund, Sicav,
Danieli International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30556
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30573
Danieli International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30562
Luxfuel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30551
Domac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30561
Magic Production Group (M.P.G.) S.A., Senninger-
Du Fort Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30550
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30536
Electro & Kichenzenter, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . .
30550
Marine Locations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30561
30530
HANDELSGEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2540 Luxemburg, 25, rue Edward Steichen.
H. R. Luxemburg B 17.934.
—
Die Gesellschaft hat ihren Sitz verlegt. Sie ist ab dem 1. Dezember 2003 unter folgender Adresse ansässig: 25, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxemburg.
Erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D Hartmann.
(034516.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
HANDELSGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 17.934.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2004.
(034519.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
JLEC ACQUISITION COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 95.650.
—
Par résolution en date du 8 mars 2004, le gérant unique de la société JLEC ACQUISITION COMPANY (LUXEM-
BOURG), S.à r.l., a décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04355. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034592.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Masters Consulting S.A., Hellange . . . . . . . . . . . . .
30575
Securitas Employee Convertible 2002 Holding
Metec S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30572
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30570
Millicom International Cellular S.A., Bertrange . .
30571
Seligman Global Horizon Funds, Sicav, Luxem-
Navimar Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30562
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30573
Nostrum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30565
Siko Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30571
Peinture Ludowissy, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . .
30549
Skipyard S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30558
ProLogis European Finance II, S.à r.l., Luxem-
Smart Venture Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
30562
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30553
SP Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30566
ProLogis European Finance III, S.à r.l., Luxem-
Stolt Offshore S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30574
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30553
Strazer Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30552
ProLogis European Finance IV, S.à r.l., Luxem-
Sungard Systems Luxembourg S.A., Luxembourg
30538
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30554
Tarvan Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30552
ProLogis European Finance V, S.à r.l., Luxem-
UBP Money Market Fund, Sicav, Luxembourg . . .
30571
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30554
Unirack Western Group S.A., Luxembourg . . . . . .
30573
ProLogis European Finance, S.à r.l., Luxembourg.
30551
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.,
Quezon Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30551
Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30559
Roche-Brune S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30555
W & W Asset Management AG, Luxemburg, Lu-
SAES Getters International Luxembourg S.A.,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30550
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30558
Walulux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30560
Sarlo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30554
Wasidor Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30553
SCAC International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
30552
Westam Longitude Fund, Sicav, Luxembourg . . . .
30574
HANDELGEST, S.à r.l.
Dr. B. Weber / S. Schwickerath
HANDELSGEST, S.à r.l.
Dr. B. Weber / S. Schwickerath
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Signature.
30531
GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 101.087.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the eighteenth day of May.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AIM SERVICES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 74.676,
here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg, on 17 May 2004.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There exists among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become
shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which shall be
governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of
incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
30532
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-
ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-
tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole Shareholder - Collective decisions of the Shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of man-
agement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorised to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
30533
<i>Subscription and Payment i>
All five hundred (500) shares are subscribed by AIM SERVICES, S.à r.l., aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisions i>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of
December 2004.
<i>Expenses i>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions i>
Immediately after the incorporation of the Company, AIM SERVICES, S.à r.l., representing the entirety of the sub-
scribed capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following legal entity is appointed as sole manager of the Company for an indefinite period:
AIM SERVICES, S.à r. l., aforementioned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundvier, den achtzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
AIM SERVICES, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz
in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg; R.C. Luxembourg B 74.676,
hier vertreten durch Frau Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 17. Mai 2004.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Partei und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung ei-
ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Es besteht hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft
Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,
sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-
ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
30534
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-
mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die
Dauer des Mandates fest.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu je-
dem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-
keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-
men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Ein-
klang stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-
heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus wel-
chem Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Haupversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
30535
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Januars jeden Jahres und endet am
letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf-
geführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. Gesellschaftsauflösung- Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten AIM SERVICES, S.à r.l., gezeichnet.
Die so gezeichneten Anteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, so wie es dem Notar nachgewiesen worden ist.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember
2004.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf EUR 1.500.-
geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
AIM SERVICES, S.à r.l., die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung
der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
2. Die folgende Gesellschaft wird als alleiniger Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
AIM SERVICES, S.à r.l., vorbenannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene hat diese mit dem amtierenden Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: A. Bellardi Ricci, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 mai 2004, vol. 427, fol. 75, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(045459.3/242/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Mersch, den 8. Juni 2004.
H. Hellinckx.
30536
MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 81.825.
—
In the year two thousand and four, on the fourth of June.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., a
société anonyme, established at L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves, R.C. Luxembourg section B number 81.825,
incorporated under the denomination of INTERNATIONAL MOTOR PARTS S.A. pursuant to a deed of Maître Jean
Seckler, notary residing at Junglinster, on the April 27, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations number 1030 of the November 19, 2001, p. 49406.
The Articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned no-
tary dated June 11, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 721 of July 8, 2003,
p. 34567.
The meeting begins at 3.30 p.m., Mr Salvatore Tosiani, assistant manager, with professional address at L-2633 Sen-
ningerberg, 6E, route de Trèves, acting on behalf of FERRERO B.V., being in the chair.
The Chairman appoints as secretary Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address at L-1750 Lux-
embourg, 74, avenue Victor Hugo.
The Chairman and the secretary appoint Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo as scrutineer.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary
to state:
<i>Agenda:i>
1) Amendment of the Article 3 of the Articles of Association in order to change the object of the Company.
2) Sundry items.
II. That the shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders, the Board
of the meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.
III. That the whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders represented de-
clare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.
IV. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The meeting decides to amend Article 3 of the Articles of Association concerning the object of the Company, which
shall henceforth read as follows:
«Art. 3: Object
The Object of the Company is:
To plan, develop, sell, acquire, transport, illustrate, enhance, produce multi-dimensional objects, surprises, web sites,
videos, video games, pictures, characters cards and greeting cards, titles, presentations, advertisements, fictions, serial-
ized novels, books, fantastic surprises, melodies, songs, films, cartoons, music and film publishing, fantastic and imaginary
stories, book publishing, software and hardware and all form of things, objects, products and accessories of any kind and
nature, and to promote, coordinate, exploit, carry out, engage, enhance, deal in and with all kind of related activities,
services, goods and investigations.
The Company may also provide services to other companies concerning advertising, entertainment and any other
services.
The Company may transfer, sell, buy, lease own, maintain, improve, register and record all intellectual property rights,
licences, patents and all kind of right concerning the web and multimedia world.
The Company may contract loans and grant all kinds of support, advances and guarantees to other companies. The
Company may also acquire, manage and dispose of participations in whichever form in domestic and foreign companies.
The Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
The Company may carry out all commercial, industrial and financial operations connected or complementary to its
business.»
There being no further item on the agenda, the meeting was closed at 3.45 p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal at Senningerberg, on the day named at the be-
ginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quatre juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
30537
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAGIC PRODUCTION
GROUP (M.P.G.) S.A., avec siège social à Senningerberg, constituée sous la dénomination de INTERNATIONAL MO-
TOR PARTS S.A., suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 avril 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1030 du 19 novembre 2001.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire
en date du 11 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 721 du 8 juillet 2003, page
34567.
La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Salvatore Tosiani, «assistant-manager», avec
adresse professionnelle à L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves, agissant pour compte de FERRERO B.V.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-
nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Monsieur le Président et le secrétaire désignent comme scrutateur, Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec
adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Le Bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentaire
d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 3 des statuts afin de changer l’objet social de la Société.
2. Divers.
II.- Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent sont indiqués sur la liste de présence; ladite liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires re-
présentés, le Bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte.
III.- Que le capital social intégral est représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés dé-
clarent avoir été auparavant dûment informés et pris connaissance de l’ordre du jour, de sorte que des convocations
préalables n’étaient pas requises.
IV.- Que la présente assemblée est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider va-
lablement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité des voix.
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts relatif à l’objet social de la Société, lequel aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 3 Objet
L’objet de la Société est:
De projeter, promouvoir, vendre, acquérir, transporter, illustrer, accroître, produire des objets pluridimensionnels,
surprises, sites web, vidéos, jeux vidéo, images, cartes caricaturales et cartes de voeux, intitulés, présentations, annon-
ces, fictions, romans de série, livres, surprises fantastiques, mélodies, chansons, films, dessins animés, édition de musique
et de films, histoires fantastiques et imaginaires, édition de livres, software et hardware et toutes formes de choses,
objets, produits et accessoires de toute sorte et de toute nature, et de promouvoir, coordonner, exploiter, exécuter,
engager, accroître, effectuer toutes activités, services, biens et investigations connexes.
La Société peut également fournir des services à d’autres sociétés en matière de publicité, de divertissement ainsi que
tous autres services.
La Société peut transférer, vendre, acquérir, donner en location, maintenir, développer, déposer et enregistrer tous
droits de propriété intellectuelle, licences, brevets ainsi que toute sorte de droits en relation avec le web et le monde
du multimédia.
La Société peut emprunter et accorder tous concours, avances ou garanties à d’autres sociétés. La Société peut éga-
lement acquérir, gérer et disposer de participations de toute sorte dans des sociétés locales ou étrangères.
La Société peut acquérir, gérer, accroître et disposer de biens immobiliers situés au Luxembourg ou à l’étranger.
La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières connexes ou complémentaires
à son entreprise.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
15.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: S. Tosiani, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, vol. 143S, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046303.3/230/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
A. Schwachtgen.
30538
SUNGARD SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.778.
—
In the year two thousand four, on the seventh day of June at 10.30 am, before Mr Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG
S.A. (the Company), a Luxembourg société anonyme, having its registered office at L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route
de Trèves, incorporated pursuant to a deed of Mr Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on 31st December
1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C-255 of 4th April 2000. The Company is regis-
tered with the Luxembourg Trade & Companies Registry under the number B73.778.
The Meeting is chaired by Cyril Pierre-Beausse, Attorney-at-law, residing in Luxembourg who appoints as Secretary,
Bernard Beerens, Attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The Meeting appoints as Scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg (the Chairman,
the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).
The shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list,
which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders
and the members of the Bureau.
The proxies from the shareholders represented at the Meeting will also remain attached to the present minutes and
signed by all the parties.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. As indicated in an attendance list established and certified by the members of the Bureau, all 61,874 (sixty one thou-
sand eight hundred and seventy-four) ordinary shares with a par value of EUR 24.78935 (twenty-four euros and seventy-
eight nine hundred thirty-five thousandth cents), representing the entire subscribed share capital of the Company of
EUR 1,533,816.24 (one million five hundred thirty-three thousand and eight hundred sixteen euros and twenty-four
cents) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having
agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the
notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) waiver of the convening notices;
(2) modification of the corporate objects clause of the Company and subsequent amendment of article 4 of the arti-
cles of incorporation of the Company (the Articles) to give it the following content:
«Art. 4. The corporation may act as a computer system and financial communication network operator, in the sense
of article 29-3 of the law of 5th April 1993 on the financial sector, as amended.
The corporation shall also have as its business purpose software developments, support and sales in the financial sec-
tor as well as to install, maintain and provide other services related to those softwares. It may provide services to a
parent company or to a subsidiary.
In general, the corporation may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable
or immovable, commercial and industrial operation, including, but not limited to, the management of a portfolio of in-
tellectual property rights, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose»;
(3) increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,500,003.57 (one million five hundred thou-
sand three euros fifty-seven cents), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 1,533,816.24
(one million five hundred thirty-three thousand and eight hundred sixteen euros and twenty-four cents) to EUR
3,033,819.81 (three million thirty-three thousand eight hundred nineteen euros and eighty-one cents) by way of the cre-
ation and issuance of 60,510 (sixty thousand five hundred and ten) ordinary shares of the Company, with a par value of
EUR 24.78935 (twenty-four euro and seventy-eight nine hundred thirty-five thousandth cents) each;
(4) waiver of its preferential subscription right by SunGard INVESTMENT VENTURES, Inc.;
(5) subscription and payments of the increase specified under item (3) above;
(6) subsequent amendment of article 5, first paragraph of the Articles to give it the following content:
«The corporate capital is set at EUR 3,033,819.81 (three million thirty-three thousand eight hundred nineteen euros
and eighty-one cents) represented by 122,384 (one hundred twenty-two thousand three hundred and eighty-four) or-
dinary shares with a par value of EUR 24.78935 (twenty-four euros and seventy-eight nine hundred thirty-five thou-
sandth cents) each, fully paid-up»;
(7) amendment in the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
to each of Mr Cyril Pierre-Beausse, Attorney-at-law, residing in Luxembourg, Mrs Katia Manhaeve, Attorney-at-law, re-
siding in Luxembourg, and Mr Bernard Beerens, Attorney-at-law, residing in Luxembourg, each individually and severally,
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Com-
pany; and
(8) in accordance with both article 49-3 of the act of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the
Law) and article 101 of the Luxembourg income tax act dated 4th December, 1967, as amended (the LIT), and subject
to the terms of articles 69.(2) and 69.(3) of the Law, reduction of the share capital of the Company from its current
amount of EUR 3,033,819.81 (three million thirty-three thousand eight hundred nineteen euros and eighty-one cents)
to the amount of EUR 1,533,841.03 (one million five hundred thirty-three thousand eight hundred and forty-one euros
and three cents) by (i) the purchase of 60,509 (sixty thousand five hundred and nine) shares of the Company with a par
30539
value EUR 24.78935 (twenty-four euros and seventy-eight nine hundred thirty-five thousandth cents) each held by SIS
EUROPE HOLDINGS Inc. and (ii) followed by the cancellation of such shares.
Then the Meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the Company’s share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-
vening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to modify the corporate objects clause of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles pertaining to the corporate object of the Company, in order
to allow the Company to perform such activities as those of a computer system and financial communication network
operator, in the sense of article 29-3 of the law of 5th April 1993 on the financial sector, as amended, which shall hence-
forth read as follows:
«Art. 4. The corporation may act as a computer system and financial communication network operator, in the sense
of article 29-3 of the law of 5th April 1993 on the financial sector, as amended.
The corporation shall also have as its business purpose software developments, support and sales in the financial sec-
tor as well as to install, maintain and provide other services related to those softwares. It may provide services to a
parent company or to a subsidiary.
In general, the corporation may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable
or immovable, commercial and industrial operation, including, but not limited to, the management of a portfolio of in-
tellectual property rights, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.»
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,500,003.57 (one million
five hundred thousand three euros fifty-seven cents), in order to bring the share capital from its present amount of EUR
1,533,816.24 (one million five hundred thirty-three thousand and eight hundred sixteen euros and twenty-four cents)
to EUR 3,033,819.81 (three million thirty-three thousand eight hundred nineteen euros and eighty-one cents) by way
of the creation and issuance of 60,510 (sixty thousand five hundred and ten) ordinary shares of the Company, with a
par value of EUR 24.78935 (twenty-four euros and seventy-eight nine hundred thirty-five thousandth cents) each.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to note that SunGard INVESTMENT VENTURES, Inc., a Delaware corporation organised under
the Delaware General Corporation Law, United States of America, with its business office at 1105 North Market Street,
Suite 1412, Wilmington Delaware 19801, United States of America, and its registered office at The Corporate Trust
Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, in its capacity as shareholder
of the Company, has waived its preferential subscription right in respect of the above-mentioned increase of the share
capital and it approves and accepts the subscription of the 60,510 (sixty thousand five hundred and ten) newly issued
ordinary shares as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
SIS EUROPE HOLDINGS Inc., a Delaware corporation organised under the Delaware General Corporation Law,
United States of America, with its business office at 1105 North Market Street, Suite 1412, Wilmington Delaware 19801,
United States of America, and its registered office at The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, United States of America, in its capacity of shareholder of the Company, hereby represented by Mr
Cyril Pierre-Beausse, Attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Wilmington, Delaware,
United States of America, on 19th May, 2004, declares to:
(i) subscribe to 60,510 (sixty thousand five hundred and ten) newly issued shares of the Company; and
(ii) fully pay them up by a contribution in cash consisting of a payment in an amount of EUR 1,500,003.57 (one million
five hundred thousand three euros fifty-seven cents) to be allocated to the share capital account of the Company.
Evidence of such payment has been given to the undersigned notary by a bank certificate.
The contribution in an amount of EUR 1,500,003.57 (one million five hundred thousand three euros fifty-seven cents)
is to be recorded at fair market value and is to be allocated in its entirety to the nominal share capital of the Company.
Following the increase of the share capital of the Company, the shareholding of the Company is as of now as follows:
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles, which will henceforth have the following
wording:
«The corporate capital is set at EUR 3,033,819.81 (three million thirty-three thousand eight hundred nineteen euros
and eighty-one cents) represented by 122,384 (one hundred twenty-two thousand three hundred and eighty-four) or-
dinary shares with a par value of EUR 24.78935 (twenty-four euros and seventy-eight nine hundred thirty-five thou-
sandth cents) each, fully paid-up.»
SIS EUROPE HOLDINGS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,383 shares
SunGard INVESTMENT VENTURES, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
30540
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-
powers and authorises each of Mr Cyril Pierre-Beausse, Attorney-at-law, residing in Luxembourg, Mrs Katia Manhaeve,
Attorney-at-law, residing in Luxembourg, and Mr Bernard Beerens, Attorney-at-law, residing in Luxembourg, each in-
dividually and severally, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share
register of the Company.
<i>Eighth resolutioni>
In accordance with both article 49-3 of the Law and article 101 LIT, and subject to the terms of articles 69.(2) and
69.(3) of the Law, i.e.:
(i) under the provision that no creditors, whose claims antedate the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations of the present resolutions, apply for the constitution of security to the competent judge within 30 days
from such publication; and/or
(ii) until such time as the creditors have obtained satisfaction or until the judge has ordered that their application
should not be acceded to,
(the Suspensive Condition),
the Meeting resolves to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 3,033,819.81 (three
million thirty-three thousand eight hundred nineteen euros and eighty-one cents) to the amount of EUR 1,533,841.03
(one million five hundred thirty-three thousand eight hundred and forty-one euros and three cents) by:
(a) the purchase of 60,509 (sixty thousand five hundred and nine) shares of the Company with a par value EUR
24.78935 (twenty-four euros and seventy-eight nine hundred thirty-five thousandth cents) each held by SIS EUROPE
HOLDINGS Inc. in consideration for a price in an aggregate amount of EUR 1,499,978.78 (one million four hundred
ninety-nine thousand nine hundred and seventy-eight euros and seventy-eight cents) (the Amount); and
(b) followed by the subsequent cancellation of such shares,
the Amount corresponding in aggregate to the reduction of the nominal share capital of the Company, all such meas-
ures to become effective upon the occurrence of the Suspensive Condition (to be witnessed by an extraordinary general
meeting of the shareholders of the Company and to be recorded in notarial form).
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting resolves, at the occurrence of the Suspensive Condition or as soon as practicable thereafter to hold an
extraordinary general meeting of the shareholders of the Company in order, inter alia, to record the occurrence of the
Suspensive Condition and to amend the first paragraph of article 5 of the Articles in relation thereto.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 18,500.- (eighteen
thousand five hundred euros).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and, at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le sept juin, à 10 heures 30,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de SunGard SYSTEMS LUXEM-
BOURG S.A. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2632 Luxembourg-
Findel, 7, route de Trèves, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
le 31 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C-255 du 4 avril 2000. La Société est
enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.778.
La séance est présidée par Cyril Pierre-Beausse, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire
Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le bureau de l’Assemblée, le Bureau).
Les actionnaires représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont mentionnés sur une liste de
présence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et les
membres du Bureau.
Les procurations émises par les actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux
présentes signées par toutes les parties.
Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 61.874 (soixante et un mille
huit cent soixante-quatorze) actions ordinaires avec une valeur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre euros et
soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents), représentant la totalité des actions émises avec droit de vote
du capital social de la Société d’un montant de EUR 1.533.816,24 (un million cinq cent trente-trois mille huit cent seize
euros et vingt-quatre cents) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement consti-
30541
tuée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, indiqués ci-après, sans convocation préalable, les action-
naires représentés à l’Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l’ordre du jour.
La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, res-
tera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
(1) renonciation aux formalités de convocation;
(2) modification de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société (les
Statuts) pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a pour objet d’agir en tant qu’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communi-
cation du secteur financier, au sens de l’article 29-3 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée.
La société a également pour objet le développement, le support et la vente de logiciels dans le secteur financier, ainsi
que l’installation, la maintenance et la fourniture d’autres services en relation avec ces logiciels. Elle peut fournir des
services à une société mère ou à une filiale.
D’une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération
financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle, incluant, mais sans limitation, la gestion d’un porte-
feuille de droits de propriété intellectuelle, qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développement de son objet»;
(3) augmentation du capital de la Société d’un montant de EUR 1.500.003,57 (un million cinq cent mille trois euros
et cinquante-sept cents), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.533.816,24 (un million cinq cent
trente-trois mille huit cent seize euros et vingt-quatre cents) à un montant de EUR 3.033.819,81 (trois millions trente-
trois mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-un cents) par la création et l’émission de 60.510 (soixante mille cinq
cent dix) actions ordinaires de la Société avec une valeur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre euros et soixante-
dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents) chacune;
(4) renonciation à son droit préférentiel de souscription par SunGard INVESTMENT VENTURES, Inc.;
(5) souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous le point 3 ci-dessus;
(6) modification subséquente de l’article 5, premier paragraphe des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 3.033.819,81 (trois millions trente-trois mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-
un cents) représenté par 122.384 (cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre) actions ordinaires avec une va-
leur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents) chacune,
entièrement libérées»;
(7) modification du registre des actions de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-
rité donnés individuellement et séparément à Cyril Pierre-Beausse, avocat, demeurant à Luxembourg, ou, à son défaut,
Katia Manhaeve, avocat, demeurant à Luxembourg ou, à son défaut, Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg,
pour procéder pour le compte de la Société l’inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions
de la Société;
(8) conformément à l’article 49-3 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi)
et à l’article 101 de la loi luxembourgeoise relative à l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle que modifiée (LIR),
et selon les termes des articles 69.(2) et 69.(3) de la Loi, réduction du capital social de la Société de son montant actuel
de EUR 3.033.819,81 (trois millions trente-trois mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-un cents) à EUR
1.533.841,03 (un million cinq cent trente-trois mille huit cent quarante et un euros et trois cents) par (i) le rachat de
60.509 (soixante mille cinq cent neuf) actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre
euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents) chacune, détenues par SIS EUROPE HOLDINGS Inc.
et (ii) suivi de l’annulation de ces actions.
L’Assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représentée à la présente l’Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir
eu parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des Statuts relatif à l’objet social de la Société, qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 4. La Société a pour objet d’agir en tant qu’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communi-
cation du secteur financier, au sens de l’article 29-3 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée.
La société a également pour objet le développement, le support et la vente de logiciels dans le secteur financier, ainsi
que l’installation, la maintenance et la fourniture d’autres services en relation avec ces logiciels. Elle peut fournir des
services à une société mère ou à une filiale.
D’une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération
financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle, incluant, mais sans limitation, la gestion d’un porte-
feuille de droits de propriété intellectuelle, qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développement de son objet»;
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital la Société d’un montant de EUR 1.500.003,57 (un million cinq cent mille
trois euros et cinquante-sept cents), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.533.816,24 (un mil-
30542
lion cinq cent trente-trois mille huit cent seize euros et vingt-quatre cents) à un montant de EUR 3.033.819,81 (trois
millions trente-trois mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-un cents) par la création et l’émission de 60.510
(soixante mille cinq cent dix) actions ordinaires de la Société avec une valeur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre
euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de noter que SunGard INVESTMENT VENTURES, Inc., une société du Delaware organisée selon
la loi du Delaware sur les sociétés commerciales (Etats-Unis d’Amérique), ayant ses bureaux à Wilmington, 1105 North
Market Street, Suite 1412, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, et son siège social à Wilmington, The Corporate
Trust Company, 1209 Orange Street, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, en sa qualité d’actionnaire de la Société,
a renoncé à son droit préférentiel de souscription concernant l’augmentation de capital susmentionnée et elle approuve
et accepte la souscription des 60.510 (soixante mille cinq cent dix) actions ordinaires nouvellement émises comme suit:
<i>Souscription - Paiementi>
SIS EUROPE HOLDINGS Inc., une société du Delaware organisée selon la loi du Delaware sur les sociétés commer-
ciales (Etats-Unis d’Amérique), ayant ses bureaux à Wilmington, 1105 North Market Street, Suite 1412, Delaware
19801, Etats-Unis d’Amérique, et son siège social à Wilmington, The Corporate Trust Company, 1209 Orange Street,
Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par Cyril Pierre-Beausse, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Wilmington, Delaware (Etats-Unis d’Amérique), le 19 mai 2004, déclare (i) souscrire
60.510 (soixante mille cinq cent dix) actions ordinaires de la Société nouvellement émises et (ii) les libérer entièrement
par un apport en espèces consistant en un paiement d’une somme de EUR 1.500.003,57 (un million cinq cent mille trois
euros et cinquante-sept cents) à affecter au compte capital social de la Société.
Preuve de ce paiement a été fournie au notaire instrumentant sous la forme d’un certificat de blocage émis par une
banque.
Cet apport d’un montant total de EUR 1.500.003,57 (un million cinq cent mille trois euros et cinquante-sept cents)
est à enregistrer à la valeur de marché et est à affecter intégralement au compte capital social de la Société.
Suite à l’augmentation du capital social de la Société, l’actionnariat de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts qui auront désormais la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à EUR 3.033.819,81 (trois millions trente-trois mille huit cent dix-neuf euros et quatre-
vingt-un cents) représenté par 122.384 (cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre) actions ordinaires avec une
valeur nominale de EUR 24,78935 (vingt-quatre euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents) cha-
cune, entièrement libérées»;
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés individuellement et séparément à Cyril Pierre-Beausse, avocat, demeurant à Luxembourg,
ou, à son défaut, Katia Manhaeve, avocat, demeurant à Luxembourg ou, à son défaut, Bernard Beerens, avocat, demeu-
rant à Luxembourg, pour procéder pour le compte de la Société l’inscription des actions nouvellement émises dans le
registre des actions de la Société.
<i>Huitième résolutioni>
Conformément à l’article 49-3 de la Loi et à l’article 101 LIR, et selon les termes des articles 69.(2) et 69.(3) de la
Loi, c’est-à-dire:
(i) sous la condition qu’aucun créancier dont la créance serait antérieure à la date de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations du procès-verbal des présentes résolutions, ne demande dans les trente jours à comp-
ter de cette publication la constitution de sûretés auprès du tribunal compétent; et/ou, le cas échéant,
(ii) dès que les créanciers auront obtenu satisfaction à leur requête ou que le tribunal compétent aura décidé qu’il n’y
a pas lieu de faire droit à leur requête
(la Condition Suspensive),
l’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 3.033.819,81 (trois millions
trente-trois mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-un cents) à EUR 1.533.841,03 (un million cinq cent trente-
trois mille huit cent quarante et un euros et trois cents) par:
(a) le rachat de 60.509 (soixante mille cinq cent neuf) actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR
24,78935 (vingt-quatre euros et soixante-dix-huit neuf cent trente-cinq millièmes cents) chacune, détenues par SIS EU-
ROPE HOLDINGS Inc. pour un prix total de 1.499.978,78 (un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
soixante-dix-huit euros et soixante-dix-huit cents) (le Prix); et
(b) suivi de l’annulation de ces actions,
le Prix correspondant intégralement à la réduction du montant nominal du capital social de la Société, toutes ces me-
sures devant produire effet dès la réalisation de la Condition Suspensive (laquelle sera constatée par une assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires de la Société enregistrée sous forme notariée).
SIS EUROPE HOLDINGS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122.383 actions
SunGard INVESTMENT VENTURES, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
30543
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée décide, dès la réalisation de la Condition Suspensive ou dans les meilleurs délais après cette réalisation
de tenir une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société pour notamment constater la réalisation
de la Condition Suspensive et modifier en conséquence le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit qui pourraient in-
comber à la Société à la suite de la présente augmentation de capital sont estimés à environ EUR 18.500,- (dix huit mille
cinq cent euros).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Pierre-Beausse, B. Beerens, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, vol. 143S, fol. 87, case 5. – Reçu 15.000,04 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048035.3/211/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.
GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 101.086.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the eighteenth day of May.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated by a deed of
the undersigned notary on this day, which will be registered before or with the present deed,
here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg, on 17 May 2004.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered Office
Art. 1. There exists among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become
shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which shall be
governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of
incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
J. Elvinger.
30544
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-
ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-
tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
30545
E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of man-
agement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorised to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
All five hundred (500) shares are subscribed by GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of
December 2004.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., representing the en-
tirety of the subscribed capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following legal entity is appointed as sole manager of the Company for an indefinite period:
AIM SERVICES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 74.676.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundvier, den achtzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht,
mit Gesellschaftssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, welche gemäß Urkunde des unterzeichneten No-
tars vom heutigen Tage gegründet wurde und welche Urkunde vor oder mit dieser Urkunde einregistriert wird,
hier vertreten durch Frau Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 17. Mai 2004.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Partei und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung ei-
ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Es besteht zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Gesell-
schafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité limitée),
30546
(die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,
sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-
ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-
mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die
Dauer des Mandates fest.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu je-
dem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-
keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-
men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Ein-
klang stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
30547
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-
heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus wel-
chem Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Januars jeden Jahres und endet am
letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf-
geführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l. ge-
zeichnet.
Die so gezeichneten Anteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, so wie es dem Notar nachgewiesen worden ist.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember
2004.
30548
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf EUR 1.500,-
geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
GLACIER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich
nach der Gründung der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
2. Die folgende Gesellschaft wird als alleiniger Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
AIM SERVICES, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz
in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg. R.C.S. Luxembourg B 74.676.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene hat diese mit dem amtierenden Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: A. Bellardi Ricci und H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 mai 2004, vol. 427, fol. 75, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(045463.3/242/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 58.075.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire de la Société, qui s’est tenue au siège social à
Schifflange, le 1
er
mars 2004:
- que le bilan et le compte de pertes et profit au 31 décembre 2002 ont été approuvés à l’unanimité;
- que le résultat de cet exercice, à savoir un profit de EUR 4.682.375,- a été reporté à l’exercice suivant;
- qu’en dépit d’une perte accumulée dépassant 100% du capital souscrit, il a été décidé de continuer les activités de
la Société;
- que décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises de la société pour les activités de l’exer-
cice susmentionné;
- que les administrateurs ont été réélus pour un mandat expirant à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle
et que le Conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
M. Patrice Waltzing, Managing Director, avec résidence professionnelle à L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtze-
buerger Heck;
M. Stefan Corti, Senior Vice President Sales and Marketing International, avec résidence professionnelle à L-3844
Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck;
M. Marc Streibel, Financial Director, avec résidence professionnelle à L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuer-
ger Heck;
M. Roy Fossett, Senior Vice President TECHNICOLOR EUROPE, avec résidence professionnelle à 26-28 Hammer-
smith Grove, London W6 7PE (United Kingdom).
M. Robert Sweet, Senior Vice President, avec résidence professionnelle à 26-28 Hammersmith Grove, London W6
7PE (United Kingdom).
- que ERNST & YOUNG a été nommée réviseur d’entreprises de la Société pour un mandat d’un an renouvelable
expirant à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05267. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034212.3/275/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Mersch, den 8. Juni 2004.
H. Hellinckx.
<i>Pour EURONIMBUS
i>J. Steffen
<i>Mandatairei>
30549
ACTARIS EXPANSION S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 95.102.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance tenu le 6 avril 2004 i>
Le siège social de la société est transféré du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 23, avenue Monterey, L-
2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04891. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034197.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.552.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 26 septembre 2002 i>
<i>Rectificatif du dépôt référence L030079668.4 du 4 décembre 2003i>
La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, a été cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle
terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2008.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04898. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034200.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
PEINTURE LUDOWISSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 29, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 73.196.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04652, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
(034203.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
INVIREX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.969.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05314, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034216.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
<i>Pour ACTARIS EXPANSION S.C.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A
Signatures
Certifié sincère et conforme
COMONT HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(32.621,65) EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.789,79 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(17.831,86) EUR
Luxembourg, le 27 avril 2004.
Signature.
30550
IMMO SUD PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, 29, rue Robert Krieps.
R. C. Luxembourg B 87.898.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04650, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
(034204.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ELECTRO & KICHENZENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3672 Kayl, 24, rue de Tétange.
R. C. Luxembourg B 74.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04647, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
(034205.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
DU FORT INVESTORS, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.603.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 janvier 2004i>
- Les mandats d’administrateur de M. Pier Franco Uzzeni, dirigeant d’entreprise, demeurant Corso Sempione 162,
Solcio di Lesa, I-28040 Novara, de M. Steven Buyse, dirigeant d’entreprise, demeurant Processiestraat 15, B-1730 Kob-
begem, de M. Geert Duyck, dirigeant d’entreprise, demeurant Bodegemstraat 132, B-1700 Dilbeck et de M. Mark Griz-
zelle, dirigeant d’entreprise, demeurant Turret House, Fitzgeorge avenue, New Malden, UK - Surrey, sont renouvelés
pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.
- Le mandat de commissaire aux comptes de la société Ernst & Young, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg, est renouvelé pour une période d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les
comptes au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04129. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034222.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
W & W ASSET MANAGEMENT AG, LUXEMBURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.222.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04594, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
(034220.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
Certifié sincére et conforme
Fait à Luxembourg, le 22 avril 2004
<i>Pour DU FORT INVESTORS
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures
<i>Pour W&W ASSET MANAGEMENT AG, LUXEMBURG, Aktiengesellschaft
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
30551
EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 58.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05276, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034213.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
QUEZON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.584.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration par voie circulairei>
- La démission de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard de leur fonction d’Administrateur de catégorie A, est
acceptée et ce à partir du 1
er
mars 2004.
- Monsieur Herbert Johanning Castillo, né à San José le 10 février 1962, de nationalité costaricaine, résidant au Centro
Comercial San José 2000 n
°
7, La Uruca, San José, Costa Rica, détenteur du passeport n
°
P-CRI-157291498, a été coopté
en tant qu’Administrateur de catégorie A, en remplacement de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard, démission-
naires. Il terminera le mandat de ses prédecesseurs, mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2007. Cette nomination sera à ratifier lors de la prochaine Assemblée Génerale Statutaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034223.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
LUXFUEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.420.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, tels qu’approuvés en assemblée générale or-
dinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05353, réf. LSO-AP05351, LSO-
AP05347, LSO-AP05344 et LSO-AP05342 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
(034235.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05365, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
(034225.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Signature.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour QUEZON FINANCE S.A.
i>SGG S.A.
P. Collarin / S. Capuzzo
<i>Senior Account Officer / Head of Departmenti>
<i>Pour LUXFUEL
i>P.-P. Boulanger
<i>Superintendanti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
30552
STRAZER INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.372.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration par voie circulairei>
- La démission de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard de leur fonction d’Administrateurs de catégorie A, est
acceptée et ce à partir du 1
er
mars 2004.
- Monsieur Herbert Johanning Castillo, né à San José le 10 février 1962, de nationalité costaricaine, résidant au Centro
Comercial San José 2000 n
°
7, La Uruca, San José, Costa Rica, détenteur du passeport n
°
P-CRI-157291498, a été coopté
en tant qu’Administrateur de catégorie A, en remplacement de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard, démission-
naires. Il terminera le mandat de ses prédécesseurs, mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2007. Cette nomination sera à ratifier lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04132. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D Hartmann.
(034224.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
TARVAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.585.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration par voie circulairei>
- La démission de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard de leur fonction d’Administrateurs de catégorie A est
acceptée et ce à partir du 1
er
mars 2004.
- Monsieur Herbert Johanning Castillo, né à San José le 10 février 1962, de nationalité costaricaine, résidant au Centro
Comercial San José 2000 n
°
7, La Uruca, San José, Costa Rica, détenteur du passeport n
°
P-CRI-157291498, a été coopté
en tant qu’Administrateur de catégorie A, en remplacement de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard, démission-
naires. Il terminera le mandat de ses prédécesseurs, mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2007. Cette nomination sera à ratifier lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04133. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034226.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
SCAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.849.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 juin 2002i>
Les mandats d’Administrateur de Monsieur Francesco Strampelli, Dottore Commercialista, I-Roma, de Monsieur
Orazio Lauri, Dottore Commercialista, I-Roma, de Monsieur Maurizio De Blasi, Ingegnere, I-Roma, et le mandat de
Commissaire aux Comptes de Monsieur Massimo Campanile, Dottore Commercialista, I-Roma, sont reconduits pour
une nouvelle période statutaire de trois ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale de l’an 2005.
Luxembourg, le 27 juin 2002
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04137. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(034234.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour STRAZER INVEST S.A.
i>SGG S.A.
P. Collarin / S. Capuzzo
<i>Senior Account Officer / Head of Departmenti>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour TARVAN INVEST S.A.
i>SGG S.A.
P. Collarin / S. Capuzzo
<i>Senior Account Officer / Head of Departmenti>
Certifié sincère et conforme
SCAC INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Administrateurs
30553
WASIDOR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.373.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration par voie circulairei>
- La démission de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard de leur fonction d’Administrateurs de catégorie A est
acceptée et ce à partir du 1
er
mars 2004.
- Monsieur Herbert Johanning Castillo, né à San José le 10 février 1962, de nationalité costaricaine, résidant au Centro
Comercial San José 2000 n
°
7, La Uruca, San José, Costa Rica, détenteur du passeport n
°
P-CRI-157291498, a été coopté
en tant qu’Administrateur de catégorie A, en remplacement de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard, démission-
naires. Il terminera le mandat de ses prédécesseurs, mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2007. Cette nomination sera à ratifier lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04135. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034228.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.445.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05367, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
(034229.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05372, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
(034233.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.124.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05229, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Signature.
(034256.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour WASIDOR FINANCE S.A.
i>SGG S.A.
P. Collarin / S. Capuzzo
<i>Senior Account Officer / Head of Departmenti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
30554
HAMPDEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.381.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration par voie circulairei>
- La démission de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard de leur fonction d’Administrateurs de catégorie A est
acceptée et ce à partir du 1
er
mars 2004.
- Monsieur Herbert Johanning Castillo, né à San José le 10 février 1962, de nationalité costaricaine, résidant au Centro
Comercial San José 2000 n
°
7, La Uruca, San José, Costa Rica, détenteur du passeport n
°
P-CRI-157291498, a été coopté
en tant qu’Administrateur de catégorie A, en remplacement de Messieurs Ricardo Sanchez et Alain Renard, démission-
naires. Il terminera le mandat de ses prédécesseurs, mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2007. Cette nomination sera à ratifier lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04136. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034230.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ProLogis EUROPEAN FINANCE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.916.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05377, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
(034237.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ProLogis EUROPEAN FINANCE V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.917.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05384, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
(034242.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
SARLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.818.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05005, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034266.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour HAMPDEN INVESTMENTS S.A.
i> SGG S.A.
P. Collarin / S. Capuzzo
<i>Senior Account Officer / Head of Departmenti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
Luxembourg, le 27 avril 2004.
Signature.
30555
GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.057.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 avril 2003i>
La cooptation de la société LOUV S.à r.l., S.à r.l., de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St
Helier, JE 2 RA, Jersey, Channel Islands, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034244.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ROCHE-BRUNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.866.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05002, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034269.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
AVENUE DE WOLVENDAEL 61 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 30.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05326, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034272.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
COLUGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.154.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2004,
les mandats des administrateurs
Monsieur Gérard Birchen, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Marie-José Reyter, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes
COMCOLUX S.A., 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034611.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Certifié sincère et conforme
GENNAIO INVESTMENT S.A.
Signatures
Administrateurs
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Signature.
<i>Pour COLUGEST S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
30556
ALTHIZE HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05311, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034293.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ALTHIZE HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05313, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034290.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ALTHIZE HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05317, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034285.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
DANIELI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.211.
—
Il ressort d’une lettre de démission du 27 janvier 2004 que Monsieur Gino Luciani a présenté sa démission comme
administrateur de la société avec effet au 31 janvier 2004.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04258. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034343.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
BLUE WINGS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 72.583.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le
1
er
décembre 1999 que:
La démission de Monsieur Gérard Clair en sa qualité de Commissaire aux Comptes est acceptée. Décharge de sa
gestion lui est accordée avec effet immédiat.
Est élue au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,
Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat prendra fin
avec l’Assemblée Générale Annuelle Statutaire de l’an 2001.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03584. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034433.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Signature.
Pour avis
Signature
30557
FLY-TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04905, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034306.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
FLY-TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04908, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034309.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
FLY-TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04912, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034312.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
FLY-TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04902, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034314.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ISLANDS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05292, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(034428.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ISLANDS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05290, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(034425.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
Signature.
30558
AGAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 72.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05318, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034281.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
BELCAR LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: B-2630 Aartselaar, 12, Bist.
Succursale: 1, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.649.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05007, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034292.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
SKIPYARD, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.057.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04943, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034299.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 55.526.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le 10 mars 2004, que
l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de
ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Paolo Della Porta, ingénieur, demeurant à Carimate (CO) (Italie), 13, Strada privata delle Acacie;
- Monsieur Guiseppe Rolando, administrateur de société, demeurant à Milan (Italie), 6, via Val Leventina;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -3- (trois) ans, la société ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège
social à L-2180 Luxembourg, Kirchberg, 6, rue Jean Monnet, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04245. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034532.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
Signature.
SAES GETTERS INTERNATIONAL S.A.
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
30559
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO, Niederlassung Luxemburg
Siège social: Luxembourg, 148-152, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04091, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034327.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 56.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04086, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034330.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.425.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP04954, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034351.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
CHIESI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.418.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AP05412, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
(034366.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
HORIZON SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 53.234.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05510, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2004.
(034580.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 27 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 avril 2004.
Signature.
Pour extrait sinc`ère et conforme
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour HORIZON SYSTEMS S.A.
i>R. Heymans
<i>Administrateur-Déléguéi>
30560
ABERDEEN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.747.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034375.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ABERDEEN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.747.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034371.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ABERDEEN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.747.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034370.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ABERDEEN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.747.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034373.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
WALULUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 25.251.
—
La société WALULUX S.A. confirme la conservation inchangée de son siège social au 16 rue de Nassau, L-2213
Luxembourg, et ce depuis le 15 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05145. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(034498.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
WILSON ASSOCIATES
Signature
WILSON ASSOCIATES
Signature
WILSON ASSOCIATES
Signature
WILSON ASSOCIATES
Signature
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / AT.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
30561
MARINE LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 74.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04249, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034333.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
DOMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 95.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04059, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(034347.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
BEBOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8154 Bridel, 1, rue de Steinsel.
R. C. Luxembourg B 89.896.
—
Les documents annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05715, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 30 avril 2004.
(034385.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
BEBOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8154 Bridel, 1, rue de Steinsel.
R. C. Luxembourg B 89.896.
—
Les documents annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05719, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 30 avril 2004.
(034386.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
ETOILE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 87.569.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 27 juin 2003i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2002;
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05504. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034588.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Signature.
<i>Pour BEBOP, S.à r.l.
i>S. Kinsch
<i>Pour BEBOP, S.à r.l.
i>S. Kinsch
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
30562
SMART VENTURE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 75.349.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04066, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(034350.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
DANIELI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.211.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04263, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034354.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
EUROPROP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 30.519.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04257, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034358.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
BIEL FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 90.667.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution circulaire du Conseil d’Administration du 30 mars 2004 que Monsieur Dilson de Oliveira
a démissionné de son mandat d’Administrateur.
Le Conseil d’Administration a décidé de coopter Monsieur Jean Martin Sigrist Junior en tant que nouvel Administra-
teur pour achever le mandat d’Administrateur laissé vacant par Monsieur Dilson de Oliveira.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par l’Assemblée Générale des actionnaires.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05465. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034527.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
NAVIMAR SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05279, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(034418.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 avril 2004.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures
30563
EUROP ASSISTANCE, SOCIETE D’ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 13.855.
—
Les comptes annuels et le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28
avril 2004, réf. LSO-AP05228, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034390.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
LUX COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8707 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 100.446.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- PHONE INVEST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt,
b) Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, bou-
levard Roosevelt,
2.- Madame Sandra Bailly, administratrice, demeurant à B-4140 Sprimont, Thier des Forges, 5,
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX COMMUNICATIONS S.A.
Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la vente en gros et détail de matériel électrique, téléphonie, informatique, alarmes
pour véhicules et bâtiments et tous produits connexes, ainsi que la vente d’équipements techniques dans le domaine des
télécommunications.
La société pourra, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-
lières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,00), divisé en trois cent vingt (320) actions
de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont l’admi-
nistrateur-délégué qui dispose d’un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué.
EUROP ASSISTANCE, SOCIETE D’ASSISTANCE S.A.
J.C. Stoos / M. Dell
<i>Administrateur-Délégué / Présidenti>
30564
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois, l’administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille
quatre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année
à 15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du
capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille euros
(EUR 4.000,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Madame Sandra Bailly, administratrice, demeurant à B-4140 Sprimont, Thier des Forges, 5,
b) PHONE INVEST S.A., société anonyme, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
c) Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille neuf.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
1.- PHONE INVEST S.A., prénommée, deux cent quatre-vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
2.- Madame Sandra Bailly, prénommée, trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
30565
Est nommée commissaire aux comptes:
REVILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille neuf.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
Madame Sandra Bailly, prénommée.
4.- Le siège social est établi à L-8707 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: L. Capiaux, E. Antona, S. Bailly, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, vol. 143S, fol. 27, case 11. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(034415.3/227/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
INTERNATIONAL MARINE TRAVEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.202.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05286, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(034420.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
NOSTRUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.206.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 17 novembre 2003, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venue à échéance en date du
2 juin 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou des nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’assemblée décide de nommer pour un terme d’un
an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de un an, la société GRANT THORNTON REVISIONS ET CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04246. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034534.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
E. Schlesser.
NOSTRUM S.A.
D. Murari / M. La Rocca
<i>Président / Administrateuri>
30566
SP IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.753.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, tenue à Luxembourg le 6 avril 2004, que l’Assemblée
a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs est venu à échéance en date du 18 mars 2004 et qu’en
l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs ont poursuivi leur mandat
jusqu’à la date de ce jour, l’Assemblée décide de renommer pour un terme de 1 (un) an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Stéphane Bosi, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs ainsi reconduits, expireront à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée, sans pour autant préjuger des décisions qui appartiennent au Conseil d’Administration, exprime le sou-
hait que l’Administrateur Stéphane Bosi prénommé soit reconduit dans sa fonction de Président.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance en date du 18 mars 2004
et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, le Commissaire aux Comptes a poursuivi
son mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de reconduire le mandat de la société PricewaterhouseCoopers 400, route d’Esch, L-1014
Luxembourg pour un terme de un an.
Le mandat du Commissaire aux Comptes ainsi reconduit, expirera à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes
de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04560. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034531.3/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
BLUE STEAM & SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05288, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(034423.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
JADO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 31.473.
—
La société JADO HOLDING COMPANY S.A. confirme la conservation inchangée de son siège social au 16 rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg, et ce depuis le 15 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05099. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(034500.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Bosi / S. Vandi
<i>Président / Administrateuri>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / AT.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
30567
JESSI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.571.
—
La société JESSI INTERNATIONAL HOLDING S.A. confirme la conservation inchangée de son siège social au 16 rue
de Nassau, L-2213 Luxembourg, et ce depuis le 15 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, réf. LSO-AP05101. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(034501.3/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
COPARCOMI, CONSORTIUM DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 100.473.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg).
Ont comparu:
1. SOBELNAT PARTICIPATIONS S.C.A., société en commandite par actions, avec siège social à L-1325 Luxembourg,
1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 99.891,
représentée par M
e
Jean Wagener, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 14 avril 2004.
2. GRASWEIJDE B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à NL-1083 HJ Ams-
terdam, 7 de Boelelaan, inscrite au registre de commerce et de sociétés d’Amsterdam sous le numéro 3327 1918,
représentée par Monsieur Vittorio Castellani, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 15 avril 2004.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de
droit luxembourgeois qu’elles vont constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONSORTIUM DE PARTICIPATIONS
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES S.A., en abrégé COPARCOMI.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit de
la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / AT.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
i>J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
30568
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à dix-huit millions cent mille euros (EUR 18.100.000), représenté par mille huit cent
dix (1.810) actions d’une valeur nominale de dix mille euros (EUR 10.000) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à vingt millions d’euros (EUR 20.000.000), représenté par deux mille (2.000) actions d’une
valeur nominale de dix mille euros (EUR 10.000) chacune.
Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte du 19 avril 2004 au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des
options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le Conseil d’Administration dé-
termine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préféren-
tiel de souscriptions pour les actions à émettre.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et
aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-
tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. Art. treize: La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée
Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-
nées.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le dernier jeudi du mois de juin à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
30569
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2004.
2) L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2005.
<i>Souscriptioni>
Les mille huit cent dix (1.810) actions ont été souscrites comme suit par:
Les mille huit cent dix (1.810) actions ont été libérées de la manière suivante:
a) pour mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (1.799) actions par SOBELNAT PARTICIPATIONS S.C.A., préqualifiée,
par un apport en nature de l’universalité de son patrimoine.
Il sera attribué à la société SOBELNAT PARTICIPATIONS S.C.A., préqualifiée, une soulte en espèces de trois cent
dix mille euros (EUR 310.000).
Conformément à l’article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le patrimoine apporté
a fait l’objet d’un rapport daté du 19 avril 2004, établi par MAZARS société anonyme, réviseur d’entreprises, ayant son
siège social à 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, qui conclut comme suit:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société à émet-
tre en contrepartie.»
b) pour onze (11) actions par GRASWEIJDE B.V., préqualifiée, par un apport en espèces de cent dix mille (110.000)
euros.
Ce montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société comme il a été prouvé au notaire instrumen-
taire par un certificat de blocage émis par la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST.
Lesdits rapport et certificat, après avoir été signés ne varietur par les mandataires des comparantes et par le soussigné
notaire, resteront annexés au présent acte afin d’être enregistrés avec ce dernier.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de six mille (6.000,-)
euros.
<i>Droit d’apporti>
L’apport en nature consistant en la totalité du patrimoine (actifs et passifs) de la société SOBELNAT PARTICIPA-
TIONS S.C.A., constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971,
qui prévoit une exonération du droit d’apport.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse du siège social est fixée à 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
1.- SOBELNAT PARTICIPATIONS S.C.A., préqualifiée, mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . 1.799
2.- GRASWEIJDE B.V., préqualifiée, onze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Total: mille huit cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.810
30570
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 2005.
a. M
e
Jean Wagener, prénommé,
b. Monsieur Marc Chatel, administrateur de sociétés, ayant pour adresse professionnelle 1, Place de Saint-Gervais,
CH-1211 Genève,
c. KEYLEX SERVICES (UK) Ltd, société à responsabilité limitée de droit britannique, avec siège social à 37, Cunnin-
gham Drive, Wickford, UK-SS12 9PF Essex.
3. M
e
Jean Wagener est nommé Président du Conseil d’Administration.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 2005, MAZARS, société anonyme, réviseur d’entreprises, ayant son siège social à 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxem-
bourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous, no-
taire, la présente minute.
Signé: J. Wagener, V. Castellani, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, vol. 20CS, fol. 99, case 1. – Reçu 1.100 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034977.3/230/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2004.
EUROPARTNERS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2540 Luxemburg, 25, rue Edward Steichen.
H. R. Luxemburg B 12.750.
—
Die Gesellschaft hat ihren Sitz verlegt. Sie ist ab dem 1. Dezember 2003 unter folgender Adresse ansässig: 25, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxemburg.
Erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 27. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05410. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034504.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
EUROPARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Robert Steichen.
R. C. Luxembourg B 12.750.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2004.
(034506.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
SECURITAS EMPLOYEE CONVERTIBLE 2002 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.676.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-
AP04696, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
(034591.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
A. Schwachtgen.
EUROPARTNERS HOLDING, S.A.
Dr. B. Weber / S. Schwickerath
EUROPARTNERS HOLDING S.A.
Dr. B. Weber / S. Schwickerath
<i>Pour SECURITAS EMPLOYEE CONVERTIBLE 2002 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>B. Nasr
<i>Administrateuri>
30571
D.R. (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 19.465.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05382, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
(034440.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
SIKO CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.524.
—
La rectification du bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05283, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(034430.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2004.
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.
—
Notice is hereby given that in consideration of the quorum required by law not having been reached at the annual
general meeting of shareholders of MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (the «Company») held on May 25,
2004 to consider and vote on the below agenda item, a
SECOND GENERAL MEETING
of shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company on <i>July 7, 2004i> at 2.30 p.m. to
consider and vote on the following resolution:
To pass a resolution in accordance with the requirements of article 100 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended.
Participation in the meeting is reserved to shareholders who file their intention to attend the meeting by mail and/or
return a duly completed and signed proxy form at the following address: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
S.A., 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, attention: Véronique Mathieu Tel: +352 27 759 287; Fax +352 27 759 359
no later than Monday July 5, 2004, 5.00 p.m. Proxy forms for the meeting are available upon request at the registered
office of the Company.
Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend or be represented at the second general meeting via proxy
have to request a power of attorney from FISCHER PARTNERS FONDKOMMISSION AB, P.O. Box 16027, SE-103-21
Stockholm, Sweden, Tel: +46 8 463 85 00 and send it duly completed to the following address: MILLICOM INTERNA-
TIONAL CELLULAR S.A., 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, attention: Véronique Mathieu Tel: +352 27 759 287;
Fax +352 27 759 359 no later than Monday July 5, 2004, 5.00 p.m. Holders of Swedish Depository Receipts having reg-
istered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily register the Swedish Depository
Receipts in their own name in the records maintained by VPC AB in order to exercise their shareholders’ rights at the
second general meeting and such registration must be completed no later than Wednesday June 23, 2004.
June 21, 2004.
(03205/253/28)
<i>The Board of Directorsi>.
UBP MONEY MARKET FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.045.
—
<i>Nouveau prospectus daté de juillet 2004i>
Il résulte de résolutions du Conseil d’Administration de UBP MONEY MARKET FUND prises avec effet au 1
er
juillet
2004 qu’un nouveau prospectus daté de juillet 2004 sera émis pour enregistrer les changements suivants apportés au
prospectus daté de février 2004:
- Changement de banque dépositaire
Le Conseil d’Administration de UBP MONEY MARKET FUND a désigné comme nouvelle banque dépositaire
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en lieu et place de CRE-
DIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
D.R. (HOLDINGS) S.A.
Signature
30572
Tous les frais liés au changement de banque dépositaire seront à charge du promoteur de UBP MONEY MARKET
FUND
- Changement d’agent administratif, agent enregistreur et de transfert et agent domiciliataire
Le Conseil d’Administration de UBP MONEY MARKET FUND a désigné comme nouvel agent administratif, agent
enregistreur et de transfert ainsi qu’agent domiciliataire, UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., 18, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg, en lieu et place de CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEM-
BOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. En conséquence, le siège de UBP MONEY MARKET FUND sera
transféré à cette nouvelle adresse.
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., dans sa fonction d’agent administratif et agent enregistreur et
de transfert pourra avoir recours pour tout ou partie de ses attributions aux services de EUROPEAN FUND ADMI-
NISTRATION («EFA») société anonyme, établie à Luxembourg.
- Changement de gestionnaire
Le Conseil d’Administration de UBP MONEY MARKET FUND a entériné le changement de gestionnaire de la Sicav:
UNION BANCAIRE PRIVEE, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1, en lieu et place de UBP GESTION INSTITU-
TIONNELLE, 8, rue Robert-Estienne, Case Postale, CH-1211 Genève 1.
Le nouveau prospectus daté de juillet 2004 pourra être obtenu gratuitement au nouveau siège de UBP MONEY MAR-
KET FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
(03383/047/31)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
METEC S.A., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 21.173.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>10. Juli 2004i> um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung statt-
findet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2002
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes.
I (03116/534/16)
<i>Der Verwaltungsrati>.
EMERGE CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.530.
—
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 30, 2004i> at 4.00 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 29, 2004
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
Resolutions of the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of
the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg.
II (02795/755/23)
<i>The Board of Directorsi>.
30573
LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.669.
—
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 30, 2004i> at 3.00 p.m.
with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 29, 2004
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no re-
strictions.
II (02796/755/21)
<i>The Board of Directorsi>.
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.792.
—
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders, which will be held on <i>June 30, 2004i> at 11.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of March 31, 2004 and the allocation of the net profits;
3. Discharge to be granted to the Directors and the Auditor for the fiscal year ended March 31, 2004;
4. Acknowledgment of the resignation of Paul C. Guidone and re-election of the following Directors for the ensuing
fiscal year:
Stephen J. Hodgdon
Richard M. Potocki
Rodney G.D. Smith
Brian T. Zino
5. Action on nomination for the re-election of the Auditor for the ensuing fiscal year;
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (02959/755/25)
<i>By order of the Board of Directors.i>
UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 43.634.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation du Commissaire aux Comptes de la société.
2. Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes de la société.
3. Divers.
II (03244/655/13)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
30574
WESTAM LONGITUDE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.648.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
(the «Meeting») of Shareholders of WESTAM LONGITUDE FUND will be held at the registered office, 23, avenue de
la Porte-Neuve, Luxembourg, on Friday <i>2nd July, 2004i> at 11.00 a.m., for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor for the accounting year ended March 31,
2004.
2. Approval of the Annual Accounts for the accounting year ended March 31, 2004.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended March 31,
2004.
5. Composition of the Board of Directors.
6. Change of the Auditor.
7. Miscellaneous.
The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of
the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend or to be represented to the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their
shares certificates five days before the Meeting at the Registered Office of the Company where proxy forms are avail-
able.
Registered shareholders have to inform the Board of Directors by mail (letter or form of proxy) of their intention
to attend the Meeting one day before this latter.
II (03162/755/27)
<i>By order of the Board of Directors.i>
STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 43.172.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company will be held at the offices of SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg at 2.00 p.m. Luxembourg time on <i>30 June 2004i> and will have the following agenda:
<i>Agenda:i>
The quorum and majority requirements of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, and of the Company’s articles of incorporation are applicable to the vote on the proposed resolutions at the
aforesaid extraordinary general meeting of the shareholders of the Company and at any adjournments thereof.
The Board of Directors of the Company has determined that Shareholders of record at the close of business on 9
June 2004 will be entitled to vote at the aforesaid extraordinary general meeting of the shareholders of the Company
and at any adjournments thereof.
Top ensure shareholders’ representation at the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company
and at any adjournments thereof, Shareholders are hereby requested to fill in, sign, date and return the form of proxy
enclosed with the Circular (which may also be obtained from the registered office of the Company) at the latest by 2.00
p.m. Luxembourg time on 25 June 2004, in the return envelope provided for such purpose. Holders of American De-
positary Receipts will receive a separate Depositary’s Notice of Shareholders’ Meeting of STOLT OFFSHORE S.A. and
should comply with the voting instructions and deadline contained therein (which will be prior to that set forth above).
The return of the proxy form will not affect your right to revoke it or vote in person should you later decide to attend
the meeting.
10 June 2004.
II (03223/267/32)
(i)
To increase the number of the members of the Board of Directors of the Company from seven to nine.
<i>(ii) i>To elect Mr George Doremus and Mr Trond Westlie as new Directors of the Company to hold office until the
next Annual General Meeting of Shareholders of the Company and until their respective successors have been
duly elected and qualified.
J. Stolt-Nielsen
<i>Chairman of the Boardi>
30575
LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 37.467.
—
Notice is hereby given to the Shareholders that the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A. (the «Company») will be held at 14, rue
Erasme, L-1468 Luxembourg, on <i>June 30, 2004i> at 9.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the report of the board of directors and of the statutory auditor on the fiscal year
2003;
2. Approval of the Company’s annual accounts (i.e. the balance sheet, the profit and loss account and the notes to
the accounts) for the fiscal year 2003;
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
4. Appointment of the members of the board of directors;
5. Appointment of a statutory auditor;
6. Decision on the results of the fiscal year 2003;
7. Miscellaneous.
II (03202/250/20)
<i>The Board of Directorsi>.
CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.797.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra dans les bureaux de la S.F.C. REVISION, SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, 24-28,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg, le mardi <i>29 juin 2004i> à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de l’arrivée du terme de la Société et donc de sa liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs et fixation des émoluments du liquidateur.
4. Divers.
II (03269/267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MASTERS CONSULTING, Société Anonyme.
Siège social: L-3333 Hellange, 44A, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 89.092.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Hellange avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nomination statutaire;
5. Divers.
II (03302/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.797.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra dans les bureaux de la S.F.C. REVISION, SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, 24-28,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg, le mardi <i>29 juin 2004i> à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
30576
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décem-
bre 2003.
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice 2003.
5. Examen de la situation de l’investissement.
6. Examen de la situation de trésorerie de la société.
7. Poursuite de l’activité ou dissolution de la société.
8. Divers.
II (03270/267/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BCILUX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.178.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>30 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 mars 2004.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 mars 2004.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004.
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (03283/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BLUE CHIP SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.119.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on Wednesday <i>June 30, 2004i> at 5.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Board of Directors’ report
2. Auditors’ report
3. Review and approval of the annual accounts as at February 29, 2004
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the company.
II (03285/584/21)
<i>The Board of Directorsi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Handelsgest, S.à r.l.
Handelsgest, S.à r.l.
JLEC Acquisation Company (Luxembourg), S.à r.l.
Glacier Luxembourg One, S.à r.l.
Magic Production Group (M.P.G.) S.A.
SunGard Systems Luxembourg S.A.
Glacier Luxembourg Two, S.à r.l.
Euronimbus S.A.
Actaris Expansion S.C.A.
Comont Holding S.A.
Peinture Ludowissy, S.à r.l.
Invirex Holding S.A.
Immo Sud Partners S.A.
Electro & Kichenzenter, S.à r.l.
Du Fort Investors
W & W Asset Management AG, Luxemburg
Euronimbus S.A.
Quezon Finance S.A.
Luxfuel S.A.
ProLogis European Finance, S.à r.l.
Strazer Invest S.A.
Tarvan Invest S.A.
SCAC International S.A.
Wasidor Finance S.A.
ProLogis European Finance II, S.à r.l.
ProLogis European Finance III, S.à r.l.
Bank Leumi (Luxembourg) S.A.
Hampden Investments S.A.
ProLogis European Finance IV, S.à r.l.
ProLogis European Finance V, S.à r.l.
Sarlo S.A.
Gennaio Investment S.A.
Roche-Brune S.A.
Avenue de Wolvendael 61 Holding S.A.
Colugest S.A.
Althize Holding S.A. Luxembourg
Althize Holding S.A. Luxembourg
Althize Holding S.A. Luxembourg
Danieli International S.A.
Blue Wings Charter S.A.
Fly-Tech S.A.
Fly-Tech S.A.
Fly-Tech S.A.
Fly-Tech S.A.
Islands Charter S.A.
Islands Charter S.A.
Agar S.A.
Belcar Luxembourg
Skipyard
SAES Getters International Luxembourg S.A.
Joh. Berenberg, Gossler & Co, Niederlassung Luxemburg
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.
Banque du Gothard (Luxembourg) S.A.
Chiesi Finance S.A.
Horizon Systems S.A.
Aberdeen International Holdings S.A.
Aberdeen International Holdings S.A.
Aberdeen International Holdings S.A.
Aberdeen International Holdings S.A.
Walulux S.A.
Marine Locations S.A.
Domac S.A.
Bebop, S.à r.l.
Bebop, S.à r.l.
Etoile Investissement S.A.
Smart Venture Holding
Danieli International S.A.
Europrop Luxembourg S.A.
Biel Fund Management Company S.A.
Navimar Services S.A.
Europ Assistance, Société d’Assistance S.A.
Lux Communications S.A.
International Marine Travel S.A.
Nostrum S.A.
SP Immobilière S.A.
Blue Steam & Shipping S.A.
Jado Holding Company S.A.
Jessi International Holding S.A.
COPARCOMI, Consortium de Participations Commerciales et Industrielles S.A.
Europartners Holding S.A.
Europartners Holding S.A.
Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.
D.R. (Holdings) S.A.
Siko Charter S.A.
Millicom International Cellular S.A.
UBP Money Market Fund
Metec S.A.
Emerge Capital
Luxembourg European and American Fund
Seligman Global Horizon Funds
Unirack Western Group S.A.
Westam Longitude Fund
Stolt Offshore S.A.
Luxembourg Cambridge Holding Group S.A.
Cranbury Holding S.A.
Masters Consulting
Cranbury Holding S.A.
BCILUX
Blue Chip Selection