logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

29137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 608

14 juin 2004

S O M M A I R E

Aegon International, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

29139

Fimaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29180

Aegon International, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

29139

Fiparmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29168

Agon Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29138

G.E.  Capital  Fleet  Services,  S.à r.l.,  Luxembourg-

Airfreight Development Worldwide S.A., Stegen  .

29177

Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29161

Almatis Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

29142

G.E.  Capital  Fleet  Services,  S.à r.l.,  Luxembourg-

Arab Horses Investment Company Holding S.A., 

Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29161

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29170

GeoSat Extended S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

29150

Athinea S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29169

Gottschol Alcuilux S.A., Clervaux/Eselborn. . . . . . 

29182

AXA World Funds II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

29139

Green Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

29171

AXA World Funds II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

29140

Hahnemann S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

29166

AXA World Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

29140

Hattrick Lux No. 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

29150

AXA World Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

29141

Hattrick Lux No. 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

29172

Banca Antoniana - Popolare Veneta, Luxembourg

Hattrick Lux No. 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

29156

Branch, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29164

Holm Trading Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

29164

Banca Antoniana - Popolare Veneta, Luxembourg

Industrial Trading Corporation S.A., Luxembourg- 

Branch, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29164

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29182

Banca Antoniana - Popolare Veneta, Luxembourg

Inter-Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

29155

Branch, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29164

International Sporting Travel S.A., Luxembourg . 

29138

Benelux Holding Company S.A., Luxembourg . . . .

29169

Interstyle Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

29170

Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

29179

Intourist S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29165

CEDEC  S.A.H.,  Compagnie  Européenne  pour  le 

Intourist S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29165

Développement d’Entreprises Commerciales, Lu- 

Jourdan Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29163

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29183

Jourdan Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29163

Comer Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

29171

Jourdan Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29163

Delco International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

29169

Julius Baer Multifund Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

29183

Diffusion de Saedeleer S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29162

KAP Global Publishers S.A., Luxembourg . . . . . . . 

29166

Diffusion de Saedeleer S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29162

Leisure Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

29178

Distributa S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29182

Masters Consulting S.A., Hellange . . . . . . . . . . . . . 

29180

Distributrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29167

Mirko Capital Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

29169

Ecoterres Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

29167

Moda Brand Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

29161

Electra Participations S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . .

29165

Natalia Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29183

EurOptic Express S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

29171

Nicoba S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29138

Euro-Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

29168

Nouvelle Soluger, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

29145

European  Business  Management  S.A.,  Luxem- 

Oeko-Fonds, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

29149

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29178

Oracle Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

29178

European Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

29139

Phelane S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29167

Felten Stein S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29146

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Lu- 

Felten Stein S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29146

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29181

Felten Stein S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29155

RPM Lux Consult S.A., Rameldange. . . . . . . . . . . . 

29149

Felten Stein S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29162

RPM Lux Consult S.A., Rameldange. . . . . . . . . . . . 

29149

29138

NICOBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.800. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 6 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03537. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032774.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

AGON FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.327. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 6 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03536. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032776.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

INTERNATIONAL SPORTING TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.907. 

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 17 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032781.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

RPM Lux Consult S.A., Rameldange . . . . . . . . . . . . 

29149

TLGB  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

RPM Lux Consult S.A., Rameldange . . . . . . . . . . . . 

29149

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29167

S.D.G.A. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

29168

Tonrm S.A., Sprinkange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29162

Samco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29147

Transports  Charles  Dugailliez,  S.à r.l.,  Heiner- 

Samco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29147

scheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29146

Santa Maura S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

29179

Verica, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29171

SCG STE Maurice 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

29171

Vitrum Lux S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29181

SGBT Esprit 2002 S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

29180

Voyages Schmit S.A., Christnach. . . . . . . . . . . . . . .

29147

Stream Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29179

Vulcalux, S.à r.l., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29166

SVMO S.A., Société de Vente de Machines Outils, 

West Africa Growth Fund, Sicav, Luxembourg . . .

29177

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29170

WestAM Compass Fund, Sicav, Luxembourg  . . . .

29148

Tennis Club de la Commune de Contern, A.s.b.l., 

WestAM Compass Fund, Sicav, Luxembourg  . . . .

29148

Moutfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29165

XMTCH (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29178

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

29139

AEGON INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.713. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 19 mai 2004 à 11.00 heures au siège social

L’Assemblée approuve, sur recommandations du conseil d’administration, la capitalisation des résultats pour AEGON

INTERNATIONAL SICAV Equity Fund et AEGON INTERNATIONAL SICAV Mix Fund.

L’Assemblée approuve la réélection de Monsieur Walter Capellmann, Monsieur Marc Feider et Monsieur Willem

Hendrick van Houwelingen comme Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.

L’Assemblée approuve la réélection d’ERNST &amp; YOUNG S.A. comme Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à la pro-

chaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.

<i>Extract of the Annual General Meeting of Shareholders held on May 19th, 2004 at 11 a.m. at the registered office

The Meeting approved, on the recommendations of the Board of Directors, the capitalization of the results for AE-

GON INTERNATIONAL SICAV Equity Fund and AEGON INTERNATIONAL SICAV Mix Fund.

The Meeting approved the reelection of Mr. Walter Cappelmann, Mr. Marc Feider and Mr. Willem Hendrick van Hou-

welingen as Directors until the next Annual General Meeting in 2005.

The Meeting approved the re-election of ERNST &amp; YOUNG S.A. as Auditors «Réviseur d’Entreprises agréé» until

the next Annual General Meeting in 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05728. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043627.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

AEGON INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.713. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05730, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043628.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

EUROPEAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 60.621. 

Les mandats des administrateurs LANNAGE S.A., VALON S.A., NEXIS S.A. et du commissaire aux comptes AUDIT

TRUST S.A. ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 8 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01784. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031306.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.

AXA WORLD FUNDS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.526. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 18 mai 2004 à 12.00 heures au siège social

L’Assemblée ratifie la décision du conseil d’administration de payer un dividende pour Continental European Oppor-

tunity Distribution Fund, European Socially Responsible Equities et UK Equities.

<i>Pour le compte de AEGON INTERNATIONAL, SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

On behalf of AEGON INTERNATIONAL, SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

<i>On behalf of AEGON INTERNATIONAL, SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

<i>Pour EUROPEAN INVESTMENT S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

29140

Le paiement a été effectué le 11 février 2004.
L’Assemblée a décidé sur recommandation du conseil d’administration qu’aucun autre paiement de dividende ne sera

effectué.

L’Assemblée approuve la réélection de Mme Catherine Adibi, Mr Jean-Benoît Naudin, Mr Christian Rabeau, Mr Russel

Catley, Adam Lessing, Emmanuel Dendauw et Mr Jean-Louis Laurens comme Administrateur jusqu’à la prochaine As-
semblée Générale Annuelle en 2005.

L’Assemblée approuve la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme «Réviseur d’entreprises agréé» jus-

qu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extract of the Annual General Meeting of Shareholders held on May 18th 2004 at 12 (noon) at the registered office

The Meeting ratified the decision of the Board of Directors to pay a dividend for the Continental European Oppor-

tunity Distribution Fund, European Socially Responsible Equities and UK Equities. The payment date was on February
11th, 2004.

The Meeting resolved, on the recommendations of the Board of Directors, that no further dividend will be distrib-

uted.

The Meeting approved the re-election of Mrs Catherine Adibi, Mr. Jean-Benoît Naudin, Mr. Christian Rabeau, Mr.

Russel Catley, Mr. Adam Lessing, Mr. Emmanuel Dendauw and Mr. Jean Louis Laurens as Directors to serve until the
Next Annual General Meeting in 2005.

The Meeting approved the re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as «Réviseur d’entreprises agréé» to serve

until the next Annual General Meeting in 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05746.– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043631.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

AXA WORLD FUNDS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.526. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05751, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043633.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

AXA WORLD FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.116. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 18 mai 2004 à 11.00 heures

- L’Assemblée a décidé d’approuver le paiement d’un dividende pour les compartiments suivants: 

<i>Pour le compte de AXA WORLD FUNDS II
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

<i>On behalf of AXA WORLD FUNDS II
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

<i>Au nom de AXA WORLD FUNDS II
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

Currency

 Class A

Class F

AXA World Funds - Euro Credit Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

0,22

AXA World Funds - Eastern European Equities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

0,76

AXA World Funds - Balanced Profile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

0,64

AXA World Funds - Euro Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

1,19

1,30

AXA World Funds - Euro Equities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

0,33

AXA World Funds - European Convergence Bond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

2,83

AXA World Funds - Global High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

6,23

5,40

(EUR + USD share classes)
AXA World Funds - Infotec Sector Equities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

0,40

AXA World Funds - Defense Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

1,53

29141

Date d’enregistrement: 4 juin 2004.
Date d’exécution: 7 juin 2004.
Date de paiement: 9 juin 2004.
- L’Assemblée approuve la réélection de M. Jean-Louis Laurens, Mme Catherine Adibi, M. Jean-Benoît Naudin, M.

Christian Rabeau, Mme Zoé Formery-Sene, M. Adam Lessing, M. Emmanuel Dendauw et l’élection de Mme Caroline
Boutier comme administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.

- L’Assemblée approuve la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme «Réviseur d’Entreprises agréé» jus-

qu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extract of the Annual General Meeting of Shareholders held on May 18th, 2004 at 11 a.m.

- The Meeting resolved, on the recommendations of the Board of Directors, to approve a dividend payment for the

following sub-funds: 

Record date as of June 4th, 2004
Ex-date as of June 7th, 2004
Payment date as of June 9th, 2004.
- The Meeting approved the re-election of Mr Jean-Louis Laurens, Mrs Catherine Adibi, Mr Jean-Benoît Naudin, Mr

Christian Rabeau, Mrs Zoé Formery-Sene, Mr Adam Lessing, Mr Emmanuel Dendauw and the election of Mrs Caroline
Boutier as Directors until the next Annual General Meeting in 2005.

- The Meeting approved the re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as «Réviseur d’Entreprises agréé» until

the next Annual General Meeting in 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043639.3/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

AXA WORLD FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.116. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05759, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043643.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

AXA World Funds - Euro Liquidity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0,21

AXA World Funds - Global Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0,79

(EUR + USD share classes)

<i>Pour le compte de AXA WORLD FUNDS SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

Currency

 Class A

Class F

AXA World Funds - Euro Credit Bonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.22

AXA World Funds - Eastern European Equities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.76

AXA World Funds - Balanced Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.64

AXA World Funds - Euro Bonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

1.19

1.30

AXA World Funds - Euro Equities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.33

AXA World Funds - European Convergence Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

2.83

AXA World Funds - Global High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

6.23

5.40

(EUR + USD share classes)
AXA World Funds - Infotec Sector Equities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.40

AXA World Funds - Defense Profile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

1.53

AXA World Funds - Euro Liquidity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.21

AXA World Funds - Global Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0.79

(EUR + USD share classes)

<i>On behalf of AXA WORLD FUNDS SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

<i>Au nom de AXA WORLD FUNDS 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

29142

ALMATIS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 98.613. 

In the year two thousand four, on the twentieth day of February, at 5.30 p.m.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

RHONE CAPITAL L.L.C., a limited liability company incorporated under the Delaware Limited Company Act, having

its registered office at C/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilm-
ington, New Castle County, Delaware 19801 registered with the Delaware Secretary of State under number
020030357-3481217,

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Delaware, on 19 February 2004;

RHONE PARTNERS II, L.P.; a limited partnership incorporated under the laws of Delaware, having its registered of-

fice at C/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, registered with the Delaware Secretary of State under number 020367366-3534147;

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Delaware, on 20 February 2004;

RHONE OFFSHORE PARTNERS II, L.P.; an exempted limited partnership incorporated under the laws of Cayman

Islands, having its registered office at C/o M&amp;C Corporate Services Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand Cayman Islands, British West Indies, registered with the Registrar of Companies,
Cayman Islands under number CR-13617;

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Cayman Islands, on 20 February 2004;

RHONE GERMAN PARTNERS II, GmbH &amp; Co. KG; a limited partnership formed pursuant to the German Commer-

cial Code, having its registered office at C/o Pöllath + Partner, Kardinal-Faulhaber-Strasse 10, 80333 Munich, Germany,
registered with the Amtsgericht München, Registergericht under number HRA 80159;

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Germany, on 20 February 2004;

RHONE CO-INVESTMENT II, L.P.; a limited partnership organized under the laws of Delaware, having its registered

office at C/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Cas-
tle County, Delaware 19801, registered with the Delaware Secretary of State under number 030364805-3665510;

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Germany, on 20 February 2004; and 

ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD; a non-share capital corporation incorporated under the laws of

Ontario, having its registered office at 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario, Canada M2M 4H5, registered under
number 0345785;

represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Canada, on 20 February 2004;

The said proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

RHONE CAPITAL L.L.C., represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing:

I. that RHONE CAPITAL L.L.C. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of ALMATIS HOLDINGS, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,
registered with the Trade and Companies Register under number B 98.613, incorporated by deed of M

e

 Henri Hellinckx

on 13 January 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the Company),

II. that the Sole Shareholder has taken the following resolution:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create two classes of shares: the A Shares and the B Shares and to classify the ex-

isting shares of the Company as A Shares.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 462,525.- to bring

it from its present amount of EUR 12,500.- to EUR 475,025.- and thus to issue 15,651 new A Shares and 2,850 B Shares
of the Company with a par value of EUR 25.- each.

<i>Declaration - Subscription - Payment

RHONE PARTNERS II, L.P. declares to subscribe to 4,627 A Shares of the Company, having a par value of EUR 25.-

each, and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to EUR 119,600.-, to be allocated as follows: (i) an
amount of EUR 115,675.- is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of
EUR 3,925.- is to be allocated to the Class A Share Premium Reserve Account (as defined below) of the Company. 

RHONE OFFSHORE PARTNERS II, L.P. declares to subscribe to 10,367 A Shares of the Company, having a par value

of EUR 25.- each, and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to EUR 267,200.-, to be allocated as
follows: (i) an amount of EUR 259,175.- is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii)

29143

an amount of EUR 8,025.- is to be allocated to the Class A Share Premium Reserve Account (as defined below) of the
Company.

RHONE GERMAN PARTNERS II, GmbH &amp; Co. KG declares to subscribe to 453 A Shares of the Company, having

a par value of EUR 25.- each, and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to EUR 11,700.-, to be allo-
cated as follows: (i) an amount of EUR 11,325.- is to be allocated to the nominal share capital account of the Company
and (ii) an amount of EUR 375.- is to be allocated to the Class A Share Premium Reserve Account (as defined below)
of the Company.

RHONE CO-INVESTMENT II, L.P. declares to subscribe to 204 A Shares of the Company, having a par value of EUR

25.- each, and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to EUR 5,300.-, to be allocated as follows: (i) an
amount of EUR 5,100.- is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of
EUR 200.- is to be allocated to the Class A Share Premium Reserve Account (as defined below) of the Company. 

ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD declares to subscribe to 2,850 B Shares of the Company, having

a par value of EUR 25.- each, and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to EUR 322,100.-, to be
allocated as follows: (i) an amount of EUR 71,250.- is to be allocated to the nominal share capital account of the Com-
pany and (ii) an amount of EUR 250,850.- is to be allocated to the Class B Share Premium Reserve Account (as defined
below) of the Company.

The Sole Shareholder accepts the above subscriptions and waives its preferential subscription rights in respect there-

of.

The amount of EUR 725,900.- is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who

expressly acknowledges it.

(RHONE PARTNERS, II L.P., RHONE OFFSHORE PARTNERS II, L.P., RHONE GERMAN PARTNERS II, GmbH &amp;

Co. KG, RHONE CO-INVESTMENT II, L.P., and ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD are hereinafter re-
ferred to as the Shareholders).

The Shareholders, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following

resolutions:

<i>Third resolution

The Shareholders and RHONE PARTNERS II, L.P. resolve, to acknowledge, and to the extent necessary, to approve

and accept, the transfer, by RHONE CAPITAL L.L.C., of its 500 A Shares in the Company, effective from now on, to
RHONE PARTNERS II, L.P.

The Shareholders acknowledge that the shareholding of the Company is as follows:
RHONE PARTNERS II, L.P.: 5,127 A Shares;
RHONE OFFSHORE PARTNERS II, L.P.: 10,367 A Shares;
RHONE GERMAN PARTNERS II, GmbH &amp; Co. KG: 453 A Shares;
RHONE CO-INVESTMENT II, L.P.: 204 A Shares; and
ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD: 2,850 B Shares.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend article 5.1 of the articles of association of the Company to read as follows:

5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 475,025.- represented by 16,151 A shares and 2,850 B shares

(the A shares together with the B shares, the Shares), in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR
25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

<i>Fifth resolution

The Shareholders further resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes

and empower and authorise, any lawyer of LOYENS WINANDY, and any employee of BENELUX TRUST (LUXEM-
BOURG), S.à r.l., acting individually, to proceed to the registration of the newly issued Shares in the share register of
the Company.

<i>Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately nine thousand five

hundred euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt février à cinq heures trente.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

RHONE CAPITAL L.L.C., une société à responsabilité limitée constituée sous le Delaware Limited Company Act,

ayant son siège social à C/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-

29144

mington, New Castle County, Delaware 19801, enregistrée auprès du Secrétaire d’Etat du Delaware sous le numéro
020030357- 3481217;

ici représentée par Céline Pignon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Delaware,

le 19 février 2004;

RHONE PARTNERS II, L.P.; un «limited partnership» constitué selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège

social à C/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Cast-
le County, Delaware 19801, enregistré auprès du Secrétaire d’Etat du Delaware sous le numéro 020367366-3534147;

ici représenté par Céline Pignon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Delaware,

le 20 février 2004;

RHONE OFFSHORE PARTNERS II, L.P.; un «exempted limited partnership» de droit des Iles Cayman, ayant son siè-

ge social à C/o M&amp;C Corporate Services Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman Islands, British West Indies, enregistré auprès du registre des sociétés des Iles Cayman sous le numéro
CR-13617;

ici représenté par Céline Pignon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Delaware,

le 20 février 2004;

RHONE GERMAN PARTNERS LI, GmbH &amp; Co. KG; un «limited partnership» de droit allemand, ayant son siège

social à Pöllath + Partner, Kardinal-Faulhaber-Strasse 10, 80333 Munich, Allemagne, enregistré auprès du Amtsgericht
München, Registergericht sous le numéro HRA 80159;

ici représenté par Céline Pignon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Delaware,

le 20 février 2004;

RHONE CO-INVESTMENT II, L.P.; un «limited partnership» constitué selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son

siège social à C/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, enregistrée auprès du Secrétaire d’Etat du Delaware sous le numéro 030364805-
3665510;

ici représenté par Céline Pignon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Delaware,

le 20 février 2004; et

ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD; un «non-share capital corporation», constitué selon les lois de

l’Ontario, ayant son siège social à 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario, Canada M2M 4H5, enregistré sous le numéro
0345785;

ici représenté par Céline Pignon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Delaware,

le 20 février 2004.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

RHONE CAPITAL L.L.C., représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit
I. Que RHONE CAPITAL L.L.C. est l’associé unique (l’Associé Unique) de la société ALMATIS HOLDINGS, S.à r.l,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L- 2636 Luxembourg, 12-14, rue
Léon Thyes, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.613,
constituée suivant acte reçu par le notaire M

e

 Henri Hellinckx en date du 13 janvier 2004, en cours de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (la Société),

Il. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de créer deux classes de parts sociales: les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales

de Classe B et de classer les parts sociales existantes de la Société en Parts Sociales de Classe A.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de 462.525,- EUR pour le porter

de son montant actuel de 12.500,- EUR à 475.025,- EUR, par l’émission de 15.651 nouvelles Parts Sociales de Classe A
et de 2.850 nouvelles Parts Sociales de Classe B, d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

<i>Déclaration - Souscription - Libération

RHONE PARTNERS II, L.P. déclare souscrire 4.627 Parts Sociales de Classe A de la Société, d’une valeur nominale

de 25,- EUR chacune et les libérer intégralement par un apport en espèces de 119.600,- EUR réparti comme suit: (i)
affectation d’un montant de 115.675,- EUR au compte capital social de la Société et (ii) affectation d’un montant de
3.925,- EUR au Compte Prime d’ Emission des Parts Sociales de Classe A (tel que défini ci-après) de la Société.

RHONE OFFSHORE PARTNERS II, L.P. déclare souscrire 10.367 Parts Sociales de Classe A de la Société, d’une va-

leur nominale de 25,- EUR chacune et les libérer intégralement par un apport en espèces de 267.200,- EUR réparti com-
me suit: (i) affectation d’un montant de 259.175,- EUR au compte capital social de la Société et (ii) affectation d’un
montant de 8.025,- EUR au Compte Prime d’ Emission des Parts Sociales de Classe A (tel que défini ci-après) de la So-
ciété.

RHONE GERMAN PARTNERS II, GmbH &amp; Co.KG déclare souscrire 453 Parts Sociales de Classe A de la Société,

d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune et les libérer intégralement par un apport en espèces de 11.700,- EUR ré-
parti comme suit: (i) affectation d’un montant de 11.325,- EUR au compte capital social de la Société et (ii) affectation
d’un montant de 375,- EUR au Compte Prime d’ Emission des Parts Sociales de Classe A (tel que défini ci-après) de la
Société.

RHONE CO-INVESTMENT II, L.P. déclare souscrire 204 Parts Sociales de Classe A de la Société, d’une valeur no-

minale de 25,- EUR chacune et les libérer intégralement par un apport en espèces de 5.300,- EUR réparti comme suit:

29145

(i) affectation d’un montant de 5.100,- EUR au compte capital social de la Société et (ii) affectation d’un montant de 200,-
EUR au Compte Prime d’ Emission des Parts Sociales de Classe A (tel que défini ci-après) de la Société.

ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD déclare souscrire 2.850 Parts Sociales de Classe B de la Société,

d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune et les libérer intégralement par un apport en espèces de 322.100,- EUR
reparti comme suit: (i) affectation d’un montant de 71.250,- EUR au compte capital social de la Société et (ii) affectation
d’un montant de 250.850,- EUR au Compte Prime d’ Emission des Parts Sociales de Classe B (tel que défini ci-après) de
la Société.

L’Associé Unique accepte les souscriptions susmentionnées et renonce à ses droits préférentiels de souscription re-

lativement auxdites souscriptions.

La somme de 725.900,- EUR est à la disposition de la Société, tel qu’il en a été certifié au notaire instrumentant, qui

le reconnaît expressément.

(RHONE PARTNERS II, L.P., RHONE OFFSHORE PARTNERS II, L.P., RHONE GERMAN PARTNERS II, GmbH &amp;

Co. KG, RHONE CO-INVESTMENT II, L.P et ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD sont dénommés ci-
après, les Associés).

Les Associés, représentés comme susmentionné, ont requis le notaire instrumentant, d’acter ce qui suit

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de prendre acte, et dans la mesure nécessaire, d’approuver et d’accepter, la cession par RHO-

NE CAPITAL L.L.C. de ses 500 Parts Sociales de Classe A dans la Société, avec effet immédiat, à RHONE PARTNERS
II, LP.

Les Associés prennent acte que les participations au sein de la Société sont les suivantes:
- RHONE PARTNERS II, L.P.: 5.127 Parts Sociales de Classe A;
- RHONE OFFSHORE PARTNERS II, L.P.: 10.367 Parts Sociales de Classe A;
- RHONE GERMAN PARTNERS II, GmbH &amp; Co. KG: 453 Parts Sociales de Classe A;
- RHONE CO-INVESTMENT II, L.P.: 204 Parts Sociales de Classe A;
- ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD: 2.850 Parts Sociales de Classe B.

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

«5.1. Le capital de la Société est fixé à 475.025,- EUR représenté par 16.151 Parts Sociales de Classe A et 2.850 Parts

Sociales de Classe B (les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B étant dénommées collectivement,
les Parts Sociales) sous forme nominative, d’une valeur nominale vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident par ailleurs d’inscrire les modifications susmentionnées dans le registre des Parts Sociales de

la Société et autorisent tout avocat de l’étude LOYENS WINANDY et tout employé de la société BENELUX TRUST
(LUXEMBOURG), S.à r.l, agissant à titre individuel, à procéder à l’inscription des Parts Sociales nouvellement émises
dans le registre des Parts Sociales de la Société. 

<i>Frais

Le montant des frais en raison du présent acte, s’élève à environ neuf mille cinq cents euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé
qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: C. Pignon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, vol. 20CS, fol. 46, case 12. – Reçu 7.259 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032180.3/211/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

NOUVELLE SOLUGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1533 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.665. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02285, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(032481.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Luxembourg, le 2 mars 2004.

J. Elvinger.

29146

TRANSPORTS CHARLES DUGAILLIEZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 36.

R. C. Luxembourg B 95.060. 

<i>Cession de parts

Entre les soussignés:
Charles Dugailliez
Christiane Geysens
Béat Schuhmacher
Il a été convenu ce qui suit:
Béat Schuhmacher cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à Charles Dugailliez qui accepte, 250

parts sociales lui appartenant dans la société TRANSPORTS C. DUGAILLIEZ constituée suivant acte:

- reçu par le notaire Christine Doerner en date du 31 janvier 1987, publié au Mémorial C de 1987, page 5704.
- Modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 mars 1989, publié au Mémorial C de 1989,

page 9564.

- Modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 mars 1995, publié au Mémorial C de 1995,

page 14474.

- Modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 mai 1999, publié au Mémorial C de 1999,

page 27472.

- L’augmentation du capital de 263,31 EUR (10.622,- BEF) est fait par transfert des réserves de bénéfice, enregistré à

Clervaux et inscrit au registre des firmes sous n

°

 vol. 119 Art. 1581.

Ainsi que tous les droits, lui appartenant dans ladite société.
En conséquence Charles Dugailliez devient, par la présente, propriétaire des droits cédés, il se trouve subrogé dans

tous les droits et action de la S.à r.l. DUGAILLIEZ TRANSPORT.

Cette cession est consentie et acceptée à titre gratuit.
Le capital social de la société est fixé à 31.250,- EUR et est attribué comme suit:
Dugailliez Charles: 1.150 à 25,- EUR
Geysens Christiane: 100 à 25,- EUR.
Aux présentes est alors intervenu Dugailliez Charles, demeurant à Maison 36 L-9753 Heinerscheid
qui déclare en sa qualité de gérant de ladite société donner son consentement à la présente cession au nom de la S.à

r.l. DUGAILLIEZ.

Fait à Heinerscheid, le 26 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02167. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901528.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2004.

FELTEN STEIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 14, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 54.920. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05333, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

(031603.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

FELTEN STEIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 14, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 54.920. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05331, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

(031601.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Lu et approuvé
Bon pour cession
C. Dugailliez / C. Geysens / B. Schuhmacher

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

29147

VOYAGES SCHMIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7640 Christnach, 44, rue Loetsch.

R. C. Luxembourg B 100.134. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 21 avril 2004, réf. DSO-AP00115, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901563.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2004.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 88.193. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille quatre, le 1

er

 avril.

S’est réunie au siège social, 8 rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg, l’Assemblée Générale Extraordinaire des ac-

tionnaires de la société anonyme SAMCO, constituée suivant acte reçu par M

e

 Jean Seckler, notaire en résidence à Jung-

linster, en date du 14 juin 2002 et enregistrée au Registre du Commerce sous le n

°

 B 88.193, le 25 juillet 2002.

L’Assemblée est présidée par BUSINESS SERVICE MANAGEMENT CONSULT Inc, ayant siège social 25 Greystone

Manor à Lewes, DE-19958 qui désigne la société YUCATAN BAY Inc, ayant son siège social à Dover, DE-19901 en
qualité de secrétaire et la société AXESS INTERNATIONAL Inc. ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands
en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président expose:
I.- que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

- Démission de l’administrateur-délégué et nomination d’un administrateur;
- Décharge de gestion à l’administrateur-délégué sortant.
II.- que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence

laquelle après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau restera annexée au
présent procès-verbal.

qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représenté.
III.- qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière après délibération prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

- l’Assemblée enregistre, à dater de ce jour, la démission de l’administrateur-délégué, Monsieur Michel Delville do-

micilié 18, rue des Genets B-4052 Beaufays.

- l’Assemblée appelle au poste d’administrateur la société BUSINESS SERVICE MANAGEMENT CONSULT Inc.,

<i>Deuxième résolution

par un vote spécial et séparé, l’Assemblée vote la décharge de gestion à l’administrateur-délégué sortant et le remer-

cie pour le travail accompli.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02327. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029815.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 88.193. 

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 1

<i>er

<i> avril 2004

Au terme de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social, aujourd’hui-même, le Conseil d’Administration

s’est réuni avec à l’ordre du jour:

- nomination d’un nouvel administrateur-délégué
- divers
Sont présents:
- la société BUSINESS SERVICE MANAGEMENT CONSULT Inc., administrateur
- la société YUCATAN BAY Inc., administrateur

Echternach, le 23 avril 2004.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

29148

- la société AXESS INTERNATIONAL Inc., administrateur
Soit la totalité des administrateurs de la S.A. SAMCO.
Le Conseil se reconnaît valablement constitué et apte à délibérer.
Après échanges de vues, il décide à l’unanimité de nommer, dès cet instant la société BUSINESS SERVICE MANAGE-

MENT CONSULT Inc. au poste d’administrateur-délégué.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant restée sans réponse, la séance est levée après lecture, ap-

probation et signature du présent procès-verbal.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02332. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029818.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

WestAM COMPASS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 67.580. 

Le bilan au 31 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00929, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.

(032452.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

WestAM COMPASS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 67.580. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 5 mars 2004

L’assemblée générale des actionnaires:
- a décidé de distribuer un dividende aux actionnaires de la classe B enregistrés au 28 avril 2004 pour l’exercice clô-

turé au 30 novembre 2003.

- a pris note de la démission de M. Werner Peters effective au 25 septembre 2003, de la démission du Dr Henning

Starke effective au 30 septembre 2003, de la démission de Mme Margit Timmermann-Rassat effective au 1

er

 décembre

2003 et de la démission de M. Franz Ruf effective au 1

er

 janvier 2004.

- a déchargé M. Werner Peters en tant qu’administrateur de la Société jusqu’au 25 septembre 2003, le Dr Henning

Starke en tant qu’administrateur de la Société jusqu’au 30 septembre 2003, Mme Margit Timmermann-Rassat en tant
qu’administrateur de la Société jusqu’au 1

er

 décembre 2003 et M. Franz Ruf en tant qu’administrateur de la Société et

Président du Conseil d’Administration de la Société jusqu’au 1

er

 janvier 2004.

- a déchargé de leur fonction d’administrateur M. Mohammed Bhatti, M. Luke Nunneley, M. Massimoluca Mattioli et

M. Jaime Gil-Delgado pour l’exercice clôturé au 30 novembre 2003.

- a approuvé la réélection de M. Jaime Gil-Delgado comme administrateur de la Société et a noté sa nomination com-

me Président du Conseil d’Administration de la Société.

- a approuvé la réélection de M. Mohammed Bhatti, M. Luke Nunneley et M. Massimoluca Mattioli en tant qu’admi-

nistrateurs de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30
novembre 2004.

- a ratifié les nominations et a élu M. Willem Labuschagne, M. Roland Wigger et M. Christoph Dahm en tant qu’ad-

ministrateurs de la Société.

- a réélu PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale

statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 novembre 2004.

Luxembourg, le 6 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032458.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

BUSINESS SERVICE MANAGEMENT CONSULT Inc. / YUCATAN BAY Inc.
Signature / Signature

AXESS INTERNATIONAL Inc.
Signature

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire de WestAM COMPASS FUND PORTFOLIO SICAV

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Agent domiciliataire de WestAM COMPASS FUND PORTFOLIO SICAV
Signature

29149

OEKO-FONDS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2663 Luxembourg, 6, rue Vauban.

BILAN FINANCIER 2003 

COMPTES D’EXPLOITATION AU 31 DECEMBRE 2003 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04299. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033107.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

RPM LUX CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.

R. C. Luxembourg B 26.599. 

Le bilan au 31 mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02893, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031394.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

RPM LUX CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.

R. C. Luxembourg B 26.599. 

Le bilan au 31 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02892, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031392.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

RPM LUX CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.

R. C. Luxembourg B 26.599. 

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02890, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031390.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

RPM LUX CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.

R. C. Luxembourg B 26.599. 

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02888, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031388.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.466,08

Non exigible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.152,47

Réalisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.769,38

Exigible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214.371,67

Disponible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65.288,68

217.524,14

217.524,14

Frais et Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541.310,78

Recettes et dons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  541.401,35

Bénéfice de l’exercice 2003 . . . . . . . . . . . . .

90,57

541.401,35

541.401,35

D. Engel
<i>Trésorière

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Signature.

29150

GeoSat EXTENDED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 85.339. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 13 mars 2004, la résolution suivante:
M. Jean-Marc Volpelière est relevé de sa fonction d’administrateur de la société et remplacé par M. Roland Cimolino

terminant ainsi le mandat de l’ancien administrateur.

Luxembourg, le 29 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031445.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

HATTRICK LUX NO. 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 100.326. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of March.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AIM SERVICES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Luxembourg, on 30 March 2004.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of HATTRICK LUX NO. 1, S. à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25,-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company. 

Pour extrait conforme
GeoSat EXTENDED S.A.
Signature

29151

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. 

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time. 

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument. 

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.

In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object. 

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the

notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management. 

Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-

ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management. 

Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason

whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company. 

Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-

tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders 

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least. 

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended. 

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

29152

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of man-

agement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. 

The sole manager or the board of management is authorised to distribute interim dividends in case the funds available

for distribution are sufficient. 

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them. 

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. 

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares are subscribed by AIM SERVICES, S.à r.l., aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of

December 2004.

<i>Expenses 

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, AIM SERVICES, S.à r.l., representing the entirety of the sub-

scribed capital of the Company has passed the following resolutions: 

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg. 
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite

period:

- Mr John W. Marren, Investor, born on 4 March 1963 in Elmhurst, Illinois, United States of America, residing at 808

Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, United States of America; and 

- Mr Bastian F. Lueken, Investor, born on 25 December 1972, in Frankfurt am Main, Germany, residing at Flat A, 7

Gloucester Road, London SW7 4PP, United Kingdom.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail. 

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung: 

Im Jahre zweitausendundvier, den dreissigtsen März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

AIM SERVICES, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz

in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg; 

hier vertreten durch Frau Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 30. März 2004.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Partei und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden. 

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung ei-

ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité limi-
tée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen. 

29153

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung HATTRICK LUX NO. 1, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt. 

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-

mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen. 

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die

Dauer des Mandates fest.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu je-
dem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-

keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist. 

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-

men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Ein-
klang stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden. 

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser

29154

Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-

heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus wel-

chem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer

Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich. 

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt. 

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören. 

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar jeden Jahres und endet am

letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres. 

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf-
geführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-

chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind. 

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation 

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten

der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt. 

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten AIM SERVICES, S.à r.l. gezeichnet.
Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember

2004.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf EUR 1.500,-

geschätzt.

29155

<i>Hauptversammlung

AIM SERVICES, S.à r.l., die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung

der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung

sind auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr John W. Marren, Kapitalanleger, geboren am 4 März 1963 in Elmhurst, Illinois, Vereinigte Staaten Amerikas,

wohnhaft in 808 Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, Vereinigte Staaten Amerikas; und 

- Herr Bastian F. Lueken, Kapitalanleger, geboren am 25 Dezember 1972, in Frankfurt am Main, Deutschland, wohn-

haft in Flat A, 7 Gloucester Road, London SW7 4PP, Großbritannien.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem

amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A. Bellardi Ricci, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 avril 2004, vol. 427, fol. 34, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(032916.3/242/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

FELTEN STEIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 14, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 54.920. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05320, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

(031588.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

INTER-SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.195. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2004

En vertu d’une assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 avril 2004 il a été décidé à

l’unanimité que le siège social de la société est transféré de L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte-Croix à L-1471 Luxem-
bourg, 188, route d’Esch et ce à compter du 21 avril 2004.

Il a également été décidé à l’unanimité de nommer Madame Nathalie Chabert, demeurant à F-75016 Paris, 41, rue

Cortambert, née le 23 avril 1959 à Monaco, employée privée, au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur
Remy Jean-François démissionnaire. Cette nomination intervient pour une durée de 6 ans à compter de ce jour et se
terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2010.

Il a été décidé à l’unanimité de nommer Madame Marie Paul Hadjez, demeurant à F-92100 Boulogne, 99, rue de Cè-

vres, née le 15 février 1932 à Alger, sans profession, au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-
Claude Vedrine démissionnaire. Cette nomination intervient pour une durée de 6 ans à compter de ce jour et se ter-
minera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2010.

Il a été décidé à l’unanimité de nommer la société AUDIT CONSULTING S.A. sise 166, rue de Dippach à L-8055

Bertrange immatriculée au registre du commerce sous le numéro B 72.543 en tant que Commissaire aux Comptes en
remplacement de la société AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A. démissionnaire. Cette nomination inter-
vient pour une durée de 6 ans à compter de ce jour et se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir
en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04341. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032789.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

 Mersch, den 22. April 2004.

H. Hellinckx.

Signature
<i>Mandataire

Signature.

29156

HATTRICK LUX NO. 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 100.327. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of March.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

HATTRICK LUX NO. 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Lux-

embourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated by a deed of the
undersigned notary on this day, which will be registered before or with the present deed,

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Luxembourg, on 30 March 2004. 

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation. 

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period. 

Art. 4. The Company will assume the name of HATTRICK LUX NO. 4, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. 

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company. 

C. Management 

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. 
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument. 

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.

29157

In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the

notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.

Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting. 

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-

ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management.

Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason

whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-

tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders 

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of man-

agement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. 

The sole manager or the board of management is authorised to distribute interim dividends in case the funds available

for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company. 

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them. 

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. 

29158

<i>Subscription and payment 

All five hundred (500) shares are subscribed by HATTRICK LUX NO. 2, S.à r.l., aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of

December 2004. 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, HATTRICK LUX NO. 2, S.à r.l., representing the entirety of

the subscribed capital of the Company has passed the following resolutions: 

 1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg. 
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite

period: 

- Mr John W. Marren, Investor, born on 4 March 1963 in Elmhurst, Illinois, United States of America, residing at 808

Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, United States of America; and 

- Mr Bastian F. Lueken, Investor, born on 25 December 1972, in Frankfurt am Main, Germany, residing at Flat A, 7

Gloucester Road, London SW7 4PP, United Kingdom.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail. 

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvier, den dreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

HATTRICK LUX NO. 2, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, mit Ge-

sellschaftssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, welche gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom
heutigen Tage gegründet wurde und welche Urkunde vor oder mit dieser Urkunde einregistriert wird,

hier vertreten durch Frau Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 30. März 2004.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Partei und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden. 

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung ei-

ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité limi-
tée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen. 

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung HATTRICK LUX NO. 4 S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

29159

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). 

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt. 

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-

mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen. 

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein. 

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die

Dauer des Mandates fest. 

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu je-
dem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen ausgestellt werden. 

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-

keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist. 

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-

men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Ein-
klang stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden. 

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-

heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus wel-

chem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

29160

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer

Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich. 

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden. 

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören. 

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar jeden Jahres und endet am

letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres. 

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf-
geführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-

chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind. 

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten

der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt. 

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten HATTRICK LUX NO. 2, S.à r.l. gezeichnet.
Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist. 

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember

2004. 

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf EUR 1.500,-

geschätzt.

<i>Hauptversammlung

HATTRICK LUX NO. 2, S.à r.l., die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der

Gründung der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst: 

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung

sind auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr John W. Marren, Kapitalanleger, geboren am 4. März 1963 in Elmhurst, Illinois, Vereinigte Staaten Amerikas,

wohnhaft in 808 Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, Vereinigte Staaten Amerikas; und

- Herr Bastian F. Lueken, Kapitalanleger, geboren am 25 Dezember 1972, in Frankfurt am Main, Deutschland, wohn-

haft in Flat A, 7 Gloucester Road, London SW7 4PP, Großbritannien.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend. 

29161

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem

amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A. Bellardi Ricci, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 avril 2004, vol. 427, fol. 35, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(032915.3/242/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

G.E. CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.814. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 

29 juin 1992, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 514 du 10 novembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03664, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032538.3/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

G.E. CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.814. 

<i>Résolutions de l’associé unique en date du 29 mars 2004

Il résulte des résolutions de l’associé unique en date du 29 mars 2004:
- que le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 sont approuvés;
- que le bénéfice a été reporté;
- qu’il est donné décharge au gérant pour l’exercice s’achevant au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 20 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03664. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032540.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

MODA BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.431. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui s’est tenue le 16 avril 2004

A l’Assemblée Générale de MODA BRAND HOLDING S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
- de changer le siège de la Société du 47, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg;

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer la perte de l’exercice de CHF 688.022,67 dans le compte perte à reporter. En prenant en considération

les bénéfices reportés de CHF 31.558.811,81, le résultat net au 31 décembre 2002 est un bénéfice reporté de CHF
30.870.789,67;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’à la date du 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032824.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

 Mersch, den 22. April 2004.

H. Hellinckx.

Signature.

Pour G.E. CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

MODA BRAND HOLDING S.A.
Signature

29162

FELTEN STEIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 14, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 54.920. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05335, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

(031609.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

TONRM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Sprinkange, 47, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.961. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03209, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2004.

(033031.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

DIFFUSION DE SAEDELEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.943. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Jean-Pierre De Saedeleer, Joaillier-Créateur, demeurant au 58, rue Daoust, B-5500 Dinant, aux fonctions

d’administrateur-délégué.

- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg, aux fonctions d’administrateur;

et ratifie la nomination de Madame Dominique Rizzi, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2004.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032793.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

DIFFUSION DE SAEDELEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.943. 

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 6 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032808.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Signature
<i>Mandataire

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

29163

JOURDAN LUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.176. 

Les comptes de liquidation de la société au 22 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-

AP04046, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004.

(032527.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

JOURDAN LUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.176. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 22 mars 2004 à 9.00 heu-

res que:

<i>Délibérations

Après avoir délibéré, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’Assemblée entend le rapport de la société GLOBAL MANAGEMENT &amp; SERVICES S.A., au titre de liquidateur de

la société JOURDAN LUX S.A. en liquidation.

L’Assemblée désigne en qualité de commissaire à la liquidation la société MESLAN ASSOCIATES S.A. avec siège social

à Tortola (B.V.I.) qui accepte la mission de faire rapport sur l’emploi des valeurs sociales et les comptes de liquidation.

L’Assemblée Générale de clôture de la liquidation a été fixée le 22 mars 2004 à 16.00 heures à tenir au 32, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg avec pour ordre du jour:

- Rapport du commissaire à la liquidation.
- Approbation des comptes de liquidation.
- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- Clôture de la liquidation.
- Désignation de l’endroit où les livres et les documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 22 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032531.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

JOURDAN LUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.176. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 22 mars 2004 à 16.00 heu-

res que:

<i>Délibérations

Après avoir délibéré, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
- Après avoir entendu le rapport du commissaire à la liquidation, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation.
- L’Assemblée accorde décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l’exécution

de leur mandat.

- L’Assemblée constate que la liquidation de la société est clôturée.
- L’Assemblée décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans dans les

locaux de la société GLOBAL MANAGEMENT &amp; SERVICES S.A. avec siège social au 32, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le liquidateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Le liquidateur

29164

Luxembourg, le 22 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032534.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HOLM TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.322. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04741, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2004.

(032478.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA, LUXEMBOURG BRANCH

Siège social: L-1650 Luxembourg, 62, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 100.304. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03677, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2004.

(033328.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA, LUXEMBOURG BRANCH

Siège social: L-1650 Luxembourg, 62, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 100.304. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03824, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2004.

(033330.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA, LUXEMBOURG BRANCH

Siège social: L-1650 Luxembourg, 62, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 100.304. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04137, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2004.

(033331.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Liquidateur

<i>Pour HOLM TRADING HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA, LUXEMBOURG BRANCH
Signatures

BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA, LUXEMBOURG BRANCH
Signatures

BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA, LUXEMBOURG BRANCH
Signatures

29165

INTOURIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 45.359. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04014, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2004.

(032895.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

INTOURIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 45.359. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04012, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2004.

(032894.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

ELECTRA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 67.348. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03477, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032513.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

TENNIS CLUB DE LA COMMUNE DE CONTERN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-5330 Moutfort, rue de Remich.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 janvier 2004

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2004 à 18.00 heures, les membres du comité se sont réunis

et ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

Sont présents:
Monsieur Camille Schweitzer,
Monsieur Paul Sunnen,
Monsieur Marc Tock,
Madame Anneke Van Hittersum,
Madame Marie-Anne Bos,
Madame Mariette Moris,
Monsieur Roger Weber.

<i>Résolution unique

 Il est décidé à l’unanimité des voix présentes de modifier l’article 18 du chapitre III des statuts enregistrés le 24 février

1994, dans le sens que le nouveau texte aura la teneur suivante:

Art. 18. Le comité ne peut comprendre qu’au maximum 2 membres unis par les liens de parenté directe.
Fait à Moutfort, le 16 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033290.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

Pétange, le 23 avril 2004.

Signature.

C. Schweitzer / P. Sunnen / M. Tock / A. Van Hittersum / M.-A. Bos / M. Moris / R. Weber

29166

VULCALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 7.493. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02949, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2004.

(032580.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HAHNEMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.751. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 février 2004, que l’Assemblée

a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mardi 9 avril 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée prend acte et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son mandat d’Ad-

ministrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 L-Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

- Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant à I-Bergamo, via Donizetti n

°

 22, Administrateur;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 L-Luxembourg, Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxem-

bourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032611.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

KAP GLOBAL PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.452. 

En date du 26 février 2004, les administrateurs de la société KAP GLOBAL PUBLISHERS S.A. ont décidé de:
1. Coopter au poste d’administrateur avec effet au 1

er

 février 2004 pour une période venant à échéance lors de l’As-

semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004:

- Monsieur Derk Haank, demeurant au 6, Pasplein, NL-7001 GC Doetinchem,
- Monsieur Martin Mos, demeurant au 1, Kerkhof, NL-7031 JE Wehl,
- Monsieur Gérard Becquer, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
en remplacement de Messieurs Rüdiger Gebauer, Dietrich Gotze, Peter Hendriks démissionnaires.
2. Transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 22 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02965. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032732.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Signature
<i>Un mandataire

HAHNEMANN S.A.
S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 9 avril 2004.

Signature.

29167

PHELANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 54.084. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03610. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032698.3/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

TLGB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 92.825. 

Il résulte d’un certificat du «Registrar of Companies» des Bermudes que l’associé unique de la Société, TELEGLOBE

INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd., une société constituée et régie selon les lois des Bermudes, ayant son siège social
à 2 Clarendon House, Church Street, Hamilton HM11, Bermudes, a changé sa dénomination sociale en TLGB INTER-
NATIONAL HOLDINGS Ltd.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP04110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032645.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

DISTRIBUTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.612. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03541. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032686.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

ECOTERRES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.940. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032687.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

<i>Pour la société
Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

TLGB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

29168

S.D.G.A. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.136. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 10 dé-

cembre 2003, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Mirko La Rocca en qualité d’Administrateur de la société, en

remplacement de Monsieur Maurizio Cottella, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en
date du 22 janvier 2003. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Mirko La Rocca en qualité d’Administrateur de
la société. Le mandat ainsi conféré viendra à échéance à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
2001.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée lors de la présente Assemblée par

Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, de sa fonction d’Administra-
teur.

En remplacement de l’Administrateur démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur

Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité
d’Administrateur.

Le mandat ainsi conféré viendra à échéance à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01660. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032641.3/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

EURO-CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 75.671. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032689.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

FIPARMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.642. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03547. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032690.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

S.D.G.A. HOLDING S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateur

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

29169

MIRKO CAPITAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.768. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03546. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032691.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

DELCO INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 41.218. 

Suite à une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, les mandats des administrateurs et du commissaire

aux comptes sont prolongés jusqu’à l’Assemblée Générale des Actionnaires de l’année 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(032694.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

BENELUX HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.356. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 6 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032699.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

ATHINEA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 49.674. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 6 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032702.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, Luxembourg
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

29170

SVMO S.A., SOCIETE DE VENTE DE MACHINES OUTILS, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 75.851. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2004

L’assemblée décide de transférer le siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’assemblée accepte la démission de MARINUS SHIPMENT LTD et GORBEK PRODUCTS INC. de leurs fonctions

d’administrateurs ainsi que celle de Monsieur Alain Strivay de ses fonctions de commissaire aux comptes et leur donne
décharge de leur mandat à ce jour.

En remplacement, l’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- la société COLINGTON MANAGEMENT INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social

à Tortola

- la société CALBURY HOLDING INC., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama
et aux fonctions de commissaire aux comptes:
- la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
qui termineront les mandats en cours qui viennent à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes de l’exercice 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032703.3/506/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

ARAB HORSES INVESTMENT COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.811. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Luxembourg, le 6 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03535. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032706.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

INTERSTYLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.556. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui s’est tenue le 16 avril 2004

A l’Assemblée Générale de INTERSTYLE HOLDING S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
- de changer le siège de la Société du 47, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg;

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer la perte de l’exercice de CHF 51.526,84 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’à la date du 31 décembre 2002;

- de corriger suivant l’art. 4 des statuts la durée du mandat des Administrateurs qui expirera à l’Assemblée Générale

Ordinaire des Actionnaires en 2004;

- de continuer les activités de la Société suite aux pertes reportées excédant 75 % du capital souscrit.
Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03303. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032826.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

<i>Pour la société
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

INTERSTYLE HOLDING S.A.
Signature

29171

SCG STE MAURICE 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 90.612. 

Par résolution en date du 10 mars 2004, l’associé unique de la société SCG STE MAURICE 2, S.à r.l. a décidé:
- d’accepter la nomination, pour une durée indéterminée, de Monsieur Gregory F. Camia, résidant au 4727 East

Conway Drive, Atlanta, Géorgie 30327, Etats-Unis en tant que gérant de classe A, en remplacement de Monsieur Rinaldi,
démissionnaire;

- de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032737.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

EurOptic EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 82.393. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2004

L’assemblée décide de transférer le siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02576. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032707.3/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

COMER GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.661. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03713, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032724.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

VERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 47.707. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP02591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

(032752.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

GREEN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 83.523. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032777.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Luxembourg, le 22 mars 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 19 avril 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Senningerberg, le 22 avril 2004.

P. Bettingen.

29172

HATTRICK LUX No. 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 100.325. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of March.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Lux-

embourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated by a deed of the
undersigned notary on this day, which will be registered before or with the present deed,

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Luxembourg, on 30 March 2004.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of HATTRICK LUX No. 2, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. 

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.

29173

In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the

notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.

Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-

ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of
management.

Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason

whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their posi-

tion, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised
agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of man-

agement prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. 

The sole manager or the board of management is authorised to distribute interim dividends in case the funds available

for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

29174

<i>Subscription and Payment

All five hundred (500) shares are subscribed by HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l., aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of

December 2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l., representing the entirety of

the subscribed capital of the Company has passed the following resolutions:

 1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite

period:

- Mr John W. Marren, Investor, born on 4 March 1963 in Elmhurst, Illinois, United States of America, residing at 808

Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, United States of America; and

- Mr Bastian F. Lueken, Investor, born on 25 December 1972, in Frankfurt am Main, Germany, residing at Flat A, 7

Gloucester Road, London SW7 4PP, United Kingdom.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail. 

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung: 

Im Jahre zweitausendundvier, den dreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, mit Ge-

sellschaftssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, welche gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom
heutigen Tage gegründet wurde und welche Urkunde vor oder mit dieser Urkunde einregistriert wird,

hier vertreten durch Frau Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 30. März 2004.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Partei und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung ei-

ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité limi-
tée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung HATTRICK LUX No. 2, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

29175

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt. 

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-

mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die

Dauer des Mandates fest.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu je-
dem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-

keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
der Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-

men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Ein-
klang stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden. 

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-

heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus wel-

chem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

29176

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer

Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Aus-
übung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlung der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.

E. Geschäftskonten - Konten - Ausschüttungen von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Januars jeden Jahres und endet am

letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf-
geführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-

chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.

F. Gesellschaftsauflösung- Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten

der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital auf-
geteilt. 

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l. gezeichnet.
Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Tag des Monats Dezember

2004.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf EUR 1.500,-

geschätzt.

<i>Hauptversammlung

HATTRICK LUX No. 1, S.à r.l., die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der

Gründung der Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung

sind auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr John W. Marren, Kapitalanleger, geboren am 4. März 1963 in Elmhurst, Illinois, Vereinigte Staaten Amerikas,

wohnhaft in 808 Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, Vereinigte Staaten Amerikas; und

- Herr Bastian F. Lueken, Kapitalanleger, geboren am 25. Dezember 1972, in Frankfurt am Main, Deutschland, wohn-

haft in Flat A, 7 Gloucester Road, London SW7 4PP, Großbritannien.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

29177

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem

amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A. Bellardi Ricci und H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 avril 2004, vol. 427, fol. 34, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(032919.3/242/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.

AIRFREIGHT DEVELOPMENT WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Stegen, 39, route de Medernach.

R. C. Diekirch B 4.278. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société 

<i>tenue à Stegen, 39, route de Medernach en date du 12 septembre 2003 à 15.00 heures

<i>Elections Statutaires

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à expiration, sont renommés adminis-

trateurs de la société pour un nouveau terme de six ans:

- Monsieur François Muller, demeurant à L-1840 Luxembourg, 11c, boulevard Joseph II, Président du Conseil d’Ad-

ministration;

- Monsieur Alain Jacqué, demeurant à L-9186 Stegen, 39, rue de Medernach;
- Monsieur Armand Dhur, demeurant à L-2630 Luxembourg, 7, rue de Trèves.
Est renommée Commissaire aux Comptes, la société S.R.E. REVISION S.A. avec siège à L-8080 Bertrange, 36, route

de Longwy.

Ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2009.
Pour extrait sincère et conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Stegen, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Diekirch, le 24 mars 2004, réf. DSO-AO00389. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901562.3/832/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2004.

WEST AFRICA GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.014. 

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of WEST AFRICA GROWTH FUND will be held at the registered office at 13 rue Goethe, Luxembourg
on Tuesday <i>29 June 2004 at 12.00 noon for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the Audit Report, the Report of the Directors and of the Annual Report and Accounts for the year

ended 31 March 2004.

2. Dividend distribution.
3. Discharge of the Board of Directors.
4. Election and re-election of Directors.
5. Re-election of Auditor.
6. Miscellaneous.

<i>Voting

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority

of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

<i>Voting Arrangements

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the registered office of the company to arrive not later than 25 June 2004.

Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the

registered office.

24 May 2004.

(03063/041/27) 

<i>The Board of Directors.

 Mersch, den 22. April 2004.

H. Hellinckx.

Signature
<i>Un administrateur

29178

ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.413. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, le <i>30 juin 2004 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

I (01973/000/15) 

XMTCH (LUX), Fonds Commun de Placement.

Distribution au 14 juin 2004 aux porteurs de parts du fonds commun de placement luxembourgeois suivant:

(date ex-coupon: 14 juin 2004, date de paiement: 16 juin 2004)

XMTCH (LUX) on MSCI Euro

ISIN: LU0154139132

Montant: EUR 1,10

Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que le prospectus

au siège de la société de gestion, XMTCH MANAGEMENT COMPANY et à celui du représentant en Suisse, CREDIT
SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS, Zürich.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.

(03213/736/16) 

LEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 68.901. 

All shareholders are hereby convened to attend the

 GENERAL MEETING

which is going to be held at the registered office, on Tuesday <i>July 6, 2004 at 3.00 p.m.

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor for the business year ended December 31st, 2003
2. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as at December 31st, 2003
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor
4. Statutory elections
5. Miscellaneous.

I (03224/783/15) 

<i>The Board of Directors.

EUROPEAN BUSINESS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.251. 

Les actionnaires sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>25 juin 2004 au siège de la société à 11.00 heures, statuant sur l’exercice 2003.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire
2. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
3. Approbation des comptes annuels et affectation
4. Nominations statutaires et divers.

II (03012/603/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

29179

SANTA MAURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.564. 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

extraordinairement convoquée pour le <i>16 juillet 2004 à 13.00 heures au siège de la société pour délibérer de l’ordre du
jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration sur la situation actuelle de la société.
2. Rapport spécial du conseil d’administration et du commissaire aux comptes en relation avec les raisons motivant

l’impossibilité d’établir des bilans et des rapports à la date de l’assemblée générale statutaire du 20 mai 2004.

3. Reconstitution entière des organes sociaux.
4. Divers.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

I (03245/535/17) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

BLUE CHIP SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.119. 

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on Wednesday <i>June 30, 2004 at 5.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Board of Directors’ report
2. Auditors’ report
3. Review and approval of the annual accounts as at February 29, 2004
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the Meeting at the registered office of the company.
I (03285/584/21) 

<i>The Board of Directors.

STREAM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.622. 

Par le présent avis, il est notifié aux actionnaires que l’Assemblée Générale Extraordinaire (l’«Assemblée») des ac-

tionnaires de STREAM SICAV (la «Société») qui s’est tenue devant notaire le 5 mai 2004 à 17.00 heures au siège social
de la Société sis à Luxembourg au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, n’a pas pu délibérer valablement sur les
points indiqués à l’ordre du jour du fait que le quorum requis par l’article 67-1 (2) de la loi luxembourgeoise du 1

er

 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée, n’a pas été atteint.

Par le présent avis, il est notifié aux actionnaires qu’une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires de la Société se tiendra au siège social de la Société le <i>30 juin 2004 à 17.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Remplacer au sein de l’Article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») les références à la loi luxembourgeoise du

30 mars 1988 par les références à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 (la «Loi»).

2. Modifier, inter alia, les articles 5, 7, 11, 13, 24, 28, 29 et 36 des Statuts, conformément aux exigences de la Loi et

concernant principalement les points suivants:
- Le capital minimum de la Société sera dorénavant de 1.250.000,- euros.
- Introduction des références à la Partie I de la Loi concernant les restrictions d’investissement.

3. Révocation de Monsieur Sylvain Imperiale de son mandat d’administrateur de la Société.
4. Nomination de nouveaux administrateurs.
5. Divers.

29180

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée pourra délibérer valablement sans condition de présence ou de re-

présentation. Toutes les décisions prises par l’Assemblée conformément aux modifications des Articles des Statuts de-
vront être approuvées par une majorité simple des actions présentes ou représentées.

Tout actionnaire a la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles

sur simple demande au siège social de la Société. Pour être prise en considération à l’Assemblée, une telle procuration
doit être complétée et retournée à la Société par fax au numéro suivant: (352) 26 202 469 puis par courrier à STREAM
SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (à l’attention de Madame Sophie Coccetta), au plus tard le jour ouvrable
bancaire luxembourgeois précédant la date de la tenue de l’Assemblée.

Le texte complet comprenant les modifications des Statuts est disponible au siège social de la Société.
Luxembourg, le 14 juin 2004.

(02900/755/35) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MASTERS CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 44A, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 89.092. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 juin 2004 à 15.00 heures au siège social à Hellange avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nomination statutaire;
5. Divers.

I (03302/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SGBT ESPRIT 2002 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 86.407. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>22 juin 2004 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil de Gérance sur l’exercice 2003-2004;
b. rapport du Conseil de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 6 avril 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Gérants et au Conseil de Surveillance;
f. divers.

II (03005/045/17) 

<i>Le Conseil de Gérance.

FIMACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.011. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 juin 2004 à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

II (00156/660/14) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

29181

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D., boulevard du Contournement.

R. C. Luxembourg B 71.365. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219, Luxembourg, le <i>24 juin 2004 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Approbation de la situation comptable au 30 avril 2004.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Décision sur la continuation de la société sur base de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, telle que modifiée.

6. Nominations statutaires.
7. Divers.

<i>Conditions de quorum, de vote et de participation

Les Actionnaires sont informés que:
1) Conformément à l’article 13 des statuts, toutes les décisions à prendre par les actionnaires en assemblées géné-

rales ordinaires et extraordinaires doivent être prises par 51% au moins des actions émises, sans tenir compte des con-
ditions de quorum de présence et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

2) Les actionnaires peuvent participer et voter en personne ou par mandataire, qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Les modèles de procurations peuvent être obtenus au siège de la société.

3) Afin de participer à l’assemblée générale ordinaire, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer leurs ac-

tions cinq jours ouvrables avant l’assemblée au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, ou auprès du siège de la BAN-
QUE GENERALE DU LUXEMBOURG, ou de toute autre banque.
II (03064/000/30) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2085 Luxemburg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

H. R. Luxemburg B 45.656. 

Einladung an die Anteilinhaber zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

 des RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS (die «Gesellschaft»), die am <i>22. Juni 2004 um 11.00 Uhr in 23,
avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxemburg stattfinden wird, um über die nachfolgenden Tagesordnungspunkte zu
beraten und zu beschließen:

<i>Tagesordnung:

1. Erörterung und Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrates;
2. Erörterung des Berichts des Abschlußprüfers;
3. Vorlage und Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. März 2004 für das Geschäftsjahr 1. April 2003 - 31. März

2004;

4. Beschließung der Gewinnverwendung;
5. Bestätigung der vorläufigen Wahl von Frau Beatrice Zwicky Staub und Herrn Patrik Gisel durch den Verwaltungs-

rat infolge des Rücktritts der Herren Peter Signer und Robert Signer;

6. Entlastung der Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 1. April 2003 - 31. März 2004;
7. Wahl der Verwaltungsräte bis zum Abhalten der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2005;
8. Wahl des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bis zum Abhalten der ordentlichen Generalversammlung im Jahre

2005;

9. Verschiedenes.

Abstimmungen werden mit der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden und abgegebenen Stimmen entschieden.

Ein Anteil berechtigt zu einer Stimme.

Jeder Anteilinhaber kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein an der

ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, können Sie ein Bevollmächtigungsformular am Sitz der Gesellschaft
oder beim Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, Wassergasse 24, Postfach, 9001 St. Gallen, beziehen und bis zum
21. Juni 2004 an obige Adresse per Post/Telefax zurücksenden.
II (03056/755/30) 

<i>Im Namen des Verwaltungsrates.

29182

INDUSTRIAL TRADING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 17.303. 

The Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on <i>5th July 2004 at 11.30 a.m.

<i>Agenda:

1. Dissolution of the Company and subsequent decision to put it into liquidation.
2. Election of Mr Feroz Allana and Mr Shiraz Allana, both of them with professional address at Inside Sharjah Sea Port,

Port Khalid, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates, as Liquidators.

3. Subject to approval of items 1 and 2 the remuneration of the Liquidators be based on usual professional fees and

customary standards, at the expense of the Company.

4. Discharge to the Directors and the Auditor with respect to their mandates for the period until the Company is

put into liquidation.

This meeting is being reconvened considering that the quorum required for the Extraordinary General Meeting of

24th May 2004, with the same agenda was not met, so that this meeting was not regularly constituted and could there-
fore not validly deliberate.
II (02770/521/20) 

<i>By order of the Board of Directors.

DISTRIBUTA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

H. R. Luxemburg B 19.220. 

Die Aktionäre der Gesellschaft DISTRIBUTA S.A. sind gebeten an der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am Gesellschaftssitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, am Donnerstag, den <i>24. Juni 2004
um 10.00 Uhr stattfinden wird, um über die folgende Tagesordnung zu beraten:

<i>Tagesordnung:

1. Verwaltungsbericht und Prüfungsbericht des Aufsichtskommissars.
2. Verabschiedung der Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2003 und Beschlussfassung über die Verwen-

dung der Ergebnisse.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars für das vergangene Geschäftsjahr

2003.

4. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Verschiedenes.

II (01883/503/19) 

<i>Der Verwaltungsrat.

GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Clervaux/Eselborn.

Einladung zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

 am <i>21. Juni 2004 um 12.00 Uhr in Clervaux - Eselborn.

<i>Tagesordnung:

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung sowie wahl des Schriftführers und

Stimmzählers;

2. Präsentation und Feststellung des Berichts des Verwaltungsrats zum Geschäftsjahr 2003;
3. Präsentation und Feststellung der Bilanz zum 31. Dezember 2003;
4. Entlastung des Verwaltungsrates der GOTTSCHOL ALCUILUX S.A. und des Wirtschaftsprüfers KPMG sowie

Neuwahl des Wirtschaftsprüfers;

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2003;
6. Wahl oder Wiederwahl von einem Mitglied des Verwaltungsrats;
7. Verschiedenes.

Clervaux, den 25. Mai 2004.

II (02960/261/21) 

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschrift

29183

CEDEC S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES 

COMMERCIALES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.412. 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>24 juin 2004 à 11.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du réviseur sur l’exercice clos au 31 décembre 2003 et

rapport de révision sur les comptes consolidés de l’exercice 2003.

2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au réviseur.
4. Nomination d’un administrateur additionnel
5. Divers

II (02897/297/17) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

NATALIA FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.509. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>22 juin 2004 à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– nominations statutaires
– divers

II (02967/2046/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JULIUS BAER MULTIFUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.161. 

The shareholders of JULIUS BAER MULTIFUND SICAV (the «Company») are hereby invited to attend an

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held at the registered office of the Company at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg at 2.30 p.m. on <i>22
June 2004.
The extraordinary shareholders meeting will have the following agenda:

<i>Agenda:

a. Change of the denomination of the Company from JULIUS BAER MULTIFUND SICAV in JULIUS BAER MULTI-

FUND.

b. Throughout the articles of incorporation the reference to «law of 30 March 1988» will be replaced by «law of 20

December 2002» and «1988 Law» will be replaced by «Law of 2002».

c. Amendment of Article 5, paragraph 2, as follows:

«The minimum capital of the Company shall be the equivalent in USD of one million two hundred and fifty thousand
Euros (1,250,000.- EUR).»

d. Amendment of Article 5, paragraph 4, as follows:

«Such shares may, as the board of directors shall determine, be of different classes of shares (herein referred to
as «class of shares» or «Sub-Fund») which may, as the board of directors shall determine, be denominated in dif-
ferent currencies and within each such class several categories of shares having specific features, such as distribu-
tion or accumulation shares or shares with specific fee structures or denominated in various currencies may be
issued. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to Article 3 hereof in parts of
open-ended or closed-ended undertakings for collective investment, in transferable securities or in other assets
corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity
or debt securities, as the board of directors shall from time to time determine in respect of each class of shares.»

e. Amendment of Article 10, paragraph 1, as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at
the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of

29184

meeting, every year on the second Tuesday in May at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg,
the general meeting takes place on the following business day in Luxembourg. The annual general meeting may be
held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.»

f. Amendment of Article 11, paragraph 2, as follows:

«Each whole share of whatever class or category and regardless of the net asset value per share within the class
or category is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at
any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax message or in any other form determined by the board of directors.»

g. Amendment of Article 14, paragraph 4 and 6, as follows:

«Any Director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram
or telex or telecopier message or in any other form determined by the board of directors another director as his
proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex or telefax or in any other form
determined by the board of directors.»
«The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors are in attendance
(which may be by way of a telephone conference call or video conference call or in any other form determined by
the board of directors) or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority
of the votes of the Directors present or represented at such meeting. The chairman of the meeting shall not have
a casting vote in any circumstances.»

h. Amendment of Article 16, as follows:

«The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts necessary and useful for accomplishing
the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or these Articles to the general meeting of share-
holders are in the competence of the board of directors.
The board of directors shall, based upon the compliance with the investment restrictions provided for by law, reg-
ulation or resolution of the board of directors and upon the principle of spreading of risks, have, inter alia, the
power to determine the investment policy and investment restrictions applicable to each Sub-Fund.»

i. Amendment of Article 20, paragraph 1, as follows:

«The general meeting of shareholders shall appoint a «réviseur d’entreprises agréé» who shall carry out the duties
prescribed by the Article 113 of the Law of 2002.»

j. Amendment of Article 21, paragraph 3, as follows:

 «The Company, on receiving on any Dealing Day (as this term is defined in the current Prospectus) requests to
redeem Shares amounting to 10 per cent or more of the total number of Shares then in issue in any Sub-Fund shall
not be bound to redeem on any such Dealing Day more than 10% of the number of Shares of any Sub-Fund in issue
on such day. If the Company receives requests on any Dealing Day for redemption of a greater number of Shares,
it may declare that such redemptions are deferred on a pro rata basis to the next following Dealing Day. On such
Dealing Day such requests for redemption will be complied with in priority to later requests.»

k. Amendment of Article 25, paragraph 1, as follows:

«The accounting year of the Company shall begin on the 1st January of each year and shall terminate on the 31st
December.»

This extraordinary shareholders’ meeting will only be able to decide effectively on the agenda if at least 50% of all the

issued shares are present or represented. The agenda will be approved by a resolution adopted by a two-thirds majority
of the shares of the shareholders present or represented at the meeting and who have cast their vote.

Proxy documents for the meeting should be sent to the registered office of the Company at the address given above,

to the attention of Ms Nadine Schaack, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg, (fax: +352 4590 3331) by no later than 18 June 2004. 

The revised and redrafted articles of incorporation are available for inspection at the registered office of the Com-

pany. A copy can be obtained on request.
II (03057/755/77) 

<i>The Board of Directors.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Nicoba S.A.

Agon Finance Holding S.A.

International Sporting Travel S.A.

Aegon International, Sicav

Aegon International, Sicav

European Investment S.A.

AXA World Funds II

AXA World Funds II

AXA World Funds

AXA World Funds

Almatis Holdings, S.à r.l.

Nouvelle Soluger, S.à r.l.

Transports Charles Dugailliez, S.à r.l.

Felten Stein S.A.

Felten Stein S.A.

Voyages Schmit S.A.

Samco S.A.

Samco S.A.

WestAm Compass Fund

WestAm Compass Fund

Oeko-Fonds

RPM Lux Consult S.A.

RPM Lux Consult S.A.

RPM Lux Consult S.A.

RPM Lux Consult S.A.

GeoSat Extended S.A.

Hattrick Lux No. 1, S.à r.l.

Felten Stein S.A.

Inter-Services S.A.

Hattrick Lux No. 4, S.à r.l.

G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l.

G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l.

Moda Brand Holding S.A.

Felten Stein S.A.

Tonrm S.A.

Diffusion de Saedeleer S.A.

Diffusion de Saedeleer S.A.

Jourdan Lux S.A.

Jourdan Lux S.A.

Jourdan Lux S.A.

Holm Trading Holding S.A.

Banca Antoniana - Popolare Veneta, Luxembourg Branch

Banca Antoniana - Popolare Veneta, Luxembourg Branch

Banca Antoniana - Popolare Veneta, Luxembourg Branch

Intourist S.A.

Intourist S.A.

Electra Participations S.A.

Tennis Club de la Commune de Contern, A.s.b.l.

Vulcalux, S.à r.l.

Hahnemann S.A.

KAP Global Publishers S.A.

Phelane S.A.

TLGB Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Distributrade Holding S.A.

Ecoterres Luxembourg S.A.

S.D.G.A. Holding S.A.

Euro-Capital S.A.

Fiparmo S.A.

Mirko Capital Finance S.A.

Delco International S.A.H.

Benelux Holding Company S.A.

Athinea S.A.

SVMO S.A., Société de Vente de Machines Outils

Arab Horses Investment Company Holding S.A.

Interstyle Holding S.A.

SCG STE Maurice 2, S.à r.l.

EurOptic Express S.A.

Comer Group S.A.

Verica, S.à r.l.

Green Management S.A.

Hattrick Lux No. 2, S.à r.l.

Airfreight Development Worldwide S.A.

West Africa Growth Fund

Oracle Properties S.A.

XMTCH (Lux)

Leisure Holding S.A.

European Business Management S.A.

Santa Maura S.A.

Blue Chip Selection

Stream Sicav

Masters Consulting

SGBT Esprit 2002 S.C.A.

Fimaco S.A.

Vitrum Lux S.A.

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds

Industrial Trading Corporation S.A.

Distributa S.A.

Gottschol Alcuilux S.A.

CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Développement d’Entreprises Commerciales

Natalia Fin S.A.

Julius Baer Multifund Sicav