This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
28561
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 596
10 juin 2004
S O M M A I R E
A Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28593
GTECH Global Services Corporation Limited S.A.,
ADD Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28576
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28562
Apollo Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28586
Hasi Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28585
Architon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28595
Immobilière Parc Everlange S.A., Erpeldange/
Bersabee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28592
Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28590
Blue Lion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28598
Immoline, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28581
Blue Lion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28598
Laperle S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28582
Bombardier Luxembourg Investments S.A., Müns-
Launer International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
28576
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28592
Littoral Côte d’Azur S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
28602
Bul-Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28601
Markets Informations Virtual Exchange S.A., Lu-
Columeta, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
28605
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28587
Compagnie de Gneis et Gabro S.A., Luxembourg .
28585
Northern Neft Investments, S.à r.l., Luxembourg
28579
Comptaplus S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28584
Northern Neft Investments, S.à r.l., Luxembourg
28579
Dalyan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28584
Northern Neft Investments, S.à r.l., Luxembourg
28579
Dalyan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28584
Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28606
Dalyan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28584
Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28608
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.,
Predicai Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28581
Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28585
Predicai Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28581
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . .
28586
Premier Cru International N.V. S.A., Luxembourg
28580
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . .
28586
(The) Private Equity Company S.A., Luxembourg
28580
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . .
28587
Provincial Capital Investment, S.à r.l., Luxem-
Dictame Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28579
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28583
Européenne de Conseils S.A., Luxembourg . . . . . .
28583
Provincial Capital Investment, S.à r.l., Luxem-
Eurowatt, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
28588
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28583
Eximp Roger Greden, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
28588
Provincial Capital Investment, S.à r.l., Luxem-
F.I.B. S.A., First International Broker, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28583
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28586
Prudential International Funds, Sicav, Luxem-
Fausis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28589
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28581
Fausis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28589
REC Real Estate Company S.A., Luxembourg . . .
28599
Fomaxx, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28582
Sea Bird Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
28605
FRS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28585
Sidarta Finance Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . .
28582
Francistown S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28595
Sidarta Finance Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . .
28582
Francistown S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28595
Sidfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28580
Full Services Engineering S.A., Tétange . . . . . . . . .
28596
Sports et Loisirs Concept S.A., Senningerberg . . .
28599
Giochi Preziosi Lussemburgo S.A., Luxembourg . .
28589
Systèmes Technologiques Industriels (S.T.I.) S.A.,
Globe Total Investments Holdings S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28589
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28602
Tallman Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28601
Griko Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28600
Tallman Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28601
Griko Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28601
Ter-Prom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28608
Groupe A.O.H., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28584
Total Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .
28588
GTECH Global Services Corporation Limited (Lu-
Total Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .
28588
xembourg branch) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28562
28562
GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED (LUXEMBOURG BRANCH),
Société Anonyme.
Siège social: Chypre, 27, Gregory Afxentiou Street 6021 Larnaca.
Succursale: L-8009 Strassen, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.171.
—
Le 18 mars 2004, le conseil d’administration de la société anonyme de droit chypriote GTECH GLOBAL SERVICES
CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à Chypre, 27, Gregory Afxentiou Street, 6021, Larnaca enregistrée
au registre de commerce de Chypre sous le numéro 100649, a décidé la création d’une succursale à Luxembourg.
La société GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED est représentée par son conseil d’administration
composé de quatre membres
- W. Bruce Turner;
- Jaymin B. Patel;
- Annita Papakyriacou;
- Christodoulos G. Pelaghias.
M. Philip Anteunis est en charge de la gestion journalière de la société.
La société GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED est engagée par la signature d’un administrateur,
respectivement par la signature du délégué à la gestion journalière dans les limites de la gestion journalière.
La succursale, dénommée GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED (LUXEMBOURG BRANCH), est
établie au 47, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
La succursale a pour activité la prestation de services dans les domaines des technologies de l’information, qu’il s’agis-
se des systèmes ou des équipements, ainsi que dans tous domaines y relatifs, ce qui inclut notamment la gestion de base
de données, la gestion et la transmission de données électroniques, le développement, l’installation et la maintenance
de logiciels, le développement, l’installation, la gestion, la maintenance et l’intégration de systèmes, la réparation des
équipements et les services d’assistance «hotline» ainsi que tous autres services connexes.
Le gérant de la succursale est Monsieur Francesco Cecchini, né le 6 mars 1965, à Paris (France), domicilié au 10, Al-
lerton Drive, LE-3 9EG Leceister, Royaume-Uni.
Le gérant de la succursale est autorisé et habilité à représenter la succursale dans toutes ses activités au Luxembourg
devant toutes autorités politiques, administratives et judiciaires et devant toutes personnes physiques et morales, avec
tous les pouvoirs que la société GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED aurait si elle était effective-
ment présente au Luxembourg.
Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs décrits ci-dessus, le gérant a un pouvoir de signature individuel.
Néanmoins lorsque les montants excèdent la somme de 6.000,- euros (à l’exception du paiement des salaires où le
plafond est porté à 18.000,- euros), la société ne sera engagée que par la signature conjointe du gérant et de tous autres
administrateurs de la société ou représentants de la société à qui un pouvoir de signature aura été délégué à l’exception
des salaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu’au Registre de
Commerce et des Sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00134. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031140.3/280/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.
GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED, (Luxembourg Branch), Société Anonyme.
Registered office: Chypre, 27, Gregory Afxentiou Street, 6021 Larnaca.
Adress of the Luxembourg Branch: L-8009 Strassen, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.649.
—
<i>Memorandum of association of GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITEDi>
1. The name of the Company is:
GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED
2. The registered office of the Company shall be in Cyprus.
3. The objects for which the Company is incorporated are:
(1) To carry on either alone or jointly with others anywhere in the world (and whether in a «free zone area», bonded
area or elsewhere), business and activities including the purchase, sale, lease and general management of vessels and
aircraft of all types as well as the business or the activities of business and general consultants, financiers, manufacturers,
processors, dealers, importers, exporters, suppliers, distributors, buyers, sellers of any kind of goods materials, mer-
chandise or things of any nature, as well as the business of merchants in general, carriers by any means of transportation,
agents on commission or otherwise, and agents in general.
(2) To carry on the business of investment advisers and to act as promoters and entrepreneurs and to carry on the
business of financiers, capitalists, concessionaires, merchants, brokers, traders, dealers, agents, importers and exporters
and to undertake and carry on and execute all types of investment, financial, commercial, mercantile, trading and other
operations.
(3) To undertake any and all such other business activities which the Directors of the Company shall determine to
be incidental or related to any of the foregoing.
Luxembourg, le 31 mars 2004.
Signature.
28563
(4) To enter into contracts, agreements or arrangements with other companies, legal or natural person or persons
of any description, for lawful consideration and to carry out in the name of said persons any activity which is related to
the objects of the Company.
(5) To borrow, procure credit facilities of any kind for the purpose of the business of the Company, and to do so
individually or jointly and severally with any other company or companies, and to use the monies from such loans or
credit facilities in whole or in part for the benefit of the Company or the benefit of any other company or companies.
(6) To issue, accept, countersign, prepay and execute promissory notes, bills of exchange and other negotiable in-
struments, payable «to the order of» or «to bearer».
(7) To purchase, take upon lease or in exchange, rent or otherwise obtain, use and possess or mortgage, sell, donate
or otherwise alienate any property or any interests, any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, ma-
chinery, patents, installations, goods or other movable or immovable property of any kind.
(8)To carry on all types of estates business, that is, the acquisition of immovable property of any type and description
by purchase, rent, exchange, donation, or any other manner, and to develop and to undertake construction on same of
all types of buildings and to lease, enter into cash or credit sale, as well as to exploit or dispose of the above in any
manner whatever, including by donation, lease, cash sale or credit sale, the exploitation and disposal of same in any way
including by donation.
(9) To purchase or in any way acquire, construct, maintain, improve, adapt any offices, laboratories, installations, fac-
tories, machinery and other things which may be considered necessary or useful for the purposes of the Company in
Cyprus or abroad.
(10) To carry on any other trade or business whatsoever, which can in the opinion of the Board of Directors be
advantageously carried on in connection with or ancillary to any of the businesses of the Company.
(11) To purchase, or by any other means acquire, possess, register, protect and renew in any part of the world, any
patents, patent rights, brevets d’ invention, licenses, secret processes, trade marks, designs, licenses and concessions,
brands, chemical formulas, and other similar things and to sell, exchange, grant licenses or alter, modify, or improve the
same as the Company may from time to time decide.
(12) To carry on or undertake the whole or any part of the business, goodwill and assets of any person, firm or com-
pany carrying on or proposing to carry on any of the business which the Company is authorized to carry on, and as part
of the consideration for such acquisition, to undertake all or any of the liabilities of such person, firm or company or to
acquire an interest in, amalgamate with or enter into partnership or other arrangement for sharing profits or for-co-
operation or for mutual assistance with any such person, firm or company or for subsidizing or otherwise assisting any
such person, firm or company and to give or accept by way of consideration for any of the acts or things aforesaid or
property acquired, any shares, debentures, debenture stock or securities that may be agreed upon and to hold and re-
tain, or sell, mortgage and deal with any shares, debentures, stock, or securities so received.
(13) To improve, manage, construct, repair, develop, exchange, let on lease or otherwise mortgage, charge, sell, dis-
pose of, turn to account, grant licenses, options, rights and privileges in respect of the property of the Company, or
otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company.
(14) To invest and deal with the monies of the Company not immediately required in such manner as may from time
to time be determined and to hold or otherwise deal with any investments made.
(15) To borrow and raise money in any manner and without any restriction and to secure the repayment of any mon-
ey borrowed, raised or owing by mortgage, charge or any other security upon the whole or any part of the company’s
property or assets (whether present or future) including its uncalled capital and also by a similar mortgage, charge or
security to secure and guarantee the performance by the Company of any obligation or liability it may undertake or
which may become binding on it.
(16) To draw, make, accept, endorse, discount, negotiate, execute and issue cheques, bills of exchange, promissory
notes, bills of lading, warrants, debentures and other negotiable or transferable instruments.
(17) To apply for, promote and obtain the enactment or issuance of any law, order or license by any appropriate
authority, which shall enable the Company to further any of its objects, or to modify any of the Company’s articles of
association, or for any other purpose which might directly or indirectly promote the company’s interests, and to oppose
any proceeding or application which might directly or indirectly prejudice the Company’s interests.
(18) To enter into any arrangements with any government or authority, national, municipal, local or otherwise,
whether in Cyprus or abroad, that may seem conducive to the attainment of the Company’s objects or to any of them,
and to obtain from any such government or authority any charters, decrees, rights or privileges which the company may
deem desirable, and to carry out, exercise and comply with any such charters, decrees, rights and privileges.
(19) To subscribe for, take, purchase or otherwise acquire, hold, sell, deal with and dispose of shares, stocks, deben-
tures, debenture stock, bonds, obligations or securities issued or guaranteed by any other company constituted or car-
rying on business in any part of the world, as well as debentures, stocks, bonds, obligations or securities issued or
guaranteed by any government or authority, municipal, local or otherwise in any part of the world.
(20) To control, manage, finance, subsidize, coordinate or otherwise assist any company or companies in which the
Company has a direct or indirect financial interest, to provide secretarial, administrative, technical, commercial and oth-
er services and facilities of all kinds for any such company or companies and to make payments by way of subsidy or
otherwise, and any other arrangement which may seem desirable with respect to any business or operations of, or gen-
erally with respect to, any such company or companies.
(21) To promote any other company for the purpose of acquiring the whole or any part of the business or property
or undertaking or any of the liabilities of such company, or for the purpose of undertaking any business or operations
which may appear likely to assist or benefit the Company or for the purpose of enhancing the value of any property or
28564
business of the Company and to place or guarantee the placing of, underwrite, subscribe for or otherwise acquire all or
any part of the shares or securities of any such company as aforesaid.
(22) To sell or otherwise dispose of the whole or any part of the business or property of the Company, either to-
gether or in portions, for such consideration as the Company may think fit, and in particular in consideration of shares,
debentures, or securities of any purchasing company.
(23) To act as agents, or brokers, and as trustees, for any person, firm or company, and to undertake and perform
sub-contracts.
(24) To remunerate any person, firm or company rendering services to the Company either by cash payment or by
the allotment to such person, firm or company of shares or other securities of the Company credited as paid in full or
in part or otherwise as may be thought expedient.
(25) To pay all or any expenses incurred in connection with the promotion, formation and incorporation of the Com-
pany, or to contract with any person, firm or company to pay the same, and to pay commissions to brokers and others
for underwriting, placing, selling, or guaranteeing the subscription of any shares or other securities of the Company.
(26) To provide for the welfare of officers or of persons in the employment of the company, or formerly in the em-
ployment of the company or its predecessors in business or officers or employees of any subsidiary or associated or
allied company, of this company, and the wives, widows, dependents and families of such persons, by grants of money,
pensions or other payments, (including payments of insurance premia) and to form, subscribe to, or otherwise aid, any
trust, fund or scheme for the benefit of such persons, and any benevolent, religious, scientific, national or other institu-
tion or object of any kind, which shall have any moral or other claims to support or aid, by the company by reason of
the nature or the locality of its operations or otherwise.
(27) To distribute among the Members of the Company in kind any property of the Company of whatever nature.
(28) To cause the Company to be registered or recognized in any part of the world.
(29) To do all or any of the things or matters aforesaid, in any part of the world, either as principals, agents, contrac-
tors or otherwise, and by or through agents, brokers, sub-contractors or otherwise and either alone or in conjunction
with others.
(30) To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the Company’s ob-
jects.
Notwithstanding the foregoing objects, powers and other provisions the Company: (a) shall not provide any financial
services other than to its shareholders or bodies corporate in its group of companies (for the purposes hereof the term
«financial services» means dealing in investments, managing investments, giving investment advice or establishing and op-
erating collective investment schemes, and the term «investments» means shares, debentures, government and public
securities, warrants, certificates representing securities, units in collective investment schemes, options, futures and
contracts for differences); and (b) shall not assume directly or indirectly, any obligations to the public, whether in the
form of deposits, securities or other evidence of debt (for the purposes hereof the term «public» does not include bank-
ing or credit institutions, the company’s shareholders or bodies corporate in the company’s own group of companies,
and the term «deposits» does not include sums of money received on terms which are referable to the provision of
goods or services other than «financial services» as defined above, and the term «debt» does not include credit obtained
in relation to the provision of goods or services).
It is understood that notwithstanding anything above contained all the business of the Company shall be carried out
outside Cyprus.
The foregoing provisions notwithstanding, nothing herein contained shall prevent the directors of the company and
the place where such non-Cyprus business is conducted, from being located on Cyprus.
The objects set forth in each sub-clause of this clause shall not be restrictively construed but the widest interpretation
shall be given thereto, and they shall not, except when the context expressly so requires, be in any way limited or re-
stricted by reference to or inference from any other object or objects set forth in such sub-clause or from the terms
of any another sub-clause or from the name of the Company. None of such sub-clause or the object or objects therein
specified or the powers thereby conferred shall be deemed subsidiary or ancillary to the objects or powers mentioned
in any other sub-clause but shall be considered as separate and distinct objects.
The word «company» in this clause except where used in reference to the Company shall be deemed to include any
partnership or other body of persons and whether incorporated or unincorporated and whether domiciled in Cyprus
or elsewhere.
4. The liability of the members is limited.
5. The share capital of the Company is Twenty Thousand United States Dollars (USD 20,000) divided into Ten Thou-
sand Ordinary Shares of USD 2 each.
It has been increased to USD 17,527,636 by ordinary res. (3/12/03).
It has been increased to USD 30,238,394 by ordinary res. (2/2/04)
The Regulations contained in Part 1 of Table A of the First Schedule of the Companies Law Cap. 113, shall not apply
to the Company. Unless otherwise indicated by this instrument, the following shall constitute the Regulations of the
Company.
<i>Articles of Associationi>
The Regulations contained in Part 1 of Table A of the first Schedule of the Companies Law Cap. 113, shall not apply
to the Company. Unless otherwise indicated by this instrument, the following shall constitute the Regulations of the
Company.
Interpretation
1. In these Regulations:
«Cyprus» means the Republic of Cyprus;
28565
«the Law» means the Companies Law, Cap. 113, as well as any changes or modifications thereof;
«the seal» means the common seal of the company;
«secretary» means any person appointed to perform the duties of the secretary of the company;
«the Managing Director» means any person appointed to perform the duties of the chief executive officer of the
Company;
«any agreement validly existing among the members» means any agreement entered into between the members of
the Company, prior or subsequent to the formation of the Company, or their participation therein, together with any
and all amendments of said agreement as made from time to time.
Expressions referring to writing shall, unless the contrary intention appears, be construed as including references to
printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words in a visible form.
Unless the content otherwise requires, words or expressions contained in these Regulations shall bear the same
meaning as in the Law or any statutory modification thereof in force at the date at which these Regulations become
binding on the company.
Introductory Provisions
2. The Company is a private company and therefor:
(a) The right of transfer of the shares of the Company shall be restricted in the manner hereinbelow set forth;
(b) The number of members of the Company (not including the persons who are in the service of the Company, and
also the persons who, having previously been in the service of the Company, were during their service and continued
after the end of such service to be members of the Company) shall be limited to fifty (50) only, provided that for the
purpose of this provision, where two or more persons hold together one or more shares of the Company they shall
be considered as a single member;
(c) Any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company shall be prohibited;
(d) The Company shall not have the right to issue share warrants to bearer.
Share Capital and Variation of Rights
3. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares,
any share in the company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions,
whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the company, subject to the provisions of any
agreement validly existing among the members, may from time to time by ordinary resolution determine.
4. Subject to the provisions of section 57 of the Law, any preference shares may, with the sanction of an ordinary
resolution, be issued on the terms that they are, or at the option of the company are liable, to be redeemed on such
terms and in such manner as the company before the issue of the shares may by special resolution determine.
5. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless
otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, whether or not the company is being wound
up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the
sanction of an extraordinary resolution passed at a separate General Meeting of the holders of the shares of the class.
To every such separate General Meeting the provisions of these Regulations relating to General Meetings shall apply.
6. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not,
unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the
creation or issue of further shares taking pari passu therewith.
7. The company may exercise the powers of paying commissions conferred by section 52 of the Law, provided that
the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required
by the said section and the rate of the commission shall not exceed the rate of 10 per cent of the price at which the
shares in respect whereof the same is paid are issued or an amount equal to 10 per cent of such price (as the case may
be). Such commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in
one way and partly in the other. The company may also on any issue of shares pay such brokerage as may be lawful.
8. Except as required by law, no person shall be recognized by the company as holding any share upon any trust, and
the company shall not be bound by or be compelled in any way to recognize (even when having notice thereof) any
equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except
only as by these Regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute
right to the entirety thereof in the registered holder.
9. Irrespective of any provision of any foregoing Regulation, but always subject to the provisions of Article 112 of the
Law, the Company may, if it so desires and if this is duly notified to it in writing, to recognize the existence of any trust
on any share, although such trust cannot be registered in the Register of Members of the Company. Such recognition
by the Company is communicated by letter to the trustees, and shall be irrevocable for as long as such trust shall con-
tinue to exist, even though the trustees or any of their number shall have been replaced.
10. Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled without payment
to receive within two months after allotment or lodgment of transfer (or within such other period as the conditions of
issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon pay-
ment, for every certificate after the first of such sum as the Directors shall from time to time determine. Every certificate
shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon. Provided that in
respect of a share or shares held jointly by several persons the company shall not be bound to issue more than one
certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such
holders.
11. If a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of a fee and on such terms (if
any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the company of investigating evidence
as the Directors think fit.
28566
12. The company shall not give, whether directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the pro-
vision of security or otherwise, any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or subscrip-
tion made or to be made by any person of or for any shares in the company or in its holding company nor shall the
company make a loan for any purpose whatsoever on the security of its shares or those of its holding company, but
nothing in this Regulation shall prohibit transactions mentioned in the proviso to section 53 (1) of the Law.
13. All the surplus shares which were authorized to be issued will be offered to the members in such manner as shall
be in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members.
Lien
14. The company shall have a first and paramount lien on every share (not being a fully paid share) for all moneys
(whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share, and the company shall also
have a first and paramount lien on all shares (other than fully paid shares) standing registered in the name of a single
person for all moneys presently payable by him or his estate to the company; but the Directors may at any time declare
any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this Regulation. The company’s lien, if any, on a share
shall extend to all dividends payable thereon.
15. The company may sell, in such manner as the Directors think fit and subject to the terms of any agreement validly
existing among the members, any shares on which the company has a lien, but no sale shall be made unless a sum in
respect of which the lien exists is presently payable, nor until the expiration of fourteen days after a notice in writing,
stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has
been given to the registered holder for the time being of the share, or the person entitled thereto by reason of his death
or bankruptcy.
16. To give effect to any such sale the Directors may authorize some person to transfer the shares sold to the pur-
chaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer, and he
shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any
irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.
17. The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in
respect of which the lien exists as is presently payable, and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not
presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of
the sale.
18. Other provisions of the Regulations not withstanding, no share shall be given by a member as security or guaran-
tees for a loan, debt or undertaking, without the approval of the Directors, and the Directors shall refuse to register
or acknowledge any such security or guarantee which shall have been in violation of the said Regulation and which shall
be void as against the Company, except as otherwise provided by the law.
Calls on Shares
19. The Directors may from time to time make calls upon the members in respect of any moneys unpaid on their
shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of
allotment thereof made payable at fixed times, and each member shall (subject to receiving at least fourteen days’ notice
specifying the time or times and place of payment) pay to the company at the time or times and place so specified the
amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine.
20. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorizing the call
was passed and may be required to be paid by instalments.
21. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
22. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person
from whom the sum is due shall pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of
actual payment at such rate not exceeding 5 per cent per annum as the Directors may determine, but the Directors
shall be at liberty to waive payment of such interest wholly or in part.
23. Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on
account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these Regulations be deemed
to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue the same becomes payable, and in case
of non-payment all the relevant provisions of these Regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or
otherwise shall apply as if such had become payable by virtue of a call duly made and notified.
24. The Directors may, on the issue of shares, differentiate between the holders as to the amount of calls to be paid
and the times of payment.
25. The Directors may, if they think fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the
moneys uncalled and unpaid upon any shares held by him, and upon all or any of the moneys so advanced may (until the
same would, but for such advance, become payable) pay interest at such rate not exceeding (unless the company in
General Meeting shall otherwise direct) 5 per cent per annum, as may be agreed upon between the Directors and the
member paying such sum in advance.
Transfer of Shares
26. The instrument of transfer of any share shall be executed by or on behalf of the transferor and transferee, and
the transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register
of members in respect thereof.
27. Subject to such of the restrictions of these Regulations as may be applicable and the terms of any agreement validly
existing among the members, any member may transfer all or any of his shares by instrument in writing in any usual or
common form or any other form which the Directors may approve.
28. The Directors, subject to the terms of any agreement validly existing among the members, including but without
limitation any restrictions on the transfer of shares and any rights of first refusal, may refuse to register the transfer of
28567
any share to any person, irrespective of the fact that such share is fully paid or not, and furthermore the Directors may
refuse the transfer of a share on which the Company has a lien.
29. The Directors, subject to any agreement validly existing among the members, may also decline to recognize any
instrument of transfer unless:
(a) a nominal fee in a sum as the Directors may from time to time require is paid to the Company in respect thereof,
(b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evi-
dence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and
(c) the instrument of transfer is in respect of only one class of share.
30. If the Directors refuse to register a transfer they shall within two months after the date on which the transfer
was lodged with the company send to the transferee notice of the refusal.
31. The registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Directors may from
time to time determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than thirty days in any
year.
32. The company shall be entitled to charge a nominal fee, on the registration of every probate, letters of adminis-
tration, certificate of death or marriage, power of attorney, or other instrument.
Transmission of Shares
33. Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member may, upon such
evidence being produced as may from time to time properly be required by the Directors and subject as hereinafter
provided, elect either to be registered himself as holder of the share or to have some person nominated by him regis-
tered as the transferee thereof, but the Directors shall, in either case, have the same right to decline or suspend regis-
tration as they would have had in the case of a transfer of the share by that member before his death or bankruptcy, as
the case may be.
34. If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself, he shall deliver or send to the company a
notice in writing signed by him stating that he so elects. If he shall elect to have another person registered he shall testify
his election by executing to that persona transfer of the share. All the limitations, restrictions and provisions of these
Regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such
notice or transfer as aforesaid as if the death or bankruptcy of the member had not occurred and the notice or transfer
were a transfer signed by that member.
35. A person becoming entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of the holder shall be entitled to the
same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except
that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise
any right conferred by membership in relation to meetings of the company.
Provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be reg-
istered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days the Directors may
thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share until the require-
ments of the notice have been complied with.
Forfeiture of Shares
36. If a member fails to pay any call or instalment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors
may, at any time thereafter during such times as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him
requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.
37. The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen days from the date of service of
the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of
non-payment at or before the time appointed the shares in respect of which the call was made will be liable to be for-
feited.
38. If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice
has been given may at any time, thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by
a resolution of the Directors to that effect.
39. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such, manner as is consistent with
the provisions of any agreement validly existing among the members.
40. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but
shall, notwithstanding, remain liable to pay to the company all moneys which, at the date of forfeiture, were payable by
him to the company in respect of the shares, but his liability shall cease if and when the company shall have received
payment in full of all such moneys in respect of the shares.
41. A statutory declaration in writing that the declarant is a Director or the secretary of the company, and that a
share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts
therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share. The company may receive the consideration, if
any, given for the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favor of the person
to whom the share is sold or disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of the share, and shall not
be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any ir-
regularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.
42. The provisions of these Regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by
the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or
by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.
28568
Conversion of Shares into Stock
43. The company may by ordinary resolution convert any paid-up shares into stock, and reconvert any stock into
paid-up shares of any denomination.
44. The holders of stock may transfer the same, or any part thereof, in the same manner, and subject to the same
Regulations, as and subject to which the shares from which the stock arose might previously to conversion have been
transferred, or as near thereto as circumstances admit; and the Directors may from time to time fix the minimum
amount of stock transferable but so that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which
the stock arose.
45. The holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and
advantages as regards dividends, voting at meetings of the company and other matters as if they held the shares from
which the stock arose, but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the com-
pany and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares,
have conferred that privilege or advantage.
46. Such of the Regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock, and the words
«share» and «shareholder» therein shall include «stock» and «stockholder».
Alteration of Capital
47. The company may from time to time by ordinary resolution increase the share capital by such sum to be divided
into shares of such amount, as the resolution shall prescribe.
48. The company may by ordinary resolution:
(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(b) subdivide its existing shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum of
association subject, nevertheless, to the provisions of section 60 (1) (d) of the Law;
(c) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken
by any person.
49. The company may by special resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve fund or any share
premium account in any manner and with, and subject to, any incident authorized, and consent required, by law.
General Meeting
50. The company shall in each year hold a General Meeting as its annual General Meeting in addition to any other
meetings in that year, and shall specify the meeting as such in the notices calling it; and not more than fifteen months
shall elapse between the date of one annual General Meeting of the company and that of the next. Provided that so long
as the company holds its first annual General Meeting within eighteen months of its incorporation, it need not hold it in
the year of its incorporation or in the following year. The annual General Meeting shall be held at such time and place
as the Directors shall appoint.
51. All General Meetings other than annual General Meetings shall be called Extraordinary General Meetings.
52. The Directors may, whenever they think fit, convene an Extraordinary General Meeting, and Extraordinary Gen-
eral Meeting shall also be convened on such requisition, or, in default, may be convened by such requisitionists, as pro-
vided by section 126 of the Law, and the terms of any agreement validly existing among the members.
Notice of General Meetings
53. An annual General Meeting and a meeting called for the passing of a special resolution shall be called by twenty-
one days’ notice in writing at the least, and a meeting of the company other than an annual General Meeting or a Meeting
for the passing of a special resolution shall be called by fourteen days’ notice in writing at the least. The notice shall be
exclusive of the day-on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given, and shall specify
the place, the day and the hour of meeting and, in case of special business, the general nature of that business, and shall
be given, in manner hereinafter mentioned or in such other manner, if any, as may be prescribed by the company in
General Meeting, to such persons as are, under the Regulations of the company, entitled to receive such notices from
the company.
Provided that a meeting of the company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in
this Regulation, be deemed to have been duly called if it is so agreed.
(a) in the case of a meeting called as the annual General Meeting, by all the members entitled to attend and vote
thereat; and
(b) in the case of any other meeting, by a majority in number of the members having a right to attend and vote at the
meeting, being a majority together holding not less than 95 per cent in nominal value of the shares giving that right.
54. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person
entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.
Proceedings at General Meetings
55. All business shall be deemed special that is transacted at an Extraordinary General Meeting, and also all that is
transacted at an annual General Meeting, with the exception of declaring a dividend, the consideration of the accounts,
balance sheets, and the reports of the Directors and auditors, the election of Directors in the place of those retiring
and the appointment of, and the fixing of the remuneration of, the auditors.
56. No business shall be transacted at Annual General Meetings, or Extraordinary General Meetings, unless a quorum
consisting of all of the issued voting share capital of the Company is present or represented by proxy at such meeting.
57. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened
upon the requisition of members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the same day in the
next week, at the same time and place or to such other day and at such other time and place as the Directors may
28569
determine, and if at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the
meeting, the members present shall be a quorum.
58. The Chairman, if any, of the board of Directors shall preside as Chairman at every General Meeting of the com-
pany, or if there is no such Chairman, or if he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for
the holding of the meeting or is unwilling to act the Directors present shall elect one of their number to be Chairman
of the meeting, in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members. The Chairman shall
have no veto rights and no tiebreaking voting power with respect to any matter arising in the General Meeting.
59. If at any meeting no Director is willing to act as Chairman or if no Director is present within fifteen minutes after
the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their number to be Chairman of
the meeting.
60. The Chairman shall pursuant to a resolution adopted by the affirmative vote of members representing at least
51% of the issued voting share capital in attendance at any meeting at which a quorum is present, adjourn the meeting
from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the
business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty
days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Save as aforesaid it
shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.
61. At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a
poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded:
(a) by the Chairman; or
(b) by at least two members present in person or by proxy; or
(c) by any member or members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total
voting rights of all the members having the right to vote at the meeting; or
(d) by a member or members holding shares in the company conferring a right to vote at the meeting being shares
on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid on all the shares
conferring that right.
Unless a poll be so demanded a declaration by the Chairman that a resolution has on a show of hands been carried
or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book containing the minutes
of the proceedings of the company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion
of the votes recorded in favor of or against such resolution. The demand for a poll may be withdrawn.
62. Where a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as the Chairman directs, and the result of the poll
shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
63. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which
the show of hands takes place or at which the poll is demanded, shall not be entitled to a second or casting vote.
64. A poll demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll
demanded on any other question shall be taken at such time as the Chairman of the meeting directs, and any business
other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with pending the taking of the poll.
65. Subject to the relevant provisions of the Law, a resolution in writing, signed by all the members at such time being
entitled to receive notice and who are entitled to attend and vote at General Meetings -or in the case of a corporate
entity by its duly authorized representative -such resolution in writing shall be as valid and effectual as if it had been
passed at a General Meeting of the Company duly convened and held.
Votes of Members
66. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of
hands every member present in person shall have one vote, and on a poll every member shall have one vote for each
share of which he is the holder.
67. In the case of joint holders the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be
accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders; and for this purpose seniority shall be determined by
the order in which the names stand in the register of members.
68. A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in
lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by the administrator of his property, his committee, receiver,
curator bonis, or other person in the nature of an administrator, committee, receiver or curator bonis appointed by
that Court, and any such administrator, committee, receiver, curator bonis or other person may, on a poll, vote by
proxy.
69. No member shall be entitled to vote at any General Meeting unless all calls or other sums presently payable by
him in respect of shares in the company have been paid.
70. No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which
the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such meetings shall be valid for all purposes.
Any such objection made in due time shall be referred to the Chairman of the meeting, whose decision shall be final and
conclusive.
71. On a poll votes may be given either personally or by proxy.
72. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly
authorized in writing, or, if the appointer is a corporation, either under seal, or under the hand of an officer or attorney
duly authorized. A proxy need not be a member of the company.
73. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed
or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the registered office of the company or at
such other place as is specified for that purpose in the notice convening the meeting, at any time prior to the time set
for holding the meeting or adjourned meeting, at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in
28570
the case of a poll, at any time prior to the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of
proxy shall not be treated as valid.
74. An instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit
«GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED.
I/We......, of...... being a member/members of the above named company, hereby appoint ........ of....... or failing him
of....., as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the [annual or extraordinary, as the case may be] General
Meeting of the company, to be held on the day of ......19... , and at any adjournment thereof.
Signed this........ day of..... ,19..».
75. Where it is desired to afford members an opportunity of voting for or against a resolution the instrument ap-
pointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit
«GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED.
I/We......, of...... being a member/members of the above named company, hereby appoint ........ of....... or failing him
of....., as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the [annual or extraordinary, as the case may be] General
Meeting of the company, to be held on the day of ......19... , and at any adjournment thereof.
Signed this........ day of..... ,19...
This form is to be used in favor of*/against the resolution. Unless otherwise instructed, the proxy will vote as he
thinks fit.
*Strike out whichever is not desired».
76. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.
77. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous
death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy is given, provided
that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer as aforesaid shall have been received by the
company at the office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.
78. Each member shall not be allowed to appoint more than one proxy to attend on the same occasion.
Corporations acting by Representatives at Meetings
79. Any corporation or other entity which is a member of the company may by resolution of its Directors or other
legal governing body authorize such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the company or
of any class of members of the company, and the person so authorized shall be entitled to exercise the same powers
on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual member of
the company.
Directors
80. The number of the Directors and the names of the first Directors shall be determined in writing by the subscrib-
ers of the memorandum of association.
81. The increase or decrease in the number of Directors, the level of their remuneration if any, their shareholding
qualification if any, and any and all other terms and conditions of service of the Directors shall be determined by the
Company from time to time in General Meeting by ordinary resolution, in accordance with the provisions of any agree-
ment validly existing among the members.
82. A Director of the company may be or become a Director or other officer of, or otherwise interested in, any
company promoted by the company or in which the company may be interested as shareholder or otherwise, and no
such Director shall be accountable to the company for any remuneration or other benefits received by him as a Director
or officer of, or from his interest in, such other company unless the company otherwise direct.
Borrowing Powers
83. The Directors may exercise all the powers of the company to borrow money, and to charge or mortgage its
undertaking, property and uncalled capital, or any part thereof, and to issue debentures, debenture stock, and other
securities whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the company or of any third party.
Powers and Duties of Directors
84. The business of the company shall be managed by the Directors, who may pay all expenses incurred in promoting
and registering the company, and may exercise all such powers of the company as are not, by the Law or by these Reg-
ulations or by the terms of any agreement validly existing among the members required to be exercised by the company
in General Meeting.
85. The Directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any company, firm or person
or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the attorney or attorneys of the
company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exer-
cisable by the Directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think
fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing
with any such attorney as the Directors may think fit and may also authorize any such attorney to delegate all or any of
the powers, authorities and discretions vested in him.
86. Any field or type of work which the Company is authorized to undertake either expressly or by implication by
the Memorandum and Articles of Association or the Regulations hereunder, may be undertaken by the Directors at
such a time or as they would think suitable, and furthermore said Directors may cause such work to remain in abeyance,
whether or not said work shall have been commenced as long as said Directors shall determine that such work should
not be commenced or should not be continued.
87. The company may exercise the powers conferred by section 36 of the Law with regards to having an official seal
for use abroad, and such powers shall be vested in the Directors.
28571
88. (a) A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract
with the company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Directors in accordance with section 191
of the Law.
(b) A Director may not vote in respect of any contract or arrangement in which he is interested, and if he shall do
so his vote shall not be counted, and he shall not be counted in the quorum present at the meeting.
(c) A Director may hold any other office or place of profit under the company (other than the office of auditor) in
conjunction with his office of Director for such period and on such terms (as to remuneration and otherwise) as the
Directors may determine and no Director or intending Director shall be disqualified by his office from contracting with
the company either with regard to his tenure of any such office or place of profits or as vendor, purchaser or otherwise,
nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the company in which any
Director is in any way interested, be liable to be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested
be liable to account to the company for any profit realized by any such contract or arrangement by reason of such Di-
rector holding that office or of the fiduciary relation thereby established.
(d) A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting whereat he or
any other Director is appointed to hold any such office or place of profit under the company or whereat the terms of
any such appointment are arranged, and he may vote on any such appointment or arrangement other than his own ap-
pointment or the arrangement of the terms thereof.
(e) Any Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the company, and he or his firm shall be
entitled to remuneration for professional services as if he were not a Director; provided that nothing herein contained
shall authorize a Director or his firm to act as auditor to the company.
89. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for mon-
eys paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, in such
manner as the Directors shall from time to time by resolution determine.
90. The Directors shall cause minutes to be made in books provided for the purpose:
(a) of all appointments of officers made by the Directors;
(b) of the names of the Directors present at each meeting of the Directors and of any committee of the Directors;
(c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the company, and of the Directors, and of committees of Di-
rectors.
Disqualification of Directors
91. The office of Director shall be vacated if the Director:
(a) ceases to be a Director by virtue of section 176 of the Law; or
(b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) becomes prohibited from being a Director by reason of any order made under section 180 of the Law; or
(d) becomes of unsound mind; or
(e) resigns his office by notice in writing to the company; or
(f) shall for more than six months have been absent without permission of the Directors from meetings of the Di-
rectors held during that period.
Appointment and Terms of Office of Directors
92. The appointment by election of each of the Directors shall be made, and the terms of office of said Directors shall
be determined by the Company at each annual General Meeting of the Company in accordance with the provisions of
any agreement validly existing among the members.
93. At the first annual General Meeting of the company and at the annual General Meeting in every subsequent year
all the Directors shall retire from office. All retiring Directors shall be eligible for re-election.
94. No person other than a Director retiring at the meeting shall unless recommended by the Directors be eligible
for election to the office of Director at any General Meeting unless not less than three nor more than twenty-one days
before the date appointed for the meeting there shall have been left at the registered office of the company notice in
writing, signed by a member duly qualified to attend and vote at the meeting for which such notice is given, of his inten-
tion to propose such person for election, and also notice in writing signed by that person of his willingness to be elected.
95. The company in accordance with the provisions of any agreement validly existing among the members, may from
time to time by ordinary resolution appoint any person to be a director to fill a casual vacancy, and furthermore may
increase or reduce the number of Directors, and may also determine in what rotation the Directors shall go out of
office.
96. The company, subject to the provisions of any agreement validly existing among the members, may by ordinary
resolution, of which special notice has been given in accordance with section 136 of the Law, remove any Director be-
fore the expiration of this period of office notwithstanding anything in these Regulations or in any agreement between
the company and such Director. Such removal shall be without prejudice to any claim such Director may have for dam-
ages for breach of any contract of service between him and the company.
Alternate Directors
97. Each Director, by duly executed and certified power of attorney may at any time appoint any person, be they a
Director of the Company or not, to act as Alternate Director in his place and for whatever period he should designate,
and said Alternate Director during the said period shall have the right to attend and vote at any meeting of the Directors,
and generally shall have and shall exercise all rights, powers and duties of the Director who appointed him, provided
always that the appointing Director may at any time revoke said appointment and in the event of death or incapacity of
the appointing Director or in the event that said appointing Director should cease for any reason to hold the position
of Director, the appointment is automatically terminated and made void.
28572
Should an Alternate Director already hold an office as Director of the Company, such Director shall have a separate
vote as Alternate Director and shall be counted separately in both capacities for the purpose of establishing a quorum.
98. Any person acting as an Alternate Director is considered an officer of the Company and he becomes personally
responsible to the Company for his acts and omissions, and his remuneration, if any, shall be paid out of the remuner-
ation of the Director who appoints him, the actual sum to be agreed upon between the appointing Director and his
Alternate.
Proceedings of Directors
99. The Directors May meet together for the despatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings,
as they think fit. Matters arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality of votes,
the Chairman shall not have a second or casting vote. The meetings of the Directors shall be summoned in accordance
with the provisions of any agreement validly existing among the members. The Directors shall meet at least once a year.
The meetings of the Directors shall normally take place at the registered office of the Company, but may also take place
elsewhere within or outside Cyprus. Meetings may also take place by conference call.
100. Written notice of Directors’ meetings must be given by the Chairman to the individual Directors and shall be
provided in the manner set forth in these Regulations so as to be received at least thirty (30) days prior to the date of
the meeting. The notice shall contain a statement of the agenda to be considered at the meeting and shall set forth the
location and time (date and hour) of the meeting. Notice of a Directors meeting may be waived in writing or if all the
Directors are present at a meeting. Directors shall be entitled at any meeting to consider matters not contained in the
notice therefor provided such matters have been properly brought before the meeting.
101. The Company shall be responsible for all travel and lodging expenses incurred by the Directors on account of
such meetings.
102. Any Director, subject to the terms of any agreement validly existing among the members, can issue a proxy to
another Director to represent him at meetings of the Directors.
103. The quorum for a valid meeting of the Directors shall be fixed in accordance with the terms of any agreement
validly existing among the members. Actions by the Directors shall require the approval of at least a majority of the
Directors in attendance.
104. Any Director may refer to the members any matter for which the necessary affirmative vote of the Directors
cannot be obtained, and the members may take up such manner at the Annual General Meeting or an Extraordinary
General Meeting convened in accordance with these Regulations and the terms of any agreement validly existing among
the members.
105. The Directors in accordance with the terms of any agreement validly existing among the members, may elect a
Chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office. The Chairman shall have a single
vote, but no veto power or additional or tie-breaking voting power with respect to any matter arising at a meeting of
the Directors.
106. The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their
body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any Reg-
ulations that may be imposed on it by the Directors.
107. A committee may elect a Chairman of its meetings; if no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chair-
man is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the members present may choose
one of their number to be Chairman of the meeting. The Chairman shall have a single vote, but no veto power or ad-
ditional or tie-breaking voting power with respect to any matter arising at a meeting of the committee or a meeting of
the Directors.
108. A committee may meet and adjourn as it thinks proper. Questions arising at any meeting shall be determined
by a majority of votes of the members present, and in the case of an equality of votes the Chairman shall not have a
second or casting vote.
109. All acts done by any meeting of the Directors or of a committee of Directors or by any person acting as a Di-
rector shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such
Director or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person
had been duly appointed and was qualified to be a Director.
110. A resolution in writing signed or authorized by a letter, telegram, radiotelegram, facsimile (telefax), or telex by
all the Directors or their Alternates, shall be equally valid and binding as if it were taken and passed at a meeting of the
Directors validly convened and held, and when it is signed it can consist of various documents, each one duly signed by
one or more of the aforementioned persons.
Managing Director
111. The Directors from time to time, subject to the terms of any agreement validly existing among the members,
may appoint an individual to the office of Managing Director for such period and on such terms as they think fit, and,
subject to the terms of any agreement of employment entered into with said Managing Director, may revoke such ap-
pointment.
112. A Managing Director shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission or participation in
profits, or partly in one way and partly in another) as the Directors may determine.
113. The Directors may entrust to and confer upon a Managing Director any of the powers exercisable by them upon
such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion
of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
28573
Other Officers
114. In addition to the Managing Director, the Company shall have such other officers, with such duties, as the Di-
rectors may authorize. The powers and terms of office of the officers shall be defined in accordance with relevant Di-
rectors resolutions. All such officers may be removed by resolution of the Directors in which event the Directors shall
appoint their replacement; provided, however, that no replacement of the Managing Director shall be appointed by the
Directors unless such appointment is nominated and approved in accordance with the provisions of any agreement val-
idly existing among the members.
Secretary
115. The Secretary shall be appointed by the Directors for such term, at such remuneration and upon such conditions
as they may think fit; and any Secretary so appointed may be removed by them.
116. No person shall be appointed or hold office as Secretary who is:
(a) the sole Director of the company; or
(b) a corporation the sole Director of which is the sole Director of the company; or
(c) the sole Director of a corporation which is the sole Director of the company.
117. A provision of the Law or these Regulations requiring or authorizing a thing to be done by or to a Director and
the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and as, or in place
of, the Secretary.
The Seal
118. a) The seal of the Company shall be used only after the authorization of the Directors and every document which
shall bear such seal shall be countersigned by a Director, an Alternate Director or the Secretary of the Company.
b) The Company may use an official seal in addition to the seal referred to in (a) above, which will be as provided by
Articles 36 (1) of the Law and will be used for the purpose therein mentioned.
Dividends and Reserve
119. The company subject to the terms of any agreement validly existing among the members may in General Meeting
by ordinary resolution declare dividends, or other distributions or appropriations of profits to the members.
120. The Directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums
as they think proper as reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose
to which the profits of the company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion,
either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the com-
pany) as the Directors may from time to time think fit. The Directors may also without placing the same to reserve
carry forward any profits which they may think prudent not to divide.
121. Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be
declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is
paid, but no amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this
Regulations as paid on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or
credited as paid on the share during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but
if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for
dividend accordingly.
122. The Directors may deduct from any dividend payable to any member all sums of money (if any) presently payable
by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.
123. Any dividend, interest or other moneys payable in respect of shares shall be paid in a manner which shall be in
accordance with the terms of any agreement validly existing among the members.
124. No dividend shall bear interest against the company.
Accounts
125. The Directors shall cause proper books of account to be kept with respect to:
(a) all sums of money received and expended by the company and the matters in respect of which the receipt and
expenditure takes place;
(b) all sales and purchases of goods by the company; and
(c) the assets and liabilities of the company.
Proper books shall not be deemed to be kept if there are not kept such books of account as are necessary to give a
true and fair view of the state of the company’s affairs and to explain its transactions.
126. The books of account shall be kept at the registered office of the company, or, subject to section 141 (3) of the
Law, at such other place or places as the Directors think fit, and shall always be open to the inspection of the Directors.
127. The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and
under what conditions or Regulations the accounts and books of the company or any of them shall be open to the in-
spection of members not being Directors, and no member (not being a Director) shall have any right of inspecting any
account or book or document of the company except as conferred by statute or authorized by the Directors or by the
company in General Meeting.
128. The Directors shall from time to time, in accordance with sections 142, 144 and 151 of the Law, cause to be
prepared and to be laid before the company in General Meeting such profit and loss accounts, balance sheets, group
accounts (if any) and reports as are referred to in those sections.
129. A copy of every balance sheet (including every document required by law to be annexed thereto) which is to be
laid before the company in General Meeting, together with a copy of the auditors’ report, shall not less than twenty-
one days before the date of the meeting be sent to every member of, and every holder of debentures of, the company
28574
and to every person registered under any foregoing Regulation. Provided that this Regulation shall not require a copy
of those documents to be sent to any person of whose address the company is not aware or to more than one of the
joint holders of any shares or debentures.
Capitalization of Profits
130. The company in General Meeting, in accordance with the provisions of any agreement validly existing among the
members may, upon the recommendation of the Directors, resolve that it is desirable to capitalise any part of the
amount for the time being standing to the credit of any of the company’s reserve accounts or to the credit of the profit
and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution
amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same propor-
tions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the
time being unpaid on any shares held by such members respectively or paying up in full unissued shares or debentures
of the company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such members in the proportion
aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution:
Provided that a share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this Regula-
tion, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus
shares.
131. Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed the Directors shall make all appropriations and
applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares
or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the
Directors to make such provision by the issue of fractional certificates or by payment in cash or, otherwise as they think
fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions, and also to authorize any person to enter
on behalf of all the members entitled thereto into an agreement with the company providing for the allotment to them
respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such cap-
italization, or (as the case may require) for the payment up by the company on their behalf, by the application thereto
of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised, of the amounts or any part of the amounts re-
maining unpaid on their existing shares, and any agreement made under such authority shall be effective and binding on
all such members.
Audit
132. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with sections 153 to 156 (both inclusive)
of the Law.
Notices
133. Any notice to be given by the Company to any member or to any other person entitled to receive notice under
these Regulations, shall be given in writing. Said notice may be given by facsimile, telegram, cable, telex, personal delivery
or by courier, to such address as the party entitled to receive such notice shall designate in writing to the Company. In
all cases of service of notice other than by personal delivery or courier, a copy of said notice shall also be sent by post.
Where a notice (or copy of notice) is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by properly
addressing, prepaying, and posting a letter containing the notice, and to have been effected in the case of a notice of a
meeting at the expiration of 72 hours after the letter containing the same is posted, and in any other case at the time
at which the letter would be delivered in the ordinary course of post. Notices served by personal delivery or by courier
shall be effective upon conclusive proof that they have been received.
134. A notice may be given by the company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder
first named in the register of members in respect of the share.
135. A notice may be given by the company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bank-
ruptcy of a member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of
representatives of the deceased, or trustee of the bankrupt, or by any like description, at the address, if any, supplied
for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or (until such an address has been so supplied) by giving the
notice in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.
136. Notice of every General Meeting shall be given in any manner herein before authorized to:
(a) every member except those members who (having no registered address within Cyprus) have not supplied to the
company an address within or outside Cyprus for the giving of notices to them;
(b) every person upon whom the ownership of a share devolves by reason of his being a legal personal representative
or a trustee in bankruptcy of a member where the member but for his death or bankruptcy would be entitled to receive
notice of the meeting; and
(c) the auditor for the time being of the company.
No other person shall be entitled to receive notices of General Meetings.
Venue of Meetings
137. Irrespective of any provision included in these Regulations which are applicable to the Company, the meetings
of the Directors as well as the General Meetings of the Company (ordinary and extraordinary) could be convened and
take place either in Cyprus or abroad, at any town or place as the majority of the Directors or the members according
to the occasion, would demand in writing.
Winding-up
138. If the company shall be wound up the liquidator in accordance with the terms of any agreement validly existing
among the members shall, with the sanction of an extraordinary resolution of the company and any other sanction re-
28575
quired by the Law, divide amongst the members in accordance with the provisions of said agreement, in specie or kind
the whole or any part of the assets of the company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and
further shall apportion the obligations of the Company amongst the members and shall determine in accordance with
the provisions of said agreement, how such division and apportionment shall be carried out.
Indemnity
139. Every Director, managing Director, agent, auditor, secretary and other officer for the time being of the company
shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings,
whether civil or criminal, in which judgment is given in his favor or in which he is acquitted or in connection with any
application under section 383 of the Law in which relief is granted to him by the Court and no Director or officer of
the company shall be liable for any loss, damage or misfortune which may happen to or be incurred by the company in
the execution of the duties of his office or in relation thereto. But this clause shall only have effect in so far as its pro-
visions are not avoided by section 197 of the Law.
Names, Addresses and Descriptions of Signatories
SEAWARD NOMINEES LTD
27 Gregory Afxentiou Avenue - Larnaca - Cyprus
SEAWARD SERVICES LIMITED 27 Gregory Afxentiou Avenue Larnaca - Cyprus
Dated on this 2nd day of March 1999.
I hereby certify that the above Memorandum and Articles of Association were drafted by me.
<i>Secretary’s certificatei>
We SEAWARD SERVICES LTD, Company Secretary of GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LTD. (the
«Company»), hereby certify that on February 2, 2004, the members of the Company unanimously passed the following
ordinary resolution:
<i>Ordinary resolutioni>
That the authorized capital of the Company which consists of USD 17,527,636 divided into 8,763,818 ordinary shares
of USD 2 each, be, and is hereby increased to USD 30,238,394 by the creation of 6,355,379 additional ordinary shares
at USD 2 per share.
This certificate is issued on this 25th day of February 2004.
<i>Secretary’s certificatei>
We SEAWARD SERVICES LTD, Company Secretary of GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LTD. (the
«Company»), hereby certify that on December 3, 2003, the members of the Company unanimously passed the following
ordinary resolution:
<i>Ordinary resolutioni>
That effective immediately the share capital of the Company be increased from USD 20,000 to USD 17,527,636 by
the creation of 8,762,818 ordinary shares of USD 2 per share.
This certificate is issued on this 10th day of December 2003.
It is hereby certified that this is a true and accurate translation of the original Greek text of the Memorandum and
Articles of Association of the company GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED which is on file with
the Registrar of Cyprus Companies.
March 24, 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03039. – Reçu 78 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031140.5/280/851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.
E. Dionysiou
<i>Witness of the above signaturesi>
Chr. G. Pelaghias
<i>Practicing Advocatei>
<i>For SEAWARD SERVICES LTD.
i>Signature
<i>Secretaryi>
<i>For SEAWARD SERVICES LTD.
i>Signature
<i>Secretaryi>
C. G. Pelaghias
<i>Advocatei>
True Copy
<i>For registrar of Companies
i>L. Christodoulides
28576
LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.356.
—
Avec effet au 19 février 2004, Monsieur Carl Speecke et Monsieur Koen van Baren et Monsieur Benoît Nasr, ont
démissionné de leurs fonctions d’administrateur.
Avec effet au 19 février 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs
démissionnaires:
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,
demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-
rant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-
sionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Avec effet au 19 février 2004, Monsieur Claude Zimmer est nommé Président du Conseil d’Admnistration.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Avec effet au 19 février 2004, AUDIEX S.A., R.C. Luxembourg B 65.469, ayant son siège social 57, avenue de la Faïen-
cerie, L-1510 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes en remplacement de ELPERS & Co. REVISEURS D’EN-
TREPRISES, S.à r.l., commissaire démissionnaire avec effet à l’exercice commençant le 1
er
janvier 2003.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Avec effet au 19 février 2004, le siège social de la société est transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
au 3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00330. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031401.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
ADD VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 100.274.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Madame Remedios Dupasquier, née Aguirre, demeurant à 5/ Floor, Pilar Building, 148 Amorsolo Street Legaspi
Village Makati City Philippines,
2. Monsieur Pierre Dupasquier, demeurant à 5/ Floor, Pilar Building, 148 Amorsolo Street Legaspi Village Makati City
Philippines,
3. Madame Catherine Dupasquier, demeurant à 33, avenue Rapp, 75007 Paris, France,
4. Madame Anne-Marie Morrongiello, née Dupasquier, demeurant à Chemin Armand Dufaux, 80 1246 Corsier Suisse,
5. Monsieur Jacques Yves Dupasquier, demeurant à 38 Pili Avenue South Forbes Park Makaty City Philippines 1120.
Ici représentés par Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 31, rue d’Eich L-
1461 Luxembourg, en vertu de cinq procurations sous seing privée, lesquelles procurations demeureront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de ADD VENTURE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
<i>Pour LAUNER INTERNATIONAL S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
28577
la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères; l’ad-
ministration, le contrôle et le développement de telles participations; la mise en valeur de ces participations, grâce à
l’octroi de tous prêts, avances ou garanties; la création, la gestion, la mise en valeur d’un portefeuille se composant de
tous titres et brevets.
La société déclare ne pas vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
de participations financières.
En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l’objet ou
le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) divisé en 320 (trois cent vingt) actions d’une
valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 6. Les actions de la société sont et resteront nominatives.
Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle
qu’elle a été modifiée.
Administration - Surveillance
Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non; ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement la durée du mandat est de
six ans.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de celles réservées par la loi à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
est conférée à l’administrateur le plus ancien en rang.
Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée
pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La société se trouve engagée par la signature collective de trois administrateurs.
Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le
conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout mo-
ment. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.
Année sociale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Droit de préemption
Art. 16. Toute cession d’actions par un actionnaire à un tiers doit indiquer les nom, prénom et domicile du cession-
naire ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme et le siège social, le prix de cession ainsi que le
nombre d’actions dont la cession est envisagée.
Le cédant doit notifier son projet de cession à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du projet de cession, le conseil d’administration notifie aux
actionnaires le projet de cession et les conditions de la cession projetée. Parallèlement, le conseil d’administration con-
fiera à un réviseur indépendant, membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du Grand-Duché de Luxembourg le
mandat de fixer la valeur des actions à céder selon les usages en vigueur dans la branche. Ce réviseur disposera d’un
délai de 2 mois pour remettre son rapport, lequel sera, dès réception, notifié aux actionnaires par les soins du conseil
d’administration. Le conseil d’administration est tenu de convoquer, dans un délai de 30 jours, une assemblée générale
28578
au cours de laquelle les actionnaires auront a statuer sur l’agrément du cessionnaire au prix détermine par le réviseur
et éventuellement de statuer sur l’agrément du cessionnaire. Si l’agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit jours
de l’assemblée générale, notifier à la société, par lettre recommandée, qu’il renonce à son projet de cession. A défaut
de renonciation, le conseil d’administration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires, soit par des
tiers agréés. Faute par le conseil d’avoir trouvé un actionnaire ou un tiers susceptible d’acquérir lesdites actions, l’agré-
ment sera réputé acquis aux conditions fixées dans le projet de cession.
Toutes les notifications prévues par le présent article seront faites par courrier recommandé avec accusé de récep-
tion.
Disposition générale
Art. 17. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y
est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de EUR 32.000,- (trente-deux
mille euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Madame Remedios Dupasquier, demeurant à 5/ Floor, Pilar Building, 148 Amorsolo Street Legaspi Village Makati
City Philippines,
2. Monsieur Pierre Dupasquier, demeurant à 5/ Floor, Pilar Building, 148 Amorsolo Street Legaspi Village Makati City
Philippines,
3. Madame Catherine Dupasquier, demeurant à 33, avenue Rapp, 75007 Paris, France,
4. Madame Anne-Marie Morrongiello, demeurant à Chemin Armand Dufaux, 80 1246 Corsier Suisse,
5. Monsieur Jacques Yves Dupasquier, demeurant à 38 Pili Avenue South Forbes Park Makaty City Philippines 1120.
La durée des mandats est de 6 (six) ans.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue de l’Ordre de La Couronne de Chêne
L-1361 Luxembourg.
La durée du mandat est de 6 (six) ans.
4) Le siège de la société est fixé à: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Dessoy, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 143S, fol. 5, case 1. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032293.3/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
Actionnaires
Capital souscrit
Capital libéré
Nombre d’actions
1. Madame Remedios Dupasquier . . . . . . . .
6.400,- EUR
6.400,- EUR
64
2. Monsieur Pierre Dupasquier . . . . . . . . . .
6.400,- EUR
6.400,- EUR
64
3. Madame Catherine Dupasquier . . . . . . . .
6.400,- EUR
6.400,- EUR
64
4. Madame Anne-Marie Morrongiello . . . . .
6.400,- EUR
6.400,- EUR
64
5. Monsieur Jacques Yves Dupasquier . . . . .
6.400,- EUR
6.400,- EUR
64
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000,- EUR
32.000,- EUR
320
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Elvinger.
28579
DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.184.
—
Avec effet au 22 mars 2004, Monsieur Carl Speecke et Monsieur Koen van Baren et Monsieur Benoît Nasr, ont dé-
missionné de leurs fonctions d’administrateur.
Avec effet au 22 mars 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs dé-
missionnaires:
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,
demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-
rant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-
sionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Avec effet au 22 mars 2004, Monsieur Claude Zimmer est nommé Président du Conseil d’Administration.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Avec effet au 22 mars 2004, AUDIEX S.A., R.C. Luxembourg B 65.469, ayant son siège social 57, avenue de la Faïen-
cerie, L-1510 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes en remplacement de COMCOLUX S.A., commissaire
démissionnaire avec effet à l’exercice commençant le 1
er
octobre 2003.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Avec effet au 22 mars 2004, le siège social de la société est transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au
3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00321. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031405.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
NORTHERN NEFT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.577.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02446, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032046.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
NORTHERN NEFT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.577.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02441, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032049.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
NORTHERN NEFT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.577.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02442, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032051.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
<i>Pour DICTAME HOLDING S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 14 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
Signature.
28580
PREMIER CRU INTERNATIONAL N.V., Société Anonyme.
Siège social: Binnenweg 1A, NL-1261 EK Blaricum.
Centre principal d’activité: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame
R. C. Luxembourg B 73.762.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 5 avril 2004,
les mandats des administrateurs:
Monsieur Carl Speecke, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Koen van Baren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Tjitske Strikwerda, Résidence du Métropole, F-9800 Monté-Carlo, Principauté de Monaco,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes
INTERAUDIT, S.à r.l., Avenue de la Faïencerie, 119, L-1511 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031430.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.556.
—
Avec effet au 22 mars 2004, Monsieur Carl Speecke et Monsieur Koen van Baren et Monsieur Benoît Nasr, ont dé-
missionné de leurs fonctions d’administrateur.
Avec effet au 22 mars 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs dé-
missionnaires:
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,
demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-
rant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-
sionnellement au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Avec effet au 22 mars 2004, Monsieur Claude Zimmer est nommé Président du Conseil d’Administration.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Avec effet au 22 mars 2004, AUDIEX S.A., R.C. Luxembourg B 65.469, ayant son siège social 57, avenue de la Faïen-
cerie, L-1510 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes en remplacement de ELPERS & Co. REVISEURS D’EN-
TREPRISES, S.à r.l., commissaire démissionnaire avec effet à l’exercice commençant le 31 décembre 2002.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Avec effet au 22 mars 2004, le siège social de la société est transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au
3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02770. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031432.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
SIDFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.744.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031737.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
<i>Pour PREMIER CRU INTERNATIONAL N.V.
i>K. van Baren
<i>Administrateuri>
<i>Pour THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Signature.
28581
PREDICAI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 55, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.007.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02869, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031478.2/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
PREDICAI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 55, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.007.
—
«Reconduction du mandat du réviseur d’entreprises»
L’assemblée générale des actionnaires du 8 avril 2004 a décidé de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers
comme réviseur d’entreprises de la Compagnie pour un mandat de trois ans qui prendra fin lors de l’assemblée générale
statutaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02869. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031482.3/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.
IMMOLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.135.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04383, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031760.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.110.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004, le Conseil d’Administration se compose
comme suit:
- Monsieur David Green, Legal Counsel, PRUDENTIAL CORPORATION, Laurence Pountney Hill, London EC4R
0EU, England.
- Monsieur Garth Jones, Managing Director, PRUDENTIAL CORPORATION ASIA, Suite 2910-14, Two Pacific Place
88 Queensway, Hong Kong.
- Monsieur Edward Navarro, Chief Executive Officer, PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE)
LIMITED, 30 Cecil Street #30-01 Prudential Tower, Singapore 049 712.
- Monsieur Ajay Srinivasan, Managing Director-Regional Mutual Funds, PRUDENTIAL CORPORATION ASIA, Suite
2910-14, Two Pacific Place 88 Queensway, Hong Kong.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03112. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031756.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
<i>Pour la société
i>PREDICAI EUROPE S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Secrétairei>
Signature.
<i>Pour PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
28582
SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer.
R. C. Luxembourg B 29.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02712, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031755.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer.
R. C. Luxembourg B 29.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02710, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031757.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 70.664.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:
Société domiciliée:
FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 70.664,
et
Domiciliataire:
FIRST TRUST, Société Anonyme, 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 80.068,
a pris fin avec effet au 1
er
avril 2004.
Fait à Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01443. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031724.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
LAPERLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.126.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 31 mars 2004i>
1. L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDINGS LLC et nomme en
son remplacement TOWERBEND LIMITED avec effet immédiat.
2. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M. Giancarlo Pagani et M. Stephen
Samaras ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 2 décembre 2000, et ce
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01770. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031749.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
FIRST TRUST
Signature
<i>Pour LAPERLE S.A.
i>Signature
28583
PROVINCIAL CAPITAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.823.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02708, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031758.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
PROVINCIAL CAPITAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.823.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02706, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031759.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
PROVINCIAL CAPITAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.823.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02704, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031761.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
EUROPEENNE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.774.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale du 9 avril 2004i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission des administrateurs suivants: Claude Schmit, Karim Van Den Ende et Marcel Buda
et leur donne décharge pour l’exécution de leurs mandats.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée donne décharge à Messieurs Mazzoni, Georis et Foubert pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à la
présente Assemblée.
L’Assemblée renouvelle les mandats de Messieurs Fabio Mazzoni et Benoît Georis en qualité d’administrateurs de la
société et celui de Monsieur Luc Foubert en tant qu’administrateur-délégué.
Leurs mandats prendront fin après l’Assemblée Générale se prononçant sur l’approbation des comptes de l’année
2008.
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
(031815.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
Pour extrait
J. Lebas
28584
GROUPE A.O.H., Société Anonyme,
(anc. LE SAVOURIN S.A.).
Siège social: L-8077 Bertrange, 263, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.716.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01297, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031745.3/1286/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
COMPTAPLUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 80.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01298, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031747.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
DALYAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02697, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031773.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
DALYAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02695, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031776.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
DALYAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02694, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031778.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Signature.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
28585
HASI INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.886.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 29 mars 2004i>
1. L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDING LLC et nomme en
son remplacement TOWERBEND LIMITED.
Son mandat s’achèvera avec celui des administrateurs à l’issue de l’assemblée annuelle de 2005.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00910. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031750.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
COMPAGNIE DE GNEIS ET GABRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.954.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02703, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031763.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
FRS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031765.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l. et Cie, Société en commandite simple.
Siège social: Steinsel, 68, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 42.888.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2003i>
Les associés de DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société en commandite simple,
- M. Marco De Cillia
- M. Georges De Cillia
- M. Pierre De Cillia
- DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l.
décident à l’unanimité de transférer le siège social de la société de Steinsel 6, rue des Templiers à Steinsel 68, rue des
Prés.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01709. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031917.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
<i>Pour HASI INVEST S.A.
i>Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
M. De Cillia / G. De Cillia / P. De Cillia / DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l.
28586
F.I.B. S.A., FIRST INTERNATIONAL BROKER, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 87.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02699, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031771.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
APOLLO VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.792.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02692, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031784.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel, 68, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 42.887.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2003i>
Les associés de DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
- M. Marco De Cillia
- M. Georges De Cillia
- M. Pierre De Cillia
décident à l’unanimité de transférer le siège social de la société de Steinsel 6, rue des Templiers à Steinsel 68, rue des
Prés.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01739. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031911.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel, 68, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 42.887.
—
<i>Cession de parts de la sociétéi>
Entre les soussignés:
M. Pierre De Cillia, demeurant à L-7235 Bereldange 2, rue de Limana, ci-après dénommé «le cédant»
et
M. Marco De Cillia, demeurant à L-7346 Steinsel 26, An den Bongerten ci-après dénommé «le cessionnaire»
il a été convenu ce qui suit:
Art. 1
er
. Cession.
Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire qui l’accepte:
1 part de 25,- EUR, entièrement libérée dont il est propriétaire au sein de la société DE CILLIA LES CARRELAGES,
S.à r.l. au capital de 12.500,- EUR, dont le siège est à Steinsel, immatriculée au R.C. de Luxembourg sous le n
°
B 42.887.
Le cessionnaire sera propriétaire du titre cédé à compter de ce jour avec tous les droits y attachés. Par l’effet de
cette cession, le cessionnaire se trouve subrogé au cédant dans toutes les droits et actions attachés au titre cédé.
Art. 2. Prix.
Le cédant donne par la présente quittance au cessionnaire pour le prix de vente.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
M. De Cillia / G. De Cillia / P. De Cillia.
28587
Fait à Steinsel, le 25 mars 2004 en autant d’exemplaires que de parties.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01696. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031914.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel, 68, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 42.887.
—
<i>Cession de parts de la sociétéi>
Entre les soussignés:
M. Pierre De Cillia, demeurant à L-7235 Bereldange 2, rue de Limana, ci-après dénommé «le cédant»
et
M. Georges De Cillia, demeurant à L-7346 Steinsel 6, rue des Templiers ci-après dénommé «le cessionnaire»
il a été convenu ce qui suit:
Art. 1
er
. Cession.
Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire qui l’accepte:
1 part de 25,- EUR, entièrement libérée dont il est propriétaire au sein de la société DE CILLIA LES CARRELAGES,
S.à r.l. au capital de 12.500,- EUR, dont le siège est à Steinsel, immatriculée au R.C. de Luxembourg sous le n
°
B 42.887.
Le cessionnaire sera propriétaire du titre cédé à compter de ce jour avec tous les droits y attachés. Par l’effet de
cette cession, le cessionnaire se trouve subrogé au cédant dans toutes les droits et actions attachés au titre cédé.
Art. 2. Prix.
Le cédant donne par la présente quittance au cessionnaire pour le prix de vente.
Fait à Steinsel, le 25 mars 2004 en autant d’exemplaires que de parties.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01707. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031915.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
MARKETS INFORMATIONS VIRTUAL EXCHANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 78.118.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2004i>
1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2003 faisant ap-
paraître une perte de EUR 9.120,-.
3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2003.
5. L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Christophe Antinori, Richard
Gauthrot, Jean-Paul Charton, et Jean-Marie Valicon.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31
décembre 2004.
6. L’Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Laurent Paul.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-
cembre 2004.
7. L’Assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide
à l’unanimité de ne pas dissoudre la Société.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06089. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031820.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
P. De Cillia / M. De Cillia
<i>Le cédant / Le cessionnairei>
P. De Cillia / G. De Cillia
<i>Le cédant / Le cessionnairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28588
EXIMP ROGER GREDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.698.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02698, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
(031772.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
TOTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 80.375.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03293, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031965.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
TOTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 80.375.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société du 15 octobre 2003i>
L’Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes et décide de lui
donner quitus pour l’exercice de son mandat.
Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, qui terminera
le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03274. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031962.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
EUROWATT, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 48.019.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale du 9 décembre 2003i>
Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 9 décembre que:
L’Assemblée Générale décide de nommer comme gérant Monsieur Dominique Darne demeurant au 10, rue Meslay
F-75003 Paris.
Le Conseil de Gérance se compose dès lors de la manière suivante:
- Monsieur Marco De Vecchi domicilié au 16, rue Henri VII L-1725 Luxembourg.
- Monsieur Dominique Darne demeurant au 10, rue Meslay F-75003 Paris.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03501. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031857.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
Senningerberg, le 20 avril 2004.
Signature.
<i>Pour TOTAL HOLDING S.A.
L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28589
FAUSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.834.
—
Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01186, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032069.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
FAUSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.834.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FAUSIS S.A. tenue
extraordinairement en date du 7 avril 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:
- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 octobre 2002 sont approuvés
- La perte de l’exercice au 31 octobre 2002 est reportée aux comptes de l’année 2003.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de
leurs mandats au 31 octobre 2002.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale
qui se tiendra en 2005.
Administrateurs
S.W. Baker
D.E. Shand
C. Néré
Commissaires aux Comptes
TEMPLE AUDIT S.C.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032061.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 41.180.
—
Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02224, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031812.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
SYSTEMES TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELS (S.T.I.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 39.640.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 mars 2004 que le siège social de la société est
transféré à partir du 1
er
avril 2004 de L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri à L-1361 Luxembourg, 9, rue
de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AO02853. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031853.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Luxembourg, le 22 avril 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
28590
IMMOBILIERE PARC EVERLANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9147 Erpeldange/Ettelbruck, 2A, beim Dreieck.
R. C. Luxembourg B 100.275.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société anonyme ELMA FINANCE S.A., avec siège social à L-8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières,
ici représentée par un de ses administrateurs-délégués, savoir Monsieur Joseph Elsen, entrepreneur de construc-
tions, demeurant à Steinfort.
2.- La société anonyme SOPROFI S.A., avec siège social à L-8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Heynen, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 26 mars 2004.
3.- Monsieur Jean-Marie Heynen, entrepreneur de constructions, demeurant à B-6780 Hondelange, 103, rue des Ro-
chers.
4.- Monsieur Patrick Peters, agent immobilier, demeurant à L-9142 Burden, 10, um Kettenhouscht,
ici représenté par Monsieur Jean-Marie Heynen, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 mars 2004.
Les deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE PARC EVERLANGE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Erpeldange/Ettelbruck.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur, la promotion, la gestion et la location de tous
immeubles bâtis et non-bâtis, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Titre II.- Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), représenté par trois cent trente (330)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
28591
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le troisième lundi du mois de juin
à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-
fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
trois mille euros (EUR 33.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
1) La société anonyme ELMA FINANCE S.A., préqualifiée, cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
2) La société anonyme SOPROFI S.A., préqualifiée, quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
3) Monsieur Jean-Marie Heynen, préqualifié, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
4) Monsieur Patrick Peters, préqualifié, cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
28592
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean-Marie Heynen, entrepreneur de constructions, né à Arlon (Belgique) le 14 mars 1954, demeurant
à B-6780 Hondelange, 103, rue des Rochers;
b) Monsieur Patrick Peters, agent immobilier, né à Ettelbruck le 22 mai 1967, demeurant à L-9142 Burden, 10, um
Kettenhouscht;
c) Monsieur Joseph Elsen, entrepreneur de constructions, né à Ettelbruck le 6 avril 1939, demeurant à L-8444 Stein-
fort, 1, rue Randlingen.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en
l’an 2009.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1220
Luxembourg, 246, rue de Beggen, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 26.096.
Le commissaire aux comptes est nommé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera
tenue en l’an 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-9147 Erpeldange/Ettelbruck, 2a, Beim Dreieck.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Elsen, J-M. Heynen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 6 avril 2004, vol. 429, fol. 39, case 3. – Reçu 330 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(032290.3/236/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
BOMBARDIER LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.981.
—
Le bilan et l’annexe au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02560, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 15 avril 2004.
(031822.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
BERSABEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.291.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 avril 2004 que:
- Monsieur Eddy Dôme, demeurant à B-6600 Marvie, Monsieur Riccardo Moraldi, demeurant au 291 route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg et Monsieur Alain Lam, demeurant au 24 rue Dr Ernest Feltgen à L-7531 Mersch ont été élus
administrateurs en remplacement de GRANT INTERNATIONAL LTD, WOBURN DEVELOPMENT INC et Monsieur
Pascal Robinet, démissionnaires.
- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 50 Val Fleuri à L-1526 Luxembourg a été
nommée Commissaire en remplacement de la société C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEIL S.A., démissionnaire.
- Le siège social de la société a été transféré du 6 place de Nancy à L-2212 Luxembourg au 50 Val Fleuri à L-1526
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03430. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031859.3/727/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Bascharage, le 20 avril 2004.
A. Weber.
ERNST & YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
28593
A HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 80.718.
—
In the year two thousand four, on the twenty-fifth day of March, before Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg,
Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of A HOLDING S.A. (the Company), a
Luxembourg société anonyme, having its registered office at 174, route de Longwy in L-1940 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of Mr Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 26 January, 2001, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, No - 807 of 25 September, 2001. The articles of association of the Company
(the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger, of 31
December, 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations No C. The Company is reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 80.718.
The Meeting is chaired by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Torgny (Belgium).
The Chairman appoints as Secretary of the Meeting, and the Meeting elects as Scrutineer of the Meeting, Mr Bernard
Beerens, lawyer, residing in Luxembourg.
(The Chairman, the Secretary and the Scutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting).
The shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list
which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders
and the members of the Bureau.
The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present min-
utes and signed by all the parties.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 841,597 (eight hun-
dred forty-one thousand five hundred ninety-seven) ordinary shares of the Company having a nominal value of £ 1.- (one
Pound Sterling), representing the entirety of the voting share capital of the Company of £ 841,597.- (eight hundred forty-
one thousand five hundred ninety-seven Pound Sterling) are duly represented at this Meeting which is consequently reg-
ularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the
shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the
notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Surrender of the 1929 holding company tax regime and submission of the Company to a fully taxable regime;
3. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
Then the Meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-
vening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to surrender the 1929 holding company tax regime of the Company, currently constituted un-
der the law dated 31 July, 1929 on holding companies, as amended and to submit the Company to a fully taxable regime.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the third resolution, the Meeting resolves to amend article 4 of the Articles, which shall be read
as follows:
«Art. 4. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-
rectly to the acquisition of shareholdings in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those shareholdings.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect shareholding and to group companies, including direct or indirect parent
companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation
of its objects.
The Company shall not be governed by the law dated 31 July, 1929 on holding companies.»
<i>Estimates of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.- (one thousand Euros).
28594
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de A HOLDING S.A. (la Société),
une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 26 janvier 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N
°
807 du 25 septembre 2001. Les statuts de la Société (les Sta-
tuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger du 31 dé-
cembre 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. La Société est enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 80.718.
La séance est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire, et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Beerens, avocat,
demeurant à Luxembourg.
(Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée).
Les actionnaires représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont mentionnés sur une liste de
présence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et les
membres du Bureau.
Les procurations émises par les actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux
présentes minutes signées par toutes les parties.
Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 841.597 (huit cent quarante
et un mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept) actions ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de £ 1,- (une livre
sterling), représentant la totalité des actions émises avec droit de vote du capital social de la Société d’un montant de
£ 841.597,- (huit cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept livres sterling) sont dûment représentées à la
présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour,
indiqués ci-après, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l’Assemblée ayant décidé de se réunir après
examen de l’ordre du jour.
La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, res-
tera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Abandon du régime fiscal de société holding 1929 et adoption d’un statut de société pleinement imposable;
3. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société; et
4. Divers.
L’Assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représentée à la présente l’Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir
eu parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’abandonner le statut fiscal de la Société, qui est actuellement soumise à la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding, telle que modifiée, et d’adopter un statut de société pleinement imposable.
<i>Troisième résolutioni>
Comme conséquence de la troisième résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 4 des Statuts qui prendra
désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Objet social. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou in-
directement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs
et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, y compris les sociétés mères directes et indirectes,
ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties.
La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement
l’accomplissement et le développement de son objet social.
28595
L’objet de la Société doit être considérée comme ne tombant pas sous l’application des dispositions de la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.000,- (mille Euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l’ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: P. Van Hees, B. Beerens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, vol. 20CS, fol. 66, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031971.3/211/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
FRANCISTOWN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01183, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032070.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
FRANCISTOWN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.543.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FRANCISTOWN
S.A. tenue extraordinairement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 25 mars 2004 que:
- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 décembre 2002 sont approuvés
- La perte de l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2003.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de
leurs mandats au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01180. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(032063.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
ARCHITON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.320.
—
<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2004i>
L’assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en
vertu de l’art. 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032258.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 22 avril 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Signature
28596
FULL SERVICES ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.
R. C. Luxembourg B 100.269.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le trente et un mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société anonyme VICTORIA FINANCE HOLDING S.A., avec siège social à L-3781 Tétange, 39, rue Neuve,
ici représentée par Monsieur Thierry Beckerich, comptable, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 mars 2004,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2.- La société anonyme COMPTAFISC S.A., avec siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Thierry Beckerich, préqualifié.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Article 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FULL SERVICES ENGINEERING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Tétange.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle
ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garan-
ties ou de toute autre manière.
La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi
que toutes celles liées directement ou indirectement à son objet.
La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II.- Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
28597
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le troisième lundi du mois de juin
à 11.30 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-
fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d’administration.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
1) La société anonyme VICTORIA FINANCE HOLDING S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions
99
2) La société anonyme COMPTAFISC S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
28598
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Martial Piazza, administrateur de société, né à Algrange/Moselle (France) le 15 septembre 1966, demeu-
rant à F-57245 Peltre, 31, rue Gargan;
2) Monsieur Guérino Piazza, administrateur de société, né à Algrange/Moselle (France) le 20 novembre 1941, de-
meurant à F-57000 Nouilly, 17, rue de Metz;
3) Madame Estelle Piazza, employée privée, née à Metz (France) le 7 août 1981, demeurant à F-57950 Montigny-les-
Metz, 3, rue des Couvents.
Monsieur Martial Piazza, préqualifé, est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager valablement la société
en toutes circonstances par sa seule signature.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en
l’an 2009.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4751
Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 50.577.
Le commissaire aux comptes est nommé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera
tenue en l’an 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Beckerich, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 avril 2004, vol. 429, fol. 40, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(032243.3/236/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
BLUE LION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03743, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
(032265.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
BLUE LION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03744, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2004.
(032263.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
Bascharage, le 20 avril 2004.
A. Weber.
Signature
Signature
28599
REC REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. ECOTRADE OVERSEAS S.A.).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 96.769.
—
L’an deux mille quatre, le trente mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de ECOTRADE OVERSEAS S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 96.769 ayant son siège social à
Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 10 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1260
du 27 novembre 2003.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement
au 15, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg,
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-cinq mille
(25.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
cinquante mille euros (EUR 50.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en REC REAL ESTATE COMPANY S.A. et modification sub-
séquente de l’article 1 alinéa 1
er
des statuts.
2. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
La dénomination sociale de la Société est changée en REC REAL ESTATE COMPANY S.A.
En conséquence, l’article 1
er
alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de REC REAL ESTATE COMPANY S.A.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 10 heures 10.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, vol. 20CS, fol. 70, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031975.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
SPORTS ET LOISIRS CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 59.330.
—
Suite à la réunion du Conseil d’Administration en date du 16 avril 2004, M. Jean Steffen, employé privé, Senningerberg,
a été coopté en qualité d’administrateur, avec effet immédiat, en remplacement de M. Paul Albrecht, administrateur dé-
missionnaire, dont il terminera le mandat.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors d’une prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031963.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
J. Elvinger.
<i>Pour SPORTS ET LOISIRS CONCEPT S.A.
i>Signatures
<i>Administrateursi>
28600
GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 71.523.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRIKO FINANCE S.A., avec
siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques
Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 872 du 19 novembre 1999, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Delvaux, en date du 25 novembre
2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 10 du 6 janvier 2003, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 71.523.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450
Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450
Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Marie-Hélène Moschini, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Modification de l’article 2 alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le siège social est établi à Luxem-
bourg.»
2. Transfert du siège social de L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, à L-2450 Luxembourg, 15, bou-
levard Roosevelt, avec effet immédiat.
3. Démission du commissaire aux comptes après lui avoir accordé décharge.
4. Election d’un nouveau commissaire aux comptes, à savoir la société REVILUX S.A., domiciliée à L-1371 Luxem-
bourg, 223, Val Ste Croix.
5. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts, pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société à L-2450 Luxembourg, 15,
boulevard Roosevelt.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuel, à savoir la société à res-
ponsabilité limitée AACO, S.à r.l., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, et de lui donner dé-
charge pleine et entière.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en son remplacement la société anonyme REVILUX S.A., avec siège social à L-1371
Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, laquelle terminera le mandat de son prédécesseur.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: J. Faber, N. Printz, H. Moschini, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, vol. 20CS, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032164.3/227/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
E. Schlesser.
28601
GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 71.523.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23
avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032168.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
TALLMAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01189, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032072.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
TALLMAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.542.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme TALLMAN CON-
SULTING S.A. tenue extraordinairement à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 7 avril 2004 que:
- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 décembre 2002 sont approuvés
- La perte de l’exercice au 31 décembre 2002 est reportée aux comptes de l’année 2003.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats au 31
décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032068.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
BUL-INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.873.
—
RECTIFICATIF
Le prénom de l’administrateur Monsieur Youlian Nikolov Kostov repris dans l’avis de publication et de réquisition
modificative du 13 avril 2004 résultant du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinaire-
ment le 6 avril 2004, était orthographié de manière erronée.
Il convient de lire Youlian Nikolov à la place de Youlina Nikolov.
Toutes les autres indications concernant cet administrateur étant correctes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03497. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031959.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 22 avril 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>X. Kotoula / M. Chong Kan
<i>Administrateur / Administrateuri>
28602
GLOBE TOTAL INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 78.111.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2004i>
1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2003 faisant ap-
paraître une perte de EUR 8.033,-.
3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2003.
5. L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Christophe Antinori, Richard
Gauthrot, et Jean-Paul Charton.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31
décembre 2004.
6. L’Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Laurent Paul.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-
cembre 2004.
7. L’Assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide
à l’unanimité de ne pas dissoudre la Société.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06088. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031821.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
LITTORAL COTE D’AZUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 100.282.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quatorze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.) CORAL LIMITED (IBC n
°
013017) ayant son siège à Suite 13, First Floor - Oliaji Trade Centre, Francis Rachel
street - Victoria - Mahe - Republic of Seychelles
2.) WESTCOAST INVESTORS INC. (IBC n
°
014224) ayant son siège sociale à Suite 13, First Floor - Oliaji Trade
Centre, Francis Rachel Street - Victoria - Mahe - Republic of Seychelles
les deux ici représentées par Mademoiselle Rosanna Garbin, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 5 avril 2004.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme, sous la dénomination de LITTORAL COTE D’AZUR S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité pour l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28603
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location et/ou l’administration de tous biens mobiliers et
immobiliers situés au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger.
La société a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières, de créances, de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur
du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y attachés.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille Euros (33.000,- EUR) représenté par trois cent trente (330) ac-
tions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur no-
minale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication des présents sta-
tuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d’ac-
tions, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment auto-
risée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plu-
sieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration-Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection dé-
finitive.
Art. 7. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-
sident ou, à défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être con-
férée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière soit à des admi-
nistrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société en observant
les dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
28604
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire et ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier jeudi du mois de novembre à 17:00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Tout actionnaire a le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale-Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux
endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’ad-
ministration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi.
Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Dissolution-Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispotitions particulièresi>
Pour tous les points non spécifiés dans les présentes statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente juin 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.
<i>Souscription-Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente trois
mille euros (33.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents (EUR 1.400,-).
1) CORAL LIMITED, précitée, cent soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2) WESTCOAST INVESTORS INC., cent soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
28605
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulière-ment constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- MAJENTEL S.A. (R. C. Luxembourg B 77.599), ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
- CLEVERDAN S.A. (R. C. Luxembourg B 77.594), ayant son siège à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
- Monsieur Gabriel Jean, administrateur de sociétés, né à Arlon, le 05 avril 1967, demeurant professionnellement à
L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire (R.C. Luxem-
bourg B 67.501).
4.- L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d’une année et prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005
6.- L’assemblée nomme Monsieur Gabriel Jean, prénommé, administrateur-délégué de la Société, en vertu de l’article
10 des statuts. Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Garbin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, vol. 20CS, fol. 85, case 11. – Reçu 330 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032356.3/220/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
COLUMETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 42, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 72.286.
—
<i>Extrait d’une cession de parts socialesi>
Il résulte d’un acte de cession du 17 avril 2004 que
la société anonyme de droit luxembourgeois ANACONDA S.A. HOLDING, RCS B 62.808, avec siège social à L-1318
Luxembourg, 21, rue des Celtes,
cède
à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois C.W.A., S.à r.l., RCS B 49.887, avec siège social L-4240
Esch-sur-Alzette, 4, rue Emile Mayrisch,
75 (soixante-quinze) parts sociales de la société à responsabilité limitée COLUMETA, S.à r.l., RCS B 72.286, avec siège
social à L-4176 Esch-sur-Alzette, 42, rue Jos. Kieffer, pour le prix de 22.000,- Euros (vingt-deux mille Euros).
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02855. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031893.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.340.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2004i>
1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2003 faisant ap-
paraître une perte de EUR 13.022,-.
3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2003.
5. L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Christophe Antinori, Richard
Gauthrot, et Jean-Paul Charton.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31
décembre 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
28606
6. L’Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Laurent Paul.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-
cembre 2004.
7. L’Assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide
à l’unanimité de ne pas dissoudre la Société.
Luxembourg, le 15 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06092. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031826.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of March at 10.00 a.m.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.
There appeared:
Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, acting as attorney in fact of the Company pursuant to a
resolution of the Board of Directors passed on 24 March 2004.
A certified copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Such appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The Company has been incorporated under the name of ORIFLAME INTERNATIONAL S.A. pursuant to a deed
of Mr Georges Altwies, notary residing in Dudelange on 22 January 1970, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, n
°
61 dated 16 May 1970, the articles of the Company have been amended several times and for
the last time pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit on 16 March 2004, not yet published.
2. The share capital of the Company is sixty seven million two hundred sixty thousand three hundred ninety one
euros and twenty-five Cents (EUR 67,260,391.25), represented by fifty three million eight hundred and eight thousand
three hundred and thirteen (53,808,313) shares of no nominal value.
3. According to article 5 of the articles of association of the Company, the authorised capital is fixed at one hundred
and two million four hundred thousand euros (EUR 102,400,000.-) and article 5 of the articles of association of the Com-
pany allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the authorised capital and to
exclude the pre-emption rights of existing shareholders, and notably to issue on these terms seven million five hundred
thousand (7,500,000) shares in connection with an initial public offering of the shares of the Company by way of Swedish
Depository Receipts on the «O»-List of the Stockholm Stock Exchange.
4. During its meeting held on 24 March 2004, the Board of Directors resolved, this resolution being expressly subject
to the receipt of the full subscription payment, to increase the share capital of the Company by an amount of three
million eight hundred seventy-five thousand euros (EUR 3,875,000.-) within the authorised share capital by the issue of
three million one hundred thousand (3,100,000) new ordinary shares of the Company of no nominal value with exclu-
sion of pre-emption rights of existing shareholders, and with an aggregate share premium of fifty nine million eight hun-
dred forty six thousand one hundred forty one euros and fifty seven cents (EUR 59,846,141.57).
5. A list containing the name of the subscribers and the number of shares subscribed subject to receipt of the full
subscription payment is attached to the present deed to be registered with it.
6. During the same meeting held on 24 March 2004, the Board of Directors granted power to CARNEGIE INVEST-
MENT BANK AB to issue a blocking certificate showing that the amount of sixty three million seven hundred twenty
one thousand one hundred forty one euros and fifty seven cents (EUR 63,721,141.57) is at the free disposal of the Com-
pany. It was resolved that the delivery of this blocking certificate by CARNEGIE INVESTMENT BANK AB to the ap-
pearing party would be conclusive evidence of the fulfilment of the condition to the above increase of share capital and
to the above issue of new shares, which would become effective and final by virtue thereof.
7. The appearing person produces a blocking certificate from CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, with registered
office in Stockholm (Sweden), dated 29 March 2004. It results from this blocking certificate that the amount of sixty
three million seven hundred twenty one thousand one hundred forty one euros and fifty seven cents (EUR
63,721,141.57) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary. Such blocking
certificate shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
8. As a consequence of such blocking certificate having been produced the sole remaining condition to the capital
increase is fulfilled so that the above increase of the share capital of the Company and the above issue of new shares
shall be considered effective and final as of the date thereof.
9. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the
Company has henceforth the following wording:
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28607
The share capital is fixed at seventy one million one hundred thirty five thousand three hundred ninety one euros
and twenty-five cents (EUR 71,135,391.25) represented by fifty six million nine hundred eight thousand three hundred
thirteen (56,908,313) shares, of no nominal value.»
<i>Declarationi>
The undersigned notary declares that, according to article 32-1 of the Companies Act as amended, he has verified
the fulfilment of the conditions as provided in article 26 of such Act.
<i>Valuationi>
The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of
the present deed are valued at approximately six hundred forty-four thousand euros (EUR 644,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known
to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf mars, à 10:00 heures.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la Société,
en vertu d’une décision du Conseil d’Administration de la Société prise en réunion en date du 24 mars 2004,
une copie du procès-verbal de ladite réunion restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la for-
malité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée sous la dénomination de ORIFLAME INTERNATIONAL S.A. (la «Société») suivant acte
reçu par-devant Maître Georges Altwies, notaire de résidence à Dudelange, en date du 22 janvier 1970, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial des sociétés C, n
°
61 du 16 mai 1970, les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises
et la dernière fois par acte reçu par-devant Maître Gérard Lecuit en date du 16 mars 2004, non encore publié.
2. Le capital social de la Société s’élève actuellement à soixante-sept millions deux cent soixante mille trois cents qua-
tre-vingt onze euros et vingt-cinq cents (EUR 67.260.391,25), représenté par cinquante-trois millions huit cent huit mille
trois cent treize (53,808,313) actions sans valeur nominale.
3. Aux termes de l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cent deux millions quatre cent mille
euros (EUR 102.400.000,-) et l’article 5 des statuts de la Société autorise le Conseil d’Administration à augmenter le
capital social de la Société dans les limites du capital autorisé et d’exclure les droits de préemption des actionnaires
existants, et notamment d’émettre selon ces termes sept millions cinq cent mille (7.500.000) actions dans le cadre d’une
offre publique initiale des actions de la Société sous forme de certificats suédois de dépôt («Swedish Depository Re-
ceipts») sur la liste «O» de la bourse de Stockholm.
4. Lors de sa réunion du 24 mars 2004, le Conseil d’Administration a décidé, cette décision étant expressément sou-
mise à la réception du paiement de l’intégralité de la souscription, d’augmenter le capital social de la Société d’un mon-
tant de trois millions huit cent soixante quinze mille euros (EUR 3.875.000,-) dans les limites du capital social autorisé
par l’émission de trois millions cent mille (3.100.000) nouvelles actions ordinaires de la Société sans valeur nominale,
avec exclusion des droits de préemption d’actionnaires existants, et avec une prime d’émission cumulée d’un montant
de cinquante neuf millions huit cent quarante six mille cent quarante et un euros et cinquante sept cents (EUR
59.846.141,57).
5. Une liste contenant le nom des présents souscripteurs et le nombre d’actions souscrites est attachée au présent
acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.
6. Lors de la même réunion du 24 mars 2004, le Conseil d’Administration a donné pouvoir à CARNEGIE INVEST-
MENT BANK AB d’émettre un certificat de blocage attestant que le montant de soixante trois millions sept cent vingt
et un mille cent quarante et un euros et cinquante sept cents (EUR 63,721,141.57) est à la libre disposition de la Société.
Il a été décidé que la remise dudit certificat de blocage par CARNEGIE INVESTMENT BANK AB au comparant consti-
tuerait la preuve formelle de la réalisation de la condition suspensive de la prédite augmentation de capital social et de
la prédite émission d’actions, qui deviendraient effectives et définitives par l’effet de ladite remise.
7. Le comparant produit un certificat de blocage émis par CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, avec siège social à
Stockholm (Suède), en date du 29 mars 2004. Il résulte dudit certificat de blocage que le montant de soixante trois mil-
lions sept cent vingt et un mille cent quarante et un euros et cinquante sept cents (EUR 63.721.141,57) est à la libre
disposition de la Société tel que la preuve en a été rapportée au notaire soussigné. Ledit certificat de blocage restera
attaché au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.
8. En conséquence de la remise dudit certificat de blocage, la seule condition subsistante pour l’augmentation de ca-
pital est réalisée de sorte que la prédite augmentation de capital social de la Société et la prédite émission de nouvelles
actions sont à considérer comme effectives et définitives à la date de ce jour.
9. En conséquence de l’augmentation de capital qui précède, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la
Société a désormais la teneur suivante:
28608
«Le capital social est fixé à soixante et onze millions cent trente cinq mille trois cent quatre-vingt onze euros et vingt
cinq cents (EUR 71.135.391,25), représenté par cinquante six millions neuf cent huit mille trois cent treize (56.908,313)
actions, sans valeur nominale.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare, par application de l’article 32-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales telle que mo-
difiée, avoir vérifié que les conditions de l’article 26 de la loi précitée ont été remplies.
<i>Frais, évaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite
aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à six cent quarante quatre mille euros (EUR 644.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, Notaire, le présent acte.
Signé: F. Brouxel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, vol. 143S, fol. 6, case 8.– Reçu 637.211,42 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032315.3/220/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(032316.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.
TER-PROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 53.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03703, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031850.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 21 avril 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 22 avril 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
GTECH Global Services Corporation Limited (Luxembourg branch)
GTECH Global Services Corporation Limited
Launer International S.A.
ADD Venture S.A.
Dictame Holding S.A.
Northern Neft Investments, S.à r.l.
Northern Neft Investments, S.à r.l.
Northern Neft Investments, S.à r.l.
Premier Cru International N.V.
The Private Equity Company S.A.
Sidfin S.A.
Predicai Europe S.A.
Predicai Europe S.A.
Immoline, S.à r.l.
Prudential International Funds
Sidarta Finance Holding S.A.
Sidarta Finance Holding S.A.
Fomaxx, S.à r.l.
Laperle S.A.
Provincial Capital Investment, S.à r.l.
Provincial Capital Investment, S.à r.l.
Provincial Capital Investment, S.à r.l.
Européenne de Conseils S.A.
Groupe A.O.H.
Comptaplus S.A.
Dalyan S.A.
Dalyan S.A.
Dalyan S.A.
Hasi Invest S.A.
Compagnie de Gneis et Gabro S.A.
FRS Luxembourg S.A.
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l. et Cie
F.I.B. S.A., First International Broker
Apollo Ventures S.A.
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l.
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l.
De Cillia Les Carrelages, S.à r.l.
Markets Informations Virtual Exchange S.A.
Eximp Roger Greden, S.à r.l.
Total Holding S.A.
Total Holding S.A.
Eurowatt, S.à r.l.
Fausis S.A.
Fausis S.A.
Giochi Preziosi Lussemburgo S.A.
Systèmes Technologiques Industriels (S.T.I.) S.A.
Immobilière Parc Everlange S.A.
Bombardier Luxembourg Investments S.A.
Bersabee S.A.
A Holding S.A.
Francistown S.A.
Francistown S.A.
Architon S.A.
Full Services Engineering S.A.
Blue Lion S.A.
Blue Lion S.A.
REC Real Estate Company S.A.
Sports et Loisirs Concept S.A.
Griko Finance S.A.
Griko Finance S.A.
Tallman Consulting S.A.
Tallman Consulting S.A.
Bul-Investment S.A.
Globe Total Investments Holdings S.A.
Littoral Côte d’Azur S.A.
Columeta, S.à r.l.
Sea Bird Investments S.A.
Oriflame Cosmetics S.A.
Oriflame Cosmetics S.A.
Ter-Prom, S.à r.l.