This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
26929
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 562
1
er
juin 2004
S O M M A I R E
FI NEW OPPORTUNITIES II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.866.
—
Conformément à un contrat signé en date du 26 mars 2004 («Forward Sale Agreement»), l’associé unique de la So-
ciété, DEUTSCHE BANK A.G., société de droit allemand a vendu 100% des parts détenues dans la Société à la société
CAYMAN CABLE HOLDING L.P., limited partnership de droit des Iles Cayman.
Le transfert des parts a pris effet à la date du 13 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02177. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030039.3/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Baypower, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26959
GC Pan European Crossing Luxembourg I, S.à r.l.,
Bechtel Enterprises Energy, S.à r.l., Luxembourg .
26931
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26932
Belair Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26962
GC Pan European Crossing Luxembourg II, S.à r.l.,
Brenntag Luxco S.C.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . .
26933
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26976
Challenger Reassurance S.A., Senningerberg . . . . .
26960
Ilos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26968
Denia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26976
Inveslife Capital Management S.A., Luxembourg .
26930
Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .
26961
Investorgames Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
26958
Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .
26969
Jinbang Steel Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
26972
Diy-Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26975
Lulu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26932
Diy-Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26975
Moet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26958
EFG Asset Management S.A., Luxembourg . . . . . .
26974
Moet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26958
EFG Profiles Fund Management Company S.A.,
MTT Services International S.A., Luxembourg. . .
26930
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26974
Shanara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26966
European Golf Association, A.s.b.l., Senningerberg
26959
Siko Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26931
European Golf Association, A.s.b.l., Senningerberg
26959
Siko Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26931
Exess Développement Luxembourg S.A., Luxem-
Toitures Zanotti et Fils, S.à r.l., Dudelange . . . . . .
26965
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26975
Versa Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26963
Expo-Prom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26967
Versa Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26965
FI New Opportunities II, S.à r.l., Luxembourg . . . .
26929
<i>Pour FI NEW OPPORTUNITIES II, S.à r.l.
i>BONN SCHMITT STEICHEN
J. Steffen
26930
MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 43.070.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d’une décision du Liquidateur prise à Luxembourg en date du 18 mars 2004 que:
Le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte est transféré à L-1258 Luxem-
bourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00751. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029933.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
INVESLIFE CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 88.663.
—
L’an deux mille quatre, le trente mars.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
S’est réunie:
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESLIFE CAPITAL MANAGEMENT
S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 2 août 2002, publié au Mémorial C n
°
1476 en date du 11 octobre 2002, dont les statuts ont été mo-
difiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mars 2003, publié au Mémorial C n
°
428 du 18 avril
2003.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Farid Bentebbal, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Décision de mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur avec fixation de ses pouvoirs.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) ne varietur par les mandataires.
III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée, et qu’il a
donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société et la fixation du nombre des liquidateurs à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée à la fonction de liquidateur:
La société REVILUX S.A., ayant son siège social au L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assem-
blée générale des actionnaires dans les cas où elle serait normalement requise.
Il peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou à plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.
<i>Fraisi>
Les frais et charges en rapport avec les présentes resteront à charge de la société.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
26931
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Bentebbal, A. Francini, L. Capiaux, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
avril 2004, vol. 883, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(030051.3/237/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
BECHTEL ENTERPRISES ENERGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 80.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00582, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2004.
(030414.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
SIKO CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 77.524.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social le 4
juillet 2003 que:
La démission de Madame Elsa Berti, établie à Via Carlo Veneziani, 58 Palais B, 00148 Roma, Italie, en sa qualité d’ad-
ministrateur est acceptée. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l’exercice au
31 décembre 2002.
Est nommée en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Antonella Menghini, née à Civitavecchia
(RM) le 17 juin 1956, demeurant à Fiumicino (RM), Via Ortona 38.
La démission de Monsieur Aldo Occhipinto, établi à Via Carlo Veneziani, 58, Palais B, 00148 Roma, Italie, en sa qualité
de Commissaire aux Comptes est acceptée. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clô-
turant l’exercice au 31 décembre 2002.
Est nommé en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire Monsieur Donato Carreta, né le 17 fé-
vrier 1960, résidant à Rome, Via Archimede 41.
Leur mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l’exercice clos au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05755. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029693.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
SIKO CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 77.524.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 4 dé-
cembre 2003 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes
suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-
Rue, L-1660.
Monsieur Mauro Cavallini, administrateur de sociétés, élisant domicile au Dott. ALDO OCCHIPINTI ASSOCIATE,
Via Carlo Veneziani, 58 Palais B, 00148 Roma, Italie.
Madame Antonella Menghini, demeurant à Fiumicino (RM), Via Ortona 38.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Le mandat du Commissaire aux comptes étant venue à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Com-
missaire aux Comptes de la personne suivante:
Differdange, le 5 avril 2004.
R. Schuman.
<i>Pour BECHTEL ENTERPRISES ENERGY, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
Pour réquisition- inscription
Signature
26932
Monsieur Donato Carreta, résidant à Rome, Via Archimede 41.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le
4 décembre 2003 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue de façon extra-
ordinaire au siège social à Luxembourg en date du 4 décembre 2003, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG)
S.A., société de droit luxembourgeois, sis au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille
euros (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de
l’achat, de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux ad-
ministrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00127. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029691.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
GC PAN EUROPEAN CROSSING LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.471.
—
<i>Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour des changements au Conseil de gérancei>
Il a été décidé:
1) de nommer trois nouveaux gérants au Conseil de gérance de GC PAN EUROPEAN CROSSING LUXEMBOURG
I, S.à r.l., à compter du 11 mars 2004:
- Monsieur Keogh Bernard, né à Baile Atha Cliath/Dublin (Irlande), le 13 septembre 1967, demeurant à 12, Brighton
Court, Brighton Road, Foxroch/Dublin, 18 Irlande
- Monsieur Arthur Eshuis, né à Rijssen (Pays-Bas), le 2 juin 1966, demeurant à Nassaukade 113-hs, 1052 EA Amster-
dam, Pays-Bas
- Mademoiselle Sylvia Infanger, né à Fribourg, (Suisse), le 5 avril 1957, demeurant à 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg
2) d’accepter la démission de:
- Monsieur Dugan Terrence Lee, né à Swain Country, North Carolina, (U.S.A.), le 21 juin 1959, demeurant à 14 Ful-
mer Way, Gerrards Cross, Buckinghamshire, SL9 8AH, Grande-Bretagne, et ce en date du 18 décembre 2003;
et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04450. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029937.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
LULU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 86.108.
—
Suite au déménagement du Cabinet d’Avocats Pierre Delandmeter, domiciliataire de la société LULU HOLDING S.A.
7, rue du Saint-Esprit L-1475 Luxembourg, R. C. B 86.108.
Il résulte que le siège social de cette société se trouve maintenant au 8-10, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 15 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01833. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029713.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour réquisition - inscription
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société LULU HOLDING S.A.
i>Signature
26933
BRENNTAG LUXCO, Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 97.313.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-fifth of February.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
Is held an extraordinary general meeting of shareholders of BRENNTAG LUXCO (the «Company»), a société en
commandite par actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the
Luxembourg trade and companies’ register under section B number 97.313, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on the 25 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 6 of 3 January 2004. The articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of the undersigned
notary, on the 26 January 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is opened at 11.50 a.m., with Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Miss Rachel Uhl, juriste, residing in Luxembourg. who was also elected as scrutineer Miss
Rachel Uhl, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Creation of different classes of shares divided into class A ordinary shares (the «Class A Ordinary Shares») and
management share(s) (the «Management Share(s)»);
2) Introduction of new provisions into the articles of incorporation providing for the issue of redeemable shares;
3) Conversion of the one hundred ninety-two thousand eight hundred (192,800) existing shares, into one hundred
ninety-two thousand seven hundred ninety-nine (192,799) Class A Ordinary Shares and one (1) Management Share,
4) Increase of the share capital from its present amount of two hundred forty-one thousand euro (EUR 241,000) up
to three million one hundred fourteen thousand five hundred two euro fifty cents (EUR 3,114,502.50) by the issue of
two million two hundred ninety-eight thousand eight hundred two (2,298,802) Class A Ordinary Shares having a nominal
value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each;
5) Authorisation of the manager to increase the share capital of the Company within the limits of the authorised share
capital without reserving a preferential subscription right to the existing shareholders,
6) Full restatement of the articles of incorporation of the Company;
7) Miscellaneous
II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.
III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to create shares divided into class A ordinary shares (the «Class A Ordinary Shares») and man-
agement share(s) (the «Management Share(s)») which are more precisely specified below in the new articles 6 and 7 of
the articles of incorporation.
The Class A Ordinary Shares and Management Share(s) are hereinafter collectively referred to as the «Shares».
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides that the Company may issue redeemable shares. The redeemable shares bear the same
rights to receive dividends and have the same voting rights as ordinary shares. Subscribed and fully paid in redeemable
shares shall be redeemable upon request of the Company in accordance with the provisions of Article 49-8 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. The redemption of the redeemable shares can only be made
by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. The redeemed shares bear no
voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.
All of the Class A Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provisions of Article 49-8 of the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, except for those issued and subscribed for prior to the
insertion of the present article in the articles of incorporation.
The article relation to the redeemable shares to be inserted into the articles of incorporation shall read as follows
«Art 6.3. Redemption; Convertibility.
(a) Redeemable Shares. The Company may issue redeemable shares in accordance with the terms of these Articles
and the provisions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. The Class A
Ordinary. Shares are redeemable shares in accordance with the present Article 6.3 and the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended. All redeemable shares shall bear the same rights to receive dividends and other
distributions (including liquidation proceeds) and shall have the same voting rights as the Class A Ordinary Shares. Sub-
26934
scribed and fully paid-in redeemable shares may be redeemed upon a request of the Company made in accordance with
the provisions of these Articles. All redemptions shall be made on a pro rata basis among all holders of each class of
redeemable shares subject to such redemption. The redemption of redeemable shares can only be made by using sums
available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (dis-
tributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the company as an issue
premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Upon redemption, the redeemed
shares shall bear no voting rights and have no rights to receive any dividends, distributions or liquidation proceeds. The
Company may cancel the redeemed shares upon a decision of the Manager.
(b) Special Reserve. In the event of a partial or total redemption of any redeemable shares, an amount equal to the
nominal value, or in the absence thereof, the par value, of all the shares redeemed must be included in a reserve which
cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the
reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves.
(c) Redemption Price. Except as otherwise provided in these Articles or by a written agreement which may be en-
tered into among the shareholders, the redemption price applicable to any redemption of the redeemable shares shall
be calculated by the Manager(s) or by such person appointed by the Manager(s) on the basis of the net asset value of all
assets and liabilities of the Company. The net asset value of the Company’s shares shall be expressed as a per share
figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value
of the Company’s assets less its liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the Company then
outstanding at such close of business, in accordance with the rules the Manager(s) shall reasonably regard as fair and
equitable. In the absence of bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the Manager(s) with respect
to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and
future shareholders.
(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among
the shareholders of the Company at least ten (10) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by
registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the shares to be re-
deemed, at his or her address last shown in the shareholder’s register of the Company, notifying such holder of the
number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price and the procedures neces-
sary to submit the shares to the Company for redemption. Each holder of shares to be redeemed shall surrender the
certificate or certificates, if any, issued in relation to such shares to the Company. The redemption price of such shares
shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank
account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.
(e) Management Share(s). The Management Share(s) are not redeemable shares and may not be redeemed by the
Company.»
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to convert the one hundred ninety-two thousand eight hundred (192,800) existing shares, into
one hundred ninety-two thousand seven hundred ninety-nine (192,799) Class A Ordinary Shares and one (1) Manage-
ment Share, as follows:
1) the one hundred ninety-two thousand seven hundred ninety-nine (192,799) shares owned by BRENNTAG-INTER-
FER (BC), a société en commandite par actions incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, with registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, are hereby converted into one hundred
ninety-two thousand seven hundred ninety-nine (192,799) Class A Ordinary Shares; and
2) the one (1) share owned by BRENNTAG, a société anonyme incorporated and governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, is hereby converted into
one (1) Management Share.
<i>Fourth resolution i>
The meeting decides to increase the share capital of an amount of two million eight hundred seventy-three thousand
five hundred two euro fifty cent (EUR 2,873,502.50) in order to increase it from its current amount of two hundred
forty-one thousand euro (EUR 241,000) up to three million one hundred fourteen thousand five hundred two euro fifty
cent (EUR 3,114,502.50) through the issue of two million two hundred ninety-eight thousand eight hundred two
(2,298,802) Class A Ordinary Shares having a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share.
The two million two hundred ninety-eight thousand eight hundred two (2,298,802) new Class A Ordinary Shares
have been subscribed as follows:
1) two million one hundred ninety-five thousand eight hundred eighty-eight (2,195,888) Class A Ordinary Shares have
been subscribed by BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A., prenamed, for a total amount of two million seven hundred
forty-four thousand eight hundred sixty euro (EUR 2,744,860);
2) twenty-one thousand thirty-six (21,036) Class A Ordinary Shares have been subscribed by Mr Daniel Yves André
Pithois, member of the Executive Board of BRENNTAG AG, residing at 4 Allée de Pommeraie, F-91570 Bièvres, France,
for a total amount of twenty-six thousand two hundred ninety-five euro (EUR 26,205);
3) twenty-five thousand two hundred forty-three (25,243) Class A Ordinary Shares have been subscribed by Mr Jür-
gen Buchsteiner, member of the Executive Board and Chief Financial Officer of BRENNTAG AG, residing at Stübben-
hauser Str. 20b, D-40822 Duisburg, Germany, for a total amount of thirty-one thousand five hundred fifty-three euro
seventy-five cent (EUR 31,553.75);
4) twenty-four thousand (24,272) Class A Ordinary Shares have been subscribed by Mr Klaus Arthur Engel, Chairman
of the Executive Board and Chief Executive Officer of BRENNTAG AG, residing at Am Botanischen Garten 20, D-
47058, Duisburg, Germany, for a total amount of thirty thousand three hundred forty euro (EUR 30,340);
26935
5) eight thousand ninety-one (8,091) Class A Ordinary Shares have been subscribed by Mrs Doris Engel, residing at
Obermatten 11, 79194 Gundelfingen, Germany, for a total amount of ten thousand one hundred thirteen euro seventy-
five cent (EUR 10,113.75);
6) twenty-four thousand two hundred seventy-two (24,272) Class A Ordinary Shares have been subscribed by Mr
Stephen Rodger Clark, member of the Executive Board of BRENNTAG AG, residing at 532 Campus Road, Wyomissing,
PA 19610, USA, for a total amount of thirty thousand three hundred forty euro (EUR 30,340).
Ms. Doris Engel shall be considered as a Permitted Transferee of Mr Klaus Engel for purposes of the articles of asso-
ciation of the Company and the Executive Equity Subscription Agreement which may be entered into between herself,
the Company, BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A., and the other Executives listed on the Schedule of Executives at-
tached thereto.
The shares subscribed have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of two million eight hundred
seventy-three thousand five hundred two euro fifty cent (EUR 2,873,502.50) representing two million eight hundred
seventy-three thousand five hundred two euro fifty cent (EUR 2,873,502.50) for the share capital is at the disposal of
the company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to renew and approve the authorisation of the manager of the Company to increase the share
capital of the Company up to an amount of five hundred million euro (EUR 500,000,000) for a period ending five years
after the date of publication of the present shareholders’ resolution in the Luxembourg official gazette (Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations).
Based on the report provided by the sole manager, the general meeting unanimously resolves in accordance with
article 32-3 (5) of the law of 1915 to authorise the manager to suppress the preferential right of subscription of the
existing shareholders within the limits of the authorised share capital.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to fully restate the articles of incorporation of the Company which shall henceforth be
read as follows:
A. Name - Registered Office - Duration - Object
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future,
a company in the form of a société en commandite par actions under the name of BRENNTAG LUXCO (hereinafter
the «Company»).
Art. 2. The registered office of the Company is established in Munsbach - Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.
Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by res-
olution of the Manager. In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have
occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
with the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
B. Management - Share Capital
Art. 5. The general partner of the Company (associé commandité) is jointly and severally liable for all liabilities which
cannot be paid out of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the
general partner), being the holder(s) of Class A Ordinary Shares, shall refrain from acting on behalf of the Company in
any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable
to the extent of their contributions to the Company.
Art. 6. Corporate Capital
Art 6.1. Subscribed Capital.
The Company has a subscribed capital of three million one hundred fourteen thousand five hundred two euro fifty
cent (EUR 3,114,502.50) represented by fully paid up shares, consisting of two million four hundred ninety-one thousand
six hundred one (2,491,601) Class A Ordinary Shares with a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each
(herein, the «Class A Ordinary Shares») and one (1) Management Share with a par value of one euro twenty-five cents
(EUR 1.25) each (herein, the «Management Share»).
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles. The Company may, to the extent and under terms permitted by
law, redeem its own shares.
26936
All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any
separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled
to any pre emptive rights with respect to any shares of the Company except as may be required by law or as otherwise
provided in any agreement which may be entered into by the Company and the Class A Ordinary Shareholders.
Art 6.2. Description of the shares.
Art. 6.2.1. The Class A Ordinary Shares.
(a) The Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A Ordinary
Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends,
which are allocated on an aggregate basis to such Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares purchased or
otherwise acquired by the Company shall, if the Manager so directs, be retired with the effect that the issued number
of Class A Ordinary Shares is reduced. Any redemption, retirement, or other acquisition by the Company of Class A
Ordinary Shares shall be done on a pro rata basis among all holders of Class A Ordinary Shares with the same terms
and conditions (including price per share) applicable to all such holders.
(b) Voting Rights. Each Class A Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which
the holders thereof have the right to vote.
Art. 6.2.2. The Management Share(s).
(a) The Management Share(s). All Management Share(s) shall be identical in all respects. All Management Share(s) shall
share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are
allocated on an aggregate basis to such Management Share(s).
(b) Voting Rights. Each Management Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which the
holders thereof have the right to vote.
Art 6.3. Redemption; Convertibility.
(a) Redeemable Shares. The Company may issue redeemable shares in accordance with the terms of these Articles
and the provisions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»). The
Class A Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the present Article 6.3 and the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended. All redeemable shares shall bear the same rights to receive dividends and
other distributions (including liquidation proceeds) and shall have the same voting rights as the Class A Ordinary Shares.
Subscribed and fully paid-in redeemable shares may be redeemed upon a request of the Company made in accordance
with the provisions of these Articles. All redemptions shall be made on a pro rata basis among all holders of each class
of redeemable shares subject to such redemption. The redemption of redeemable shares can only be made by using
sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraor-
dinary reserve established with the funds received by the company as an issue premium) or the proceeds of a new issue
made with the purpose of such redemption. Upon redemption, the redeemed shares shall bear no voting rights and have
no rights to receive any dividends, distributions or liquidation proceeds. The Company may cancel the redeemed shares
upon a decision of the Manager.
(b) Special Reserve. In the event of a partial or total redemption of any redeemable shares, an amount equal to the
nominal value, or in the absence thereof, the par value, of all the shares redeemed must be included in a reserve which
cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the
reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves.
(c) Redemption Price. Except as otherwise provided in these Articles or by a written agreement which may be en-
tered into among the shareholders, the redemption price applicable to any redemption of the redeemable shares shall
be calculated by the Manager(s) or by such person appointed by the Manager(s) on the basis of the net asset value of all
assets and liabilities of the Company. The net asset value of the Company’s shares shall be expressed as a per share
figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value
of the Company’s assets less its liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the Company then
outstanding at such close of business, in accordance with the rules the Manager(s) shall reasonably regard as fair and
equitable. In the absence of bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the Manager(s) with respect
to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and
future shareholders.
(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among
the shareholders of the Company at least ten (10) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by
registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the shares to be re-
deemed, at his or her address last shown in the shareholder’s register of the Company, notifying such holder of the
number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price and the procedures neces-
sary to submit the shares to the Company for redemption. Each holder of shares to be redeemed shall surrender the
certificate or certificates, if any, issued in relation to such shares to the Company. The redemption price of such shares
shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank
account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.
(e) Management Share(s). The Management Share(s) are not redeemable shares and may not be redeemed by the
Company.
Art 6.4. Right to Purchase Certain Ordinary Shares.
(a) Call Option. In the event that any holder of Ordinary Shares employed by the Company or one of its Subsidiaries
(an «Executive») is no longer employed by the Company or any of its Subsidiaries for any reason (the date of such ter-
mination being referred to herein as the «Termination Date»), such Executive’s Ordinary Shares together with any oth-
er Securities of the Company subscribed for by such Executive (collectively, «Executive Securities»), whether held by
26937
such Executive or one or more of his or her Permitted Transferees, will be subject to be purchased by the Investors or
Tier 1 Executives pursuant to the terms and conditions set out in this Article 6.4 (the «Call Option»).
(b) Executive’s Termination for Cause. If such Executive is no longer employed by the Company or any of its Subsid-
iaries as a result of such Executive’s employment with the Company or its Subsidiaries being terminated for Cause by
the Company or any of its Subsidiaries (such Executive, a «Bad Leaver»), (and the burden of proving Cause shall rest
with the Person exercising the Call Option), then on or after the Termination Date, the Investors may elect to purchase
all or any portion of such Executive’s Executive Securities at the Bad Leaver Call Option Price, and, if the Investors elect
not to exercise the Call Option, then the Tier 1 Executives shall have the right to purchase such Executive’s Executive
Securities at the Bad Leaver Call Option Price, in each case in accordance with the procedures set out below.
(c) Resignation Not For Good Reason. If such Executive is no longer employed by the Company or any of its Subsid-
iaries as a result of such Executive’s (i) resigning and terminating his or her employment without Good Reason or (ii) if
such Executive has an employment agreement with a fixed term, refusing an offer to renew such employment agreement
on no less favorable terms and conditions without Good Reason (a «Non Good Reason Leaver»), (and the burden of
proving Good Reason shall rest with the Executive), then on or after the Termination Date, the Investors and the Tier
1 Executives may elect to purchase all or any portion of such Executive’s Executive Securities at a price per Executive
Security equal to such Executive Securities Non Good Reason Leaver Call Option Price, and if the Investors elect not
to exercise the Call Option, then the Tier 1 Executives shall have the right to purchase such Executive’s Executive Se-
curities at the Non Good Reason Leaver Call Option Price, in each case in accordance with the procedures set out
below.
(d) Executive’s Termination As Good Leaver. If such Executive is no longer employed by the Company or any of its
Subsidiaries as a result of such Executive’s employment being terminated by the Company or any of its Subsidiaries, or,
if such Executive has an employment agreement with a fixed term, if the Company or any of its Subsidiaries does not
offer to renew such Executive’s employment agreement on no less favorable terms and conditions, then such Executive
shall be presumed to be a «Good Leaver» unless (i) his or her employment was terminated for Cause, (ii) if such Exec-
utive has an employment agreement with a fixed term, he or she was not offered a new employment agreement for
Cause, or (iii) if such Executive has an employment agreement with a fixed term, he or she was offered a new employ-
ment agreement but on terms and conditions less favorable than those of the employment agreement previously in force
for Cause, (and the burden of proving Cause shall rest with the Person exercising the Call Option), then on or after the
Termination Date, the Investors and the Tier 1 Executives may elect to purchase all or any portion of such Executive’s
Executive Securities at a price per Executive Security equal to the Good Leaver Call Option Price, and, if the Investors
elect not to exercise the Call Option, then the Tier 1 Executives shall have the right to purchase such Executive’s Ex-
ecutive Securities at the Good Leaver Call Option Price, in each case in accordance with the procedures set forth below.
(e) Executive’s Termination for Good Reason. If such Executive is no longer employed by the Company or any of its
Subsidiaries as a result of such Executive (i) resigning and terminating his or her employment for Good Reason (and the
burden of proving Good Reason shall rest with the Executive), or (ii) if such Executive has an employment agreement
with a fixed term, refusing an offer to renew such employment agreement for Good Reason, (and the burden of proving
Good Reason shall rest with the Executive), then on or after the Termination Date the Investors may elect to purchase
all or any portion of such Executive’s Executive Securities at the Good Leaver Call Option Price, and if the Investors
elect not to exercise the Call Option, then the Tier 1 Executives shall have the right to purchase such Executive’s Ex-
ecutive Securities at the Good Leaver Call Option Price, in each case in accordance with the procedures set out below.
(f) Call Option Exercise Procedures. Within thirty (30) days of the Termination Date of an Executive, the Company
will deliver written notice to the Investors setting out the name of such Executive and the Termination Date. The In-
vestors may elect to exercise the right to purchase all or any portion of such Executive’s Executive Securities pursuant
to the Call Option by delivering written notice (the «Call Option Exercise Notice») to the holder or holders of such
Executive’s Executive Securities within ninety (90) days after such Executive’s Termination Date. The Call Option Ex-
ercise Notice will set out the amount of such Executive’s Executive Securities to be acquired from such holder(s), the
aggregate consideration to be paid for such Executive Securities and the time and place for the closing of the transaction.
If any of the Executive Securities is held by Permitted Transferees of the relevant Executive, the Investors shall purchase
the Executive Securities elected to be purchased from such holder(s) of Executive Securities pro rata according to the
number of Executive Securities held by such holder(s) at the time of delivery of such Call Option Exercise Notice.
(g) Assignment Rights. If the Investors shall have elected to exercise the Call Option, then at any time prior to the
exercise of the Call Option, the Investors shall first offer to each Tier 1 Executive employed by the Company or any of
its Subsidiaries as of the date that such Call Option is exercisable the opportunity to purchase such Tier 1 Executive’s
pro rata portion of the Executive Securities to be acquired in connection with such Call Option (based on the percent-
age of the total number of outstanding Class A Ordinary Shares held by such Tier 1 Executive as of the relevant Termi-
nation Date). If the Tier 1 Executive does not elect to purchase such Tier 1 Executive’s pro rata share, the Investors
may elect either to allocate such non-participating Tier 1 Executive’s portion to Tier 1 Executives who have elected to
exercise the Call Option or to assign all or any portion of the Call Option on the remaining Executive Securities (in-
cluding, for the avoidance of doubt, the Investors’ pro rata portion) to the Company or to other Securityholders, if any
(the «Other Investors»). Such election shall be effective with respect to all or any portion of the Call Option. If any
portion of the Call Option is assigned to any Executive, the Company, or the Other Investors, as the case may be, then
prior to the ninetieth (90th) day following the Termination Date, such Tier 1 Executives, the Company or the Other
Investors, as the case may be, will be entitled to exercise the Call Option in the manner set forth in this Article 6.4. If
the Company exercises the Call Option, the Securities so acquired shall be redeemed in accordance with the provisions
of Article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. If any Executive Securities shall not
26938
have been purchased by any of the Executives, the Company or the Other Investors pursuant to this Article 6.4(f), then
the Investors shall purchase any remaining Executive Securities pursuant to the Call Option.
(h) Executive Call Option Rights. If the Investors shall have elected not to exercise the Call Option, then the Tier 1
Executives shall have sixty (60) days from the earlier of the date as of which the Investors shall have notified the Com-
pany that they do not intend to exercise the Call Option and the ninety-first (91st) day after the relevant Executive’s
Termination Date (the «Call Option Transfer Date»), to exercise the Call Option. Each Executive shall have the right
to purchase such Executive’s pro rata portion of the Executive Securities to be acquired in connection with such Call
Option (based on the number of Class A Ordinary Shares held by the Executives). If any Tier 1 Executive does not elect
to purchase such Executive’s pro rata share, such Tier 1 Executive may elect to assign all or any portion of the Call
Option to any Tier 1 Executives who have exercised, or have indicated that they intend to exercise, the Call Option. If
any portion of the Call Option is exercised by any Executive pursuant to this Article 6.4(g), then prior to the sixtieth
(60th) day following the Call Option Transfer Date, such Executives will be entitled to exercise the Call Option in the
manner set forth in this Article 6.4.
Closing. The closing of the transactions contemplated by this Article 6.4 will take place on the date designated by the
Investors or the Tier 1 Executives in the Call Option Exercise Notice, which date will not be more than sixty (60) days
after the delivery of such Call Option Exercise Notice. The Investors or their permitted assignees, including the Tier 1
Executives, the Other Investors, and the Company, as the case may be, will pay for the Executive Securities to be pur-
chased pursuant to the Call Option by delivery of a check or a wire transfer of immediately available funds payable to
the holder of such Executive Securities in the aggregate amount equal to the purchase price for such Executive Securi-
ties. The Investors, the Other Investors, the Tier 1 Executives, or the Company, as the case may be, will receive no
representations and warranties from any seller regarding the sale of the Executive Securities to the relevant purchaser,
other than representations and warranties that such seller has good and marketable title to the Executive Securities to
be transferred free and clear of all liens, claims and other encumbrances, and the representation that the seller has due
authority to enter into the agreements for the sale of Executive Securities.
(j) Termination of Repurchase Right. The rights of the Investors to purchase Executive Securities pursuant to this
Article 6.4 shall terminate upon a Sale of the Company.
Art 6.5. Right to Sell Certain Ordinary Shares.
(a) Put Option. In the event that an Executive is no longer employed by the Company or any of its Subsidiaries due
to the death or Disability of such Executive and in the event of the death or Disability of a holder of Executive Securities
whose employment with the Company or any of its Subsidiaries has terminated, and if the Investors and the Tier 1 Ex-
ecutives choose not to exercise the Call Option under Article 6.4 above, then the relevant Executive, or one or more
of his or her Permitted Transferees, shall have the right to require the Investors to purchase pursuant to the terms and
conditions set out in this Article 6.5 such number of the Executive’s Executive Securities at the Good Leaver Call Option
Price that the aggregate purchase price is equal to or less than the aggregate Original Cost of all such Executive’s Exec-
utive Securities (the «Put Option»). For the avoidance of doubt, the relevant Executive, or one or more of his or her
Permitted Transferees, shall have the right to keep any remaining Executive’s Executive Securities pursuant to the terms
and conditions of these Articles.
(b) Put Option Exercise Procedures. If an Executive or one or more of his or her Permitted Transferees elects to
exercise the Put Option, such Executive or Permitted Transferee must deliver a written notice (the «Put Option Exer-
cise Notice») to the Investors within sixty (60) days of the sixtieth (60th) day following the Call Option Transfer Date.
The Put Option Exercise Notice will set out the amount of such Executive’s Executive Securities to be sold, the aggre-
gate consideration to be paid for such Executive Securities and the time and place for the closing of the transaction.
(c) Assignment Rights. Any Investor may assign its rights and obligations under the Put Option to any of its Permitted
Transferees or to the Company. If the Company acquires the Executive Securities pursuant to the Put Option, the Se-
curities so acquired shall be redeemed in accordance with the provisions of Article 49-8 of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended.
(d) Closing. The closing of the transactions contemplated by this Article 6.5 will take place on the date designated by
the relevant Executive or his or her Permitted Transferees in the Put Option Exercise Notice, which date will not be
more than sixty (60) days after the delivery of such Put Option Exercise Notice. The Investors or their permitted as-
signees, including the Tier 1 Executives, the Other Investors, and the Company, as the case may be, will pay for the
Executive Securities to be purchased pursuant to the Put Option by delivery of a check or a wire transfer of immediately
available funds payable to the holder of such Executive Securities in the aggregate amount equal to the purchase price
for such Executive Securities. The Investors, the Other Investors, the Tier 1 Executives, or the Company, as the case
may be, will receive no representations and warranties from any each seller regarding the sale of the Executive Securities
to the relevant purchaser other than representation and warranties that such seller has good and marketable title to
the Executive Securities to be transferred free and clear of all liens, claims and other encumbrances, and the represen-
tation that the seller has due authority to enter into the agreements for the sale of Executive Securities.
(e) Termination of Repurchase Right. The rights and obligations of the Investors to purchase Executive Securities
pursuant to this Article 6.5 shall terminate upon a Sale of the Company.
Art 6.6. Distributions to Shareholders.
If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by
the Manager (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive dis-
tributions, when, as, and if declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Manager out of funds legally
available therefor, in accordance with applicable law, in the manner described in the remaining provisions of this Article
6.6. The holders of the Class A Ordinary Shares and the Management Share(s) shall be entitled to receive all distributions
made by the Company to shareholders, and such distributions shall be made pro rata among the holders of the Class A
26939
Ordinary Shares and the Management Share(s) based on the number of shares held by such holder and should be made
on identical terms and conditions applicable to all holders thereof.
Art 6.7. Liquidation Rights.
In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Com-
pany will be distributed to the shareholders in the manner set out in Article 6.6 above. Neither a merger or consolida-
tion of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or
entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration)
of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article 6.7,
unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan
of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.
Art 6.8. Authorised Capital.
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorised capital which is fixed at five hundred million
euro (EUR 500,000,000) represented by four hundred million (400,000,000) Class A Ordinary Shares having a par value
of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share.
During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-
thorised capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is
authorised to increase in one or several times the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorised capital. Such new shares (Ordinary Shares, preferred shares or shares of any class which
may be issued by the Company) may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may
determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new
shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly
subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Any share issuance by the Company shall
comply with the terms and conditions set forth in any agreement which may be entered into between the Company and
the Class A Ordinary Shareholders. Unless the shareholders shall have otherwise agreed or as set forth otherwise in
any other agreement that may be entered into between the Company and the Class A Ordinary Shareholders, when
realising the authorised capital in full or in part, the Manager is expressly authorised to limit or to waive the preferential
subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly authorised director or of-
ficer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving pay-
ment for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the
subscribed capital performed in the legally required form and in accordance with these Articles by the Manager, this
Article 6.8 shall be adjusted accordingly to reflect such increase.
Art 6.9. Amendment of the subscribed and of the authorised capital.
The subscribed and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles or as set forth in
any agreement that may be entered into between the Company and the Class A Ordinary Shareholders.
Art 6.10. Definitions.
For the purpose of these Articles:
«Articles» means these articles of incorporation as amended from time to time.
«Base Shares» means the Series 1 PECs, the Series 1 CPECs and Class A Ordinary- Shares subscribed for by an Ex-
ecutive.
«Bad Leaver» has the meaning provided in Article 6.4(b).
«Bad Leaver Call Option Price» means, with respect to the Executive Securities subscribed by the relevant Executive,
an amount equal to the lower of (i) the Original Cost and (ii) the Fair Market Value of the Base Shares as of the Termi-
nation Date.
«Call Option» has the meaning provided in Article 6.4(a).
«Call Option Exercise Notice» has the meaning provided in Article 6.4(e).
«Call Option Transfer Date» has the meaning provided in Article 6.4(g).
«Cause» means (i) chronic alcoholism or drug addiction, (ii) material misappropriation of any money or other assets
or property of the Company or the Subsidiaries, (iii), a material breach by an Executive of his contract of employment
which is not cured within thirty (30) days of receipt of a notice from his or her employer requiring cure, (iv) the com-
mission of an imprisonable criminal offence or fraud by an Executive, that in each case results in the termination of the
relevant Executive’s employment and in the removal, resignation or non-renewal of his or her membership of any man-
agement board, Supervisory Board or Board of Directors of the Company or the Subsidiaries of which he or she is a
member or (v) repeated failure to follow directions reasonable for such Executive’s position and given to the Executive
by the Company or any of its Subsidiaries, which directions do not breach or violate any applicable law or the terms of
such employee’s employment contract, for fifteen (15) days following receipt of written notice by the General Partner
of such failure. For the avoidance of doubt, the burden of proof for Cause in any case rests with the person exercising
the Call Option.
«Class A Ordinary Shareholder(s)» means the holders of the Class A Ordinary Shares.
«Class A Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Company» has the meaning provided in Article 1.
«Disability» shall mean, with respect to an Executive, such Executive’s inability to perform the essential duties, re-
sponsibilities and functions of such Executive’s position with the Company as a result of any mental or physical disability
or incapacity taking into account any reasonable accommodations of such disability or incapacity provided by the Com-
pany or in the case of a former Executive, such former Executive’s inability to perform the essential duties, responsibil-
26940
ities and functions of a position similar to the position the former Executive held with the Company or Subsidiary as a
result of any mental or physical disability or incapacity in each case as determined by an independent appropriately qual-
ified medical practitioner appointed by the board of directors of the Manager in its reasonable discretion.
«Executive» has the meaning provided in Article 6.4(a).
«Executive Securities» has the meaning provided in Article 6.4(a).
«Fair Market Value» means, with respect to any Security or Securities, the proportion of the aggregate net proceeds
which the holder of such Security or Securities would be entitled to receive pursuant to a hypothetical liquidating dis-
tribution of the Company where the aggregate proceeds to be distributed in connection with such hypothetical liqui-
dating distribution shall be deemed to be an amount equal to the aggregate net proceeds that the holders of Securities
of the Company would receive in connection with a Sale of the Company at its market value. The process for determi-
nation of such value shall be as follows: (i) with respect to any Tier 1 Executive Security, the value of such Security as
agreed by the board of directors of the Manager and such Tier 1 Executive acting in good faith, provided that if the
Manager and such Tier 1 Executive are not able to reach agreement on such valuation within a period of fifteen (15)
days, the value of such Security or Securities shall be calculated within a period of thirty (30) days thereafter by an in-
vestment firm mutually agreed upon by the Manager and the Tier 1 Executive, provided further that if the Manager and
the Tier 1 Executive cannot mutually agree on an investment firm within a period of thirty (30) days, such investment
firm shall be selected by lot from investment firms listed in Annex A attached here to such valuation being binding upon
the Tier 1 Executive and the Manager, with the costs and expenses of such appraisal to be borne equally by the Company
and such Tier 1 Executive; and (ii) with respect to any Tier 2 Executive Security, as determined by the board of directors
of the Manager acting in good faith.
«Family Group» means an Executive’s parents (whether natural or adopted), spouse and descendants (whether nat-
ural or adopted) and any trust (whether arising under a settlement inter vivos, a testamentary disposition or an intes-
tacy) solely for the benefit of the Executive and/or the Executive’s parents, spouse and/or descendants.
«Good Leaver» has the meaning provided in Article 6.4(d).
«Good Leaver Accretion Percentage» means the Accretion Percentage as set out below, if as of each such date the
Executive is employed by the Company or any of its Subsidiaries:
provided, that if the Good Leaver Accretion Percentage is to be determined on any date falling within one of the
calendar years set out above, the Good Leaver Accretion Percentage will be pro rated on a monthly basis based on the
number of full calendar months which have elapsed since the last date specified in the table above (i.e. if a Termination
Date was determined as 25 August 2007, the applicable Good Leaver Accretion Percentage would be seventy percent
(70%)); provided that upon the occurrence of a Sale of the Company, the Good Leaver Accretion Percentage shall be
deemed to be one hundred percent (100%).
«Good Leaver Call Option Price» means (i) with respect to the Series 1 PECs subscribed for by the relevant Execu-
tive, the face value of such Series 1 PEC plus any unpaid yield thereon and (ii) with respect to the Class A Ordinary
Shares and the Series 1 CPECs subscribed for by the relevant Executive, (A) the Fair Market Value of such Executive
Security multiplied by the Good Leaver Accretion Percentage plus (B) the product of (x) the lower of Fair Market Value
and Original Cost of such Executive Security plus interest accrued at four percent (4%) per annum from the date of
purchase of such Executive Security and (y) one hundred percent (100%) minus the Good Leaver Accretion Percentage.
«Good Reason» means, with respect to any Executive, (A) if he or she resigns from employment or office with the
Company and its Subsidiaries or he or she does not renew his or her employment or office with the Company or any
of its Subsidiaries for one or more of the following reasons: (i) a material breach by the Company or any of the Subsid-
iaries of the employment agreement with such Executive, (ii) change of the Executive’s title or reduction of his or her
responsibilities in a manner materially inconsistent with the position he or she holds, (iii) removal of the Executive from
or failure to renew the Executive’s appointment to any management board, supervisory board or board of directors
without Cause, (iv) failure by the Company or any of its Subsidiaries to offer to renew or prolong the Executive’s em-
ployment agreement a reasonable time before its expiry on terms no less favorable than those of his or her employment
agreement then in force, (v) resignation due to a change in family circumstances that the board of directors of the Man-
ager reasonably determines makes it materially impracticable for the Executive to continue to perform his responsibil-
ities to the Company under the employment agreement between such Executive and the Company, (vi) retirement at
a normal retirement age, and (vii) Disability; (B) any failure by the Company or any Subsidiary to renew the Executive’s
contract of employment on no less favorable terms than his employment contract prior to termination date for any
reason other than Cause; and (C) death in service; provided that written notice of the Executive’s resignation for Good
Reason is be delivered by the Executive to the Company within sixty (60) days after the occurrence of any such event
(except for the death of the Executive).
«Independent Third Party» means any Person who, immediately prior to the contemplated transaction, does not ben-
eficially own in excess of five percent (5%) of the Company’s Ordinary Shares on a fully-diluted basis (a «5% Owner»)
who is not controlling, controlled by or under common control with any such 5% Owner and who is not the spouse or
descendent (by birth or adoption) of any such 5% Owner or a trust for the benefit of such 5% Owner and/or such other
Persons.
Date
Accretion Percentage
Prior to the First Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
First Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Second Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Third Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Fourth Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
Fifth Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
26941
«Initial Closing Date» means, with respect to each Executive, the first date of closing on which such Executive sub-
scribed for any Securities of the Company and on which the Company issued Securities to such Executive.
«Investor» means BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A. and any assignee or transferee of any interest in the Company
directly from BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A. and «Investors» means more than one of them.
«Management Share» has the meaning provided in Article 6.1.
«Manager» has the meaning provided in Article 8.
«Non Good Reason Leaver» has the meaning provided in Article 6.4(c).
«Non Good Reason Leaver Accretion Percentage» means the Accretion Percentage as set out below, if as of each
such date the Executive is employed by the Company or any of its Subsidiaries:
provided, that if the Non Good Reason Leaver Accretion Percentage is to be determined on any date falling within
one of the calendar years set out above, the Non Good Reason Leaver Accretion Percentage will be pro rated on a
monthly basis based on the number of full calendar months which have elapsed since the last date specified in the table
above (i.e. if a Termination Date was determined as 25 August 2007, the applicable Non Good Reason Leaver Accretion
Percentage would be thirty-five percent (35%)); provided that upon the occurrence of a Sale of the Company, the Good
Leaver Accretion Percentage shall be deemed to be one hundred percent (100%).
«Non Good Reason Leaver Call Option Price» means (i) with respect to the Series 1 PECs subscribed for by the
relevant Executive, the face value of such Series 1 PEC plus any unpaid yield thereon and (ii) with respect to the Class
A Ordinary Shares and the Series 1 CPECs subscribed for by the relevant Executive, (A) the Fair Market Value of such
Executive Security multiplied by the Non Good Reason Leaver Accretion Percentage plus (B) the product of (x) the
lower of Fair Market Value and Original Cost of such Executive Security and (y) one hundred percent (100%) minus the
Non Good Reason Leaver Accretion Percentage.
«Ordinary Shares» means the ordinary shares of the Company (excluding the Management Share(s)).
«Original Cost» means, with respect to any Security, the original subscription price paid to the Company by the orig-
inal purchaser of such Security.
«Other Investors» has the meaning provided in Article 6.4(f).
«Permitted Transferee» means any holder of Executive Securities transferred (i) pursuant to applicable laws of de-
scent and distribution or (ii) among an Executive’s Family Group, provided that the restrictions contained in Article 7.3
will continue to be applicable to the Executive Securities after any such transfer.
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an associations, a joint stock
company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.
«Put Option» has the meaning provided in Article 6.5(a).
«Put Option Exercise Notice» has the meaning provided in Article 6.5(b).
«Termination Date» has the meaning provided in Article 6.4(a).
«Trigger Date» means, with respect to an Executive, the later of the Initial Closing Date or the date such Executive
is first employed by the Company.
«Sale of the Company» means a bona fide, arm’s-length sale to an Independent Third Party or group of Independent
Third Parties involving: (i) a sale of assets pursuant to which such party or parties acquire all or substantially all of the
assets of the Company and its Subsidiaries on a consolidated basis in one transaction or series of related transactions;
(ii) any sale of all or substantially all of the Securities in one transaction or series of related transactions; or (iii) a merger
or consolidation which accomplishes one of the foregoing.
«Securities» means any duly authorized securities of the Company, including but not limited to, any Series 1 PECs,
Series 1 CPECs, or Ordinary Shares issued by the Company.
«Securityholder» means any holder of Securities.
«Series 1 CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates which may be issued by the Company
from time to time and, if applicable, any additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and
issued by the Company from time to time.
«Series 1 PECs» means the Series 1 preferred equity certificates which may be issued by the Company from time to
time and, if applicable, any additional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company
from time to time.
«Termination Date» has the meaning provided in Article 6.4(a).
«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article 7.3(c).
«Tier 1 Executives» means Jürgen Buchsteiner, Klaus Engel, Steve Clark, and Daniel Pithois.
«Tier 2 Executives» means all Executives other than Tier 1 Executives.
C. Shares - Shareholders Register - Share Transfers
Art. 7. Shares
Art. 7.1. Shareholders Register.
All the shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders register which may be examined
by any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each share-
Date
Accretion Percentage
Prior to the First Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0%
First Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%
Second Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20%
Third Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30%
Fourth Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40%
Fifth Anniversary of the Trigger Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50%
26942
holder and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as
the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its ad-
dress and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates
of these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.
Art. 7.2. Share Ownership.
Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register. The Company rec-
ognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is dis-
puted, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s)
towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such
shares.
Art. 7.3. Share Transfer.
(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer registered into the
shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers
of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the
Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders’ register any trans-
fer referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.
(b) Limitations on transfer. Prior to 25 February 2014, or during such shorter period as may be consistent with ap-
plicable law, except as otherwise provided in any agreement which may be entered into between the Company and the
Class A Ordinary Shareholders, the shareholders of the Company may not validly transfer the shares issued by the Com-
pany, other than to Permitted Transferees or pursuant to Article 7.5(e) below, without the prior written approval of
the Company’s Manager.
(c) Transfer. For the purposes of this article, «Transfer» or «transfer» shall mean any transaction, whether voluntary
or involuntary or by operation of law, resulting in a transfer of the ownership, «nue-propriété«, «usufruit» or any rights
of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend rights) to any person other than the Com-
pany itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means whatsoever (including, without limitation, gifts,
partial contributions of assets («apports partiels d’actifs»), mergers, splits («scissions»), sales, assignments, pledges or
any other for of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial interest in the shares, as well as any com-
bination of such methods of transfer of ownership.
(d) Transfer of Management Share(s). The Management Share(s) held by the Manager is/are not transferable except
to a successor manager to be appointed in accordance with Article 8 of these Articles.
(e) Permitted Transfers. The restrictions set out in this Article 7.3 shall not apply with respect to any transfer of
Executive Securities by a holder of Executive Securities to Permitted Transferees after delivering written notice of such
Permitted Transfer to the Manager.
(f) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any pro-
vision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor record
such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any
purpose.
D. Manager
Art. 8. The Company shall be managed by BRENNTAG S.A., a joint stock company (société anonyme) existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, in its
capacity as sole general partner (associé commandité) and manager of the Company (herein referred to as the «Man-
ager»). The other shareholders shall neither participate in nor interfer with the management of the Company. In the
event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as manager of the
Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board, as provided
for in Article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent man-
agement acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within 15 days of
his appointment At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the
quorum and majority requirements for amendment of the Articles. Failing such appointment, the Company shall be dis-
solved and liquidated. The appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.
Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the
Company’ stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of share-
holders or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.
Art. 10. The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager which itself is bound
vis-à-vis third parties by the joint signatures of any duly appointed representatives, or by the signature(s) of any other
person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion, save that the Manager may not
delegate any authority to any limited shareholder.
E. Supervision
Art. 11. The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be super-
vised by a Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members, who need not be share-
holders. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory
auditor, as provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to
time. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as he may determine and may authorise
any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under the Articles, exceed the powers of
the Manager. The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for
26943
a period of one year and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory Board are
re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general
meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board
must be convened if any of its members so requests.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior
to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall
be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda there-
of. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of commu-
nication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.
The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory
Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or rep-
resented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Cop-
ies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chair-
man of the meeting or any two (2) members.
Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as
resolutions voted at the Boards’ meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex,
telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. All such documents shall together form
the document which proves that such resolution has been taken.
Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The member(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments reg-
ularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory Board and his
heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or
proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the Supervisory Board
of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he
shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct; in the event of set-
tlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of duty. The foregoing
right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any pro-
ceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding undertaking by
such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to in-
demnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea
of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an obligation to in-
demnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably require.
Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected
or invalidated by the fact that the Manager, or any one or more of the directors or officers of the Manager, or any Af-
filiate thereof, has any interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm; pro-
vided, however, that any such transaction shall be at arms-length on commercially reasonable and customary terms. Any
director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the
Company contracts or otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company
or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.
F. General Meeting of Shareholders
Art. 13. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest
powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.
The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory
Board.
The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other
place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Friday of May at 11.00 a.m. If
such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following busi-
ness day in Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the
26944
respective convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda
and sent by the Manager by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of
the Company at the address indicated in the share register.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. If all of the
shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of
the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
G. Accounting Year - Balance Sheet
Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first (1
st
) of January and shall terminate on the thirty-
first (31
st
) of December of the same year.
Art. 15. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated, to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten per-
cent (10%) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager,
shall determine how the remainder of the annual net profit will be disposed of. Interim dividends may be distributed by
the Company upon decision of the Manager by observing the terms and conditions provided for by law. Any such dis-
posal of profits or distributions shall be in compliance with any agreement which may be entered into between the Com-
pany and the Class A Ordinary Shareholders.
H. Liquidation - Amendment of the Articles
Art. 16. These Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meeting of sharehold-
ers under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies
as amended, unless otherwise provided herein.
Notwithstanding anything to the contrary in these Articles, the amendment of any provision that affects the rights of
any holder of Class A Ordinary Shares adversely to the rights of the other holders of Class A Ordinary Shares shall
require the unanimous consent of all holders of the adversely affected shares.
Art. 17. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out
the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall
determine their powers and compensation.
I. Final Dispositions - Applicable Law
Art. 18. For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg Law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended.
J. Miscellaneous
Art. 19. The Company intends timely to elect to be classified as a fiscally transparent (i.e., pass-through) entity for
U.S. tax purposes effective for its first taxable year. In this connection, the Manager, and each other person so authorized
by action of the Shareholders, shall have the authority to execute and file such an election on behalf of the Company.
The Shareholders shall cooperate to effect such election.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,
civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendvier, den fünfundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar M
e
Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Kommanditgesellschaft auf Aktien BRENNTAG LUXCO (die «Gesellschaft»), mit Gesell-
schaftssitz in 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, eingetragen im Luxemburg Gesellschafts- und Handelsregister
unter Sektion B Nummer 97.313, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft
wurde am 25. November 2003 gegründet, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde am 3. Januar
2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 6 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft
wurde am 26. Januar 2004 abgeändert, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde noch nicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wurde um 10.50 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Marc Elvinger, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,
eröffnet,
welche zum Schriftführerin Rachel Uhl, Juristin, wohnhaft in Luxemburg bestellt.
Die Hauptversammlung wählt zum Stimmzählerin Fräulein Rachel Uhl, vorgenannt.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgen-
des zu beurkunden:
I. - Dass die gegenwärtige Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
<i>Tagesordnung:i>
1. Schaffung von verschiedenen Klassen von Aktien in Form von Stammaktien der Klasse A (die «Stammaktien der
Klasse A») und Komplementärsaktien (die «Komplementärsaktien»`);
2. Einführung neuer Bestimmungen in die Satzung der Gesellschaft über die Ausgabe von Rückkaufsaktien;
26945
3. Umwandlung der einhundertzweiundneunzigtausendachthundert (192.800) existierenden Aktien in einhundert-
zweiundneunzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (192.799) Stammaktien der Klasse A und eine (1) Komplemen-
tärsaktie;
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem jetzigen Betrag von zweihunderteinundvierzigtausend Euro (EUR
241.000) auf drei Millionen einhundertvierzehntausendfünfhundertzwei Euro fünfzig Cent (EUR 3.114.502,50), durch die
Schaffung von zwei Millionen zweihundertachtundneunzigtausendachthundert (2.298.802) Stammaktien der Klasse A mit
einem Nennwert von je ein Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25);
5. Genehmigung an den Geschäftsführer das Gesellschaftskapital innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals zu
erhöhen ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugszeichungsrecht einzuräumen;
6. Vollständige Abänderung der Satzung.
7. Verschiedenes.
II. - Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die
Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird von
den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unter-
zeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben eingetragen zu werden. Die Vollmachten der
vertretenen Aktionäre, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen bleibt auch gegenwärtiger Urkunde als
Anlage beigefügt.
III. - Dass das gesamte Gesellschaftskapital auf gegenwärtiger außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder
gültig vertreten ist und die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und
erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass die förmliche Einberufung unterlassen werden
konnte.
IV. - Dass die gegenwärtige Versammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, ordnungsgemäß einberufen ist
und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die Schaffung von verschiedenen Klassen von Aktien in Form von Stammaktien der
Klasse A (die «Stammaktien der Klasse A») und Komplementärsaktien (die «Komplementärsaktien»), welche in Artikel
6 und 7 der untenstehenden neuen Satzung genauer beschrieben sind.
Die Stammaktien der Klasse A und die Komplementärsaktien werden hier unten zusammen als die «Aktien» bezeich-
net.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt dass die Gesellschaft Rückkaufsaktien ausgeben kann. Mit sämtlichen rückkaufba-
ren Aktien sind die gleichen Rechte in bezug auf den Erhalt von Dividenden und sonstigen Ausschüttungen (einschließlich
Abwicklungserlösen) verbunden, und sie sind mit den gleichen Stimmrechten wie die Stammaktien der Klasse A verse-
hen. Gezeichnet und vollständig eingezahlte rückkaufbare Aktien können bei entsprechender Aufforderung der Gesell-
schaft, die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung erfolgen muss, rückgekauft werden. Der Rückkauf rückkaufbarer
Aktien kann nur unter Einsatz von Beträgen erfolgen, die für eine Ausschüttung gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaft in der letzten Fassung zur Verfügung stehen oder aber unter Einsatz der Erlöse
aus einer neuen Ausgabe, die zum Zwecke einem solchen Rückkauf vorgenommen wird. Nach ihrem Rückkauf verfallen
die mit den rückgekauften Aktien verbundenen Stimmrechte; weiterhin besteht auch kein Recht mehr auf Bezug von
Dividendenausschüttungen oder Abwicklungserlösen.
Alle Stammaktien der Klasse A sind rückkaufbare Aktien gemäß den Bestimmungen des Artikels 49-8 des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzter Fassung, mit Ausnahme der Aktien die vor der Ein-
führung dieser Bestimmungen in die Satzung gezeichnet wurden.
Die Bestimmungen über die Rückkaufsaktien in der Satzung lauten wie folgt:
«Art. 6.3 - Rückkauf; Konvertibilität.
(a) Rückkaufbare Aktien. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der Bedingungen dieser Satzung sowie der Bestimmun-
gen des Artikels 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzter Fassung, rück-
kaufbare Aktien ausgeben. Die Stammaktien der Klasse A sind rückkaufbare Aktien gemäß diesem Artikel 6.3 und dem
Gesetz. Mit sämtlichen rückkaufbaren Aktien sind die gleichen Rechte in bezug auf den Erhalt von Dividenden und son-
stigen Ausschüttungen (einschließlich Abwicklungserlösen) verbunden, und sie sind mit den gleichen Stimmrechten wie
die Stammaktien der Klasse A versehen. Gezeichnet und vollständig eingezahlte rückkaufbare Aktien können bei ent-
sprechender Aufforderung der Gesellschaft, die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung erfolgen muss, rückgekauft
werden. Sämtliche Rückkäufe erfolgen anteilmäßig bezogen auf sämtliche Inhaber jeder Klasse rückkaufbarer Aktien, die
den Rückkäufen unterworfen werden. Der Rückkauf rückkaufbarer Aktien kann nur unter Einsatz von Beträgen erfol-
gen, die für eine Ausschüttung gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft in der
letzten Fassung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Gelder, einschließlich der außergewöhnlichen Rücklage, die
mit den Geldern eingerichtet wurde, die die Gesellschaft als Emissionsagio eingenommen hat), oder aber unter Einsatz
der Erlöse aus einer neuen Ausgabe, die zum Zwecke einem solchen Rückkauf vorgenommen wird. Nach ihrem Rück-
kauf verfallen die mit den rückgekauften Aktien verbundenen Stimmrechte; weiterhin besteht auch. kein Recht mehr auf
Bezug von Dividendenausschüttungen oder Abwicklungserlösen. Je nach Entscheidung des Geschäftsführers kann die
Gesellschaft die rückgekauften Aktien ungültig machen.
(b) Sonderrücklage. Im Falle eines teilweisen oder vollständigen Rückkaufs der rückkaufbaren Aktien ist ein Betrag in
Höhe des Nominalwerts oder - liegt ein solcher Wert nicht vor - in Höhe des Pari-Wertes aller rückgekauften Aktien
in eine Rücklage zu geben, die nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet werden darf, außer im Falle einer Senkung des
26946
gezeichneten Aktienkapitals; diese Rücklage darf nur für eine Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals durch Umwand-
lung der Rücklage verwendet werden.
(c) Rückkaufspreis. Soweit in dieser Satzung oder in einer schriftlichen Vereinbarung, die zwischen den Gesellschaf-
tern abgeschlossen werden kann, nicht anderweitig vorgesehen, ist der auf eine Einziehung aller ablösbaren Aktien an-
wendbare Einziehungspreis vom/von den Geschäftsführer/n oder einer von ihm/ihnen bestellten Person auf der
Grundlage des Nettovermögenswertes aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu bestimmen.
Der Nettovermögenswert der Aktien der Gesellschaft ist als Ziffer pro Aktie auszudrücken und ist in bezug auf jeden
Bewertungstag durch Dividieren der Nettovermögenswerte der Gesellschaft - der Wert der Vermögenswerte der Ge-
sellschaft abzüglich ihrer Verbindlichkeiten bei Geschäftsschluss an einem solchen Tag - durch die Anzahl der Aktien der
Gesellschaft, die bei Geschäftsschluss an einem solchen Tag ausstehen, nach Maßgabe der Regeln festzustellen, die der/
die Geschäftsführer zumutbarerweise als fair und billig betrachten. Soweit kein böser Glaube, keine grobe Fahrlässigkeit
und kein manifester Fehler vorliegen, ist jede vom/von den Geschäftsführer/n getroffene Entscheidung über die Berech-
nung des Einziehungspreises für die Gesellschaft und ihre derzeitigen, vergangenen und zukünftigen Gesellschafter end-
gültig und verbindlich.
(d) Einziehungsverfahren. Soweit nicht in einer schriftlichen Vereinbarung, die mindestens zehn (10) Tage vor dem
Einziehungsdatum zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft abgeschlossen werden kann, anderweitig vereinbart,
erhält jeder eingetragene Inhaber von einzuziehenden Aktien per Einschreiben oder durch einen international anerkann-
ten Nachtcourier eine schriftliche Mitteilung an die im Aktionärsregister zuletzt eingetragene Anschrift, mit der er unter
Angabe des Einziehungsdatums, des Einziehungspreises und des erforderlichen Verfahrens zur Vorlage der Aktien bei
der Gesellschaft zur Einziehung über die Anzahl der einzuziehenden Aktien in Kenntnis gesetzt wird. Jeder Inhaber ein-
zuziehender Aktien hat der Gesellschaft in diesem Zusammenhang seine/n etwaige/n Aktienschein/e, die für die Aktien
ausgestellt worden waren, auszuhändigen. Der Einziehungspreis für diese Aktien ist an die Order der Person, deren
Name im Aktienregister als Inhaber erscheint, auf das Bankkonto zu zahlen, das der betreffende Gesellschafter der Ge-
sellschaft vor dem Einziehungsdatum mitgeteilt hat.
(e) Komplementärsaktie/n. Die Komplementärsaktie/n ist/sind keine rückkaufbare/n Aktie/n und kann von der Ge-
sellschaft nicht zurückgekauft werden.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die Umwandlung der einhundertzweiundneunzigtausendachthundert (192.800)
existierenden Aktien in einhundertzweiundneunzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (192.799) Stammaktien der
Klasse A und eine (1) Komplementärsaktie, wie folgt:
1) die einhundertzweiundneunzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (192.799) Aktien die von BRENNTAG-IN-
TERFER (BC), eine Kommanditegesellschaft auf Aktien gegründet nach dem Luxemburger Recht, mit Sitz in 5, Parc d’Ac-
tivité Syrdall, L-5365 Munsbach sind hiermit in einhundertzweiundneunzigtausendsiebenhundertneunundneunzig
(192.799) Stammaktien der Klasse A umgewandelt; und
2) die eine Aktie die von Brenntag, eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Luxemburger Recht, mit Sitz in 5,
Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach ist hiermit in eine Komplementärsaktie umgewandelt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um zwei Millionen achthundertdreiund-
siebzigtausendfünfhundertzwei Euro fünfzig Cent (EUR 2.873.502,50) von seinem jetzigen Betrag von zweihundertein-
undvierzigtausend Euro (EUR 241.000) auf drei Millionen einhundertvierzehntausendfünfhundertzwei Euro fünfzig Cent
(EUR 3.114.502,50), durch die Schaffung von zwei Millionen zweihundertachtundneunzigtausendachthundert (2.298.802)
neuen Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von je ein Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) zu erhöhen.
Die zwei Millionen zweihundertachtundneunzigtausendachthundert (2.298.802) neuen Stammaktien der Klasse A
wurden wie folgt gezeichnet
1) zwei Millionen einhundertfünfundneunzigtausendachthundertachtundachtzig (2.195.888) Stammaktien der Klasse
A wurden durch BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A., vorgenannt, für einen Betrag von zwei Millionen siebenhundert-
vierundvierzigtausendachthundertsechzig Euro (EUR 2.744.860) gezeichnet;
2) einundzwanzigtausendsechsunddreißig (21.036) Stammaktien der Klasse A wurden durch Herrn Daniel Yves An-
dré Pithois, member of the Executive Board of BRENNTAG AG, wohnhaft in 4 Allée de Pommeraie, F-91570 Bièvres,
Frankreich, für einen Betrag von sechsundzwanzigtausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 26.295) gezeichnet;
3) fünfundzwanzigtausendzweihundertdreiundvierzig (25.243) Stammaktien der Klasse A wurden durch Herrn Jürgen
Buchsteiner, member of the Executive Board and Chief Financial Officer of BRENNTAG AG, wohnhaft in Stübbenhauser
Str. 20b, D-40822 Duisburg, Deutschland, 11 für einen Betrag von einunddreißigtausendfünfhundertdreiundfünfzig Euro
fünfundsiebzig Cent (EUR 31.553,75) gezeichnet;
4) vierundzwanzigtausendzweihundertzweiundsiebzig (24.272) Stammaktien der Klasse A wurden durch Herrn Klaus
Arthur Engel, Chairman of the Executive Board and Chief Executive Officer of BRENNTAG AG, wohnhaft in Am Bo-
tanischen Garten 20, D47058, Duisburg, Deutschland, für einen Betrag von dreißigtausenddreihundertvierzig Euro (EUR
30.340) gezeichnet;
5) achttausendeinundneunzig (8.091) Stammaktien der Klasse A wurden durch Frau Doris Engel, wohnhaft in Ober-
matten 11, 79194 Gundelfingen, Deutschland, für einen Betrag von zehntausendeinhundertdreizehn Euro fünfundsiebzig
Cent (EUR 10.113,75) gezeichnet;
6) vierundzwanzigtausendzweihundertzweiundsiebzig (24.272) Stammaktien der Klasse A wurden durch Herrn Ste-
phen Rodger Clark, member of the Executive Board of BRENNTAG AG, wohnhaft in 532 Campus Road, Wyomissing,
PA 19610, Vereinigte Staaten von Amerika, für einen Betrag von dreißigtausenddreihundertvierzig Euro (EUR 30.340)
gezeichnet.
26947
Frau Doris Engel hält diese Stammaktien der Klasse A, für Zwecke der Satzung der Gesellschaft und eines Executive
Equity Subscription Agreement welcher zwischen ihr, der Gesellschaft, BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A. und ande-
ren leitenden Angestellten die darin aufgeführt sind abgeschlossen werden könnte, als zulässiger Übertragungsempfänger
von Herrn Klaus Engel
Die so gezeichneten Aktien wurden voll durch Geldeinlage eingezahlt, so dass die Gesamtsumme von zwei Millionen
achthundertdreiundsiebzigtausendfünfhundertzwei Euro fünfzig Cent (EUR 2.873.502,50) bestehend aus einer Kapital-
einlage von zwei Millionen achthundertdreiundsiebzigtausendfünfhundertzwei Euro fünfzig Cent (EUR 2.873.502,50) zur
Verfügung der Gesellschaft stehen, wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt den Geschäftsführer weiterhin zu genehmigen das Gesellschaftskapital bis zu ei-
nem Betrag von fünfhundert Millionen Euro (EUR 500.000.000) für eine Zeit von fünf Jahren ab der Veröffentlichung
dieses Beschlusses der Hauptversammlung im Luxemburger Amtsblatt zu erhöhen.
Auf Grund des Berichts des Geschäftsführers der Gesellschaft, beschließt die Hauptversammlung einstimmig, gemäß
den Bestimmungen von Artikel 32-3 (5) des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften, den Geschäftsführer zu ge-
nehmigen das Vorzugszeichungsrecht der bestehenden Aktionären innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals ein-
zuschränken oder wegfallenzulassen.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die völlige Abänderung der Satzung die fortan wie folgt lautet:
A. Name - Sitz - Dauer - Zweck
Art. 1. Es besteht eine zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestellten
Aktien eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die Bezeichnung BRENNTAG LUXCO führt (die «Gesellschaft»).
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach-Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg. Die Verlegung
des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der gleichen Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers.
Durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Groß-
herzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden. Aufgrund eines bestehenden oder unmittelbar drohen-
den politischen, militärischen oder anderen Notfalls von höherer Gewalt außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit
und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungs-
losen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigt, kann der Geschäftsführer durch einen einfachen
Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland ver-
legen. In diesem Falle wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an inund ausländischen Gesellschaften,
sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur
betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.
B. Geschäftsführung - Aktienkapital
Art. 5. Der Komplementär (associé commandité) haftet gesamtverbindlich für alle Schulden, die nicht aus den Gü-
tern der Gesellschaft beglichen werden können. Die anderen Aktionäre (zum Ausschluss jedes Zweifels, ausschließlich
des Komplementärs), der/die Eigentümer von Aktien der Klasse A, sollen jede Handlung im Namen der Gesellschaft, in
jeder Art und Funktion unterlassen, außer die Ausübung Ihrer Rechte als Aktionäre bei Hauptversammlungen. Die Kom-
manditäre haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.
Art. 6. Gesellschaftskapital
Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf drei Millionen einhundert-
vierzehntausendfünfhundertzwei Euro fünfzig Cent (EUR 3.114.502,50) und setzt sich zusammen aus vollständig einge-
zahlten Aktien, bestehend aus zwei Millionen vierhunderteinundneunzigtausendsechshundertein (2.491.601)
Stammaktien der Klasse A im Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (nachstehend
«Stammaktien der Klasse A» genannt) sowie einer (1) Komplementärsaktie im Pari-Wert von einem Euro fünfundzwan-
zig Cents (EUR 1,25) (nachstehend «Komplementärsaktie» genannt).
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann anhand eines Beschlusses der Gesellschafter, der genauso anzunehmen
ist wie ein Beschluss über eine Satzungsänderung, erhöht oder gesenkt werden. Die Gesellschaft ist in dem gesetzlich
zulässigen Ausmaß sowie unter den gesetzlich zulässigen Bedingungen berechtigt, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen.
Abstimmungen der Inhaber sämtlicher Aktien sind gemeinsam vorzunehmen, und die Inhaber separater Klassen von
Aktien sind nicht befugt, separat über Angelegenheiten abzustimmen, es sei denn, dies ist kraft des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzten Fassung erforderlich oder in dieser Satzung festgelegt. In Ver-
bindung mit keiner Aktienklasse bestehen in bezug auf Aktien der Gesellschaft Vorkaufsrechte, es sei denn, dies ist des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzten Fassung erforderlich oder in einer sonstigen
Vereinbarung, die zwischen der Gesellschaft und den Inhabern der Stammaktien der Klasse A abgeschlossen werden
kann, vorgesehen.
26948
Art. 6.2 - Beschreibung der Aktien
Art. 6.2.1 - Stammaktien der Klasse A
(a) Die Stammaktien der Klasse A. Die Stammaktien der Klasse A sind in jeder Hinsicht identisch. Sämtliche Stamm-
aktien der Klasse A nehmen anteilmäßig an der Ausschüttung von Dividenden sowie an jeglichen Verteilungen von Ver-
mögenswerten auf anderem Wege als durch Dividenden teil, die insgesamt diesen Stammaktien der Klasse A zugewiesen
werden. Sämtliche Stammaktien der Klasse A, die von der Gesellschaft gekauft oder anderweitig erworben werden,
werden - soweit der Geschäftsführer entsprechendes anweist - mit der Wirkung zurückgekauft, daß die ausgegebene
Anzahl der Stammaktien der Klasse A gesenkt wird. Rückkäufe, Rückkäufe oder sonstige Erwerbungen von Stammaktien
der Klasse A durch die Gesellschaft finden anteilmäßig auf sämtliche Inhaber der Stammaktien der Klasse A unter Be-
dingungen und Konditionen (inklusive Preis pro Aktie) Anwendung, die gleichermaßen für sämtliche Inhaber gelten.
(b) Stimmrechte. Eine Stammaktie der Klasse A erteilt dem Inhaber eine Stimme in Zusammenhang mit sämtlichen
Angelegenheiten, über die diese Inhaber abstimmen dürfen.
Art. 6.2.2. - Die Komplementärsaktie(n).
(a) Die Komplementärsaktie(n). Sämtliche Komplementärsaktie(n) sind in jeder Hinsicht identisch. Sämtliche Kom-
plementärsaktie(n) nehmen anteilmäßig an der Ausschüttung von Dividenden sowie jeglichen Verteilungen von Vermö-
genswerten auf anderem Wege als durch Dividenden teil, die insgesamt dieser/diesen Komplementärsaktie(n)
zugewiesen werden.
(b) Stimmrechte. Eine Komplementärsaktie erteilt dem Inhaber eine Stimme in Zusammenhang mit sämtlichen Ange-
legenheiten, über die diese Inhaber abstimmen dürfen.
Art. 6.3 - Rückkauf; Konvertibilität.
(a) Rückkaufbare Aktien. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der Bedingungen dieser Satzung sowie der Bestimmun-
gen des Artikels 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzten Fassung, rück-
kaufbare Aktien ausgeben. Die Stammaktien der Klasse A sind rückkaufbare Aktien gemäß diesem Artikel 6.3 und dem
Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzten Fassung. Mit sämtlichen rückkaufbaren Aktien
sind die gleichen Rechte in bezug auf den Erhalt von Dividenden und sonstigen Ausschüttungen (einschließlich Abwick-
lungserlösen) verbunden, und sie sind mit den gleichen Stimmrechten wie die Stammaktien der Klasse A versehen. Ge-
zeichnet und vollständig eingezahlte rückkaufbare Aktien können bei entsprechender Aufforderung der Gesellschaft, die
gemäß den Bestimmungen dieser Satzung erfolgen muss, rückgekauft werden. Sämtliche Rückkäufe erfolgen anteilmäßig
bezogen auf sämtliche Inhaber jeder Klasse rückkaufbarer Aktien, die den Rückkäufen unterworfen werden. Der Rück-
kauf rückkaufbarer Aktien kann nur unter Einsatz von Beträgen erfolgen, die für eine Ausschüttung gemäß Artikel 72-1
des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft in der letzten Fassung zur Verfügung stehen (ausschüttungs-
fähige Gelder, einschließlich der außergewöhnlichen Rücklage, die mit den Geldern eingerichtet wurde, die die Gesell-
schaft als Emissionsagio eingenommen hat), oder aber unter Einsatz der Erlöse aus einer neuen Ausgabe, die zum
Zwecke einem solchen Rückkauf vorgenommen wird. Nach ihrem Rückkauf verfallen die mit den rückgekauften Aktien
verbundenen Stimmrechte; weiterhin besteht auch kein Recht mehr auf Bezug von Dividendenausschüttungen oder Ab-
wicklungserlösen. Je nach Entscheidung des Geschäftsführers kann die Gesellschaft die rückgekauften Aktien ungültig
machen.
(b) Sonderrücklage. Im Falle eines teilweisen oder vollständigen Rückkaufs der rückkaufbaren Aktien ist ein Betrag in
Höhe des Nominalwerts oder - liegt ein solcher Wert nicht vor - in Höhe des Pari-Wertes aller rückgekauften Aktien
in eine Rücklage zu geben, die nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet werden darf, außer im Falle einer Senkung des
gezeichneten Aktienkapitals; diese Rücklage darf nur für eine Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals durch Umwand-
lung der Rücklage verwendet werden.
(c) Rückkaufspreis. Soweit in dieser Satzung oder in einer schriftlichen Vereinbarung, die zwischen den Gesellschaf-
tern abgeschlossen werden kann, nicht anderweitig vorgesehen, ist der auf einen Rückkauf aller rückkaufbaren Aktien
anwendbare Rückkaufspreis vom/von den Geschäftsführer/n oder einer von ihm/ihnen bestellten Person auf der Grund-
lage des Nettovermögenswertes aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu bestimmen. Der Net-
tovermögenswert der Aktien der Gesellschaft ist als Ziffer pro Aktie auszudrücken und ist in bezug auf jeden
Bewertungstag durch Dividieren der Nettovermögenswerte der Gesellschaft - der Wert der Vermögenswerte der Ge-
sellschaft abzüglich ihrer Verbindlichkeiten bei Geschäftsschluss an einem solchen Tag - durch die Anzahl der Aktien der
Gesellschaft, die bei Geschäftsschluss an einem solchen Tag ausstehen, nach Maßgabe der Regeln festzustellen, die der/
die Geschäftsführer zumutbarerweise als fair und billig betrachten. Soweit kein böser Glaube, keine grobe Fahrlässigkeit
und kein manifester Fehler vorliegen, ist jede vom/von den Geschäftsführer/n getroffene Entscheidung über die Berech-
nung des Rückkaufspreises für die Gesellschaft und ihre derzeitigen, vergangenen und zukünftigen Gesellschafter end-
gültig und verbindlich.
(d) Rückkaufsverfahren. Soweit nicht in einer schriftlichen Vereinbarung, die mindestens zehn (10) Tage vor dem
Rückkaufsdatum zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft abgeschlossen werden kann, anderweitig vereinbart, er-
halt jeder eingetragene Inhaber von einzuziehenden Aktien per Einschreiben oder durch einen international anerkannten
Nachtcourier eine schriftliche Mitteilung an die im Aktionärsregister zuletzt eingetragene Anschrift, mit der er unter
Angabe des Rückkaufsdatums, des Rückkaufspreises und des erforderlichen Verfahrens zur Vorlage der Aktien bei der
Gesellschaft zum Rückkauf über die Anzahl der zurückzukaufenden Aktien in Kenntnis gesetzt wird. Jeder Inhaber zu-
rückzukaufenden Aktien hat der Gesellschaft in diesem Zusammenhang seine/n etwaige/n Aktienschein/e, die für die Ak-
tien ausgestellt worden waren, auszuhändigen. Der Rückkaufspreis für diese Aktien ist an die Order der Person, deren
Name im Aktienregister als Inhaber erscheint, auf das Bankkonto zu zahlen, das der betreffende Gesellschafter der Ge-
sellschaft vor dem Rückkaufsdatum mitgeteilt hat.
(e) Komplementärssaktie/n. Die Komplementärsaktie/n ist/sind keine rückkaufbare/n Aktie/n und kann von der Ge-
sellschaft nicht zurückgekauft werden.
26949
Art. 6.4 - Recht auf Erwerb bestimmter Stammaktien
(a) Kaufoption. Wenn ein bei der Gesellschaft oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften angestellter Inhaber von
Stammaktien («Führungskraft») aus einem beliebigen Grunde nicht mehr für die Gesellschaft oder eine ihrer Zweig/
Tochtergesellschaften tätig ist (das Datum der Einstellung seiner Tätigkeiten wird im folgenden «Kündigungsdatum» ge-
nannt), unterliegen die Stammaktien dieser Führungskraft zusammen mit jeglichen weiteren Wertpapieren der Gesell-
schaft,. die diese Führungskraft gezeichnet hat (zusammen «Wertpapiere der Führungskraft» genannt), unabhängig
davon, ob sie von dieser Führungskraft oder von einem oder mehreren ihrer zulässigen Übertragungsempfänger gehal-
ten werden, einem Erwerb durch die Anleger oder den Tier 1-Führungskräften; dabei gelten die Bedingungen und Kon-
ditionen dieses Artikels 6.4 (die «Kaufoption»).
(b) Gerechtfertigte Kündigung der Führungskraft. Wenn diese Führungskraft nicht mehr bei der Gesellschaft oder
einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften angestellt ist, weil das Anstellungsverhältnis von der Gesellschaft oder einer
ihrer Zweig/Tochtergesellschaften gerechtfertigt gekündigt wurde (die Führungskraft wird dann als «schlechter Aus-
scheider» bezeichnet) (die Last des Beweises des Vorliegens solcher Gründe liegt bei der Person, die die Kaufoption
wahrnimmt), können die Anleger zu diesem Zeitpunkt oder nach dem Kündigungsdatum die Entscheidung treffen, alle
oder einige der Wertpapiere der Führungskraft zum Kaufoptionspreis des schlechten Ausscheiders zu erwerben; ent-
scheiden, sich die Anleger dafür, die Kaufoption nicht wahrzunehmen, steht den Tier 1-Führungskräften das Recht zu,
die Wertpapiere der Führungskraft zum Kaufoptionspreis des schlechten Ausscheiders zu erwerben, wobei in jedem
Fall die nachfolgend aufgeführten Verfahren zur Anwendung kommen.
(c) Ausscheiden aus anderen als aus guten Gründen. Wenn die Führungskraft nicht mehr bei der Gesellschaft oder
einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften angestellt ist, (i) weil die Führungskraft ihr Anstellungsverhältnis ohne guten
Grund beendet bzw. aufgegeben hat, oder (i) soweit die Führungskraft einen befristeten Anstellungsvertrags Zeit hatte,
weil sie ein Angebot zur Verlängerung des Anstellungsverhältnisses unter denselben günstigen Bedingungen und Kondi-
tionen wie zuvor ohne guten Grund ablehnt (ein «Ausscheider aus anderen als guten Gründen») (die Last des Beweises
des Vorliegens guter Gründe liegt bei der Führungskraft) können die Anleger und die Tier 1-Führungskräfte zu einem
solchen Zeitpunkt oder nach dem Kündigungsdatum die Entscheidung treffen, alle oder einige der Wertpapiere dieser
Führungskraft zu einem Preis pro Wertpapier der Führungskraft zu erwerben, der dem Wertpapier-Kaufoptionspreis
der aus anderen als guten Gründen ausscheidenden Führungskraft entspricht; entscheiden die Anleger sich dafür, die
Kaufoption nicht wahrzunehmen, steht den Tier 1-Führungskräften das Recht zu, diese Wertpapiere der Führungskraft
zum Wertpapier-Kaufoptionspreis der aus anderen als guten Gründen ausscheidenden Führungskraft zu erwerben; in
jedem Fall finden die nachfolgend dargelegten Verfahren Anwendung.
(d) Beendigung des Anstellungsverhältnisses der Führungskraft als guter Ausscheider. Wenn die Führungskraft nicht
mehr bei der Gesellschaft oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften angestellt ist, weil das Anstellungsverhältnis von
der Gesellschaft oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften gekündigt wurde oder, soweit ein befristeter Anstel-
lungsvertrag bestand, weil die Gesellschaft oder eine ihrer Zweig/Tochtergesellschaften kein Angebot über eine Verlän-
gerung des Anstellungsverhältnisses zu genauso günstigen Bedingungen und Konditionen wie zuvor angeboten hat, gilt
die Führungskraft als «guter Ausscheider», es sei denn, (i) das Anstellungsverhältnis wurde gerechtfertigt gekündigt,
oder (ii) soweit ein befristeter Anstellungsvertrag bestand, der Führungskraft wird ein neuer Anstellungsvertrag ange-
boten, allerdings gerechtfertigterweise unter weniger günstigen Bedingungen und Konditionen als zuvor (und die Last
des Beweises des Vorliegens der Gründe liegt bei der Person, die die Kaufoption wahrnimmt); in den letztgenannten
Fällen können die Anleger und die Tier 1-Führungskräfte zu einem solchen Zeitpunkt oder nach dem Kündigungsdatum
die Entscheidung treffen, einige oder alle der Wertpapiere der Führungskraft zu einem Preis pro Wertpapier zu erwer-
ben, der dem Kaufoptionspreis des guten Ausscheiders entspricht, und soweit die Anleger die Kaufoption nicht wahr-
nehmen wollen, steht den Tier 1-Führungskräften das Recht zu, die Wertpapiere der Führungskraft zum
Kaufoptionspreis des guten Ausscheiders zu erwerben; in jedem Fall kommen die nachfolgend dargelegten Verfahren
zur Anwendung.
(e) Kündigung der Führungskraft aus triftigem Grund. Wenn die Führungskraft nicht mehr von der Gesellschaft oder
einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften angestellt ist, (i) weil die Führungskraft ihr Anstellungsverhältnis aus triftigem
Grund kündigt oder einstellt (die Last des Beweises des Vorliegens triftiger Gründe liegt bei der Führungskraft), oder
(ii) soweit ein befristeter Anstellungsvertrag bestand, weil die Führungskraft ein Angebot zur Verlängerung des Anstel-
lungsverhältnisses aus triftigem Grund ablehnt (die Last des Beweises des Vorliegens triftiger Gründe liegt bei der Füh-
rungskraft), können die Anleger zu einem solchen Zeitpunkt oder nach dem Kündigungsdatum die Entscheidung treffen,
alle oder einige der Wertpapiere dieser Führungskraft zum Kaufoptionspreis des guten Ausscheiders zu erwerben, und
soweit die Anleger sich entscheiden, die Kaufoption nicht wahrzunehmen, steht den Tier 1-Führungskräften das Recht
zu, diese Wertpapiere der Führungskraft zum Kaufoptionspreis des guten Ausscheiders zu erwerben; in jedem Fall kom-
men die nachfolgend dargelegten Verfahren zur Anwendung.
(f) Verfahren zur Wahrnehmung der Kaufoption. Innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Kündigungsdatum einer
Führungskraft erteilt die Gesellschaft den Anlegern eine entsprechende schriftliche Mitteilung unter Angabe des Namens
der betreffenden Führungskraft und des Kündigungsdatums. Die Anleger können sodann die Entscheidung treffen, das
Recht zum Kauf aller oder einiger Wertpapiere der Führungskraft gemäß der Kaufoption wahrzunehmen, indem sie dem
oder den Inhabern der Wertpapiere der Führungskraft innerhalb von neunzig (90) Tagen nach deren Kündigungsdatum
eine schriftliche Mitteilung («die Mitteilung über die Wahrnehmung der Kaufoption») zukommen lassen. In der Mittei-
lung über die Wahrnehmung der Kaufoption ist die Anzahl der Wertpapiere der Führungskraft, die von diesem/diesen
Inhaber/n zu erwerben sind, die gesamte Gegenleistung, die für solche Wertpapiere der Führungskraft zu zahlen sind,
und Zeitpunkt und Ort des Closings anzugeben. Werden bestimmte Wertpapiere der Führungskraft von deren zulässi-
gen Übertragungsempfängern gehalten, ist die Anzahl solcher Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Zustellung der Mit-
26950
teilung über die Wahrnehmung der Kaufoption von diesem/solchen Inhaber/n gehalten werden, zu berücksichtigen und
der Erwerb von diesem/solchen Inhabern auf dieser Grundlage anteilmäßig vorzunehmen.
(g) Abtretungsrechte. Wenn die Anleger die Entscheidung getroffen haben, die Kaufoption wahrzunehmen, werden
die Anleger vor der Wahrnehmung der Kaufoption zunächst jeder Tier 1-Führungskraft, die von der Gesellschaft oder
einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften zu dem Zeitpunkt angestellt sind, an dem die Kaufoption wahrzunehmen ist,
die Gelegenheit geben, den proportionalen Anteil zu erwerben, der der jeweiligen Tier 1-Führungskraft an den betref-
fenden Wertpapieren zusteht (ausgehend von dem Prozentsatz an der Gesamtanzahl der ausstehenden Stammaktien
der Klasse A, die zum betreffenden Kündigungsdatum von dieser Tier 1-Führungskraft gehalten wird) Wenn eine Tier
1-Führungskraft sich entscheidet, den ihr somit zustehenden proportionalen Anteil nicht zu erwerben, können die An-
leger diesen Anteil entweder den Tier 1Führungskräften zuweisen, die sich für die Wahrnehmung der Kaufoption ent-
schieden haben, oder die gesamte oder einige Teile der in Zusammenhang mit den verbleibenden Wertpapieren der
Führungskraft bestehenden Kaufoption (einschließlich, um jegliche Zweifel auszuschalten, den proportionalen Anteil der
Anleger) der Gesellschaft oder anderen Wertpapierinhabern, soweit vorhanden («andere Anleger») zuweisen. Diese
Entscheidung wird dann in bezug auf die gesamte oder einige Teile der Kaufoption wirksam. Wenn ein Teil der Kaufop-
tion einer oder mehreren Führungskräften, der Gesellschaft oder anderen Anlegern zugewiesen wird, haben diese Tier
1-Führungskräfte, die Gesellschaft oder die anderen Anleger das Recht, die Kaufoption auf die in diesem Artikel 6.4 ge-
nannte Art und Weise vor dem neunzigsten (90.) Tag nach dem Kündigungsdatum wahrzunehmen. Übt die Gesellschaft
die Kaufoption aus, werden die derart erworbenen Wertpapiere gemäß den Bestimmungen des Artikels 49-8 des Ge-
setzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft in der letzten Fassung zurückgekauft. Wenn eine Anzahl von
Wertpapieren weder von Führungskräften noch von der Gesellschaft noch von anderen Anlegern gemäß diesem Artikel
6.4(f) erworben wird, werden die Anleger alle verbleibenden Wertpapiere der Führungskraft gemäß der Kaufoption er-
werben.
(h) Kaufoptionsrechte der Führungskraft. Wenn die Anleger die Kaufoption nicht wahrnehmen wollen, können die
Tier 1-Führungskräfte innerhalb von einem Zeitraum von sechzig (60) Tagen ab dem ehesten Datum, an dem die Anleger
der Gesellschaft ihre Absicht über den Nichterwerb mitgeteilt haben, oder ab dem einundneunzigsten (91.) Tag nach
dem betreffenden Kündigungsdatum, soweit dieser Zeitpunkt früher eintritt, (das «Kaufoptionsübertragungsdatum») die
Kaufoption wahrzunehmen. Jede Führungskraft hat das Recht, den ihr zustehenden proportionalen Anteil an den Wert-
papieren der Führungskraft, die in Zusammenhang mit der Kaufoption zu erwerben sind, zu kaufen (auf der Grundlage
der Anzahl der Stammaktien der Klasse A, die die jeweilige Führungskraft hält). Entscheidet sich eine Tier 1-Führungs-
kraft gegen den Erwerb des ihr zustehenden Anteils, kann diese Tier 1-Führungskraft alle oder einige Teile der Kaufop-
tion einer anderen Tier 1-Führungskraft zuweisen, die die Kaufoption wahrgenommen hat oder ihre
Wahrnehmungsabsicht zum Ausdruck gebracht hat. Wenn ein Teil der Kaufoption von einer Führungskraft gemäß die-
sem Artikel 6.4(g) wahrgenommen wird, hat diese Führungskraft das Recht, die Kaufoption auf die in diesem Artikel 6.4
festgelegte Art und Weise vor dem sechzigsten (60.) Tag nach dem Kaufoptionsübertragungsdatum wahrzunehmen.
(i) Closing. Das Closing der in diesem Artikel 6.4 dargelegten Transaktionen findet an dem Datum statt, das die An-
leger oder die Tier 1-Führungskräfte in der Mitteilung über die Wahrnehmung der Kaufoption angeben; diese Datum
liegt höchstens sechzig (60) Tage nach der Zustellung der Mitteilung über die Wahrnehmung der Kaufoption. Die An-
leger oder ihre zulässigen Abtretungsempfänger, einschließlich den Tier 1-Führungskräften, den anderen Anleger und
der Gesellschaft, nehmen als Gegenleistung für die gemäß Kaufoption zu erwerbenden Wertpapiere der Führungskraft
eine Zahlung per Scheck oder telegraphischer Überweisung von umgehend verfügbaren Geldern an den Inhaber dieser
Wertpapiere der Führungskraft vor; der zu zahlende Betrag beläuft sich insgesamt auf den Kaufpreis für diese Wertpa-
piere der Führungskraft. Die Anleger, die anderen Anleger, die Tier 1-Führungskräfte oder die Gesellschaft erhalten be-
züglich des Verkaufs der Wertpapiere der Führungskraft an den jeweiligen Käufer von keinem Verkäufer Zusagen oder
Gewährleistungen, außer den Zusagen und Gewährleistungen, nach denen dieser Verkäufer das unbestreitbare und hin-
reichende Eigentumsrecht an den Wertpapieren der Führungskraft hält, die ohne jegliche Pfandrechte, Forderungen
oder sonstige Belastungen zu übertragen sind; außerdem gilt die Gewährleistung, dass dem Verkäufer die ordnungsge-
mäße Befugnis obliegt, die Verträge über den Verkauf der Wertpapiere der Führungskraft abzuschließen.
(j) Wegfall des Rücknahmerechts. Die Rechte der Anleger, die Wertpapiere der Führungskraft gemäß diesem Artikel
6.4 zu erwerben, enden mit einem Verkauf der Gesellschaft.
Art. 6.5 Recht zum Verkauf bestimmter Stammaktien
(a) Verkaufsoption. Wenn eine Führungskraft wegen Tod oder Geschäftsunfähigkeit nicht mehr bei der Gesellschaft
oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften angestellt ist oder wenn ein Inhaber von Wertpapieren von Führungskräf-
ten, dessen Anstellung bei der Gesellschaft oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften gekündigt wurde, stirbt oder
arbeitsunfähig wird, und wenn die Anleger und die Tier 1-Führungskräfte sich entscheiden, die Kaufoption gemäß Artikel
6.4 oben nicht wahrzunehmen, steht der betreffenden Führungskraft oder einem oder mehreren ihrer zulässigen Über-
tragungsempfänger das Recht zu, die Anleger aufzufordern, diejenige Anzahl der Wertpapiere der Führungskraft gemäß
den in diesem Artikel 6.5 niedergelegten Bedingungen und Konditionen zu dem Kaufoptionspreis des guten Ausschei-
ders zu erwerben, dass der zustandekommende gesamte Kaufpreis den gesamten ursprünglichen Kosten für alle Wert-
papiere der Führungskraft entspricht oder unterschreitet (die «Verkaufsoption»). Um jegliche Zweifel auszuschalten,
gilt, dass die betreffende Führungskraft oder einer oder mehrere ihrer zulässigen Abtretungsempfänger das Recht haben,
jegliche verbleibenden Wertpapiere der Führungskraft gemäß den Bedingungen und Konditionen dieser Satzung zu be-
halten.
(b) Verfahren zur Wahrnehmung der Verkaufsoption. Wenn eine Führungskraft oder einer oder mehrere ihrer zu-
lässigen Übertragungsempfänger die Verkaufsoption wahrnehmen wollen, ist die Führungskraft bzw. sind die zulässigen
Übertragungsempfänger verpflichtet, den Anlegern innerhalb von sechzig (60) Tagen des sechzigsten (60.) Tages nach
dem Kaufoptionsübertragungsdatum eine schriftliche Mitteilung (die «Mitteilung über die Wahrnehmung der Verkaufs-
26951
option») zu erteilen. In der Mitteilung über die Wahrnehmung der Verkaufsoption sind die Anzahl der zu verkaufenden
Wertpapiere der Führungskraft, die dafür insgesamt zu zahlende Gegenleistung sowie Zeitpunkt und Ort des Closings
der Transaktion anzugeben.
(c) Abtretungsrechte. Jeder Anleger kann seine Rechte und Verpflichtungen aus der Verkaufsoption an einen seiner
zulässigen Übertragungsempfänger oder an die Gesellschaft abtreten. Wenn die Gesellschaft die Wertpapiere der Füh-
rungskraft gemäß der Verkaufsoption erwirbt, gelten die derart erworbenen Wertpapiere gemäß den Bestimmungen
des Artikels 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft in der letzten Fassung als eingezogen.
(d) Closing. Das Closing der in diesem Artikel 6.5 dargelegten Transaktion findet an dem Datum statt, das von der
betreffenden Führungskraft oder ihren zulässigen Übertragungsempfängern in der Mitteilung über die Wahrnehmung
der Verkaufsoption angegeben wird; dieses Datum darf höchstens sechzig (60) Tage nach der Zustellung der vorerwähn-
ten Mitteilung liegen. Die Anleger oder ihre zulässigen Abtretungsempfänger, einschließlich den Tier 1-Führungskräften,
den anderen Anlegern und der Gesellschaft, nehmen die Zahlung der Gegenleistung für die gemäß Verkaufsoption zu
erwerbenden Wertpapiere der Führungskraft durch Zustellung eines Schecks oder telegraphische Überweisung umge-
hend verfügbarer Gelder an den Inhaber der Wertpapiere der Führungskraft vor; der Betrag der Gegenleistung ent-
spricht insgesamt dem Kaufpreis für solche Wertpapiere der Führungskraft. Die Anleger, die anderen Anleger, die Tier
1-Führungskräfte oder die Gesellschaft erhalten bezüglich des Verkaufs der Wertpapiere der Führungskraft an den be-
treffenden Käufer von keinem Verkäufer Zusagen oder Gewährleistungen, außer den Zusagen und Gewährleistungen,
dass der Verkäufer das unbestreitbare und hinreichende Eigentumsrecht an den Wertpapieren der Führungskraft hält,
die frei von jeglichen Pfandrechten, Forderungen oder sonstigen Belastungen zu verkaufen sind, und außer der Gewähr-
leistung, dass der Verkäufer ordnungsgemäß befugt ist, die Verträge über den Verkauf der Wertpapiere der Führungs-
kraft abzuschließen.
(e) Wegfall des Rücknahmerechts. Die Rechte und Verpflichtungen der Anleger, die Wertpapiere der Führungskraft
gemäß diesem Artikel 6.5 zu erwerben, enden mit dem Verkauf der Gesellschaft.
Art. 6.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter
Wenn die Gesellschafterversammlung und/oder der Geschäftsführer der Gesellschaft die Vornahme einer Ausschüt-
tung an die Gesellschafter beschließt (sei es durch Zwischendividende, Rückkauf oder anderweitig), haben die Gesell-
schafter ein Recht auf Erhalt der Ausschüttungen - wenn, so wie und soweit von der Gesellschafterversammlung und/
oder dem Geschäftsführer erklärt - aus den dafür rechtmäßig zur Verfügung stehenden Geldern gemäß geltendem Recht
und in der Art und Weise, die in den restlichen Bestimmungen dieses Artikels 6.6 dargelegt ist. Die Inhaber von Stamm-
aktien der Klasse A und der Komplementärsaktie/n haben Anspruch auf Erhalt aller Ausschüttungen, die die Gesellschaft
an die Gesellschafter vornimmt, und diese Ausschüttungen werden anteilmäßig unter den Inhabern der Stammaktien der
Klasse A und der Komplementärsaktie/n auf der Grundlage der vom jeweiligen Inhaber gehaltenen Anzahl an Aktien
vorgenommen; darüber hinaus sollten dabei für alle Inhaber die gleichen Bedingungen und Konditionen gelten.
Art. 6.7 - Rechte bei Liquidation
Im Falle einer Liquidation werden die nach Zahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleiben-
den Vermögenswerte der Gesellschaft auf die im Artikel 6.6 oben genannte Art und Weise zwischen den Gesellschaf-
tern verteilt. Eine Fusion oder Verschmelzung der Gesellschaft in oder mit einer anderen oder mehreren anderen
Körperschaften oder eine Fusion oder Verschmelzung einer oder mehrerer anderer Körperschaften in bzw. mit der
Gesellschaft oder ein Verkauf, eine Übertragung, eine Verpachtung oder die Vornahme eines Tauschgeschäfts (gegen
Bargeld, Wertpapiere oder sonstige Gegenleistungen) von allen oder einigen Teilen der Vermögenswerte der Gesell-
schaft gilt im Sinne dieses Artikels 6.7 nicht als Liquidation, es sei denn, eine solche Fusion, Verschmelzung, ein solcher
Verkauf, eine solche Übertragung, Verpachtung oder ein solches Tauschgeschäft wird in Zusammenhang mit einer voll-
ständigen Auflösung, Liquidation oder Abwicklung der Gesellschaft vorgenommen oder ist in einem solchen Rahmen
geplant.
Art. 6.8 - Genehmigtes Kapital
Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über ein genehmigtes Kapital in Höhe von fünfhundert
Millionen Euro (EUR 500.000.000), bestehend aus vierhundert Millionen (400.000.000) Stammaktien der Klasse A mit
einem Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25).
In einem Zeitraum, der fünf (5) Jahre nach dem Datum der Bekanntgabe des Gesellschafterbeschlusses über die Ein-
richtung des genehmigten Kapitals im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil et Associations, endet, ist der Ge-
schäftsführer befugt, das gezeichnete Kapital in einem oder mehreren Schritten zu erhöhen, indem er die Gesellschaft
zur Ausgabe neuer Aktien innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals veranlasst. Diese neuen Aktien (Stammak-
tien, Vorzugsaktien oder Aktien einer beliebigen Klasse, die von der Gesellschaft ausgegeben werden dürfen) können
unter den Bedingungen und Konditionen gezeichnet und ausgegeben werden, die der Geschäftsführer bestimmt, genau-
er gesagt, die er in bezug auf die Zeichnung und die Einzahlung der auszugebenden und zu zeichnenden neuen Aktien
bestimmt; Entscheidung über den Zeitpunkt und Menge der zu zeichnenden und auszugebenden neuen Aktien; Entschei-
dung darüber, ob die neuen Aktien mit oder ohne Emissionsagio gezeichnet werden sollen; Entscheidung darüber, in
welchem Ausmaß die Zahlung der neu gezeichneten Aktien in bar oder anhand anderer Vermögenswerte als Bargeld
erfolgen soll. Jede Aktienausgabe der Gesellschaft muss nach Maßgabe der Bedingungen und Konditionen erfolgen, die
in Verträgen niedergelegt sind, welche zwischen der Gesellschaft und den Inhabern der Stammaktien der Klasse A ab-
geschlossen worden sein mögen. Soweit die Gesellschafter keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen haben oder
ein anderer Vertrag, der zwischen der Gesellschaft und den Inhabern der Stammaktien der Klasse A abgeschlossen wor-
den sein mag, keine anderweitige Bestimmungen enthält, gilt bei der vollständigen oder teilweisen Umwandlung des ge-
nehmigten Kapitals, dass der Geschäftsführer ausdrücklich befugt ist, die Vorzugszeichnungsrechte, die bestehenden
Aktionären vorbehalten sind, einzuschränken oder wegfallen zu lassen. Der Geschäftsführer kann die Pflichten zur An-
nahme von Zeichnungen und Entgegennahme von Zahlungen für neue Aktien, die den gesamten Betrag der Kapitaler-
26952
höhung oder einen Teil davon ausmachen, an ordnungsgemäß bevollmächtige Verwaltungsräte oder leitende Angestellte
der Gesellschaft oder anderweitig ordnungsgemäß bevollmächtige Personen delegieren. Nach jeder Erhöhung des ge-
zeichneten Kapitals durch den Geschäftsführer in der rechtlich vorgeschriebenen Form und gemäß dieser Satzung ist
dieser Artikel 6.8 im Sinne der Berücksichtigung dieser Erhöhung entsprechend abzuändern.
Art. 6.9 Änderungen des gezeichneten und des genehmigten Kapitals
Erhöhungen oder Senkungen des gezeichneten und genehmigten Kapitals der Gesellschaft unterliegen der Entschei-
dung der Gesellschafterversammlung, die darüber mit der gleichen beschlussfähigen Anzahl abzustimmen hat wie die die
für Änderungen der vorliegenden Satzung erforderlich ist oder die in einem Vertrag, der zwischen der Gesellschaft und
den Inhabern der Stammaktien der Klasse A abgeschlossen worden sein mag vorgesehen ist.
Art. 6.10 Definitionen
Für die Zwecke dieser Satzung gilt wie folgt:
«Satzung» ist die vorliegende Satzung in ihrer jeweils letzten Fassung.
«Kernkapitalaktien» bezeichnet die von einer Führungskraft gezeichnete/n Serie 1 der PECs, die Serie 1 der CPECs
und die Stammaktien der Klasse A.
«Schlechter Ausscheider» hat die im Artikel 6.4(b) genannte Bedeutung.
«Kaufoptionspreis des schlechten Ausscheiders» bezeichnet in bezug auf die Wertpapiere einer Führungskraft, die
von einer solchen Führungskraft gezeichnet wurden, einen Betrag in Höhe der (i) ursprünglichen Kosten oder, soweit
niedriger, (ii) den Marktwert der Kernkapitalaktien zum Kündigungsdatum.
«Kaufoption» hat die im Artikel 6.4(a) genannte Bedeutung.
«Mitteilung über die Wahrnehmung der Kaufoption» hat die im Artikel 6.4(e) genannte Bedeutung.
«Kaufoptionsübertragungsdatum» hat die im Artikel 6.4(g) genannte Bedeutung.
«Grund» bezeichnet (i) chronische/n Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit, (ii) wesentliche Unterschlagungen von
Geldern oder sonstigen Vermögenswerten oder von Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Zweig/Tochtergesellschaften,
(iii) wesentliche Verletzungen des Anstellungsvertrags seitens einer Führungskraft, die nicht innerhalb von dreißig (30)
Tagen nach Erhalt einer Abmahnung des Arbeitgebers mit der Aufforderung zur Wiedergutmachung behoben werden,
(iv) Begehung einer Straftat oder eines Betrugs seitens einer Führungskraft, die/der mit Gefängnisstrafe geahndet werden
kann und jeweils zur Kündigung der Anstellung der betreffenden Führungskraft und zur Entlassung, zum Rücktritt oder
zur Nichtverlängerung der Mitgliedschaft in der Geschäftsführung, im Aufsichtsrat oder im Vorstand der Gesellschaft
oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften führt, in der/dem die Führungskraft Mitglied ist, oder (v) wiederholte
Nichtbefolgung von Weisungen, die für die Position einer Führungskraft zumutbar sind und die der Führungskraft von
der Gesellschaft oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften erteilt wurden, soweit solche Weisungen weder ein maß-
gebliches Recht noch die Bedingungen des Anstellungsvertrags des Mitarbeiters verletzen, über einen Zeitraum von fünf-
zehn (15) Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Abmahnung des Komplementärs in Zusammenhang mit einer solchen
Nichteinhaltung. Um jegliche Zweifel auszuschalten, gilt, dass die Last des Beweises des Vorliegens einer Rechtfertigung
in jedem Fall bei der Person liegt, die die Kaufoption ausübt.
«Inhaber von Stammaktien der Klasse A» bezeichnet die Inhaber der Stammaktien der Klasse A.
«Stammaktien der Klasse A» hat die im Artikel 6.1 genannte Bedeutung.
«Gesellschaft» hat die im Artikel 1 genannte Bedeutung.
«Arbeitsunfähigkeit» bezeichnet in bezug auf eine Führungskraft deren Unfähigkeit, die wesentlichen Pflichten, Ver-
antwortlichkeiten und Funktionen der Führungsposition bei der Gesellschaft infolge geistiger oder körperlicher Unfä-
higkeiten auszuüben, wobei jegliche zumutbaren Hilfen für solche Unfähigkeiten seitens der Gesellschaft berücksichtigt
werden; oder im Falle einer früheren Führungskraft, die Unfähigkeit dieser früheren Führungskraft, die wesentlichen
Pflichten, Verantwortlichkeiten und Aufgaben einer Funktion auszuüben, die der Position der früheren Führungskraft bei
der Gesellschaft oder ihrer Zweig/Tochtergesellschaft entspricht, und zwar infolge von geistigen oder körperlichen Un-
fähigkeiten, die jeweils von einem neutralen und angemessen qualifizierten Arzt zu verifizieren sind, der vom Verwal-
tungsrat des Geschäftsführers nach dessen Ermessen bestellt wurde.
«Führungskraft» hat die im Artikel 6.4(a) genannte Bedeutung.
«Wertpapiere, der Führungskraft/kräfte» hat die im Artikel 6.4(a) genannte Bedeutung.
«Angemessener Marktwert» bezeichnet in bezug auf ein oder mehrere Wertpapiere die Proportion des Gesamtnet-
toerlöses, den der Inhaber solcher Wertpapiere gemäß einer hypothetischen Abwicklungsausschüttung der Gesellschaft
entgegenzunehmen berechtigt wäre, wenn der Gesamterlös in Zusammenhang mit einer solchen hypothetischen Ab-
wicklungsausschüttung als ein Betrag zu betrachten ist, der dem Gesamtnettoerlös entspricht, den die Inhaber von
Wertpapieren der Gesellschaft in Zusammenhang mit dem Verkauf der Gesellschaft zum angemessenen Marktwert er-
halten würden. Das Verfahren der Bestimmung dieses Wertes ist wie folgt: (i) in bezug auf ein Wertpapier einer Tier
1-Führungskraft wird der Wert eines solchen Wertpapiers vom Verwaltungsrat des Geschäftsführers und der betref-
fenden Tier 1-Führungskraft gutgläubig vereinbart; dabei gilt allerdings die Voraussetzung, dass dann, wenn der Ge-
schäftsführer und die Tier 1-Führungskraft bei dieser Wertermittlung nicht innerhalb von fünfzehn (15) Tagen zu einer
Einigung gelangen können, der Wert dieses Wertpapiers oder dieser Wertpapiere innerhalb eines Zeitraums von wei-
teren dreissig (30) Tagen von einer Anlagegesellschaft berechnet wird, die zwischen dem Geschäftsführer und der Tier
1-Führungskraft in beidseitigem Verständnis bestellt wird; es gilt weiterhin die Voraussetzung, dass dann, wenn der Ge-
schäftsführer und die Tier 1-Führungskraft sich nicht in beidseitigem Einverständnis innerhalb von dreissig (30) Tagen
auf eine solche Anlagegesellschaft einigen können, diese Gesellschaft durch Auslösung einer Gesellschaft aus den Anla-
gegesellschaften so wie diese in der beigefügten Anlage A, aufgeführt sind, bestimmt wird; der von dieser Gesellschaft
ermittelte Wert ist für die Tier 1-Führungskraft und den Geschäftsführer verbindlich; die Kosten und Ausgaben für diese
Wertermittlung werden zu gleichen Teilen von der Gesellschaft und der Tier 1-Führungskraft getragen; und (ii) in bezug
26953
auf ein Wertpapier einer Tier 2-Führungskraft gilt die Festlegung des Verwaltungsrats des Geschäftsführers, der in gu-
tem Glauben handelt.
«Familiengruppe» bezeichnet die (leiblichen oder Adoptiv-) Eltern, den/die Ehegatten/gattin und (leiblichen oder Ad-
optiv-) Kinder einer Führungskraft und jeden Trust (im Rahmen einer Einigung unter Lebenden, einer testamentarischen
Verfügung oder eines Ablebens ohne Testament), der für den alleinigen Nutzen der Führungskraft und/oder ihrer Eltern,
ihres/ihrer Ehegatten/gattin und/oder ihrer Kinder eingerichtet wurde.
«Guter Ausscheider» hat die im Artikel 6.4(d) genannte Bedeutung.
«Wertzuwachs-Prozentsatz eines guten Ausscheiders» bezeichnet den nachfolgend aufgeführten Wertzuwachs-Pro-
zentsatz, als wäre die Führungskraft zu jedem Datum bei der Gesellschaft oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften
angestellt.
in diesem Zusammenhang gilt allerdings als Voraussetzung, dass dann, wenn der Wertzuwachs-Prozentsatz des guten
Ausscheiders an einem Datum zu bestimmen ist, das in eines der oben aufgeführten Kalenderjahre fällt, dieser Wertzu-
wachs-Prozentsatz des guten Ausscheiders auf Monatsbasis ausgehend von der Anzahl der vollen Kalenderjahre, die seit
dem letzten in der obigen Tabelle genannten Datum verstrichen sind, anteilmäßig berechnet wird (d.h. wenn als Kündi-
gungsdatum der 25. August 2007 festgelegt wurde, läge der Wertzuwachs-Prozentsatz des guten Ausscheiders bei sieb-
zig Prozent (70%)); dabei gilt die Voraussetzung, dass im Falle eines Verkaufs der Gesellschaft, der Wertzuwachs-
Prozentsatz des guten Ausscheiders bei einhundert Prozent (100%) liegt.
«Kaufoptionspreis des guten Ausscheiders» bezeichnet (i) in bezug auf die Serie 1 PECs, die von der betreffenden
Führungskraft gezeichnet wurde, den Nennwert dieser Serie 1 PECs zuzüglich allen ungezahlten Renditen, und (ii) in
bezug auf die Stammaktien der Klasse A und der Serie 1 CPECs, die von der betreffenden Führungskraft gezeichnet wur-
den, (A) den angemessenen Marktwert dieses Wertpapiers der Führungskraft, multipliziert mit dem Wertzuwachs-Pro-
zentsatz des guten Ausscheiders zuzüglich (B) dem Produkt aus (x) dem angemessenen Marktwert oder, soweit
niedriger, den ursprünglichen Kosten für dieses Wertpapier der Führungskraft plus aufgelaufenen Zinsen zum Satz von
vier Prozent (4%) pro Jahr ab dem Datum des Erwerbs dieses Wertpapiers der Führungskraft und (y) einhundert Pro-
zent (100%) minus dem Wertzuwachs-Prozentsatz des guten Ausscheiders.
«Triftige Gründe» liegen in bezug auf eine Führungskraft vor, (A) wenn sie aus ihrem Anstellungsverhältnis oder Amt
mit bzw. bei der Gesellschaft und ihren Zweig/Tochtergesellschaften ausscheidet oder ihr Anstellungsverhältnis oder
Amt mit bzw. bei der Gesellschaft oder einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften aus einem oder mehreren der folgen-
den Gründe nicht verlängert: (i) wesentliche Verletzung des Anstellungsvertrags seitens der Gesellschaft oder einer ih-
rer Zweig/Tochtergesellschaften; (ii) Änderung des Titels der Führungskraft oder ihrer Verantwortlichkeiten auf eine
Art und Weise, die mit der von ihr gehaltenen Position im wesentlichen unvereinbar ist; (iii) Enthebung der Führungs-
kraft aus oder Nichtverlängerung ihrer Bestellung in einen Verwaltungsrat, Aufsichtsrat oder Vorstand ohne Grund, (iv)
Nichtunterbreitung des Angebots einer Verlängerung des Anstellungsvertrags der Führungskraft durch die Gesellschaft
in einem angemessenen Zeitraum vor Vertragsablauf unter Bedingungen, die denen des geltenden Anstellungsvertrags
entsprechen; (v) Rücktritt infolge einer Änderung der familiären Umstände, wozu der Verwaltungsrat des Geschäftsfüh-
rers zumutbarerweise feststellt, dass es für die Führungskraft dann im wesentlichen nicht mehr möglich ist, ihren Ver-
antwortlichkeiten gegenüber der Gesellschaft im Rahmen des Anstellungsvertrags zwischen der Führungskraft und der
Gesellschaft weiterhin nachzukommen; (vi) Ausscheiden bei Erreichen des üblichen Rentenalters, und (vii) Arbeitsunfä-
higkeit; (B) wenn die Gesellschaft oder eine Zweig/Tochtergesellschaft den Anstellungsvertrag mit der Führungskraft
nicht unter Bedingungen verlängert, die genauso günstig sind wie die Bedingungen des Anstellungsvertrags, der vor dem
Kündigungsdatum existierte, und dies aus anderen als aus gerechtfertigten Gründen; und (C) bei Tod während des An-
stellungsverhältnisses; grundsätzlich gilt die Voraussetzung, dass die schriftliche Mitteilung über das Ausscheiden der
Führungskraft aus triftigem Grund der Gesellschaft von der Führungskraft innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Ein-
treten eines solchen Vorfalls erteilt wird (außer bei Tod der Führungskraft).
«Unabhängige dritte Partei» bezeichnet jede Person, die umgehend vor der erwogenen Transaktion nicht wirtschaft-
liche Eigentümerin von über fünf Prozent (5%) der Stammaktien der Gesellschaft auf vollständig verwässerter Basis ist
(ein «5%-Inhaber»), die nicht zusammen mit einem solchen 5%-Inhaber kontrolliert, kontrolliert wird oder mit diesem
5%-Inhaber unter gemeinsamer Kontrolle steht und die nicht Ehegatte/gattin oder Abkömmling (leiblicher Art oder-
durch Adoption) eines solchen 5%-Inhabers oder ein Trust zugunsten eines solchen 5%-Inhabers und/oder solcher an-
deren Personen ist.
«Ursprünglicher Übergabestichtag» bezeichnet in bezug auf jede Führungskraft das erste Datum des Closings, an dem
diese Führungskraft Wertpapiere der Gesellschaft unterzeichnet hat und an dem die Gesellschaft dieser Führungskraft
Wertpapiere ausgestellt hat.
«Anleger» ist die BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A. und jeder direkte Empfänger von Übertragungen oder Abtre-
tungen von Anteilen an der Gesellschaft von BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A., und «die Anleger» bezeichnet mehr
als einen Anleger.
«Komplementärsaktie» hat die im Artikel 6.1 genannte Bedeutung.
«Geschäftsführer» hat die im Artikel 8 genannte Bedeutung.
«Ausscheider aus anderen als triftigen Gründen» hat die im Artikel 6.4(c) genannte Bedeutung.
Datum Wertzuwachs-Prozentsatz
Vor dem ersten Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Erster Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Zweiter Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Dritter Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Vierter Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
Fünfter Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
26954
«Wertzuwachs-Prozentsatz eines Ausscheiders aus anderen als triftigen Gründen» bezeichnet den nachfolgend ge-
nannten Wertzuwachs-Prozentsatz, als wäre die Führungskraft zu jedem einer diesen Daten bei der Gesellschaft oder
einer ihrer Zweig/Tochtergesellschaften angestellt.
in diesem Zusammenhang gilt allerdings als Voraussetzung, dass dann, wenn der Wertzuwachs-Prozentsatz des Aus-
scheiders aus anderen als triftigen Gründen an einem Datum zu bestimmen ist, das in eines der oben aufgeführten Ka-
lenderjahre fällt, dieser Wertzuwachs-Prozentsatz des Ausscheiders aus anderen als triftigen Gründen auf Monatsbasis
ausgehend von der Anzahl der vollen Kalenderjahre, die seit dem letzten in der obigen Tabelle genannten Datum ver-
strichen sind, anteilmäßig berechnet wird (d.h. wenn als Kündigungsdatum der 25. August 2007 festgelegt wurde, läge
der Wertzuwachs-Prozentsatz des Ausscheiders aus anderen als triftigen Gründen bei fünfunddreißig Prozent (35%));
dabei gilt die Voraussetzung, dass im Falle eines Verkaufs der Gesellschaft der Wertzuwachs-Prozentsatz des Ausschei-
ders aus anderen als triftigen Gründen bei einhundert Prozent (100%) liegt.
«Kaufoptionspreis des Ausscheiders aus anderen als triftigen Gründen» bezeichnet (i) in bezug auf die Serie 1 PECs,
die von der betreffenden Führungskraft gezeichnet wurde, den Nennwert dieser Serie 1 PECs zuzüglich allen ungezahl-
ten Renditen, und (ii) in bezug auf die Stammaktien der Klasse A und der Serie 1 CPECs, die von der betreffenden Füh-
rungskraft gezeichnet wurden, (A) den angemessenen Marktwert dieses Wertpapiers der Führungskraft, multipliziert
mit dem Wertzuwachs-Prozentsatz des Ausscheiders aus anderen als triftigen Gründen zuzüglich (B) dem Produkt aus
(x) dem angemessenen Marktwert oder, soweit niedriger, den ursprünglichen Kosten für dieses Wertpapier der Füh-
rungskraft und (y) einhundert Prozent (100%) minus dem Wertzuwachs-Prozentsatz des Ausscheiders aus anderen als
triftigen Gründen.
«Stammaktien» bezeichnet die Stammaktien der Gesellschaft (außer der/den Komplementärsaktie/n).
«Ursprüngliche Kosten» sind in bezug auf ein Wertpapier der ursprüngliche Zeichnungspreis, der vom ursprünglichen
Käufer eines Wertpapiers an die Gesellschaft gezahlt wurde.
«Andere Anleger» hat die im Artikel 6.4(f) genannte Bedeutung.
«Zulässige Abtretungsempfänger» bezeichnet Inhaber von Wertpapieren von Führungskräften, die (i) gemäß den an-
wendbaren Gesetzen über Abstammung und Verteilung oder (ii) innerhalb der Familiengruppe der Führungskraft über-
tragen wurden, vorausgesetzt, die im Artikel 7.3 genannten Auflagen gelten für die Wertpapiere der Führungskraft auch
nach einer solchen Übertragung.
«Person» bezeichnet eine Privatperson, eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, eine Vereinigung, eine Aktiengesellschaft, einen Trust, ein Joint Venture, eine nicht eingetragene
Organisation, eine Regierungskörperschaft oder eine Abteilung, Agentur oder politische Unterabteilung davon.
«Verkaufsoption» hat die im Artikel 6.5(a) genannte Bedeutung.
«Mitteilung über die Wahrnehmung einer Verkaufsoption» hat die im Artikel 6.5(b) genannte Bedeutung.
«Kündigungsdatum» hat die im Artikel 6.4(a) genannte Bedeutung.
«Auslösedatum» bezeichnet in bezug auf eine Führungskraft entweder den ursprünglichen Übergabestichtag oder, so-
weit später, das Datum, an dem die Führungskraft erstmals in ein Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft trat.
«Verkauf der Gesellschaft» bezeichnet einen gutgläubigen und auf rein geschäftlicher Basis erfolgenden Verkauf an
eine unabhängige dritte Partei oder eine Gruppe unabhängiger Dritter unter Einschluss von: (i) einem Verkauf der Ver-
mögenswerte, nach dem diese Partei oder Parteien alle oder im wesentlichen alle Vermögenswerte der Gesellschaft und
ihrer Zweig/Tochtergesellschaften auf konsolidierter Basis im Rahmen einer Transaktion oder einer Reihe zusammen-
gehöriger Transaktionen erwerben; (ii) einem Verkauf von allen oder im wesentlichen allen Wertpapieren im Rahmen
einer Transaktion oder einer Reihe zusammengehöriger Transaktionen; oder (iii) einer Fusion oder Verschmelzung, bei
der einer der vorgenannten Aspekte erfüllt wird.
«Wertpapiere» sind sämtliche ordnungsgemäß genehmigten Wertpapiere der Gesellschaft, einschließlich aber nicht
beschränkt auf jegliche Serien 1 PECs, Serien 1 CPECs oder die Stammaktien, die von der Gesellschaft ausgegeben wur-
den.
«Wertpapierinhaber» bezeichnet einen Inhaber von Wertpapieren.
«Serie 1 CPECs» bezeichnet die Serie 1 von umwandelbaren, bevorzugten Eigenkapitalscheinen, die von Zeit zu Zeit
von der Gesellschaft ausgegeben werden können, und, soweit anwendbar, alle weiteren Serien umwandelbarer, bevor-
zugter Eigenkapitalscheine, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft ordnungsgemäß genehmigt und ausgegeben wer-
den.
«Serie 1 PECs» bezeichnet die Serie 1 von bevorzugten Eigenkapitalscheinen, die von Zeit zu Zeit von der Gesell-
schaft ausgegeben werden können, und, soweit anwendbar, alle weiteren Serien bevorzugter Eigenkapitalscheine, die
von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft ordnungsgemäß genehmigt und ausgegeben werden.
«Kündigungsdatum» hat die im Artikel 6.4(a) genannte Bedeutung.
«Übertragung» hat die im Artikel 7.3(c) genannte Bedeutung.
«Tier 1-Führungskräfte» sind Jürgen Buchsteiner, Klaus Engel, Steve Clark und Daniel Pithois.
«Tier 2-Führungskräfte» sind alle anderen Führungskräfte als die Tier 1-Führungskräfte.
Datum Wertzuwachs-Prozentsatz
Vor dem ersten Jahrestag des Auslösedatums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Erster Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Zweiter Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Dritter Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
Vierter Jahrestag des Auslösedatums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Fünfter Jahrestag des Auslösedatums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
26955
C. Aktien - Aktienregister - Aktienübertragungen
Art. 7. Aktien
Art. 7.1 Aktienregister
Sämtliche Aktien weisen jetzt und in Zukunft die Form eingetragener Aktien auf. Ein Aktienregister, das von jedem
Aktionär eingesehen werden kann, wird am eingetragenen Geschäftssitz gehalten. Dieses Register enthält die genauen
Bezeichnungen aller Aktionäre sowie Angaben über die Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Aktien, über die auf die
Aktien erfolgten Einzahlungen sowie über die Aktienübertragungen und die Übertragungsdaten. Jeder Aktionär hat die
Gesellschaft per Einschreiben über seine Anschrift und jegliche Anschriftenänderungen zu informieren. Die Gesellschaft
ist befugt, sich auf die zuletzt mitgeteilte Anschrift zu berufen. Zertifikate über diese Eintragungen werden auf Wunsch
der jeweiligen Aktionäre vom Geschäftsführer ausgegeben und unterzeichnet.
Art. 7.2 Aktieneigentum
Das Eigentumsrecht an den eingetragenen Aktien geht aus den Eintragungen im Aktienregister hervor. Die Gesell-
schaft erkennt pro Aktie nur einen Eigentümer an. Wenn eine oder mehrere Aktien in einem Gemeinschaftseigentum
stehen oder wenn das Eigentumsrecht an einer oder mehreren Aktien strittig ist, müssen sämtliche Personen, die ein
Recht auf eine oder mehrere Aktien anmelden, einen einzigen Vertreter zwecks Vertretung dieser Aktie/n gegenüber
der Gesellschaft bestellen. Wird ein solcher Vertreter nicht bestellt, führt dies zu einer Aufhebung sämtlicher mit sol-
chen Aktien verbundenen Rechte.
Art. 7.3 - Aktienübertragung
(a) Erklärung einer Übertragung. Die Übertragung von Aktien wird von einer Erklärung einer im Aktienregister ein-
getragenen Übertragung begleitet, die von der übertragenden Person und von dem Übertragungsempfänger oder dessen
Vertreter/n datiert und unterzeichnet wird. Weiterhin unterliegen Aktienübertragungen den Bestimmungen über die
Übertragung von Forderungen gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von Luxemburg. Die Gesellschaft
kann außerdem jegliche Übertragungen annehmen und im Aktionärsregister eintragen, die in schriftlichen Mitteilungen
oder sonstigen Dokumenten niedergelegt sind, in denen die Zustimmung der übertragenden Person und des Übertra-
gungsempfängers enthalten ist.
(b) Übertragungsauflagen. Vor dem 25. Februar 2014 oder während eines kürzeren Zeitraums, der dem maßgeblichen
Recht entsprechen mag, es sei denn, ein Vertrag zwischen der Gesellschaft und den Inhabern von Stammaktien der Klas-
se A enthält anderweitige Vorkehrungen, ist es den Gesellschaftern der Gesellschafter nicht erlaubt, die von der Gesell-
schaft ausgegebenen Aktien an andere Personen als an die zulässigen Übertragungsempfänger oder auf anderem Wege
als gemäß Artikel 7.5(e) unten rechtswirksam zu übertragen, soweit nicht die vorherige schriftliche Zustimmung des
Geschäftsführers der Gesellschaft vorliegt.
(c) Übertragung. Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff «Übertragung» jede freiwillig oder zwangsläu-
fig oder kraft Gesetz vonstatten gehende Transaktion, die zu einer Übertragung des Eigentumsrechts, «nue-propriété»,
«usufruit» oder anderer Rechte an den von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien (einschließlich Stimmrechten oder
Rechten auf Dividenden) an andere Personen als an die Gesellschaft führt, unabhängig davon, ob es sich dabei um einen
Gesellschafter dieser Gesellschaft oder nicht handelt; die dazu führenden Maßnahmen spielen dabei keine Rolle (und
umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Schenkungen, Teileinlagen auf Vermögenswerte («apports partiels d’actifs»`),
Fusionen, Spaltungen («scissions»), Verkäufe, Abtretungen, Pfändungen oder sonstige Formen von Übertragungen,
Übereignungen oder Veräußerungen rechtmäßiger oder wirtschaftlicher Anteile an Aktien sowie Kombinationen dieser
Eigentumsübertragungsmaßnahmen.
(d) Übertragung einer oder mehrerer Komplementärsaktie/n. Die vom Geschäftsführer gehaltene/ Komplementärs-
aktie/n ist/sind nicht übertragbar, außer an einen Nachfolgegeschäftsführer, der gemäß Artikel 8 dieser Satzung zu er-
nennen ist.
(e) Zulässige Übertragungen. Die in diesem Artikel 7.3 niedergelegten Auflagen finden keine Anwendung auf die Über-
tragung von Wertpapieren von Führungskräften durch den Inhaber solcher Wertpapiere an zulässige Übertragungsemp-
fänger nach Zustellung einer schriftlichen Mitteilung einer solchen zulässigen Übertragung an den Geschäftsführer.
(f) Übertragungen bei Verletzung dieser Satzung. Jegliche Übertragungen oder versuchten Übertragungen von Wert-
papieren bei Verletzung von Bestimmungen dieser Satzung sind nichtig und wirkungslos, und die Gesellschaft verleiht
solchen Übertragungen weder Wirkung noch trägt sie diese Übertragungen in ihre Bücher ein oder behandelt einen
vermeintlichen Übertragungsempfänger solcher Wertpapiere für irgendwelche Zwecke als den Eigentümer solcher
Wertpapiere.
D. Geschäftsführer
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch BRENNTAG A.G., eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Recht des Groß-
herzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, in ihrer Eigenschaft als
Komplementär (associé commandité) und Geschäftsführer der Gesellschaft verwaltet («der Geschäftsführer»). Die an-
deren Aktionäre dürfen an dieser Verwaltung der Gesellschaft weder teilnehmen noch sich darin einmischen. Im Falle
einer rechtlichen Geschäftsunfähigkeit, einer Liquidation, oder einer anderen endgültigen Lage welche den Geschäfts-
führer verhindert als Geschäftsführer der Gesellschaft zu fungieren, wird die Gesellschaft nicht unmittelbar aufgelöst
und liquidiert, sofern der Aufsichtsrat gemäß Artikel 11 dieser Satzung, einen Geschäftsführer ernennt, welcher nicht
Aktionär sein muss, damit dieser die dringende Geschäftsführung übernimmt, bis eine Hauptversammlung der Aktionäre
stattgefunden hat, die der Geschäftsführer innerhalb von 15 Tagen nach seiner Ernennung, einberuft. Auf dieser Haupt-
versammlung können die Aktionäre, den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen folgend, einen
Nachfolger des Geschäftsführers ernennen. Sollte diese Ernennung nicht geschehen, wird die Gesellschaft aufgelöst und
liquidiert. Die Ernennung des Nachfolgers des Geschäftsführers benötigt nicht die Zusage, des Geschäftsführers.
26956
Art. 9. Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-
fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Geschäftsführer hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzten Fassung oder durch
diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.
Art. 10. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet, der selbst
gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei bevollmächtigten Vertretern des Geschäftsführers ver-
pflichtet wird, oder durch die Unterschrift jeder vom Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en), nach seinem eige-
nem Ermessen, außer jede Übertragung einer Befugnis an einen Kommanditisten.
E. Aufsichtsrat
Art. 11. Die Geschäfte sowie die finanzielle Situation der Gesellschaft, insbesondere ihre Bilanzen und Konten, un-
terliegen der Überwachung des Conseil de Surveillance (der «Aufsichtsrat»), der aus mindestens drei Mitgliedern be-
steht, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Aufsichtsrat hat für seine Überwachungsfunktion die in
Artikel 62 des Gesetzes des 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehene
Befugnisse eines Rechnungsprüfers. Der Aufsichtsrat wird befragt über spezielle Fragen vom Komplementär und geneh-
migt jede Handlung die, durch Anwendung des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen
letzten Fassung oder durch gegenwärtige Satzung, die Befugnisse des Komplementärs überschreiten. Die jährliche
Hauptversammlung der Aktionäre wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats für eine Dauer von einem Jahr. Die Mitglieder
behalten ihr Mandat. bis zur Ernennung eines Nachfolgers. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können mehrmals hinter-
einander gewählt werden und können jederzeit und unbegründet durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen
werden. Der Aufsichtsrat kann aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden wählen.
Der Aufsichtsrat wird von seinem Vorsitzenden oder von dem Geschäftsführer einberufen. Der Aufsichtsrat muss
auf Anfrage einer seiner Mitglieder einberufen werden.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält mindestens drei (3) Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung, ein
Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlich-
keit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Das Einberufungsschreiben enthält den Ort und die Tages-
ordnung der Sitzung. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel
(eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitglieds der Aufsichtsrates, kann auf die Einberufungs-
schreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Aufsichtsrates,
die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Aufsichtsrates auf
dem Kalender festgesetzt wurden.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Aufsichtsrates; in seiner Abwesenheit kann der Aufsichtsrat mit
Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig
zu führen. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertra-
gung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mit-
glied des Aufsichtsrats vertreten lassen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats kann mehrere andere Mitglieder vertreten.
Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten
sind. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Protokollen festgehalten und von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Ver-
tretungsvollmächte werden an dieser angeheftet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder ander-
weitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Mitgliedern unterzeichnet.
Einstimmige Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftli-
cher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommu-
nikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.
Die Mitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche sie im Namen der Ge-
sellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft und sind daher aus-
schließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt auf die im weitest möglichen Sinne nach Recht zulässige Art und Weise jedes Mitglied
des Aufsichtsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Geschäftsführer für angemessene Kosten die im Zusam-
menhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als
Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind. Das Mitglied hat kein Recht auf Entschädigung, wenn im Zusammenhang
mit jeder diesbezüglichen Handlung, jedem Prozess oder jedem Verfahren gerichtlich festgestellt wurde, dass es wegen
Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung haftbar ist. Im Falle eines Vergleiches wird Entschädigung nur in Bezug
auf die im Vergleich einbegriffenen Angelegenheiten gezahlt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtbeistand Bestä-
tigung erhält, dass das betroffene Mitglied seine Pflichten nicht verletzt hat. Das hiervor aufgeführte Recht auf Entschä-
digung schließt andere Rechte die dem Mitglied zustehen sollten nicht aus.
Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit
jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung
dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf
Entschädigung von der Gesellschaft besteht. Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines
Verfahrens durch ein Urteil, eine Anweisung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Vertei-
digung, entsteht nicht die Vermutung, dass die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart,
26957
durch den das Entschädigungsrecht entsteht, nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Ent-
schädigungsberechtigten machen, in gleicher Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflich-
tungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt
von den Informationen welche die Gesellschaft vernünftigerweise fordern kann.
Art. 12. Kein Vertrag oder andere Transaktion zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma
soll dadurch beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden, dass der Geschäftsführer, oder ein oder mehrere Verwal-
tungsratsmitglieder oder leitende Angestellte dieses Geschäftsführers, oder einer Zweig/Tochtergesellschaft davon, ein
Interesse darin hat, oder ein Verwaltungsratsmitglied, ein leitender Angestellter oder ein Angestellter dieser anderen
Gesellschaft oder Firma ist; jedoch, vorausgesetzt, dass eine solche Transaktion auf gutgläubiger und auf rein geschäftli-
cher Basis an eine unabhängige dritte Partei erfolgt. Jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeder leitende Angestellte dieses
Geschäftsführers, der als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Fir-
ma handelt, mit der die Gesellschaft handelt oder in anderer Weise Geschäfte macht, soll nicht wegen dieser Bindung
an diese andere Gesellschaft oder Firma, von der Betrachtung, vom Wählen oder Handeln betreffend einer Angelegen-
heit im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder Geschäft ausgeschlossen werden.
F. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 13. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft, mit Vorbehalten, dass ein Beschluss nur fähig ist wenn dieser vom Geschäftsführer genehmigt wird, insofern
diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft. Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer oder
den Aufsichtsrat einberufen.
Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einla-
dung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 11.00 Uhr morgens am dritten Freitag vom Mo-
nat Mai oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere
Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen wer-
den. Die Hauptversammlungen werden durch Einberufungsschreiben welche die Tagesordnung beinhalten einberufen.
Die Einberufungsschreiben werden vom Geschäftsführer wenigsten acht (8) Tage vor der Hauptversammlung per Ein-
schreiben an jeden Aktionär der Gesellschaft an die in dem Aktienregister eingetragene Adresse geschickt.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-
simileübertragung oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tages-
ordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
G. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden
Jahres.
Art. 15. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen
Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen. Die Hauptversamm-
lung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Geschäftsführers über die Verwendung des restlichen Betrages des Rein-
gewinns. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
Vorschussdividenden ausschütten. Solche Gewinn- oder Ausschüttungsverfügungen sollen mit jedem Vertrag der von
der Gesellschaft mit Inhabern der Stammaktien der Klasse A von Zeit zu Zeit abgeschlossen werden würde überein-
stimmen.
H. Auflösung der Gesellschaft - Satzungsänderung
Art. 16. Die gegenwärtige Satzung kann, mit Zustimmung des Geschäftsführers, von einer Hauptversammlung der
Aktionäre abgeändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915 über Handelsgesellschaften, in dessen letzten Fassung, werden beachtet, insofern keine anderweitigen Bestim-
mungen in der Satzung vorgesehen sind.
Ungeachtet anderwärtiger Bestimmungen in dieser Satzung, erfordert eine Abänderung von Bestimmungen, die die
Rechte von Inhabern von Stammaktien der Klasse A gegenüber den anderen Inhabern von Stammaktien der Klasse A
beinträchtigen, das Einverständnis all der Inhaber von Stammaktien der Klasse A deren Aktien beeinträchtigt worden
sind.
Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese(n) Liquidator(en) und setzt seine/ihre Befugnisse und Vergütung fest.
I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 18. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, ist das Gesetz vom 10. August 1915,
über Handelsgesellschaften bestimmend, in dessen letzten Fassung.
J. Verschiedenes
Art. 19. Die Gesellschaft beabsichtigt sich wegen U.S. Steuergründen rechtzeitig anzumelden um, mit Wirksamkeit
ab ihrem ersten Steuerjahr, als steuerlich transparente Körperschaft eingestuft zu werden (d.h. pass-through). In diesem
Zusammenhang, hat der Geschäftsführer, und jede andere durch die Aktionäre bevollmächtigte Person, die Befugnis die-
26958
se Anmeldung im Namen der Gesellschaft durchzuführen und einzuregistrieren. Die Aktionäre sollen kooperieren um
diese Anmeldung durchzuführen.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Debatte stehen, wird die Versammlung geschlossen.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-
teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Elvinger, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, vol. 20CS, fol. 49, case 2. – Reçu 28.735,03 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(029211.3/211/1630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.
INVESTORGAMES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 78.458.
—
Suite au déménagement du Cabinet d’Avocats Pierre Delandmeter, domiciliataire de la société INVESTORGAMES
HOLDING S.A. 7, rue du Saint-Esprit L-1475 Luxembourg, R. C. B 78.458.
Il résulte que le siège social de cette société se trouve maintenant au 8-10, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 15 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01828. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029714.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
MOET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.361.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01479, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029927.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
MOET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.361.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2004i>
1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décem-
bre 2003.
3. L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2004.
L’Assemblée accepte la démission de ELPERS & CO. Réviseurs d’Entreprises avec siège social au 11, boulevard du
Prince Henri à L-1724 Luxembourg du poste de Commissaire aux Comptes de la société et nomme en remplacement
la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera
lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.
4. Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
J. Elvinger.
<i>Pour la société INVESTORGAMES HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
26959
Luxembourg, le 6 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01475. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029899.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
BAYPOWER,. S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 80.041.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00579, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2004.
(030413.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
EUROPEAN GOLF ASSOCIATION, Association sans but lucratif.
Siège social: Senningerberg, Höhenhof.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des délégués du 18 octobre 2003 que les articles 3 [§ (e), (f), (g)]
et 10 [§ (a), (b), (c)] ont été modifiés et prennent la teneur suivante:
Art. 3. Objets
(e) Consolider les vues sur le handicapping et l’évaluation des parcours de golf au sein de l’EGA.
(f) Etablir, développer, maintenir et administrer un système de Handicap EGA auquel tous les membres peuvent ad-
hérer.
(g) Superviser l’administration du système de Handicap EGA dans le pays où le système a été adopté et contrôler
l’observance des principes et règles fondamentales du système dans ces pays.
Art. 10. Compétences du Comité Exécutif
(a) Proposer le «Chairman» et nommer les personnes physiques qui siègent au sein du comité de championnat après
que les membres appropriés aient consulté leurs zones respectives.
(b) Proposer le «Chairman» et nommer les personnes physiques qui siègent au sein du comité technique profession-
nel avec l’accord du membre approprié.
(c) Désigner le «Chairman» et les personnes physiques qui siègent au sein du comité d’évaluation des parcours et de
handicapping avec l’accord du membre approprié.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05587. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029745.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
EUROPEAN GOLF ASSOCIATION, Association sans but lucratif.
Siège social: Senningerberg, Höhenhof.
—
Le texte des statuts coordonnés au 18 octobre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029748.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour BAYPOWER, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
Pour réquisition
EUROPEAN GOLF ASSOCIATION
J. Storjohann
<i>Secrétaire générali>
EUROPEAN GOLF ASSOCIATION
J. Storjohann
<i>Secrétaire générali>
26960
CHALLENGER REASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.820.
—
L’an deux mille quatre, le douze mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHALLENGER REASSU-
RANCE, avec siège social à Münsbach, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à
Mersch, en date du 29 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 138 du 22 mai 1989, inscrite au Registre de Com-
merce de Luxembourg sous la section B et le numéro 29.820.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Paul Decker,
de résidence à Luxembourg, en date du 18 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 36 du 14 janvier 2003.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Dardenne, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Senningerberg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Anne Dietsch, employée privée, demeurant professionnellement à
Senningerberg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Ingrid Ninane, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Senningerberg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social de L-5365 Münsbach - 6 Parc d’Activités Syrdall à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trè-
ves, et modification de la première phrase du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution unique
suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-5365 Münsbach - 6 Parc d’Activités Syrdall à L-
2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier la première phrase du premier alinéa de l’article deux des statuts
comme suit:
«Art. 2. 1
er
alinéa. 1
ère
phrase. Le siège social est établi à Senningerberg.»
La résolution qui précède a été prise à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i> Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire
le présent acte.
Signé: G. Dardenne, A. Dietsch, I. Ninane, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, vol. 142S, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(030358.3/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Senningerberg, le 22 mars 2004.
P. Bettingen.
26961
DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 61.402.
—
In the year two thousand and four, on the eight of March, at 3.00 p.m.
Before us the undersigned notary Paul Bettingen, residing in Niederanven.
Was held an extraordinary general meeting of the company DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., R.C. Luxembourg
B number 61.402, with registered office at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, incorporated by deed of Maître Jean
Seckler on October 29, 1997, published in the Mémorial C No 63 of 30th January 1998.
The articles of incorporations were amended pursuant by a deed of the undersigned notary, on this day, at 2.00 p.m.
not yet published in the Mémorial C.
The meeting is presided by Alain Steichen, attorney-at-law, residing at L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
The chairman appoints as secretary Laura Rossi, attorney-at-law, residing at L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
The meeting elects as scrutineer Nicole Wilson, attorney-at-law, residing at L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the associates present as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which
after having been signed by the associates shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with
the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda which reads
as follows:
<i>Agendai>
1. Decision to dissolve the Company and to put the Company into liquidation
2. Appointment of Sévérine Michel as liquidator and definition of her functions
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The meeting decides on the dissolution of the Company and pronounces its liquidation from this day on.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to appoint Mrs. Sévérine Michel Manager, born in Epinal (France) on July 19, 1977, residing in
L-5751 Frisange, 31a, rue Robert Schuman, as liquidator.
The liquidator has the widest powers as foreseen by articles 144 to 148 bis of the co-ordinated law on commercial
companies. He can accomplish all deeds foreseen by article 145 without having to request prior approval of the general
shareholders’ meeting.
He can dispense the registrar of mortgages to proceed automatically with registrations; he can renounce to real
rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant releases, with or without payment of all registrations of liens or mort-
gages, transcriptions, seizure, attachments or other impediments.
The liquidator is dispensed from inventory making and can rely on the accounts of the company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies parts
of his powers which he will define and for the duration fixed by him.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
<i> Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille quatre, le huit mars à 15.00 heures.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DENTAL SYS-
TEMS HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61.402, constituée par acte du notaire Jean Seckler en date du 29
octobre 1997 publié au Mémorial C n
°
63 du 30 janvier 1998.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire, en date de ce jour, à 14.00
heures, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Alain Steichen, avocat à la cour, demeurant au L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Laura Rossi, avocat à la cour, demeurant au L-2661 Luxembourg,
44, rue de la Vallée.
26962
L’assemblée choisit comme scrutateur Nicole Wilson, avocat à la cour, demeurant au L-2661 Luxembourg, 44, rue
de la Vallée.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Que les associés présents ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés présents et les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
portés à l’ordre du jour.
Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation
2) Nomination de Sévérine Michel comme liquidateur et définition de ses pouvoirs
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur, Mademoiselle Sévérine Michel, Manager, née à Epinal (France) le
19 juillet 1977, demeurant à L-5751 Frisange, 31a, rue Robert Schuman.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: A. Steichen, L. Rossi, N. Wilson, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, vol. 142S, fol. 80, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(030353.3/202/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
BELAIR ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 72.692.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 8 mars 2004 que:
1) Les mandats des trois administrateurs:
- M. Roger Greden, demeurant à L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Letzebuerg;
- M. Pierre-Paul Boegen, demeurant à B-6700 Viville (Arlon), 65, rue de Freylande;
- Mme Nelly Noel, demeurant à L-2440 Luxembourg, 121, rue de Rollingergrund;
ont été reconduits pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010.
2) Le mandat du commissaire EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg,
9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, a été reconduit pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’as-
semblée générale statutaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06044. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029717.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Senningerberg, le 23 mars 2004.
P. Bettingen.
Pour extrait sincère et conforme
BELAIR ASSET S.A., Luxembourg
Signature
26963
VERSA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 35.827.
—
In the year two thousand and four, on the thirty-first of March.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under
the denomination of VERSA HOLDINGS S.A., R. C. Luxembourg B N° 35.827, with registered office in Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated November 16, 1990, published in the Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 174 of April 11, 1991.
The Articles of Incorporation have been amended at several times and for the last time pursuant to a deed of Maître
Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of the undersigned notary, dated April 12, 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 593 of August 19, 2000.
The meeting begins at ten a.m., Mrs Geneviève Blauen, company director, with professional address at 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Ingrid Heintz, secretary, with professional address at 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Sandra Kaiser, corporate executive, with professional address at 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one hundred
sixty thousand four hundred and forty-two (160,442) shares having a par value of twenty (20.-) US dollars each, repre-
senting the total capital of three million two hundred and eight thousand eight hundred and forty (3,208,840.-) US dollars
are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on
its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the shareholders having agreed to meet after examination
of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Decision to be taken on the basis of Article 100 of the amended law of 10th August 1915 on commercial compa-
nies.
2. Decrease of the share capital by partial absorption of forwarded losses in the amount of 3,168,840.- US dollars, so
as to bring it from its present amount of 3,208,840.- US dollars down to 40,000.- US dollars and relevant reduction of
the number of shares.
3. Subsequent amendment of Article 3, first paragraph of the Company’s Articles of Incorporation.
4. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
after deliberation, passed by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
After having acknowledged the balance sheet as at December 31, 2003 and referring to Article 100 of the Luxem-
bourg law of 10th August 1915 on commercial companies, it is resolved not to dissolve the Company but to continue
it while implementing a capital decrease by partial absorption of forwarded losses.
<i>Second resolutioni>
The share capital is reduced by an amount of 3,168,840.- US dollars, so as to bring it from its present amount of
3,208,840.- US dollars down to 40,000.- US dollars by partial absorption of forwarded losses and by cancellation of
158,442 shares having a par value of 20.- US dollars each.
The reality of such forwarded losses has been proved to the undersigned notary by the remittance of the accounts
as at December 31, 2003, and of a declaration of the Company’s statutory auditor dated March 18, 2004, which accounts
and declaration, after signature ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
As a consequence Article 3, paragraph 1 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and shall henceforth
read as follows:
«Art. 3. Paragraph 1. The corporate capital is set at forty thousand (40,000.-) US dollars divided into two thousand
(2,000) shares with a par value of twenty (20.-) US dollars each, all fully paid up.»
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting is closed at ten fifteen a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, said persons signed with Us the notary, the present original
deed.
26964
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le trente et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de VERSA HODINGS S.A., R. C. Luxembourg B N° 35.827, ayant son siège social à Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N° 174 du 11 avril 1991.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Mar-
tine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 12
avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 593 du 19 août 2000.
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec
adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Ingrid Heintz, secrétaire, avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Sandra Kaiser, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent soixante mille
quatre cent quarante-deux (160.442) actions d’une valeur nominale de vingt (20,-) dollars US chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social de trois millions deux cent huit mille huit cent quarante (3.208.840,-) dollars US sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision à prendre sur base de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
2. Réduction du capital social par absorption partielle de pertes reportées à concurrence de 3.168.840,- dollars US
pour le ramener de son montant actuel de 3.208.840,- dollars US à 40.000,- dollars US et par réduction correspondante
du nombre d’actions.
3. Modification subséquente de l’article 3, alinéa 1
er
des statuts de la Société.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2003 et en se référant à l’article 100 de la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il est décidé de ne pas dissoudre la Société mais de la continuer tout en
mettant en oeuvre une réduction de capital par absorption partielle de pertes reportées.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social de la Société est réduit à concurrence de 3.168.840,- dollars US pour le ramener de son montant
actuel de 3.208.840,- dollars US à 40.000,- dollars US par absorption partielle de pertes reportées et par annulation de
158.442 actions d’une valeur nominale de 20,- dollars US chacune.
La réalité de ces pertes reportées a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise des états financiers au 31
décembre 2003 ainsi que d’une attestation du commissaire aux comptes de la Société datée du 18 mars 2004, lesquels
états financiers et attestation, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront
annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
En conséquence l’article 3, alinéa 1
er
des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à quarante mille (40.000,-) dollars US divisé en deux mille (2.000) actions
d’une valeur nominale de vingt (20,-) dollars US chacune, entièrement libérées.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Blauen, I. Heintz, S. Kaiser, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, vol. 143S, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030388.3/230/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
A. Schwachtgen.
26965
VERSA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 35.827.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
358 du 31 mars 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(030389.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
TOITURES ZANOTTI ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TOITURES ZANOTTI, S.à r.l.).
Siège social: L-3514 Dudelange, 245B, route de Kayl.
R. C. Luxembourg B 40.551.
—
L’an deux mille quatre, le onze mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) Madame Odette Zanotti-Kass, employée privée, demeurant à L-3514 Dudelange, 245, route de Kayl.
2) Madame Manon Amari, employée privée, demeurant à L-3514 Dudelange, 245, route de Kayl,
ici représentée par Madame Odette Zanotti-Kass, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, qui res-
tera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquelles comparantes déclarent être les seules associées de la société à responsabilité limitée TOITURES ZANOT-
TI, S.à r.l., avec siège social à L-3514 Dudelange, 245, route de Kayl, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg
sous la section B et le numéro 40.551,
constituée par acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21
mai 1992, publié au Mémorial C du 20 octobre 1992, numéro 475.
Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées décident de modifier la dénomination sociale en TOITURES ZANOTTI ET FILS, S.à r.l.
L’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination TOITURES ZANOTTI ET FILS, S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident d’augmenter le capital par apport de cent cinq virgule trente-deux euros (EUR 105,32) de
façon à ce que le capital social soit établi à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans création de parts nouvelles
mais augmentation de leur valeur nominale.
L’augmentation du capital est réalisée par apport d’espèces, preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.
Le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sera représenté par cinq cents (500) parts sociales
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
L’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
<i> Troisième résolutioni>
Madame Manon Amari, prénommée, déclare par la présente céder une (1) part sociale lui appartenant à Madame
Odette Zanotti-Kass, prénommée, qui accepte au prix convenu entre parties, ce dont quittance.
Toutes les cinq cents (500) parts sociales appartiennent désormais à Madame Odette Zanotti, prénommée.
<i> Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).
Dont procès-verbal, passé à Munsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: O. Zanotti-Kass, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, vol. 142S, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(030355.3/202/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Senningerberg, le 22 mars 2004.
P. Bettingen.
26966
SHANARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 86.872.
—
L’an deux mille quatre, le seize mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SHANARA HOL-
DING S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 86.872,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 mars 2002, publié au Mémorial C numéro
1011 du 3 juillet 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Laurent Heiliger, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence deux cent soixante-neuf mille euros (EUR
269.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent mille euros (EUR
300.000,-) par l’émission de deux mille six cent quatre-vingt-dix (2.690) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles à émettre par l’actionnaire majoritaire, les autres action-
naires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.
3.- Augmentation du capital autorisé pour le porter à la somme de dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-).
4.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
5.- Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-neuf
mille euros (EUR 269.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois
cent mille euros (EUR 300.000,-) par l’émission de deux mille six cent quatre-vingt-dix (2.690) actions nouvelles d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i> Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté Messieurs Laurent Heiliger et Henri Grisius et Madame Michelle Delfosse ont re-
noncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles
l’actionnaire majoritaire ci-après nommé:
La société CAPINVEST LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar,
Laquelle est ici représentée par Monsieur Henri Grisius,
En vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg le 16 mars 2004, laquelle, après avoir été para-
phée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être
soumise aux formalités de l’enregistrement,
Lequel comparant, agissant ès-nom et qualités, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir par-
faite connaissance des statuts et de la situation financière de la société SHANARA HOLDING S.A. et a déclaré souscrire
26967
aux 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des actions
nouvelles par la personne prénommée.
<i>Libérationi>
Le souscripteur, préqualifié, a libéré intégralement la souscription des deux mille six cent quatre-vingt-dix (2.690)
actions nouvelles au moyen d’un paiement en espèces d’un montant de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR
269.000,-).
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital autorisé de la société pour le porter de son montant ac-
tuel de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-) représenté par cent mille
(100.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5.- 1
er
et 4
ème
alinéas des statuts, afin de
leur donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille euros) représenté par 3.000 (trois
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000,- (dix
millions d’euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500,-).
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire
le présent acte.
Signé: H. Grisius, N. Gautier, L. Heiliger, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, vol. 20CS, fol. 53, case 2. – Reçu 2.690 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(030360.3/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
EXPO-PROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 69.433.
—
L’an deux mille quatre, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXPO-PROM S.A., avec siè-
ge social à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous la section B et le numéro 69.433,
constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 12 avril 1999,
publié au Mémorial C du 29 juin 1999 numéro 496.
La séance est ouverte sous la présidence Madame Maria Arminda Goncalves Afonso, aide sociale familiale, demeurant
à Dudelange.
Madame le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Gre-
venmacher.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur de Monsieur Carlos Da Silva Tavares, carreleur, demeurant à Dude-
lange.
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
Senningerberg, le 19 mars 2004.
P. Bettingen.
26968
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social.
2) Décision de dissoudre la société et de mettre la société en liquidation.
3) Nomination de Maître Joseph Hansen, avocat, en tant que liquidateur de la société et fixation des pouvoirs du
liquidateur.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à celle ci-après:
L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
Et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Maître Joseph Hansen, avocat, né à Luxembourg le 16 mars 1940,
domicilié à L-2011 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
<i>Quatrième résolutioni>
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus
aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemble générale dans les cas où elle est prévue par la loi.
Il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,
pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: M. A. Goncalves Afonso, N. Steuermann, C. Da Silva Tavares, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, vol. 20CS, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(030362.3/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
ILOS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.
H. R. Luxemburg B 44.684.
—
Herr Michael Steging, wohnhaft in L-Wasserbillig legt mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Mitglied des Verwal-
tungsrates der Gesellschaft ILOS S.A. nieder.
Luxemburg, am 17. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029921.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Senningerberg, le 26 mars 2004.
P. Bettingen.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
26969
DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 61.402.
—
In the year two thousand and four, on the eight of March at 2.00 p.m.
Before us the undersigned notary Paul Bettingen, residing in Niederanven.
Was held an extraordinary general meeting of the company DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., R.C. Luxembourg
B number 61.402, with registered office at 73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Jean
Seckler on October 29, 1997, published in the Mémorial C No 63 of 30th January 1998. The articles of incorporation
were amended the last time pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, on 14 may 2002, published in the mémorial C
No 1270 of 2nd September 2002.
The meeting is presided by Alain Steichen, avocat à la cour, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Laura Rossi, avocat à la cour, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Nicole Wilson, avocat à la cour, residing in Luxembourg.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the associates present as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which
after having been signed by the associates shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with
the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda which reads
as follows:
<i>Agenda:i>
1. To amend article 5 of the articles of incorporation in order to indicate the current shareholders of the company
as well as their holding in the corporate capital.
2. To amend article 18 of the articles of incorporation in order to insert the order of distribution in case of the wind-
ing-up of the Company.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation in order to indicate the current shareholders
of the company as well as their holding in the corporate capital. Following text shall be added to the current article:
«The corporate capital is subscribed as follows:
Name
Number of shares % of Participation
Schroder German Buy-Out 1992 LP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,871
0.9373%
Schroder German Buy-Out 1992 LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,857
1.8809%
Schroder German Buy-Out 1992 LP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,574
2.1986%
Schroder UK Buy-Out Fund III LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62,356
3.4642%
Schroder UK Buy-Out Fund III Trust 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98,215
5.4564%
Schroder UK Buy-Out Fund III Trust 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,211
1.0673%
Schroder UK Buy-Out Fund III Co-Investment Scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
820
0.0456%
Permira Europe I LP1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209,099
11.6166%
Permira Europe I LP2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88,455
4.9142%
Permira Europe I LP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174,130
9.6739%
Permira Europe I LP4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184,778
10.2654%
Permira Europe I LP5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220,474
12.2486%
Permira Europe I LP6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76,841
4.2689%
Permira Europe I PGGM LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,007
6.7226%
Schroder Ventures Investment Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,487
3.5826%
Permira Europe I Co-Investment Scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,547
0.2526%
Schroder UK Venture Fund IV Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,924
1.5163%
Schroder UK Venture Fund IV LP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,823
1.6013%
Schroder UK Venture Fund IV LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,532
0.6962%
Schroder UK Venture Fund IV Co-Investment Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
582
0.0323%
Schroder UK Venture Fund III Trust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,204
0.6780%
Schroder UK Venture Fund III LP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,929
0.6627%
Schroder UK Venture Fund III LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,966
0.3314%
Schroder Ventures International Life Sciences Fund LP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,246
1.9026%
Schroder Ventures International Life Sciences Fund LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,609
0.4227%
Schroder Ventures International Life Sciences Fund Trust . . . . . . . . . . . . . . . .
12,055
0.6697%
Schroder Ventures International Life Sciences Fund Co-Investment Scheme . .
271
0.0151%
Metropolitan Life Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108,362
6.0201%
B Invest 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,835
0.2131%
26970
<i>Second resolutioni>
The assembly decides to amend article 18 of the articles of incorporation with the aim to insert the order of distri-
bution in case of the winding-up of the Company. Following wording shall be added to the existing article:
«The liquidator may only make payments to the shareholders after having set aside sufficient funds for satisfying the
creditors of the Company. The payments to be made to the shareholders will be split as follows:
1) All shareholders will receive an amount equal to the nominal value of shares they own.
2) Liquidation proceeds in excess of the nominal value of the shares shall be allocated to the shareholders of the
Company in proportion to the nominal shareholdings in the Company unless the following paragraphs state otherwise.
3) The holder Simone Blank shall receive a percentage of the liquidation proceeds that equals 9.7242% of the first
liquidation tranche to be distributed by the liquidator and 0.9500% of any further liquidation tranches to be distributed
by the liquidator.
4) The holder Theo Haar shall receive a percentage of the liquidation proceeds that equals 6.5780% of the first liqui-
dation tranche to be distributed by the liquidator and 0.4000% of any further liquidation tranches to be distributed by
the liquidator.
5) The holder Jost Fischer shall receive a percentage of the liquidation proceeds that equals 15.3025% of the first
liquidation tranche to be distributed by the liquidator and 0.5500% of any further liquidation tranches to be distributed
by the liquidator.
6) The remaining liquidation proceeds shall be allocated among the other shareholders in proportion to their nominal
shareholdings in the Company».
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated to about one thousand three hundred euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille et quatre, le huit mars, à 14.00 heures.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., R.C. Luxem-
bourg numéro B 61.402, avec siège social à 73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg, constituée par acte du notaire Jean
Seckler en date du 29 octobre 1997 publié au Mémorial C n
°
63 du 30 janvier 1998. Les statuts ont été modifiés une
dernière fois suivant acte du notaire Jean Seckler en date du 14 mai 2002, publié au Mémorial C n
°
1270 du 2 septembre
2002.
L’assemblée est présidée par M
e
Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M
e
Laura Rossi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Nicole Wilson, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Que les associés présents ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés présents et les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
portés à l’ordre du jour.
Squam Lake Investors II LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,830
0.2128%
Dental Société Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,440
1.0800%
Dr. Franz Scherer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,000
0.5000%
Paul Macdonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,000
1.0000%
Jost Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,900
0.5500%
Maria Fischer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,100
0.4500%
Theo Haar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,200
0.4000%
Simone Blank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,100
0.9500%
Gabriele Mauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,500
0.7500%
Christina Scherer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,000
0.5000%
Stephanie Mauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,250
0.1250%
Philipp Nikolas Mauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,250
0.1250%
26971
Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 5 des statuts afin d’indiquer les Associés actuels de la société, ainsi que leur participation
dans le capital social.
2. Modification de l’article 18 des statuts afin d’insérer l’ordre de distribution en cas de dissolution de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin d’indiquer les Associés actuels de la société, ainsi que leur
participation dans le capital social. Le texte suivant sera ajouté à l’article actuel:
«Le capital social est souscrit comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts afin d’insérer l’ordre de distribution en cas de dissolution de
la société. Le texte suivant sera ajouté à l’article actuel:
«Le liquidateur effectuera des paiements aux Associés après avoir établi que les fonds sont suffisants pour que tous
les créanciers de la société soient payés. Les paiements aux Associés se feront comme suit:
1) Tous les Associés recevront d’abord un montant égal à la valeur nominale des Parts Sociales qu’ils détiennent.
Nom
Nombre d’actions % de Participation
Schroder German Buy-Out 1992 LP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.871
0,9373%
Schroder German Buy-Out 1992 LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.857
1,8809%
Schroder German Buy-Out 1992 LP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.574
2,1986%
Schroder UK Buy-Out Fund III LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.356
3,4642%
Schroder UK Buy-Out Fund III Trust 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98.215
5,4564%
Schroder UK Buy-Out Fund III Trust 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.211
1,0673%
Schroder UK Buy-Out Fund III Co-Investment Scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
820
0,0456%
Permira Europe I LP1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209.099
11,6166%
Permira Europe I LP2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.455
4,9142%
Permira Europe I LP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174.130
9,6739%
Permira Europe I LP4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184.778
10,2654%
Permira Europe I LP5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.474
12,2486%
Permira Europe I LP6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.841
4,2689%
Permira Europe I PGGM LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121.007
6,7226%
Schroder Ventures Investment Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.487
3,5826%
Permira Europe I Co-Investment Scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.547
0,2526%
Schroder UK Venture Fund IV Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.924
1,5163%
Schroder UK Venture Fund IV LP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.823
1,6013%
Schroder UK Venture Fund IV LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.532
0,6962%
Schroder UK Venture Fund IV Co-Investment Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
582
0,0323%
Schroder UK Venture Fund III Trust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.204
0,6780%
Schroder UK Venture Fund III LP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.929
0,6627%
Schroder UK Venture Fund III LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.966
0,3314%
Schroder Ventures International Life Sciences Fund LP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.246
1,9026%
Schroder Ventures International Life Sciences Fund LP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.609
0,4227%
Schroder Ventures International Life Sciences Fund Trust . . . . . . . . . . . . . . . .
12.055
0,6697%
Schroder Ventures International Life Sciences Fund Co-Investment Scheme . .
271
0,0151%
Metropolitan Life Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108.362
6,0201%
B Invest 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.835
0,2131%
Squam Lake Investors II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.830
0,2128%
Dental Société Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.440
1,0800%
Dr. Franz Scherer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000
0,5000%
Paul Macdonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000
1,0000%
Jost Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.900
0,5500%
Maria Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.100
0,4500%
Theo Haar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.200
0,4000%
Simone Blank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.100
0,9500%
Gabriele Mauser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.500
0,7500%
Christina Scherer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000
0,5000%
Stéphanie Mauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.250
0,1250%
Philipp Nikolas Mauser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.250
0,1250%
26972
2) Le bénéfice de liquidation excédant la valeur nominale des Parts sera réparti entre les Associés de la société en
fonction du pourcentage qu’ils détiennent dans le capital social à moins que les paragraphes suivants n’en stipulent autre-
ment.
3) L’Associé Simone Blank recevra un pourcentage du bénéfice de liquidation équivalent à 9,7242% de la première
tranche de liquidation à distribuer par le liquidateur et 0,9500% de toute autre tranche de liquidation à distribuer par le
liquidateur.
4) L’Associé Theo Haar recevra un pourcentage du bénéfice de liquidation équivalent à 6,5780% de la première tran-
che de liquidation à distribuer par le liquidateur et 0,4000% de toute autre tranche de liquidation à distribuer par le
liquidateur.
5) L’Associé Jost Fischer recevra un pourcentage du bénéfice de liquidation équivalent à 15,3025% de la première
tranche de liquidation à distribuer par le liquidateur et 0,5500% de toute autre tranche de liquidation à distribuer par le
liquidateur.
6) Le solde sera réparti de manière égale entre les autres Associés en fonction du pourcentage qu’ils détiennent dans
le capital social.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ mille trois cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: A. Steichen, L. Rossi, N. Wilson, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, vol. 142S, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(030348.2/202/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
JINBANG STEEL LUX, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 99.846.
—
In the year two thousand and four, on the eighteenth of March.
Before Maître Paul Bettingen, notary public, residing in Niederanven.
There appeared:
The company JINBANG STEEL CAYMAN CO., LTD. with registered Office at Walkers SPV Limited Walker House,
Mary Street PO Box 908GT, George Town Grand Cayman, Cayman Islands, Register Number 133200,
Acting as the sole shareholder of JINBANG STEEL LUX a société à responsabilité limitée, with registered office at 8-
10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 10 March
2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation have not
yet been amended, (the «Company»).
Duly represented by Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17 March
2004, in Luxembourg, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
The appearing person representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) rep-
resented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each up to four hundred twelve
thousand five hundred euros (EUR 412,500.-) by payment in cash of four hundred thousand euros (EUR 400,000.-) and
the issuance of sixteen thousand (16,000) new shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
2. Subsequent amendment of article 5 - 1st paragraph of the articles of incorporation of the Company, that now reads
as follow:
«Art. 5. 1st paragraph. The Company’s share capital is fixed at four hundred twelve thousand five hundred euros
(EUR 412,500.-) represented by sixteen thousand five hundred (16,500) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all
fully paid-up and subscribed.»
And has taken the following resolutions:
Senningerberg, le 22 mars 2004.
P. Bettingen.
26973
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each
up to four hundred twelve thousand five hundred euros (EUR 412,500.-) by payment in cash of four hundred thousand
euros (EUR 400,000.-), and the issuance of sixteen thousand (16,000) new shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
All the new shares have been subscribed by JINBANG STEEL CAYMAN CO., LTD, as aforementioned.
All the new issued shares are fully paid up by the subscriber by a contribution in cash so that the amount of four
hundred thousand euros (EUR 400,000.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned no-
tary.
<i>Second resolutioni>
Further the foregoing resolutions, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles
of incorporation is modified and now reads as follows:
«Art. 5. 1st paragraph. The Company’s share capital is fixed at four hundred twelve thousand five hundred euros
(EUR 412,500.-) represented by sixteen thousand five hundred (16,500) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all
fully paid-up and subscribed.»
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, this deed was drawn up in Senningerberg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by her first and surname,
civil status and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Traduction française:
L’an deux mille quatre, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
La société JINBANG STEEL CAYMAN CO., LTD. ayant son siège social à Walkers SPV Limited Walker House, Mary
Street PO Box 908GT, George Town Grand Cayman, Cayman Islands, Register Number 133200,
En sa qualité de seule associée de JINBANG STEEL LUX, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social
à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée suivant acte notarié du notaire Maître Paul Bettingen, en
date du 10 mars 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société
n’ont pas été modifiés (la «Société»).
Dûment représenté par Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée le 17 mars 2004, à Luxembourg. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire sous-
signé restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune à quatre
cent douze mille cinq cents euros (EUR 412.500,-) par paiement en espèce de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-)
et l’émission de seize mille (16.000) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-).
2. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la te-
neur suivante:
«Art. 5. 1
er
paragraphe. Le capital social est fixé à quatre cent douze mille cinq cents euros (EUR 412.500,-) re-
présenté par seize mille cinq cents (16.500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
Et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune, à quatre cent douze mille cinq cents euros (EUR 412.500,-) par paiement en espèce de quatre cent mille euros
(EUR 400.000,-), et par l’émission de seize mille (16.000) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
Toutes les parts sociales ont été souscrites par JINBANG STEEL CAYMAN CO., LTD. mentionnée ci-avant.
Toutes les parts sociales émises ont été entièrement libérées par le souscripteur par un apport en numéraire afin que
la somme de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) affecté au capital social est à la disposition de la Société ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier en conséquence le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société, qui
aura désormais la teneur suivante:
26974
«Art. 5. 1
er
paragraphe. Le capital social est fixé à quatre cent douze mille cinq cents euros (EUR 412.500,-) re-
présenté par seize mille cinq cents (16.500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: U. Bräuer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, vol. 20CS, fol. 55, case 12. – Reçu 4.000 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(030364.3/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
EFG PROFILES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 73.065.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 mars 2004i>
La séance est ouverte à 16.00 heures.
Monsieur François Ries, Président, désigne comme Secrétaire Monsieur Eric Kata, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Eimear Crowley, demeurant à Luxembourg.
Les membres du bureau ainsi constitué constatent qu’à ce jour les comptes annuels pour l’année se clôturant le 31
décembre 2003 n’ont pas été reçus. L’Assemblée n’est donc pas en mesure d’approuver les comptes et décide de re-
pousser l’Assemblée Générale Ordinaire à une date ultérieure.
Monsieur le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02020. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029950.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
EFG ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 32.000.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 mars 2004i>
La séance est ouverte à 15.00 heures.
Monsieur François Ries, Président, désigne comme Secrétaire Monsieur Eric Kata, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Eimear Crowley, demeurant à Luxembourg.
Les membres du bureau ainsi constitué constatent qu’à ce jour les comptes annuels pour l’année se clôturant le 31
décembre 2003 n’ont pas été reçus. L’Assemblée n’est donc pas en mesure d’approuver les comptes et décide de re-
pousser l’Assemblée Générale Ordinaire à une date ultérieure.
Monsieur le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02033. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029947.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Senningerberg, le 26 mars 2004.
P. Bettingen.
F. Ries / E. Kata / E. Crowley
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
F. Ries / E. Kata / E. Crowley
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
26975
DIY-TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 75.071.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05674, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029886.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
DIY-TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 75.071.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société anonyme DIY-TECH S.A.
tenue extraordinairement en date du 14 janvier 2004 que:
- l’Assemblée décide d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 décembre 2002;
- l’Assemblée approuve l’affectation par le Conseil d’Administration, d’un montant de 16.000,- EUR à la réserve légale
et décide de reporter à nouveau le solde du bénéfice de l’exercice;
- décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de leurs mandats au
31 décembre 2002;
- les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont confirmés et renouvelés jusqu’à l’Assemblée
Générale Annuelle qui se tiendra en 2008.
Administrateurs
M. Simon W. Baker
M. Jay Vallabh
Mlle Corinne Néré
Commissaire aux Comptes
TEMPLE AUDIT S.C.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05673. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029884.3/1349/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
EXESS DEVELOPPEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 84.946.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement i>
Le 19 mars 2004.
S’est réunie l’Assemblée Générale réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme EXESS DEVE-
LOPPEMENT LUXEMBOURG S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B
84.946.
L’assemblée est ouverte et présidée par Denis Colin, expert-comptable, demeurant professionnellement 31, Val Sain-
te Croix, L-1371 Luxembourg.
Il est appelé aux fonctions de secrétaire Mlle Laetitia Moras, employée privée, demeurant professionnellement 31,
Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Mme Charlotte Fouquet, employée privée, demeurant 3, rue Nicolas Sim-
mer, L-2538 Luxembourg.
Le bureau constate:
1. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.
2. - Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Précision quant à l’adresse de la société
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
S.-W. Baker
<i>Administrateuri>
26976
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de préciser l’adresse de la société, à savoir: «2A, place de Paris,
L-2314 Luxembourg».
Plus rien étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04931. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029941.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
GC PAN EUROPEAN CROSSING LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.472.
—
<i>Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour des changements au Conseil de gérancei>
Il a été décidé:
1) de nommer trois nouveaux gérants au Conseil de gérance de GC PAN EUROPEAN CROSSING LUXEMBOURG
II, S.à r.l., à compter du 15 mars 2004:
- Monsieur Keogh Bernard, né à Baile Atha Cliath/Dublin (Irlande), le 13 septembre 1967, demeurant à 12, Brighton
Court, Brighton Road, Foxrock/Dublin, 18, Irlande
- Monsieur Arthur Eshuis, né à Rijssen (Pays-Bas), le 2 juin 1966, demeurant à Nassaukade 113-hs, 1052 EA Amster-
dam, Pays-Bas
- Mademoiselle Sylvia Infanger, née à Fribourg, (Suisse), le 5 avril 1957, demeurant à 24-28, rue Goethe, L-1637
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
2) d’accepter la démission de:
- Monsieur Dugan Terrence Lee, né à Swain Country, North Carolina, (U.S.A.), le 21 juin 1959, demeurant à 14 Ful-
mer Way, Gerrards Cross, Buckinghamshire, SL9 8AH, Grande-Bretagne, et ce en date du 18 décembre 2003;
et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04448. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029938.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
DENIA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.266.
—
Par la présente, Maître Eyal Grumberg, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclare avoir résilié avec effet
immédiat en date du 13 février 2004, la convention de domiciliation conclue avec la société anonyme DENIA S.A.
Le siège social de la société DENIA S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05572. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(029913.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
E. Grumberg
<i>Le domiciliatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
FI New Opportunities II, S.à r.l.
MTT Services International S.A.
Inveslife Capital Management S.A.
Bechtel Enterprises Energy, S.à r.l.
Siko Charter S.A.
Siko Charter S.A.
GC Pan European Crossing Luxembourg I, S.à r.l.
Lulu Holding S.A.
Brenntag Luxco
Investorgames Holding S.A.
Moet S.A.
Moet S.A.
Baypower, S.à r.l.
European Golf Association
European Golf Association
Challenger Réassurance S.A.
Dental Systems Holding, S.à r.l.
Belair Assets S.A.
Versa Holdings S.A.
Versa Holdings S.A.
Toitures Zanotti et Fils, S.à r.l.
Shanara Holding S.A.
Expo-Prom S.A.
Ilos S.A.
Dental Systems Holding, S.à r.l.
Jinbang Steel Lux
EFG Profiles Fund Management Company S.A.
EFG Asset Management S.A.
Diy-Tech S.A.
Diy-Tech S.A.
Exess Développement Luxembourg S.A.
GC Pan European Crossing Luxembourg II, S.à r.l.
Denia S.A.